This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1374
28 mai 2014
SOMMAIRE
Aircraft Solutions Lux XIX S.à r.l. . . . . . . . 65924
Change Management Consulting - MCG
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65950
C Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65941
CSRE I European Property (Luxembourg)
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65932
Isamco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65906
JM Logis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65907
Kaly S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65906
Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A. . . . . 65907
KBC Financial Indemnity Insurance . . . . . . 65907
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l. . . . . . 65914
Lavenden Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . 65914
Liberté Marques S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65914
Luleo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65913
Luxieco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65912
Macquarie Private Markets Fund S.C.A.,
SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65912
Marguerite Waste Polska S.à r.l. . . . . . . . . 65913
Marven S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65906
Marven S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65906
Marven S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65906
MCG - Change Management Consulting
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65950
Media Entertainment Communication
Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65913
M.H. Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65912
Octagon Residential S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . 65913
Orkor Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65918
Otto Invest & Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . 65912
O.Z. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65906
Parthus Finance SPF SA . . . . . . . . . . . . . . . . 65909
PATRIZIA Lux 60 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . 65908
PG Europe Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . 65909
Phil Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65909
Plafonlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65910
Plan Tivan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65910
P.O.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65912
P.O.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65952
POL 1 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65910
Predicare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65916
Prime Oil Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65948
Profenêtre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65909
PRO Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65921
Promethée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65911
Promethée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65911
QDVEO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65908
RBC Investor Services Bank S.A. . . . . . . . . 65908
Red Grafton I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65911
Red Grafton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65908
Respol Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65911
Rio Forte Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . 65908
ROLLINGER Chauffage/Sanitaire . . . . . . . . 65910
Sagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65907
Smiths Detection International Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65922
Sovecasi S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65951
T & E Gefahrgutlogistik A.G. . . . . . . . . . . . . 65909
TwinLux ValueInvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 65915
TwinLux ValueInvest SICAV-SIF . . . . . . . . 65915
65905
Marven S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 74.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044726/9.
(140051042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Kaly S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4996 Schouweiler, 17, rue de la Résistance.
R.C.S. Luxembourg B 151.550.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044666/9.
(140051359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Isamco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 172.321.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044648/9.
(140051170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Marven S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 74.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044727/9.
(140051043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Marven S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 74.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044728/9.
(140051044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
O.Z. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 48.867.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044758/9.
(140051190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65906
JM Logis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 178.100.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. März 2014.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2014044654/14.
(140051622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 178.546.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014044656/14.
(140051331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
KBC FII, KBC Financial Indemnity Insurance, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 75.878.
Le bilan au 31 décembre 2013 de la société KBC Financial Indemnity Insurance a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014044668/11.
(140051416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Sagra, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 59, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 151.841.
<i>Déclaration de l'Associé Unique/Gérant Unique en date du 18 mars 2014:i>
Monsieur Armand SAGRILLO, agissant tant en sa qualité d'associé unique que de gérant unique de la Société, informe
de sa nouvelle adresse:
7, rue de la Forêt F-57330 Entrange (France).
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Pour avis sincère et conforme
M. Armand SAGRILLO
<i>Associé unique/gérant uniquei>
Référence de publication: 2014044857/15.
(140051628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65907
Rio Forte Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.741.
Il résulte d'un procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 mars 2014 que M. Lou-
renço Maria LOPES SARAIVA LOBO, directeur financier, né le 26 juin 1964 à Lisbonne (Portugal), avec adresse
professionnelle au 61, Avenida Alvares Cabral, P-1250-017 Lisbonne (Portugal), a été nommé, avec effet au 18 mars 2014,
au poste de Directeur de la Société, en remplacement de M. José Carlos CARDOSO CASTELLA, démissionnaire à cette
même date.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.
Référence de publication: 2014044823/14.
(140051565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
RBC Investor Services Bank S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 47.192.
Les comptes annuels au 31.10.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2014.
RBC Investor Services Bank S.A.
Référence de publication: 2014044815/11.
(140051487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Red Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 159.416.310,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 136.002.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044810/11.
(140051039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
QDVEO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trêves.
R.C.S. Luxembourg B 151.849.
Les comptes annuels au 31 December 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044807/9.
(140050829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
PATRIZIA Lux 60 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 123.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044785/9.
(140051367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65908
Phil Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 176.207.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044777/9.
(140051147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Parthus Finance SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 182.000.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 20 mars 2014i>
Transfert du siège social:
- 1, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044783/11.
(140051562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
PG Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 183.329.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 mars 2014.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2014044790/11.
(140051110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Profenêtre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3490 Dudelange, 19-21, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 142.853.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014044802/10.
(140050921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
T & E Gefahrgutlogistik A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 23, am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 66.757.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 21. März 2014i>
Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis von der Adressänderung des Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, Herrn
Oliver Bjelanovic.
Herr Oliver Bjelanovic, geboren am 15.01.1980 in Trier (Deutschland), hat seinen Wohnsitz ab 15.03.2014 in Graf-
Reginar-Str. 20, D-54294 Trier.
T&E Gefahrgutlogitik A.G.
Référence de publication: 2014044896/13.
(140050804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65909
Plan Tivan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 70.808.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044795/9.
(140051237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Plafonlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 84.393.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014044794/10.
(140050882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
POL 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 72.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 115.874.
<i>Extrait des résolutions prises à l'associé unique de la société tenue en date du 17 mars 2014i>
1. L'associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz, né le 26 juli 1948 demeurant profession-
nellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 17 mars 2014.
2. L'associé unique nomme Monsieur David Bannerman, né le 2 février 1962 à Edinburgh, Royaume-Uni, résidant
professionnellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg en qualité gérant de la Société avec effet au 17 mars 2014.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre
2013.
Le conseil de gérance de la de Société se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (gérant),
2. Monsieur Pii KETVEL (gérant),
3. Monsieur David BANNERMAN (gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014044798/21.
(140051572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
ROLLINGER Chauffage/Sanitaire, Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 117.654.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2014 que:
- Nomination d'un administrateur-délégué:
* Nomination de Monsieur Serge Rollinger, demeurant professionnellement au 50, rue des Prés, L-7333 Steinsel, au
poste d'administrateur-délégué jusqu'à la prochaine Assemblée Générale à tenir en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Référence de publication: 2014044825/14.
(140050990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65910
Respol Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.886.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 21 mars 2014i>
1. Monsieur João Manuel PEREIRA DOS REIS, administrateur de sociétés, né à Barreira, Leiria (Portugal), le 16 février
1969, demeurant à 2410-351 Leiria (Portugal), 343, Estrada da Mourã, Telheiro, a été coopté comme administrateur A
de la société en remplacement de Madame Valérie PECHON, administrateur B démissionnaire. Le mandat d'administra-
teur A de Monsieur João Manuel PEREIRA DOS REIS viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2019.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. Madame Odília DE JESUS MARIANO MANSO, administrateur de sociétés, née à Marrazes, Leiria (Portugal), le 18
décembre 1969, demeurant à L-1750 Luxembourg, 31, avenue Victor Hugo, a été cooptée comme administrateur B de
la société en remplacement de Monsieur Etienne BIREN, administrateur B démissionnaire. Le mandat d'administrateur B
de Madame Odïlia DE JESUS MARIANO MANSO viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2019.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
3. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Respol Lux S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014044812/24.
(140051616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Red Grafton I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.851.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044809/10.
(140051220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Promethée S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 50.704.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014044803/10.
(140050932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Promethée S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 50.704.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014044804/10.
(140050933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65911
Luxieco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 142.025.
EXTRAIT
Par la présente, Monsieur Christophe ANTINORI, informe avoir démissionné en date du 27 mars 2014 de son mandat
d'administrateur de la société LUXIECO S.A., société anonyme, L-1660 Luxembourg, 30, Grand Rue, immatriculée au
R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B142025.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Référence de publication: 2014044702/13.
(140051508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
M.H. Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 265A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 84.943.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg du 25 février 2014i>
L'Assemblée générale approuve la nomination comme commissaire aux comptes pour l'exercice 2012, Frank Rossi,
demeurant au 5 rue Principale, à Ell, L-8530, GD de Luxembourg en remplacement de la société PKF ABAX Audit.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044703/11.
(140050494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Macquarie Private Markets Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 162.637.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Référence de publication: 2014044709/11.
(140051404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
P.O.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7350 Lorentzweiler, 18, rue Bellevue.
R.C.S. Luxembourg B 138.897.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044769/9.
(140051282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Otto Invest & Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 138.643.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2014.
Référence de publication: 2014044767/10.
(140051142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65912
Luleo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 133.284.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 mars 2014,
que:
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2013 qui se tiendra en l'année 2014:
- Madame Mireille GEHLEN, demeurant au 2, rue J.-F. Kennedy, L-3502 Dudelange.
- Monsieur Thierry JACOB, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
- Monsieur Mattia MALACALZA, demeurant à Via San Lorenzo, 3, CH-6900 Lugano (Suisse).
- Monsieur Roberto GALERI, demeurant Villa Luganese, CH-6966 Lugano (Suisse).
Et réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 25 mars 2014.
Référence de publication: 2014044684/21.
(140050997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Media Entertainment Communication Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 148.247.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 05 novembre 2012i>
Lors du Conseil de gérance tenu en date du 05 novembre 2012, Monsieur José Rodrigo de Freitas Branco, s'est démis
de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 12 novembre 2012.
Pour extrait conforme
Clémency, le 27 mars 2014.
Référence de publication: 2014044712/13.
(140051183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Octagon Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 118.990.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044760/9.
(140051180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Marguerite Waste Polska S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.467.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 17 octobre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 18 novembre 2013.
Référence de publication: 2014044710/11.
(140051119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65913
Liberté Marques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.666,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 181.312.
Suite aux résolutions des associés en date du 31 janvier 2014 de la Société, les décisions suivantes ont été prises:
1. Démission du gérant A suivant à compter du 31 janvier 2014:
Monsieur Franciscus W.J.J. Welman, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Démission du gérant B suivant à compter du 31 janvier 2014:
Madame Stéphanie Jung-Schut, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3. Nomination du gérant A suivant à compter du 31 janvier 2014 pour une durée indéterminée:
Monsieur Olivier Pierre Jacques Gardies, né le 12 avril 1965 à Talence, France, demeurant au 9, avenue de la marguerite,
F-78110 Le Vesinet, France.
4. Nomination du gérant B suivant à compter du 31 janvier 2014 pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Baptiste Paul Olivier Devade, né le 5 février 1957 à Sainte-Adresse, France, demeurant au 2, Impasse
blanche, F-76600 Le Havre, France.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Madame Lutgarde Françoise A. Denys, Gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier Pierre Jacques Gardies, Gérant de catégorie A
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, Gérant de catégorie B
- Monsieur Jean-Baptiste Paul Olivier Devade, Gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Patrick Leonardus Cornelis van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2014044676/27.
(140051444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.942.
Veuillez noter que le siège social de Universal Management Services S.à r.l., gérant de catégorie B, se situe désormais
au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 27 mars 2014.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Kulczyk Real Estate Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014044664/13.
(140051135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Lavenden Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 176.582.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014044689/14.
(140051498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
65914
TwinLux ValueInvest S.A., Société Anonyme,
(anc. TwinLux ValueInvest SICAV-SIF).
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 157.550.
Im Jahre zweitausendvierzehn,
am siebzehnten Tag des Monats März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum
Luxemburg) in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim
(Großherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,
ist erschienen:
Herr Christian LENNIG, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, handelnd für Rechung von:
„Südwestbank Aktiengesellschaft“, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB
4100, geschäftsansässig Rotebühlstraße 125, D-70178 Stuttgart,
auf Grund einer Vollmacht, die in Stuttgart, Deutschland, am 19. Februar 2014 ausgestellt wurde, die der Urkunde
vom 26. Februar 2014 (Urkunde Nr. 35180) des unterzeichnenden Notars, einregistriert zu Esch/Alzette, am 27, Februar
2014: Relation EAC/2014/2894 und hinterlegt beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, am 19. März 2014,
unter der Referenz L140046483) beigefügt ist, von "TwinLux ValueInvest SICAV - FIS" einer nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) errichteten Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d’investissement
spécialisé, SICAV-FIS) mit Gesellschaftssitz in 20, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Ge-
sellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 157.550 (die "Gesellschaft"), die gemäß einer notariellen Urkunde
vom 15. Dezember 2010 gegründet und deren Satzung am 5. Januar 2011 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (das "Mémorial") unter Nummer 14, Seite 631 veröffentlicht wurde (die "Satzung").
Die Satzung wurde das letzte Mal durch Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER vom 26. Februar 2014 abgeändert,
die noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde, diese Urkunde dokumentiert die Beschlüsse des alleinigen Gesellschaf-
ters, der unter anderem eine Neufassung der Satzung vor dem Hintergrund der Aufgabe des Status als société
d’investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé unter dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar
2007 über spezialisierte Investmentfonds beschloss.
Die erscheinende Partei, vertreten wie oben dargestellt, nachdem sie erklärt hat, dass der Betrag des Gesellschafts-
kapitals (EUR 31.000,-), im vierten Beschluss sowie in der Neufassung der vorerwähnten Urkunde vom 26. Februar 2014,
korrekt erwähnt ist, aber dass die erforderliche Kapitalherabsetzung in Höhe von drei Millionen zweihundertsechsund-
sechzigtausendvierhundertzehn Euro und zweiundfünfzig Cents (EUR 3.266.410,52), durch die Annullierung von sechs-
hundertsiebenundfünfzigtausendeinhundertsechsundsiebzig (657.176) Aktien und durch Einzahlung eines Betrags von drei
Millionen zweihundertsechsundsechzigtausendvierhundertzehn Euro und zweiundfünfzig Cents (EUR 3.266.410,52) in die
Kapitalrücklage (share premium account) nicht berücksichtigt wurde, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Ur-
kunde vom 26. Februar 2014 wie folgt zu berichtigen:
- Punkt 4 der Tagesordnung wird vollständig wie folgt ergänzt:
Beschluss, (i) das bislang variable Kapital der Gesellschaft unter Bezugnahme auf den letzten festgestellten Nettoin-
ventarwert der Gesellschaft vom 30. September 2013 in fixes Kapital umzuwandeln und auf drei Millionen drei Millionen
zweihundertsiebenundneunzigtausendvierhundertzehn Euro und zweiundfünfzig Cent (EUR 3.297.410,52) zu fixieren; (ii)
dieses Gesellschaftskapital um drei Millionen zweihundertsechsundsechzigtausendvierhundertzehn Euro und zweiund-
fünfzig Cent (EUR 3.266.410,52) auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zu reduzieren, und zwar durch eine
Annullierung von fünfundsechzig Komma sieben eins sieben sechs (65,7176) Aktien und durch Einzahlung eines Betrags
von drei Millionen zweihundertsechsundsechzigtausendvierhundertzehn Euro und zweiundfünfzig Cent (EUR
3.266.410,52) in die Kapitalrücklage (share premium account).
- Der vierte Beschluss wird vollständig wie folgt ergänzt:
„Die Alleinaktionärin BESCHLIESST (i) das bislang variable Kapital der Gesellschaft unter Bezugnahme auf den letzten
festgestellten Nettoinventarwert der Gesellschaft vom 30. September 2013 in fixes Kapital umzuwandeln und auf drei
Millionen zweihundertsiebenundneunzigtausendvierhundertzehn Euro und zweiundfünfzig Cent (EUR 3.297.410,52) zu
fixieren; (ii) dieses Gesellschaftskapital um drei Millionen zweihundertsechsundsechzigtausendvierhundertzehn Euro und
zweiundfünfzig Cents (EUR 3.266.410,52) auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zu reduzieren, und zwar durch
eine Annullierung von fünfundsechzig Komma sieben eins sieben sechs (65,7176) Aktien und durch Einzahlung eines
Betrags von drei Millionen zweihundertsechsundsechzigtausend-vierhundertzehn Euro und zweiundfünfzig Cents (EUR
3.266.410,52) in die Kapitalrücklage (share premium account).“
Alle anderen Bestimmungen des vorerwähnten Protokolls vom 26. Februar 2014 bleiben unverändert.
Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
65915
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-
kannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar
unterzeichnet.
Gezeichnet: C. LENNIG, M. SCHAEFFER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 20. März 2014. Relation: EAC/2014/3973. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2014044235/66.
(140050449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Predicare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 118.926.
In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of March,
before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
the company PREDICA S.A., with registered office at 50-56, rue de la Procession, F-75015 Paris (the “Sole member”),
here represented by Mr. Martin SCHOLTER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given
under private seal on March 12, 2014.
A copy of which power, after having been signed “ne varietur” by the appearing acting on behalf of the appearing party
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party is the sole member of the company PREDICARE S.à r.l., a private limited liability company having
its registered office at L-2557 Luxembourg, 7A rue Robert Stümper, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under the number B 118.926, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas known as Tom
METZLER, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on August 9, 2006, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1890 dated October 9, 2006, whose articles have been amended
on several occasions and on the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, dated
May 30, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1755 dated July 22, 2013
(hereinafter referred to as the “Company”).
The appearing party, represented as here above stated, requested the undersigned notary to act the following reso-
lutions that it takes in its capacity as Sole Member:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to reduce the share capital of the Company, by reduction of the par value but without
cancellation of any of the existing corporate units, so as to bring it from its present amount of two hundred twenty-eight
million six hundred ninety-two thousand sixty-seven euro and seventy-two cents (EUR 228,692,067.72) represented by
two million nine hundred nineteen thousand six hundred seventy-four (2,919,674) corporate units, with no indication of
par value, to the amount of one hundred fifty-five million nine hundred sixty-five thousand seven hundred thirty-nine euro
and seventeen cents (EUR 155,965,739.17) and to repay the corresponding amount of seventy-two million seven hundred
twenty-six thousand three hundred twenty-eight euro and fifty-five cents (EUR 72,726,328.55) to the Sole Member.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolved to reduce the legal reserve of the Company so as to bring it from its present amount of
twenty-two million eight hundred sixty-nine thousand two hundred six euro and seventy-eight cents (EUR 22,869,206.78)
to the new amount of fifteen million five hundred ninety-six thousand five hundred seventy-three euro and ninety-two
cents (EUR 15,596,573.92) and to repay the corresponding amount of seven million two hundred seventy-two thousand
six hundred thirty-two euro and eighty-six cents (EUR 7,272,632.86) to the Sole Member.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the sole member resolves to amend paragraph 1 of Article 5 of the Articles
of Association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
“ Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at one hundred fifty-five million nine hundred sixty-
five thousand seven hundred thirty-nine euro and seventeen cents (EUR 155,965,739.17) represented by two million nine
hundred nineteen thousand six hundred seventy-four (2,919,674) corporate units, with no indication of par value.”
All other paragraphs of Article 5 remain unchanged and are hereby reiterated as far as necessary.
<i>Fourth resolutioni>
The sole member resolves to grant authorisation to (i) any manager of the Company or (ii) to any lawyer of the Law
Firm WILDGEN to take all the necessary actions in relation to the present resolutions.
65916
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 2,100.-The undersigned notary who understands and speaks English, states
herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French
version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text,
the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder representing the appearing person, the said signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quatorze mars,
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
la société PREDICA S.A., ayant son siège social au 50-56, rue de la Procession, F-75015 Paris (ci-après dénommé
l’«Associé Unique»), ici représentée par M. Martin SCHOLTER, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 12 mars 2014.
Copie de ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La personne comparante est l’associée unique de la société PREDICARE S.à r.l., une société à responsabilité limitée
ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7A rue Robert Stümper, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.926, constituée par un acte notarié de Maître Léon Thomas, dit Tom
METZLER, notaire, résidant à Luxembourg-Bonnevoie, daté du 9 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1890 du 9 octobre 2006, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu
par acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg, du 30 mai 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1755 du 22 juillet 2013 (ci-après dénommée la "Société").
La personne comparante, représentée comme indiqué précédemment, a requis le notaire soussigné d’acter les réso-
lutions suivantes qu'elle adopte en sa qualité d’associée unique de la Société:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de réduire le capital de la Société, par réduction de la valeur nominale des parts sociales
existantes et sans annulation de parts sociales existantes, pour le porter de son montant actuel de deux cent vingt-huit
millions six cent quatre-vingt-douze mille soixante-sept euros et soixante-douze centimes (EUR 228.692.067,72) repré-
senté par deux millions neuf cent dix-neuf mille six cent soixante-quatorze (2.919.674) parts sociales, sans mention de
valeur nominale, au montant de cent cinquante-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent trente-neuf euros et
dix-sept centimes (EUR 155.965.739,17), et de rembourser le montant correspondant de soixante-douze millions sept
cent vingt-six mille trois cent vingt-huit euros et cinquante-cinq centimes (EUR 72.726.328,55) à l’Associé Unique.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de réduire la réserve légale de la Société pour la porter de son montant actuel de vingt-deux
millions huit cent soixante-neuf mille deux cent six euros et soixante-dix-huit centimes (EUR 22.869.206,78) au montant
de quinze millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-treize euros et quatre-vingt-douze centimes
(15.596.573,92), et de rembourser le montant correspondant de sept millions deux cents soixante-douze mille six cent
trente-deux euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 7.272.632 ,86) à l’Associé Unique.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions prises ci-dessus, l’associée unique décide de modifier le paragraphe 1 de l’article 5
des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent cinquante-cinq millions neuf cent soixante-
cinq mille sept cent trente-neuf euros et dix-sept centimes (EUR 155.965.739,17) représenté par deux millions neuf cent
dix-neuf mille six cent soixante-quatorze (2.919.674) parts sociales, sans mention de valeur nominale.»
Les autres paragraphes de l’article 5 demeurent inchangés et sont réitérés par la présente pour autant que de besoin.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associée unique décide d’autoriser (i) tout gérant de la Société ou (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN, d’effectuer
toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du présent agenda;
65917
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à 2.100,- EUR Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la
requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la requête
de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, celui-ci a signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: Martin SCHOLTER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2014. Relation GRE/2014/1158. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044137/113.
(140050714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Orkor Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 177.728.
In the year two thousand and fourteen, on the sixth of March,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Orkor Luxco 1 S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital
of twelve thousand five hundred one euro (EUR 12,501.-), with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 177681 (the “Shareholder”),
hereby represented by Me Alexandre Koch, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 5 March 2014,
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
Orkor Luxco 2 S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of
twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 29 May
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1795 of 25 July 2013 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 177.728 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have not yet been amended.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) so as to raise it from its
present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred one euro (EUR
12,501.-).
2 To issue one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the
existing shares.
3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of seven hundred
twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine euro (EUR 729,999.-) by Mitha Shuku Investment Ltd and to accept full
payment in cash for this new share.
4 To amend the 1
st
paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the
capital increase.
5 To amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, in order to amend the cross reference so as to
refer to article 28 of the articles of incorporation.
6 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
65918
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) so
as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five
hundred one euro (EUR 12,501.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same
rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholder, represented as stated above.
The Shareholder declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), together
with the payment of a share premium in a total amount of seven hundred twenty-nine thousand nine hundred ninety-nine
euro (EUR 729,999.-) and to fully pay in cash for these shares.
The amount of seven hundred thirty thousand euro (EUR 730,000.-) was thus as from that moment at the disposal of
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one (1) new share according to
the above mentioned subscription.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend 1
st
paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order
to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred one euro (EUR
12,501.-) divided into twelve thousand five hundred one (12,501) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
all of which are fully paid up.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to amend the
cross reference so as to refer to article 28 of the articles of incorporation. Said article will from now on read as follows:
“ Art. 4 Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 28 of the Articles of Incorporation.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at two thousand three hundred euro (EUR 2,300,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, who is known to the undersigned
notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned
notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le six mars,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Orkor Luxco 1 S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de
douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-), dont le siège social est au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 177.681 (l’«Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Alexandre Koch, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 5 mars 2014.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
65919
L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de Orkor Luxco 2 S.à
r.l, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 29 mai 2013, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1795 du 25 juillet 2013 et enregistrée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.728 (la «Société»). Les statuts n’ont pas encore été modifiés.
L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un euro (EUR 1,-) pour le porter de son montant actuel
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-).
2 Émission d’une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant
total de sept cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 729.999,-) par Orkor Luxco 1 S.à r.l à
libérer intégralement en espèces.
4 Modification de l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital.
5 Modification de l’article 4 des statuts de la Société, afin de modifier le renvoi pour qu'il fasse désormais référence à
l’article 28 des statuts.
6 Divers.
a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un euro (EUR 1,-) pour le porter de son
montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé d’émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes
droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu l’Associé, représenté comme indiqué ci-dessus.
L’Associé a déclaré souscrire une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-), ensemble avec
le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de sept cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros
(EUR 729.999,-) à libérer intégralement en espèces.
Le montant de sept cent trente mille euros (EUR 730.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce
moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre la part sociale nouvelle conformément
à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.
Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Emis. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-), divisé en douze
mille cinq cent une (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,.-) chacune, celle-ci étant entiè-
rement libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de modifier le renvoi pour qu'il fasse désormais
référence à l’article 28 des statuts. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l’article 28 des Statuts.»
65920
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante ci-avant, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: A. Koch, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 10 mars 2014. REM/2014/567. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044097/154.
(140050658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
PRO Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 55, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 35.662.
L’AN DEUX MILLE QUATORZE, LE DIX-NEUF MARS.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Euro Information International, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 55, rue
des Scillas, L-2529 Howald, inscrite au Registre de commerce et des sociétés section B sous le numéro 162.712,
ici représentée par Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert,
en vertu d’une procuration datée du 14 mars 2014, laquelle procuration, après avoir été signée Ne Varietur par le
comparant et le notaire soussigné, restera ci-annexée.
Lequel comparant, agissant en sa qualité dont question ci-avant, requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Que suite à une cession de parts datée du 28 janvier 2014, dûment acceptée par la société en conformité avec l’article
190 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, Euro Information International, est la seule et unique
associée de la société PRO Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1450 Lu-
xembourg, 17 Côte d’Eich, constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte du notaire Frank BADEN, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre 1990, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 155 de l’année 1991. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Jacques DELVAUX,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2010, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2664 du 4 décembre 2010.
Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire,
restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Qu'en tant qu'associée unique, elle déclare détenir le total des neuf cents (900) parts sociales, sans désignation de
valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de la Société s’élevant à un million trois cent cinquante-cinq
mille quatre cents euros (EUR 1.355.400,-).
Qu'en sa qualité de seul et unique associée de la Société, après avoir déclaré faire abstraction des règles formelles
pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocation, ordre du jour et reconnaissant être parfaite-
ment au courant des décisions à intervenir, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social du 17, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, au 55, rue des Scillas, à
L-2529 Howald, Commune de Hesperange.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Hesperange. Il peut être crée, par simple décision du
gérant, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.»
65921
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Didier HUARD, en sa qualité de gérant unique de la
société, et décide de lui donner décharge entière et définitive pour l’exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer en sa qualité de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Olivier Christian NOSETTI, administrateur de sociétés, né à Draguignan le 15 juillet 1973, demeurant pro-
fessionnellement au 55, rue des Scillas, à L-2529 Howald.
Il aura les pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. TASSIGNY, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 24 mars 2014. Relation: RED/2014/643. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 25 mars 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014044141/57.
(140050110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 106.277.
In the year two thousand and fourteen.
On the thirteenth day of March.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"SMITHS DETECTION INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.àr.l..", with registered office at 21, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 106 277, incorporated by deed of Joseph Elvinger, notary residing in
Luxembourg, on the 27
th
, January 2005, published in the Mémorial C number 652 of the 5
th
, July 2005, The meeting
is presided by Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de
Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholder present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an
attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting
can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads
as follows:
<i>Agenda:i>
1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. Appointment of SMITHS DETECTION GROUP LIMITED, as liquidator with the broadest power mentioned in the
articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
4. Miscellaneous.
65922
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to dissolve the company and to liquidate its assets.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint as liquidator of the company:
The company SMITHS DETECTION GROUP LIMITED, with register office at c/o Smiths Detection-Watford Limited,
459 Park Avenue, Bushey, Watford, Herts, UK, WD23 2BW. (Companies House of England and Wales Number
05138140)
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915, concerning commercial companies, without having to ask
for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
<i>Third resolutioni>
The meeting gives full discharge to the directors of the company for the performance of their mandate.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 950.-Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze.
Le treize mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée " SMITHS DETECTION INTERNATIONAL
LUXEMBOURG S.àr.l.", ayant son siège social au 21 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 106 277, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 27 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 652 du 5 juillet 2005, L'assemblée est présidée par Monsieur Bob
PLEIN, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son adresse professionnelle à
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster,
3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de SMITHS DETECTION GROUP LIMITED, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats.
4. Divers.
65923
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société SMITHS DETECTION GROUP LIMITED, ayant son siège social à c/o Smiths Detection-Watford Limited,
459 Park Avenue, Bushey, Watford, Herts, UK, WD23 2BW (Companies House of England and Wales Numéro
05138140)
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par
les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société pour l’exécution de leur mandat.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 950,- EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2014. Relation GRE/2014/1143. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044172/115.
(140050305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Aircraft Solutions Lux XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.587.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the tenth of March.
Before Us Me Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"ACO II Investment Holding Company (Offshore) LLC” a limited liability company formed and existing under the laws
of Anguilla, registered with the Registrar of Companies of Anguilla under number 3005386 and having its registered office
at in Anguilla, Mitchell House, P.O. Box 174, The Valley, B.W.I,
here represented by Ms Marilyn KRECKE, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy, given on March
7, 2014.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
65924
Art. 1. Denomination. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Aircraft
Solutions Lux XIX S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the investment through any means whatsoever, the acquisition, the
holding and the disposal of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other
business entities, as well as in aircrafts, airplanes or related assets, and by purchase, subscription, or in any other manner
as well as by the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates or deposits and
other securities or financial instruments of any kind, as well as aircrafts, airplanes and assets relating directly or indirectly
to the aviation sector and the ownership, administration, development and management of its assets.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or
origin whatsoever. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in
Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings
including without limitation for any margin and/ or short selling activities or otherwise as well as for the obligations of
any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies
to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for its own benefit or such
entities benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all
of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has
an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending or similar transaction. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to any of its investments for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and
instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager, or as the case may be, the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-)
divided into twenty thousand (20,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1.-) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of
these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its
shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
65925
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation).
In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class
A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication.
The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions,
including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual
signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated
by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in
the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
65926
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on December 31, 2014.
65927
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:
Subscriber
Number of shares Subscription price (USD)
ACO II Investment Holding Company (Offshore) LLC . . . . . 20,000 (twenty thousand) 20,000 (twenty thousand)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 (twenty thousand) 20,000 (twenty thousand)
Evidence of the payment of the total subscription price of an amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-)
has been shown to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company each with such signature powers as set forth in the articles:
- Ms Julie K. Braun, manager, born on 1
st
January 1958 in Minneapolis, U.S.A., with professional address at 4600 Wells
Fargo Center, 90 So 7
th
Street, Minneapolis, MN 55402, U.S.A., and
- Mr Pedro Fernandes das Neves, born on 15
th
October 1974 in Sao Domingos de Benfica Lisboa, Portugal, with a
professional address at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«ACO II Investment Hoding Company (Offshore) LLC.», une société à responsabilité limitée régie par la loi d'Anguilla,
immatriculée auprès du Registrar of Companies of Anguilla sous le numéro 3005386, et ayant son siège social à Anguilla,
Mitchell House, The Valley, B.W.I,
ici représentée par Madame Marilyn KRECKE, résidant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé en date du 7 mars 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Aircraft Solutions Lux XIX S.à r.l.'' (la "Société"). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l’investissement, sous quelque forme que ce soit, l’acquisition, la détention et
la disposition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou
dans d'autres entités ainsi que dans des aéronefs, des avions ou des valeurs y relatives et par l’achat, la souscription, ou
par tout autre moyen, de même que la cession par vente, l’échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats
de créance, notes, certificats ou dépôts et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toute sorte, de même
que des aéronefs, des avions et valeurs relatives directement ou indirectement au secteur de l’aviation, et la détention,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
65928
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété
intellectuelle de toute nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de
personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l’émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle
juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises
comprenant sans limitation pour toute activité de marge commerciale et/ou de vente à court terme ou autrement ainsi
que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du
groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter
ou créer autrement des garanties sur quelques uns ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles
la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou
entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opé-
ration qu'elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.
La Société peut entrer dans, exécuter et délivrer et effectuer tout swap, contrat à terme, opération à terme, dérivés,
options, rachats, prêts sur action ou transaction similaire. La Société peut généralement employer toute technique et
tout instrument en relation avec un quelconque de ses investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans
limitation des techniques et des instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit, de taux de change,
taux d'intérêt et tout autre risque.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
20.000,-) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD
1,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière
requise pour la modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en
vertu d'une décision de ses associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l’agrément donné par
au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec
65929
les autres. Une réunion peut également être tenue à tout moment sous forme de conférence téléphonique ou autre
moyen similaire. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à
une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de
gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation).
Dans le cas toutefois où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne pourront être valablement prises
que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe
B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la
signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature d'un des gérants, à condition toutefois que dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera
valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués
par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance ou un des gérants, ou, en cas
de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots "demande", "action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou pro-
cédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
"responsabilité" et "dépenses" devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants
payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l’accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l’égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l’encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour le compte du représentant
65930
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas
échéant) représentera l’intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l’intégralité du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré les
parts sociales suivantes:
65931
Souscipteur
Nombre de parts
sociales
Prix de souscription
(USD)
ACO II Investment Holding Company (Offshore) LLC . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 (vingt mille) 20.000 (vingt mille)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 (vingt mille) 20.000 (vingt mille)
Preuve du paiement du prix total de souscription d'un montant de vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
20.000,-) par apport en numéraire a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, évaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa
formation sont évalués à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société chacun avec pouvoir de signature comme prévu dans les statuts:
- Madame Julie K. Braun, manager, née le 1
er
janvier 1958 à Minneapolis, ETATS-UNIS, avec adresse professionnelle
au 4600 Wells Fargo Center, 90 So 7
th
Street, Minneapolis, MN 55402, ETATS-UNIS, et
- Monsieur Pedro Fernandes das Neves, né le 15 octobre 1974 à São Domingos de Benfica Lisboa, Portugal, avec
adresse professionnelle au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 mars 2014. LAC/2014/12707. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2014.
Référence de publication: 2014044322/440.
(140051223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 185.605.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen,
on the seventeenth day of the month of March.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,
there appeared:
“CS Real Estate SICAV-SIF I”, a public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company
with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d’investissement
spécialisé or SICAV-SIF) in accordance with the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment
funds, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Trade and Companies under company number R.C.S. B178.987, acting specifically for
its sub-fund Credit Suisse (Lux) European Property,
here represented by Me Alexander Wagner, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 12 March 2014.
65932
Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration.
Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "CSRE I European Property (Luxembourg)
Holding S.à r.l." a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by Luxembourg
Law (hereafter the "Company"), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board
of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Objectives. The company's object is
- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment
Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling
Real Estate held by it.
For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings),
property related long-term interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and
lease-hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and
property-related long term interests and other assets that are necessary to operate such property and property-related
long term interests. For the purpose of this clause, "Investment Company" means any company or other investment
vehicle whose object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate
and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more
investment vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles
with a similar object clause and/ or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment
vehicle is ultimately controlled by the company.
The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge
interest and/ or currency exchange risks.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Units.
Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by one hundred and twenty-five (125) units with no reference to nominal value.
Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there
is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.
Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted
per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely
transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
65933
Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of
the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company’s unit capital.
Chapter III. - Management.
Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers
need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The board of managers shall meet upon call by the chairman,
or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of unitholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or
another manager appointed by the Board of managers shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or
inability to act, the unitholders may appoint another manager, an officer of the Company or such other individual as they
may determine as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.
The board of managers from time to time may appoint the officers of the Company, including general managers, any
assistant general manager, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and
management of the Company, who need not be managers or unitholders of the Company. The officers appointed, unless
otherwise stipulated in these articles, shall have the powers and duties given to them by the board of managers. The
board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers
to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to such officers of the Company. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of managers.
Notice of any meeting of the Board of managers shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by
other electronic means of transmission to all manager at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting.
The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other
than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board not
referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex
or telefax or by other electronic means of transmission of each manager and shall be deemed to be waived by any manager
who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable or telegram, telex
or telefax another manager as his proxy. Any manager may attend a meeting of the board of managers using teleconference,
video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of board of
managers by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.
A meeting of the board of managers held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means
of communication, in which a quorum of managers participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Managers who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have
a casting vote.
Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and
held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as mentioned therein.
In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature
of a board member is affixed.
Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be
formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.
Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of managers.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.
65934
Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the
competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.
Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound by the joint signature of any two managers,
officers or of any other persons to whom authority has been delegated by the board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his
powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the manager. In the exercise of their mandate, the members of the board of managers are not to
be personally held liable for the indebtedness of the Company. As agent of the Company they are responsible for the
correct performance of their duties.
Chapter IV. - General meeting of unitholders
Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the
general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.
A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal
representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, e-mail as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit
capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.
Chapter V. - Financial year - Balance sheet.
Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of
each year.
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.
The operations of the Company, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or
other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur d’entrepri-
ses»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of unitholders for a period ending at the
date of the next annual general meeting of unitholders and until his successor is elected.
The independent auditor in office may be removed at any time by the unitholders in accordance with the provisions
of article 256 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies.
Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts,
after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company’s unit capital.
The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the
Company.
Chapter VI. - Dissolution - Liquidation.
Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
65935
Chapter VII. - Applicable law.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
st
December 2014.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
CS Real Estate SICAV-SIF I acting specifically for its sub-fund Credit Suisse (Lux) European Property . . . 125 Units
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Units
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now available to
the Company, as evidenced before the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, CS Real Estate SICAV-SIF, acting specifically for its sub-fund
Credit Suisse (Lux) European Property, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers
devolved to the general meeting of Unitholders, passed the following resolutions:
1) The number of Managers is three (3).
2) The following are appointed as Managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Rudolf Kömen, born on January 01, 1967 in Trier, Germany, having his professional address at 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg;
- Mr. Fernand Schaus, born on April 26, 1967 in Sandweiler, Luxembourg having his professional address at 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg;
- Mr. Frank Schäfer, born on September 06, 1973 in Heidelberg, Germany, having his professional address at Kalan-
derplatz 5, CH-8045 Zurich.
3) The Company shall have its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
4) “PricewaterhouseCoopers”, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (RCS Luxembourg, section B number 65477)
is appointed as independent auditor of the Company until the end of the next annual general meeting of unitholders which
will deliberate on the annual accounts of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with Us the notary the
present deed.
Follows the German translation of the preceding text:
Im Jahre zweitausendvierzehn,
am siebzehnten März.
Vor Uns dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Lu-
xemburg, in Vertretung von Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,
welch letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,
ist erschienen:
die „CS Real Estate SICAV-SIF I“, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in Form einer Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital (société d'investissement à capitale variable - fonds d'investissement spécialisé or SICAV-SIF) gemäß
dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 hinsichtlich spezieller Investmentfonds, mit Sitz in 5, rue Jean Monnet,
65936
L-2180 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer R.C.S. B 178.987, ausdrücklich
handelnd für ihren Teilfonds Credit Suisse (Lux) European Property,
hier vertreten durch Me Alexander Wagner, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 12. März 2014.
Dieselbe Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei und
den unterzeichneten Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der
Firma "CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l." (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem
Luxemburger Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell
gültigen Fassung (nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.
Art. 2. Sitz. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft
innerhalb des Gemeindegebietes des satzungsmäßig festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.
Der Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung gemäß dem für Satzungsänderun-
gen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder vor-
hersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende
Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschafts-
sitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen wird von der Geschäftsführung
getroffen.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.
Art. 3. Zweck. Das Ziel der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Investmentgesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen an Investmentgesellschaften, vorausgesetzt,
dass sie direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investmentgesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert
werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von ihr
gehaltener Immobilien.
Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäuden), langfristige
Immobilien-bezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-lease), Voll-
eigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold), Erwerbsoptionen
und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogene Lang-
zeitinteressen und andere Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und
grundstückbezogene Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel meint "Investmentge-
sellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, deren Ziel (gemäß ihrer Satzung oder anderen Gründungs-
unterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von
ihr gehaltener Immobilien, (direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit einer ähnlichen Ziel-
setzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikeln mit einer ähnlichen
Zielsetzung und/oder Gewährung von Finanzierungen an solche Investitionsvehikel ist, vorausgesetzt, dass das finanzierte
Investitionsvehikel letztendlich von der Gesellschaft kontrolliert wird.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele
zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt
in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile ohne Bezug zu einem Nennwert.
Art. 6. Kapitaländerungen. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilsinhabers (so-
weit es nur einen Anteilsinhaber gibt) oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 16 dieser
Satzung geändert werden.
Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der
Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.
65937
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar insofern nur ein
Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet eine einzige Person als ihren
Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 9. Übertragung der Anteile. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilinhaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei
auf Dritte übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehrere Anteilinhaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes
vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.
Jeder Anteilinhaber ist damit einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht ohne das vorherige Einverständnis der
Mehrheit der Anteilinhaber, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, zu verpfänden oder als Garantie
zu verwenden.
Kapitel III. Geschäftsführung
Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung, die aus mindestens drei Geschäftsführern besteht, verwaltet die
Gesellschaft. Die Geschäftsführer müssen nicht Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit durch einen
Beschluss der Anteilinhaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund abberufen werden.
Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer
gefasst.
Die Geschäftsführer wählen einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzenden sowie,
falls erforderlich, einen Sekretär, der nicht Geschäftsführer sein muss, und der die Protokolle der Geschäftsführersit-
zungen aufsetzt. Die Geschäftsführerversammlung wird vom Vorsitzenden bzw. von zwei Geschäftsführern eingeladen
und an dem in der Einladung angegebenen Ort abgehalten.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen der Gesellschafter vor. Für den Fall seiner Abwesenheit oder Handlungs-
unfähigkeit wird er vom Vize-Vorsitzenden oder einem anderen durch die Geschäftsführung bestimmten Geschäftsführer
als Vertreter auf Zeit vertreten. Für den Falle der Abwesenheit oder Handlungsfähigkeit auch dieser Personen können
die Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer, einen leitenden Angestellten oder eine sonstige Person zum Vorsit-
zenden auf Zeit durch Beschluss mit Mehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Gesellschaftsanteile wählen.
Die Geschäftsführung hat die Befugnis zur Anstellung von leitenden Angestellten, insbesondere Prokuristen, Assisten-
zen von Prokuristen, Sekretären, Assistenzsekretären oder anderen Angestellten, die als erforderlich für die Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft angesehen werden können, wobei diese Personen keine Geschäftsführer oder Gesellschafter
sein müssen. Die Angestellten haben, solange nichts anderes in dieser Satzung geregelt ist, die ihnen von der Geschäfts-
führung übertragene Handlungsbefugnis. Die Geschäftsführung kann die laufende Geschäftsführung sowie die Abwicklung
von Gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten im Einklang mit der Gesellschaftspolitik und dem Gesellschaftszweck an
diese Angestellten delegieren. Eine solche Delegation kann jederzeit von der Geschäftsführung widerrufen werden.
Die Einladung zu einer Versammlung der Geschäftsführung erfolgt schriftlich bzw. per Kabel, Telegramm, Telex, Fax
oder auf elektronischem Wege und soll mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt werden.
Die Einladung beinhaltet die Tagesordnung der Versammlung. Ein nicht in der Tagesordnung enthaltener Agenda-Punkt
kann nicht rechtsgültig in der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung zur Versammlung der Geschäftsführer
kann verzichtet werden mittels schriftlicher Einwilligung bzw. mittels einer Zustellung der Mitteilung per Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischer Mittel. Das Erfordernis der Einberufung gilt als verzichtet für alle in der
Versammlung anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Geschäftsführer. Für die Versammlungen, die gemäß einem
durch Beschluss der Geschäftsführer festgesetzten Zeitplan abgehalten werden, ist keine zusätzliche Einladung zur Ver-
sammlung erforderlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich in der Versammlung der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer ver-
treten lassen, in dem er schriftlich bzw. per Kabel, Telefax, Telegramm, Telex, einen anderen Geschäftsführer als seinen
Bevollmächtigten ernennt. Die Teilnahme der Geschäftsführer an der Geschäftsführungssitzung kann per Telefon, Video-
Konferenzschaltung oder anderen ähnlichen Kommunikationsmittel, die es allen an der Geschäftsführungssitzung teil-
nehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig zu hören, erfolgen. Ein Geschäftsführer, der durch die Kommunikations-
mittel an einer Geschäftsführungssitzung teilnimmt, gilt als persönlich Anwesender dieser Sitzung.
Eine Versammlung der Geschäftsführer per Telefon oder Video-Konferenzschaltung oder jeder anderen Art von Au-
dio- oder Videokommunikation, an der ein Quorum von Geschäftsführern teilnimmt, ist genauso bindend als ob alle
Geschäftsführer persönlich anwesend gewesen wären, vorausgesetzt, ein Protokoll wurde erstellt und vom Vorsitzenden
der Geschäftsführungssitzung unterzeichnet.
Die Geschäftsführung kann rechtsgültig Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Geschäftsführer gefasst,
welche bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Nicht persönlich anwesende oder nicht vertretene Geschäftsführer
können schriftlich bzw. durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder durch Einsatz anderer elektronischer Mittel an der
Abstimmung teilnehmen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
65938
Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, sind genauso rechtswirksam und bindend, als
ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Die Unterschrift der Geschäftsführer kann auf
einer einzelnen Ausfertigung bzw. auf mehreren Ausfertigungen eines jeden Beschlusses vermerkt sein, und auch per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des im Umlaufbeschluss vermerkten
Datums. Sollte dort kein spezielles Datum vermerkt sein, wird der Umlaufbeschluss gültig an dem Tag, an dem die letzte
Unterschrift getätigt wird.
Beschlüsse, die durch elektronische Mittel wie z.B. per E-Mail, ein Telegramm oder ein Telex gefasst werden, müssen
anschließend durch einen Zirkularbeschluss formalisiert werden. Das Inkrafttreten des Zirkularbeschlusses erfolgt am
Tage der letzten Zustimmungserklärung, welche die Gesellschaft in elektronischer Form erhielt. Die Zustimmungen von
allen Mitgliedern der Geschäftsführung werden dem Umlaufbeschluss beigefügt und bilden dabei einen integralen Be-
standteil derselben, wobei der Umlaufbeschluss die zuvor in elektronischer Form gefassten Beschlüsse bestätigt.
Umlaufbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer gefasst werden.
Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung müssen durch den Vorsitzenden der Sitzung unterzeichnet werden.
Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, welche für die Zwecke von juristischen Verfahren oder andersweitig erstellt
werden, sind vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder seinem zeitweisen Vertreter in dieser Sitzung oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.
Art. 11. Befugnisse der Geschäftsführer. Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die Befugnis unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen, die dem Geschäftszweck der
Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt, dass die Bestimmungen dieses Artikels beachtet
wurden.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere
Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakleroder Grundstücksverwaltungsver-
träge abschließen.
Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer
oder anderer Personen, welche hierzu von der Geschäftsführung wirksam bevollmächtigt wurden, rechtsgültig verpflich-
tet.
Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für
bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.
Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und (gegebenenfalls) Entlohnung, die Dauer der Vertretung und alle
anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.
Art. 14. Entlohnung der Geschäftsführer. Die Befugnisse und die Entlohnung eines möglicherweise zu einem späteren
Zeitpunkt zusätzlich oder zu Ersatzzwecken ernannten Geschäftsführern werden im jeweiligen Ernennungsschreiben
festgelegt.
Art. 15. Haftung der Geschäftsführer. In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar
für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte
Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Der alleinige Anteilinhaber übernimmt alle der Gesellschafterver-
sammlung zuerkannten Befugnisse.
Falls es mehrere Anteilinhaber geben sollte, kann jeder Anteilinhaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen,
unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilinhaber verfügt über Stimmrechte, entsprechend der ihm
gehörenden Anteile.
Ein Anteilinhaber kann in jeder Gesellschafterversammlung handeln, indem er eine andere Person, die selbst nicht
Anteilinhaber sein muss (oder wenn der Anteilinhaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter),
schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-Mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.
Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilinhabern die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer
Mehrheit der Anteilinhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften gefasst werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird
ein Inventar, einschließlich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.
65939
Jeder Anteilinhaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und
die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen.
Die Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich insbesondere ihrer Bücher und Steuerangelegenheiten oder anderer
Berichte, welche nach Luxemburger Gesetz erforderlich sind, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschafts-
prüfer («réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis
zur nächsten jährlichen Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.
Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 256 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften abberufen werden.
Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen. Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz
aufgeführt ergibt nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art den Reingewinn. Vom
Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn
Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilinhaber im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen
in der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
Kapitel VI. Auflösung - Liquidation
Art. 19. Auflösungsgründe. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Außerkraftsetzung der
Bürgerrechte, bei Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des alleinigen Anteilinhabers oder von einem der Anteilinhaber.
Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere durch die
Anteilinhaber ernannten Liquidatoren durchgeführt, die nicht unbedingt selbst Anteilinhaber sein müssen; die Anteilin-
haber legen die Aufgaben und Vergütung der Liquidatoren fest.
Ein alleiniger Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen,
wobei er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesell-
schaft bekannt oder unbekannt sind.
Kapitel VII. Geltendes Recht
Art. 21. Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten für alle weiteren Angelegenheiten die Bestimmungen des Ge-
setzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:
Anteile:
CS Real Estate SICAV-SIF I ausdrücklich handelnd für ihren Teilfonds Credit Suisse (Lux) European
Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Diese Anteile wurden voll in bar einbezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
entsprechend einem Anteilkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) nunmehr der Gesellschaft zur Ver-
fügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Geschätzte Kosteni>
Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-
dung zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst CS Real Estate SICAV-SIF I, ausdrücklich handelnd für ihren Teil-
fonds Credit Suisse (Lux) European Property, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die
Befugnisse der Versammlung der Anteilsinhaber ausübt, folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen unbegrenzten Zeitraum ernannt:
- Herr Rudolf Kömen, geboren am 01. Januar 1967 in Trier, Deutschland, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg;
- Herr Fernand Schaus, geboren am 26. April 1967 in Sandweiler, Luxemburg, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxemburg;
- Herr Frank Schäfer, geboren am 06. September 1973 in Heidelberg, Deutschland, mit Geschäftsanschrift Kalander-
platz 5, CH-8045 Zurich.
65940
3) Zum Gesellschaftssitz wird 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.
4) Zum Wirtschaftsprüfer wird „PricewaterhouseCoopers“, 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg (RCS. Luxemburg,
Sektion B Nummer 65477) bis zum Ende der nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt, die über den Jahresab-
schluss der Gesellschaft befindet.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch
der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version beigefügt
ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text
die englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum
aufgesetzt wurde.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer
mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. WAGNER, M. SCHAEFFER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 20. März 2014. Relation: EAC/2014/3974. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2014044462/473.
(140051607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
C Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 163.053.
In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of March,
Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of C Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private
limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 42-44, Avenue de la Gare,
L-1610 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, and registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 163.053 (the “Com-
pany”).
There appeared:
- Cipriani Acquisition LLC, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of New
York, United States of America, having its registered office at 110, East 42
nd
Street, 10017 New York, United States of
America and registered with the Department of State Division of Corporation and state Records under number
12231-0001 (“Cipriani”);
- Jacaranda Investissements S.A., a société anonyme (public limited liability company) duly incorporated and validly
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
(Register of Trade and Companies) under number B 108.876 (“Jacaranda”); and
- Terryglas S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 49, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, and registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 162.790 (“Terryglas” and
together with Cipriani and Jacaranda the “Shareholders”),
all three here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of three (3) powers of attorney, delivered to him.
The said powers of attorney, signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The 12,500 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been duly informed.
The Shareholders through their proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the
following:
65941
<i>Agendai>
1. Creation of three classes of shares;
2. Allocation of the existing shares among new classes of shares;
3. Amendment of the articles 6 and 10 of the articles of association of the Company to specify the conditions for the
transfer of shares; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to create three classes of shares, namely classes A to C that will entitle their holders to the rights
described under resolution 3 below.
<i>Second resolutioni>
It is resolved that the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company be allocated among the
new classes of shares A to C included as follows:
- 3,648 (three thousand six hundred and forty-eight) shares in class A, corresponding to the shares held by Cipriani.
- 6,977 (six thousand nine hundred and seventy-seven) shares in class B, corresponding to the shares held by Jacaranda;
and
- 1,875 (one thousand eight hundred and seventy-five) shares in class C, corresponding to the shares held by Terryglas;
<i>Third resolutioni>
It is resolved to amend articles 6 and 10 of the articles of association of the Company in order to set the conditions
to be fulfilled by the Company for the transfer of a whole class of shares and to set the rights to be attached to the shares:
“ Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euro)
divided into:
- 3,648 (three thousand six hundred and forty-eight) class A (the “Class A Shares”);
- 6,977 (six thousand nine hundred and seventy-seven) class B (the “Class B Shares”); and
- 1,875 (one thousand eight hundred and seventy-five) class C (the “Class C Shares”);
(the shares composing the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares, hereafter collectively referred
to as the “Shares” and individually as a “Share”).
All the Shares have a nominal value of EUR 1 each, are fully paid-up and such rights and obligations as set out in the
present Articles of Association.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. For purposes of these Articles:
Affiliate means in relation to any person, a Subsidiary of that person or a Holding Company of that person or any other
Subsidiary of that Holding Company.
Beneficial Owner 1 means the ultimate beneficial owners or beneficiaries of the Class A Shares or the Class B Shares
or their respective family members.
Beneficial Owner 2 means the ultimate beneficial owners or beneficiaries of the Class C Shares or their respective
family members.
Business Day means any calendar day other than Saturdays, Sundays and any other day on which banks are not opened
for regular business in Milan and Luxembourg.
Capital Contribution Amount means a contribution into an available reserve of the Company by the Class C Share-
holder in an amount equal to USD 15,000,000 plus any interest which may be agreed upon between the Class C
Shareholder and the Class B Shareholder from time to time.
Class A Shareholder means the holder of the Class A Shares.
Class B Shareholder means the holder of the Class B Shares.
Class C Shareholder means the holder of the Class C Shares.
Control or Controlled means either the direct or indirect right of ownership of at least 51 per cent. of the issued
share capital of an entity or the direct or indirect right to direct the business and/or policies (including dividend policies)
65942
and/or affairs of an entity whether by law, contract, arrangement, governmental decree or regulation, ownership of voting
power, appointment of directors (or management) or otherwise.
Group 1 Entity means any entity which is directly or indirectly Controlled by, or whose ultimate beneficial owners or
beneficiaries is the Beneficial Owner 1.
Group 2 Entity means any entity which is directly or indirectly Controlled by, or whose ultimate beneficial owners or
beneficiaries is the Beneficial Owner 2.
Group 1 Shareholders means collectively the Class A Shareholder and Class B Shareholder and includes any of their
respective assigns or transferees, individually a Group 1 Shareholder.
Holding Company means in relation to a person, any other person in respect of which it is a Subsidiary.
Subsidiary means (a) an entity of which a person has direct or indirect control or owns directly or indirectly more
than 50 per cent. of the voting capital or similar right of ownership and control for this purpose means the power to
direct the management and the policies of the entity whether through the ownership of voting capital, by contract, or
otherwise, or (b) an entity treated as a subsidiary in the financial statements of any person pursuant to the applicable
accounting principles.
Transfer means any transaction that has as its purpose the transfer of any interest in any of the Company shares, with
or without consideration, including but not limited to (i) any contributions to capital, swaps or exchanges, mergers,
demergers, liquidations; (ii) any transfers, sales or assignments of beneficial interest, usufruct, bare ownership (i.e. ow-
nership without beneficial interest) or full title by any legal means; (iii) any transfer or waiver of any rights to be allocated
to the shares pursuant to an increase of capital by way of capitalization of reserves or profits, any transfer or waiver of
preferential subscription rights pursuant to an increase of capital by way of contribution in cash or individual renouncement
to such preferential subscription rights in favour of identified persons and all other forms of transfers.
10.2. Permitted transfers.
a) a Group 1 Entity shall be permitted to freely Transfer its Company shares to another Group 1 Entity or any third
party (subject to the provisions of article 10.3 below); and
b) the Class C Shareholder shall be permitted to freely Transfer its Company shares to:
(i) any of its Affiliates or a Group 2 Entity and any such transferee shall have the benefit of all the rights of the Class
C Shareholder under these Articles; and/or
(ii) any third party, provided that any such Transfer is made after the date on which the Capital Contribution Amount
is paid in full by the Class C Shareholder, and provided further that if the entity to whom the Company shares held by
the Class C Shareholder are transferred is not or ceases to be (as relevant) an entity Controlled by the Class C Share-
holder or a Group 2 Entity, any such entity shall not have or shall lose (as relevant) the rights under article 12 paragraphs
2 and 3 of these Articles, and such right shall instead automatically vest in Class B Shareholder.
10.3. Tag along right of the Class C Shareholder.
(a) The provisions of this article 10.3 shall not apply to any Transfers which are permitted under the terms of article
10.2 of these Articles. If a Group 1 Shareholder (the "Relevant Group 1 Shareholder") intends to Transfer any of its
Company shares to one or more third parties (the "Purchasing Third Party"), the Relevant Group 1 Shareholder shall
notify its intention in writing (the "Transfer Notice") to Class C Shareholder with copy of the notice to the board of
managers.
(b) The Transfer Notice shall specify:
(i) the number of Company shares being transferred (the "Specified Shares") and the percentage that the Specified
Shares represent as a proportion of the total number of Company shares held by the Group 1 Shareholders (the "Specified
Proportion");
(ii) the personal details of the Purchasing Third Party and sufficient background information on the Purchasing Third
Party, including without limitation relating to its professional/trading history and financial covenant strength, to enable
the Class C Shareholder to satisfy itself that the Purchasing Third Party is an independent and good faith potential subject;
(iii) the price per Company share and all the other material terms and conditions of the Transfer; and
(iv) the term (not exceeding three months) within which such Group 1 Shareholder intends to proceed with the
Transfer of the Specified Shares, it being understood that if the Transfer does not take place within the expiry of the term
specified by the Relevant Group 1 Shareholder in the Transfer Notice, then the Relevant Group 1 Shareholder may not
proceed to the Transfer of the Specified Shares without complying once more with the provisions of this article 10.3.
(c) If the Relevant Group 1 Shareholder issues the Transfer Notice and, as a result of the Transfer of the Specified
Shares, the interest jointly held by the Group 1 Shareholders would fall below 50 per cent of the then issued Company
shares, the Class C Shareholder will be entitled (through the issue of an Exercise Notice as described in article 10.3(f))
to exercise the right to sell to the Purchasing Third Party. If a valid Exercise Notice is issued by the Class C Shareholder,
the Relevant Group 1 Shareholder shall ensure that the Purchasing Third Party also purchases all (100 per cent) of the
Company shares owned by the Class C Shareholder (and shall not otherwise sell the Specified Shares to the Purchasing
Third Party).
65943
(d) If the Relevant Group 1 Shareholder issues the Transfer Notice and, as a result of the Transfer of the Specified
Shares, the shareholding of the Group 1 Shareholders would not fall below 50 per cent of the then issued Company
shares, the Class C Shareholder will be entitled (through the issue of an Exercise Notice as described in article 10.3(f))
to exercise the right to sell to the Purchasing Third Party. If a valid Exercise Notice is issued by the Class C Shareholder,
the Relevant Group 1 Shareholder shall ensure that the Purchasing Third Party also purchases a percentage of Company
shares owned by the Class C Shareholder equal to the Specified Proportion (and shall not otherwise sell the Specified
Shares to the Purchasing Third Party), rounded up to the nearest whole share. The rights of the Class C Shareholder
under articles 10.3(c) and (d) shall be referred to in these Articles as the "Tag Along Right".
(e) If the Tag Along Right is exercised, the Transfer of the relevant Company shares owned by the Class C Shareholder
shall be effected in accordance with article 10.3(h), it being understood that, in no case the Class C Shareholder will grant
any representations or warranties (other than customary representations and warranties on title to its Company shares)
or will undertake indemnification obligations to the Purchasing Third Party irrespective of whether the Relevant Group
1 Shareholder granted any such representations or warranties to the Purchasing Third Party or undertook any indem-
nification obligations towards the same.
(f) The Class C Shareholder shall be entitled to exercise the Tag Along Right by notifying the Relevant Group 1
Shareholder in writing with a copy of the notice to the board of managers (the "Exercise Notice"), within fifteen (15)
Business Days from the date of receipt of the Transfer Notice.
(g) If the Relevant Group 1 Shareholder transfers to a single third party or such third party's Affiliates any Specified
Shares and the Class C Shareholder exercises its Tag Along Right, the transfer of all Company shares held by the Class
C Shareholder shall occur at the highest price per share paid in the various deeds of transfer (so that if a lower price has
already been paid, in whole or in part, to the Class C Shareholder, it shall be entitled to such additional amount as would
be required to comply with the statements in this sub-article).
(h) If the Class C Shareholder exercises the Tag Along Right, the execution of the sale of the Company shares held
by the Class C Shareholder shall take place concurrently and in the same location as the execution of the transfer to the
Purchasing Third Party of the last Specified Shares.
10.4. Other limits to Transfer.
10.4.1. Notwithstanding anything to the contrary in these Articles, no Transfer of Company shares shall be made other
than for cash consideration.
10.4.2. Any share Transfer must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the
Company or third parties unless they have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the
provisions of article 1690 of the Luxembourg civil code.
10.4.3. Notwithstanding anything to the contrary in these Articles, Transfers of shares inter vivos to non shareholders
may only be made with the prior approval given in general meeting of shareholders deciding at the quorum and voting
requirements set forth in the Law.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 900.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le douzième jour de mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société C Management S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.053 (la «Société»).
Ont comparu:
- Cipriani Acquisition LLC, une société dûment constituée et existant valablement en vertu des lois de l’Etat de New
York, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social à 110, East 42
nd
Street, 10017 New York, Etats-Unis d’Amérique et
65944
immatriculée auprès du «Department of State Division of Corporation and state Records» sous le numéro 12231-0001
(«Cipriani»);
- Jacaranda Investissements S.A., une société anonyme dûment constituée et existant valablement en vertu des lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.876
(«Jacaranda»); et
- Terryglas S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement en vertu des lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 49, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 162.790 («Terryglas» et ensemble avec Cipriani et Jacaranda, les «Associés»),
tous trois ici représentées par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur», resteront annexées au présent acte pour être enregistrées
avec ce dernier.
Les 12.500 parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les Associés, ont été préalablement
informés.
Les Associés représentés par leur mandataire prient le notaire d’acter que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Création de trois classes de parts sociales;
2. Allocation des parts sociales existantes aux nouvelles classes de parts sociales;
3. Modification des articles 6 et 10 des statuts de la Société pour spécifier les conditions de la cession des parts sociales;
et
4. Divers.
Après que l’agenda a été approuvé par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de créer trois classes de parts sociales, à savoir les classes A à C, qui donneront droits à leurs détenteurs
aux droits tels que décrit à la résolution 3 ci-dessous.
<i>Seconde résolutioni>
Il est décidé que les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales existantes de la Société soient allouées parmi les
nouvelles classes de parts sociales A à C incluse comme suit:
- 3.648 (trois mille six cent quarante-huit) parts sociales dans la classe A, correspondantes aux parts sociales détenues
par Cipriani;
- 6.977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales dans la classe B, correspondantes aux parts sociales dé-
tenues par Jacaranda; et
- 1.875 (mille huit cent soixante-quinze) parts sociales dans la classe C, correspondantes aux parts sociales détenues
par Terryglas.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de modifier les articles 6 et 10 des statuts de la Société en vue d'établir les conditions devant être remplies
par la Société pour le transfert de l’entièreté d'une classe de parts sociales et d’établir les droits attachés aux parts sociales:
« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) divisé en:
- 3.648 (trois mille six cent quarante-huit) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);
- 6,977 (six mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»); et
- 1.875 (mille huit cent soixante-quinze) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);
(les parts sociales composant les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B et les Parts Sociales de
Classe C sont ci-après désignées collectivement comme les “Parts Sociales” ou individuellement, la “Part Sociale”).
Toutes les Parts Sociales ont une valeur nominale de 1 USD (un US Dollar) chacune, sont entièrement libérées et avec
les droits et obligations prévus dans les présents statuts.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
65945
Art. 10. Cession des Parts Sociales.
10.1. Aux fins de ces Statuts:
Société Affiliée signifie, par rapport à toute personne, une Filiale de cette personne ou une Société Holding de cette
personne ou toute autre Filiale de cette Société Holding.
Bénéficiaire Economique 1 signifie le bénéficiaire économique ou les bénéficiaires des Parts Sociales de Classes A ou
des Parts Sociales de Classes B ou les membres de leurs familles respectives.
Bénéficiaire Economique 2 signifie le bénéficiaire économique ou les bénéficiaires des Parts Sociales de Classes C ou
les membres de leurs familles respectives.
Jour Ouvré signifie tout jour calendrier autre qu'un samedi, un dimanche ou tout autre jour lors duquel les banques
ne sont normalement pas ouvertes à Milan et à Luxembourg.
Montant de l’Apport en Capital signifie un apport à une réserve disponible de la Société par l’Associé de Classe C,
d'un montant égal à 15.000.000 USD plus tout intérêt qui pourrait être convenu entre l’Associé de Classe C et l’Associé
de Classe B de temps à autre
Associé de Classe A signifie le détenteur des Parts Sociales de Classe A.
Associé de Classe B signifie le détenteur des Parts Sociales de Classe B.
Associé de Classe C signifie le détenteur des Parts Sociales de Classe C.
Contrôle ou Contrôlé(e) signifie soit le droit direct ou indirect de propriété d'au moins 51 pourcent du capital social
émis d'une entité ou le droit direct ou indirect de diriger les affaires et/ou les politiques (en ce compris les politiques de
dividendes) et/ou les activités d'une entité, que ce soit en vertu de la loi, d'un contrat, d'un accord, d'un arrêté ou
règlement gouvernemental, de la propriété d'un droit de vote, de la nomination d'administrateurs (ou de la direction) ou
autrement.
Entité de Groupe 1 signifie toute entité qui est directement ou indirectement contrôlée par, ou dont le bénéficiaire
économique ultime ou les bénéficiaires est le Bénéficiaire Economique 1.
Entité de Groupe 2 signifie toute entité qui est directement ou indirectement contrôlée par, ou dont le bénéficiaire
économique ultime ou les bénéficiaires est le Bénéficiaire Economique 2.
Associés de Groupe 1 signifie collectivement l’Associé de Classe A et l’Associé de Classe B et comprend tous leurs
ayants droit ou cessionnaires respectifs, individuellement un Associé de Groupe 1.
Société Holding signifie par rapport à une personne, toute autre personne par rapport à laquelle elle est une Filiale.
Filiale signifie (a) une entité sur laquelle une personne a un contrôle ou détient directement-ou indirectement plus de
50 pourcent du capital donnant droit de vote ou un droit de propriété similaire et le contrôle signifie à cette fin le pouvoir
de diriger la gestion et les politiques de l’entité, que ce soit par la propriété du capital donnant droit de vote, par contrat,
ou autrement, ou (b) une entité traitée comme une filiale dans les états financiers de toute personne en vertu des principes
comptables applicables.
Céder ou Cession signifient toute transaction qui a pour but le transfert de tout intérêt dans quelque part sociale de
la Société que ce soit, avec ou sans contrepartie, en ce compris mais sans limitation (i) tous apports au capital, contrats
d'échange (swap) ou échanges, fusions, scissions, liquidations; (ii) toutes cessions, ventes ou transferts d'un intérêt bé-
néficiaire, d'un usufruit, de la nue-propriété (c'est-à-dire la propriété sans l’usufruit) ou du titre entier, de quelque manière
légale que ce soit; (iii) toute cession ou renonciation à tout droit de se voir allouer des parts sociales en vertu d’une
augmentation de capital par voie de capitalisation des réserves ou bénéfices, tout transfert ou toute renonciation à un
droit de souscription préférentielle conformément à une augmentation de capital par voie d'un apport en espèces ou
toute renonciation individuelle à de tels droits de souscription préférentielle en faveur de personnes identifiées et toutes
autres formes de cession.
10.2. Cessions autorisées.
a) une Entité de Groupe 1 sera autorisée à Céder librement ses parts sociales de la Société à une autre Entité de
Groupe 1 ou à tout tiers (sous réserve des dispositions de l’article 10.3 ci-dessous); et
b) L’Associé de Classe C sera autorisé à Céder librement ses parts sociales de la Société à:
(i) 'importe laquelle de ses Sociétés Affiliées ou à une Entité de Groupe 2 et un tel cessionnaire bénéficiera de tous
les droits de l’Associé de Classe C en vertu de ces Statuts; et/ou
(ii) out tiers, attendu que quelque Cession que ce soit est effectuée après la date à laquelle le Montant de l’Apport en
Capital est entièrement payé par l’Associé de Classe C, et attendu qu'en outre si l’entité à laquelle les parts sociales de
la Société détenues par l’Associé de Classe C sont transférées n'est pas ou cesse d'être une entité Contrôlée par l’Associé
de Classe C ou par une Entité de Groupe 2, une telle entité n'aura pas ou perdra (le cas échéant) les droits en vertu de
l’article 12 paragraphes 2 et 3 de ces Statuts, et tout droit sera, à la place, automatiquement conféré à l’Associé de Classe
B.
10.3. Droit de sortie conjointe de l’Associé de Classe C.
(a) Les dispositions de cet article 10.3 ne s'appliqueront pas aux Cessions qui sont autorisées selon les termes de
l’article 10.2 des présents Statuts. Si un Associé de Groupe 1 (l’«Associé de Groupe 1 Concerné») envisage de Céder
quelque part sociale de la Société que ce soit à un ou plusieurs tiers (Ie «Tiers Acquéreur»), l’Associé de Groupe 1
65946
Concerné notifiera son intention par écrit (l’«Avis de Cession») à l’Associé de Classe C avec une copie de l’avis adressé
au conseil de gérance.
(b) L’avis de Cession spécifiera:
(i) le nombre de parts sociales à transférer (les «Parts Sociales Concernées») et le pourcentage que les Parts Sociales
Concernées représentent proportionnellement au nombre total de parts sociales de la Société détenues par les Associés
de Groupe 1 (la «Proportion Précisée»);
(ii) les détails personnels du Tiers Acquéreur et des informations de référence suffisantes concernant le Tiers Acqué-
reur, en ce compris et sans limitation en relation avec son parcours professionnel/commercial et sa solidité financière,
afin de permettre à l’Associé de Classe C de s'assurer que le Tiers Acquéreur est un sujet potentiellement indépendant
et de bonne foi;
(iii) le prix par part sociale de la Société et tous autres termes et conditions essentiels de la Cession; et
(iv) le délai (n'excédant pas trois mois) endéans lequel l’Associé de Groupe 1 entend procéder à la Cession des Parts
Sociales Concernées, étant entendu toutefois que si la Cession n'a pas lieu endéans l’expiration du délai précisé par
l’Associé de Groupe 1 Concerné dans l’Avis de Cession, l’Associé de Groupe 1 Concerné ne peut pas procéder à la
Cession des Parts Sociales Concernées sans respecter à nouveau les dispositions de cet article 10.3.
(c) Si l’Associé de Groupe 1 Concerné émet l’Avis de Cession et que, suite à la Cession des Parts Sociales Concernées,
les intérêts détenus conjointement par les Associés de Groupe 1 tombent en dessous de 50 pourcent des parts sociales
de la Société alors émises, l’Associé de Classe C pourra (par l’émission d'un Avis d'Exercice tel que décrit à l’article 10.3
(f) exercer son droit de vendre au Tiers Acquéreur. Si un Avis d'Exercice valable est émis par l’Associé de Classe C,
l’Associé de Groupe 1 Concerné s'assurera que le Tiers Acquéreur acquière également la totalité (100 pourcent) des
parts sociales de la Société détenues par l’Associé de Classe C (et ne procédera pas autrement à la vente des Parts Sociales
Concernées au Tiers Acquéreur).
(d) Si l’Associé de Groupe 1 Concerné émet l’Avis de Cession et que, suite à la Cession des Parts Sociales Concernées,
les intérêts détenus conjointement par les Associés de Groupe 1 ne tombent pas en dessous de 50 pourcent des parts
sociales de la Société alors émises, l’Associé de Classe C pourra (à travers l’émission d'un Avis d'Exercice tel que décrit
à l’article 10.3(f) exercer son droit de vendre au Tiers Acquéreur. Si un Avis d'Exercice valable est émis par l’Associé de
Classe C, l’Associé de Groupe 1 Concerné s'assurera que le Tiers Acquéreur acquière également un pourcentage des
parts sociales de la Société détenues par l’Associé de Classe C égal à la Proportion Précisée (et ne procédera pas autre-
ment à la vente des Parts Sociales Concernées au Tiers Acquéreur), arrondi à l’unité supérieure de la part sociale entière
la plus proche. Les droits de l’Associé de Classe C sous l’article 10.3(c) et (d) sont mentionnés dans les présents Statuts
comme étant le «Droit de Sortie Conjointe».
(e) Si le Droit de Sortie Conjointe est exercé, la Cession des parts sociales de la Société concernées détenues par
l’Associé de Classe C sera effectuée conformément à l’article 10.3(h), étant entendu qu'en aucun cas l’Associé de Classe
C ne donnera de représentations et garanties (autres que les représentations et garanties habituelles par rapport au titre
sur ses parts sociales de la Société) ou ne s'engagera à des obligations d'indemnisation envers le Tiers Acquéreur, indé-
pendamment du fait que l’Associé de Groupe 1 Concerné ait donné des représentations ou garanties au Tiers Acquéreur
ou se soit engagé à des obligations d'indemnisation envers celui-ci.
(f) L’Associé de Classe C pourra exercer le Droit de Sortie Conjointe en notifiant par écrit à l’Associé de Groupe 1
Concerné une copie de l’avis adressé au conseil de gérance (I'«Avis d'Exercice»), endéans quinze (15) Jours Ouvrés à
partir de la date de réception de l’Avis de Cession.
(g) Si l’Associé de Groupe 1 Concerné cède une ou plusieurs Parts Sociales
Concernées à un seul tiers ou aux Sociétés Affiliées à ce tiers et l’ Associé de Classe C exerce son Droit de Sortie
Conjointe, la cession de toutes les parts sociales de la Société détenues par l’Associé de Classe C se produira au prix par
part sociale le plus élevé payé dans les divers actes de cession (de telle sorte que si le prix le plus bas a déjà été payé, en
tout ou en partie, à l’Associé de Classe C, ce dernier aura droit au montant complémentaire qui pourrait être requis
pour respecter les dispositions de ce sous-article).
(h) Si l’Associé de Classe C exerce son Droit de Sortie Conjointe, l’exécution de la vente des parts sociales de la
Société détenues par l’Associé de Classe C aura lieu concomitamment à et au même endroit que l’exécution de la cession
des dernières Parts Sociales Concernées au Tiers Acquéreur.
10.4. Autres restrictions de Cession.
10.4.1. Nonobstant toute énonciation contraire dans les présents Statuts, aucune Cession de parts sociales de la Société
ne sera effectuée autrement que contre une contrepartie en espèces.
10.4.2. Toute Cession de parts sociales doit être attestée dans un acte notarié ou sous seing privé. Les Cessions ne
seront pas valables vis-à-vis de la Société ou des tiers sauf si elles ont été notifiées à la Société ou acceptées par elle
conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil luxembourgeois.
10.4.3. Nonobstant toute énonciation contraire dans les présents Statuts, les Cessions de parts sociales entre vifs à
des non-associés peuvent uniquement être effectuées avec l’accord préalable donné par l’assemblée générale des associés
décidant selon les quorums de présence et de majorité énoncés dans la Loi».
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
65947
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou
qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 900,- EUR
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande des comparantes repré-
sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2014. Relation GRE/2014/1086. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME
Junglinster, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044407/388.
(140050611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Prime Oil Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 57.961.
L'an deux mille quatorze, le douze mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “PRIME OIL FINANCE S.A.”, ayant son
siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 57.961, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul FRIEDERS, alors de résidence à Lu-
xembourg, en date du 22 janvier 1997, publié au Mémorial C, numéro 243 du 20 mai 1997 et dont les statuts ont été
modifiés suivant:
- procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 28 juin 2002,
contenant conversion du capital social en euros, publié au Mémorial C, numéro 1429 du 3 octobre 2002
- actes reçus par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage en date du:
(i) 13 mars 2007, publié au Mémorial C, numéro 1032 du 1
er
juin 2007 et
(ii) 21 octobre 2008, publié au Mémorial C, numéro 2798 du 20 novembre 2008
mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 29 novembre 2013, publié au Mémorial C, numéro 196 du 22 janvier 2014,
ayant un capital de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76- EUR), repré-
senté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel FONDU, expert-comptable, demeurant professionnel-
lement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutatrice, Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnelle-
ment à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société de L-4740 Pétange, 5 rue Prince Jean à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas et
modification corrélative du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Hesperange. Il pourra être transféré dans tout
autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d’Administration.»
65948
Le reste de l’article demeure inchangé.
2. Acceptation des démissions du liquidateur et commissaire-vérificateur de la Société nommés lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de mise en liquidation de la Société tenue par-devant Maître Alex WEBER en date du 29 no-
vembre 2013;
3. Nomination de Monsieur Frank Heite, en qualité de nouveau liquidateur de la Société, avec les pouvoirs les plus
étendus prévus par la loi, et notamment par les articles 144 à 148 bis la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales avec la faculté d’accomplir les actes prévus à l’article 145 de ladite loi, sans devoir recourir à l’autorisation
de l’assemblée générale dans les cas où celle-ci est normalement requise;
4. Nomination de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, établie et ayant son siège social à L-2529 Howald,
37 rue des Scillas, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29501, en
qualité de nouveau commissaire-vérificateur de la liquidation de la Société, conformément aux dispositions de l’article
151 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, et de modifier en conséquence
le premier alinéa de l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (1
er
alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Hesperange. Il pourra être transféré dans tout
autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d’Administration.»
Le reste de l’article demeure inchangé.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte les démissions du liquidateur et commissaire-vérificateur de la Société nommés lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire de mise en liquidation de la Société tenue par-devant Maître Alex WEBER en date du 29
novembre 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée nomme Monsieur Frank HEITE, administrateur de sociétés, né à Ieper (Belgique) le 31 octobre 1971,
demeurant à B-8900 Ieper, Diksmuidseweg 25 B, Belgique, à la fonction de nouveau liquidateur de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus prévus par la loi, et notamment par les articles 144 à 148 bis la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales avec la faculté d’accomplir les actes prévus à l’article 145 de ladite loi, sans devoir recourir
à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où celle-ci est normalement requise.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée nomme la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, établie et ayant son siège social à L-2529 Howald,
37 rue des Scillas, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29501, en
qualité de nouveau commissaire-vérificateur de la liquidation de la Société, conformément aux dispositions de l’article
151 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à huit cent cinquante euros.
DONT ACTE, fait et passée à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Daniel FONDU, Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2014. Relation GRE/2014/1079. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
65949
Junglinster, le 26 mars 2014.
Référence de publication: 2014044140/93.
(140050525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
MCG - Change Management Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Change Management Consulting - MCG Sàrl).
Siège social: L-3861 Schifflange, 197, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 147.574.
Im Jahre zweitausend und dreizehn.
Den dritten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Monique FOLLMANN-FOHL GCM sàrl“, mit Sitz in L-3861 Schifflange,
197, rue de Noertzange;
hier vertreten durch seine alleinige Geschäftsführerin Frau Monique FOHL, Consultant, geboren in Esch/Alzette am
2. Mai 1964 (No. Matricule 19640502129), wohnhaft in L-3861 Schifflange, 197, rue de Noertzange.
Frau Monique FOHL handelnd in ihrer Eigenschaft als alleine Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Monique FOLLMANN-FOHL GCM sàrl“, erklärt dass die Gesellschaft „Monique FOLLMANN-FOHL GCM
sàrl“ alleinige Besitzerin ist der gesamten Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Change Mana-
gement Consulting - MCG sàrl“ (Matricule 20092420346), mit Sitz in L-3861 Schifflange, 197 rue de Noertzange;
eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer B 147.574;
gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Georges d'Huart, im damaligen Amtswohnsitz in Petingen,
am 21. Juli 2009, veröffentlicht im Memorial C, im Jahre 2009, Nummer 1.702, Seite 81.694;
Frau Monique FOHL handelnd in ihrer Eigenschaft als alleine Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Monique FOLLMANN-FOHL GCM sàrl“, hat sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung einbefunden
hat und folgende Beschlüsse gefasst hat.
<i>Erster Beschluss:i>
Die Gesellschafterin beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft in „MCG - Change Management Consulting sàrl“
umzubenennen.
<i>Zweiter Beschluss:i>
Gemäß vorhergehendem Beschluss erhält der erste Artikel der Statuten, folgenden Wortlaut:
„ Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „MCG - Change Management Consulting sàrl.“
<i>Dritter Beschluss:i>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Zweck der Gesellschaft umzuändern.
<i>Vierter Beschluss:i>
Gemäß vorhergehendem Beschluss erhält der Artikel drei der Staruten folgenden Wortlaut:
„ Art. 3. Der Gesellschaftszweck umfasst Coaching und Beratung, Vorträge und Konferenzen, Weiterentwicklungs-
und Weiterbildungsmassnahmen, sowie alle direkt und indirekt damit verbundenen Tätigkeiten in den Bereichen Change
und Werte.“
<i>Fuenfter und Letzter Beschluss:i>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Austritt des Geschäftsführers Herrn Elmar FOLLMANN, Consultant,
geboren in Wittlich (Deutschland) am 12. April 1962 (No. Matricule 19620412492), wohnhaft in L-3861 Schifflange, 197
rue de Noertzange, vom heutigen Tage an, anzunehmen und erteilt demselben vollen Entlast.
Zur neuen und alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft wird ernannt Frau Monique FOHL, vorgenannt, die die
Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welcher der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung ob-
liegen oder zur Last gelegt werden, werden auf ACHT HUNDERT ZWANZIG EURO (EURO 820.-) abgeschätzt.
WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettemburg in der Amtsstube des handelnden Notars. Datum wie Ein-
gangs erwähnt.
65950
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: Fohl, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 13 juin 2013. Relation: EAC/2013/7614. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés.
Bettembourg, le 17 juin 2013.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2014044303/58.
(140050212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Sovecasi S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 12, rue Haupeschhaff.
R.C.S. Luxembourg E 5.307.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le quatre mars.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. - Rhett SINNER, avocat à la cour, né le 18 août 1945 à Luxembourg, demeurant à L-6910 Roodt-sur-Syre, 12, rue
Haupeschhaff,
2. - Sophie SINNER, fonctionnaire, née le 4 juin 1975 à Luxembourg, demeurant à L-2550 Luxembourg, 16, Avenue
du Dix Septembre,
3. - Véronique SINNER, fonctionnaire, née le 29 septembre 1977 à Luxembourg, demeurant à L-6912 Roodt-sur-Syre,
7, route de Grevenmacher,
4. - Catherine SINNER, employée privée, née le 24 novembre 1979 à Luxembourg, demeurant à L-1520 Luxembourg,
49, rue Adolphe Fischer.
Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:
Titre I
er
. Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: SOVECASI S.C.I.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de
plusieurs immeubles que la société pourrait détenir ou acquérir au Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-
tement à cet objet de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à L-6910 Roodt-sur-Syre, 12, rue Haupeschhaff.
Titre II. Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital est fixé à cinq mille (5.000.-) euros, divisé en cent (100) parts de cinquante (50.-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:
1. - Rhett SINNER, prédit,
dix parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2. - Sophie SINNER, prédite,
trente parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3. - Véronique SINNER,
prédite, trente parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
4. - Catherine SINNER, prédite,
trente parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d'un droit de préemption qui fonctionnera
comme suit: L'associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession et
65951
adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, également par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans
la société.
Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S'ils laissent passer le dit délai, sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise.
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.
Art. 7. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts que chacun détient.
À l’égard des tiers, ils sont tenus conformément aux dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil.
Titre III. Administration
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 10. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant
(s).
Art. 11. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l’assemblée n'en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-
mativement à la somme de quatre cents (400.-) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme
dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2) Est nommé gérant:
Rhett SINNER, avocat à la cour, né le 18 août 1945 à Luxembourg, demeurant à L-6910 Roodt-sur-Syre, 12, rue
Haupeschhaff.
3) La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.
4) La durée de ses fonctions est illimitée.
5) Le siège social est fixé à L-6910 Roodt-sur-Syre, 12, rue Haupeschhaff.
Dont acte; fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Sinner, S. Sinner, V. Sinner, C. Sinner et Molitor.
Enregistré à LUXEMBOURG A.C., le 10 mars 2014. Relation LAC/2014/11133. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Référence de publication: 2014044213/81.
(140050163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.
P.O.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7350 Lorentzweiler, 18, rue Bellevue.
R.C.S. Luxembourg B 138.897.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014044770/9.
(140051290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
65952
Aircraft Solutions Lux XIX S.à r.l.
Change Management Consulting - MCG Sàrl
C Management S.à r.l.
CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Isamco S.à r.l.
JM Logis S.à r.l.
Kaly S.à r.l.
Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A.
KBC Financial Indemnity Insurance
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.
Lavenden Investments S.A.
Liberté Marques S.à r.l.
Luleo S.A.
Luxieco S.A.
Macquarie Private Markets Fund S.C.A., SICAV-FIS
Marguerite Waste Polska S.à r.l.
Marven S.A.
Marven S.A.
Marven S.A.
MCG - Change Management Consulting Sàrl
Media Entertainment Communication Holding
M.H. Luxembourg S.A.
Octagon Residential S.à r.l.
Orkor Luxco 2 S.à r.l.
Otto Invest & Finance S.A.
O.Z. S.A.
Parthus Finance SPF SA
PATRIZIA Lux 60 S.à r.l.
PG Europe Holding S.à r.l.
Phil Consulting S.à r.l.
Plafonlux S.A.
Plan Tivan S.A.
P.O.E. S.à r.l.
P.O.E. S.à r.l.
POL 1 Sàrl
Predicare S.à r.l.
Prime Oil Finance S.A.
Profenêtre S.à r.l.
PRO Investment S.à r.l.
Promethée S.A.
Promethée S.A.
QDVEO S.à r.l.
RBC Investor Services Bank S.A.
Red Grafton I S.à r.l.
Red Grafton S.à r.l.
Respol Lux S.A.
Rio Forte Investments S.A.
ROLLINGER Chauffage/Sanitaire
Sagra
Smiths Detection International Luxembourg S.à r.l.
Sovecasi S.C.I.
T & E Gefahrgutlogistik A.G.
TwinLux ValueInvest S.A.
TwinLux ValueInvest SICAV-SIF