This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1301
21 mai 2014
SOMMAIRE
AFMH Architecture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
62422
AI Chem (Luxembourg) Topco S.à r.l. . . .
62413
Alfa Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62436
Alma Santa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62441
Alov Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62424
Atmosphere Group (Lux) S.à r.l. . . . . . . . .
62423
B&B Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62415
Belfond (Luxembourg) Sàrl . . . . . . . . . . . . .
62412
Borgo Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
62419
Compagnie des Artisans Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62418
Evia Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62418
Falcon Investor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62428
Fatilu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62424
Fita Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62424
FR Romania S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62424
GES Holding I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62448
Geslux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62448
Ginger S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62423
Global Trade Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62443
Infigen Energy Vest Holdings S.à r.l. . . . . .
62441
International Business Operations . . . . . . .
62422
Larma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62444
Laubach Ferrailles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62443
Lavica Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
62435
L'Immobiliàire Financiaire Nautique S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62444
Maxam Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
62433
Medusa Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
62419
Middle East Internet (GP) S.à r.l. . . . . . . . .
62402
Minvest & SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62415
Motor Reinsurance Company . . . . . . . . . . .
62423
Nano Bubble Technologies (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62448
National General Life Insurance Europe
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62440
Netaxel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62433
Norama Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62425
Nouvelle TEC-Inter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
62447
NREP Transactions Holding 1 S.à r.l. . . . .
62447
NREP Transactions Holding 2 S.à r.l. . . . .
62447
Pimalo-Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62429
Play Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62429
Poerf Holdco No 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
62436
P Ro Service & Consult . . . . . . . . . . . . . . . . .
62448
Repass Express S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62440
TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l. . . . .
62416
Venture 1 Global Equity (Luxembourg) SIF
SICAV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62434
West Africa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62422
62401
L
U X E M B O U R G
Middle East Internet (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.-P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 185.338.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of February.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Middle East Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 183.137,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 January 2014.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered Office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Middle East Internet (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
62402
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
62403
L
U X E M B O U R G
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
62404
L
U X E M B O U R G
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
62405
L
U X E M B O U R G
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Middle East Internet Holding S.à
r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; and
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
62406
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebten Februar.
Vor uns, Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Middle East Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 183.137,
hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 30. Januar 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Middle East Internet (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
62407
L
U X E M B O U R G
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Gesellschafterversammlung“in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
62408
L
U X E M B O U R G
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger
Geschäftsführer“nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich aufgrund der Einberufung durch einen der Geschäftsführer. Die
Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesell-
schaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
62409
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevoll-
mächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder
mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlus-
ses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer
(falls vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Pro-
tokollführer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäfts-
führer (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterver-
sammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und
Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A
und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unter-
schrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterver-
sammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und
Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Ge-
schäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
62410
L
U X E M B O U R G
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
62411
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile wurden ordnungsgemäß von Middle East Internet Holding S.à r.l., vorbe-
nannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Die Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, haben daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; und
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 février 2014. Relation: LAC/2014/7270. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 12. März 2014.
Référence de publication: 2014040242/582.
(140046406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
Belfond (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.050.
EXTRAIT
Il convient de prendre note que Continental Property Investments, associé unique de la Société, a désormais son siège
social au 18, rue Marbeau, 75116 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2014.
Référence de publication: 2014041321/12.
(140047872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62412
L
U X E M B O U R G
AI Chem (Luxembourg) Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 184.898.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“AI Global Investments S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619, here represented by
Mrs Caroline SCULTEUR, maître en droit, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg on 24 February 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of “AI Chem (Luxembourg) Topco S.à r.l.” (the “Company”), a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register is pending and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 14
February 2014, these articles of incorporation have not yet been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations (the “Mémorial C”).
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of one million seven hundred and
eighty thousand US Dollars (USD 1,780,000.-), so as to raise it from its present amount of twenty thousand US Dollars
(USD 20,000.-) up to one million eight hundred thousand US Dollars (USD 1,800,000.-), by the issue of one million seven
hundred and eighty thousand (1,780,000) new ordinary shares each having a par value of one US Dollar (USD 1.-), for a
global amount of one million seven hundred and eighty thousand US Dollars (USD 1,780,000.-) (referred as the “New
Shares”), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the
below resolution, which shall be issued with a share premium of fourteen thousand four hundred and seven US Dollars
(USD 14,407.00), to be paid up by means of contribution in kind consisting in one million seven hundred and ninety-four
thousand four hundred and seven (1,794,407) shares (the “Contributed Shares”) of AI Chem (Luxembourg) S.à r.l., a
société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with its re-
gistered office at 76, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 171.888 (“Luxco 2”), currently held by AI Global Investments S.à r.l., prenamed (the “Contribution”).
<i>Subscription/Paymenti>
“AI Global Investments S.à r.l.”, prenamed, has declared to subscribe for one million seven hundred and eighty thousand
(1,780,000) New Shares, each having a par value of one US Dollar (USD 1.-) and to pay them up by a contribution in kind
consisting in one million seven hundred and ninety-four thousand four hundred and seven (1,794,407) shares of Luxco 2,
having all together a value of one million seven hundred and ninety-four thousand four hundred and seven US Dollars
(USD 1,794,407.00). The above contribution is valued at one million seven hundred and ninety-four thousand four hundred
and seven US Dollars (USD 1,794,407.00) and is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of one million
seven hundred and eighty thousand US Dollars (USD 1,780,000.00) and (ii) to the share premium account for an amount
of fourteen thousand four hundred and seven US Dollars (USD 14,407.00).
The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend the article 5.1 of the articles of
incorporation of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:
“ 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at one million eight hundred thousand US Dollars (USD 1,800,000.-), represented
by one million eight hundred thousand (1,800,000) shares of one US Dollar (USD 1.-), each having such rights and obli-
gations as set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the Shares
and “Shareholder” shall be construed accordingly.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euro.
62413
L
U X E M B O U R G
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil
status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq février.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
sera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
«AI Global Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 140.619,
ici représentée par Madame Caroline SCULTEUR, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Howald, Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 24 février 2014.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique d'«AI Chem (Luxembourg) Topco S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une
société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 76, Grand
Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
et dont le numéro n'a pas encore été attribué, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 14 février 2014
et dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial
C»).
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant d'un million sept cent quatre-vingt
mille US Dollars (USD 1.780.000,-), de façon à l'accroître de son montant actuel de vingt mille US Dollars (USD 20.000,-)
à un million huit cent mille US Dollars (USD 1.800.000,-), par l'émission d'un million sept cent quatre-vingt mille
(1.780.000) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un Dollar US (USD 1.00), pour un montant
total d'un million sept cent quatre-vingt mille US Dollars (USD 1.780.000,-) (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les
droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, qui
sont émises avec une prime d'émission de quatorze mille quatre cent sept US Dollars (USD 14.407,-), payées par un
apport en nature consistant en un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent sept (1.794.407) parts sociales
(les «Parts Sociales Apportées») d'AI Chem (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 171.888 («Luxco 2»),
actuellement détenue par AI Global Investments S.à r.l., prénommée, (l'«Apport»).
<i>Souscription/Paiementi>
«AI Global Investments S.à r.l.», prénommée, déclare souscrire à un million sept cent quatre-vingt mille (1.780.000)
Nouvelles Parts Sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,-), payées par un apport en nature
consistant en un million sept cent quatre-vingt quatorze mille quatre cent sept (1.794.407) parts sociales de Luxco 2,
ayant toutes ensemble une valeur d'un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent sept US Dollars (USD
1.794.407,-). Le montant de l'apport est d'un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent sept US Dollars
(USD 1.794.407,-) et est alloué (i) au capital social de la Société pour un montant d'un million sept cent quatre-vingt mille
US Dollars (USD 1.780.000,-) et (ii) au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de quatorze mille
quatre cent sept US Dollars (USD 14.407,-).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les décisions
ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est d'un million huit cent mille US Dollars (USD 1.800.000,-), représenté par un
million huit cent mille (1.800.000) parts sociales d'une valeur d'un dollar US (USD 1.-) chacune ayant les droits et obli-
62414
L
U X E M B O U R G
gations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun
de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-
mentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. SCULTEUR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 février 2014. Relation: EAC/2014/2886. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014041275/128.
(140047819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
B&B Holding S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 125.899.
<i>Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 20 février 2014i>
En date du 20 février 2014, les membres du conseil d'administration, ont décidé à l'unanimité des voix de:
- transférer le siège social de la Société du 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg, au 4, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec date effective au 1
er
mars 2014.
La nouvelle adresse professionnelle de Massimo Raschella est la suivante: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
La nouvelle adresse professionnelle de Jean-Marie Bettinger est la suivante: 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.
La nouvelle adresse professionnelle de Magali Fetique est la suivante: 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2014.
B&B HOLDING SA
Référence de publication: 2014041305/17.
(140047771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Minvest & SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.114.
<i>Assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 19 mars 2014i>
1- Monsieur Richard MAZELIER, Entrepreneur, né le 23 mai 1975 à Thiers, France, résidant 4, rue des Treize, F-57070
Metz, France, et
2- Mlle Julia ROLAND, née le 30 septembre 1982 à Pertuis, France, demeurant 96, rue Amelot, F-75011 Paris;
Les comparants détenant l'intégralité du capital social de la Société, ont tenu une assemblée générale extraordinaire
sous seing privée qui a pris la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide nommer Mlle Julia ROLAND, précitée, en qualité de gérante de la Société.
Son mandat débute au jour des présentes, pour une durée indéterminée.
Richard MAZELIER / Julia ROLAND.
Référence de publication: 2014041587/17.
(140047775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62415
L
U X E M B O U R G
TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 156.941.
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh of February.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette.
THERE APPEARED
Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing in Esch/Alzette,
acting by virtue of resolutions taken by the board of managers (the “Board of Managers”) of “TRG Blue Rock HBM
Holdings S.à r.l.” on 7 February 2014 (the “Board Resolutions”), after having been signed ne varietur by the appearing
person and the undersigned notary, will be annexed to this document to be filed together with the registration authorities,
declared and required the notary to record that:
I. - The company “TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l.” is a private limited liability company, société à responsabilité
limitée, incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.941, incorporated by
deed of the undersigned notary, on 25 October 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 5 of 3 January 2011 (the “Company”), whose articles have been modified several times and the last time pursuant
to a constatation of the undersigned notary, on 29 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2412 of 30 September 2013.
II. - According to article 5 of the articles of incorporation of the Company, the subscribed share capital of the Company
is set at one hundred and four thousand nine hundred and twenty USD (USD 104,920) divided into two thousand four
hundred and ninety-one (2,491) Class A Shares (as defined below), eight thousand (8,000) Class B Shares (as defined
below) and one (1) Class D Share (as defined below).
The Board of Managers is authorised pursuant to article 5 of such articles of incorporation to increase the share capital
of the Company within the limits of the authorised share capital. The Company has an authorised share capital of three
billion one hundred million and ten USD (USD 3,100,000,010) represented by two hundred million (200,000,000) ordinary
class A shares having a nominal value of ten USD (USD 10) each (the “Class A Shares”) one hundred million (100,000,000)
convertible preferred class B shares having a nominal value of ten USD (USD 10) each (the “Class B Shares”), ten million
(10,000,000) redeemable class C shares having a nominal value of ten USD (USD 10) each (the “Class C Shares”) and
one (1) preferred class D share (the “Class D Share”).
The Board of Managers is authorised and appointed for a period of five years from publication of the last amendment
of the articles whereby the general meeting of shareholders granted such authority to the Board of Managers, to increase
from time to time the subscribed capital of the Company within the limits of the authorised capital, at once or by successive
portions, by issuance of new shares with or without share premium, provided however that any issuance of new shares
to a non-shareholder requires the prior approval of shareholders representing three-quarters of the share capital. The
new shares with or without share premium may be paid up in cash or by contribution-in-kind of securities or other assets,
in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, and provided that such securities or other assets comply
with the investment objectives and strategy of the Company.
When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,
it shall be obliged to take steps to amend the articles in order to record the change and the Company’s management is
authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.
III.- Following receipt by the Company of the sum of two million two hundred and fifty thousand USD (USD 2,250,000)
and based on the Board Resolutions having resolved on the capital increase referred to below and recording the sub-
scription by the subscriber of the new shares listed below and issued under that capital increase, the person appearing,
acting by virtue of the documents mentioned above, asked the notary to record the increase of the share capital of the
Company by an amount of two thousand two hundred and fifty USD (USD 2,250) to bring it from its present amount of
one hundred and four thousand nine hundred and twenty USD (USD 104,920) to one hundred and seven thousand one
hundred and seventy USD (USD 107,170) by the issue of two hundred and twenty-five (225) new Class A Shares having
a nominal value of ten USD (USD 10) and a share premium of nine thousand nine hundred and ninety USD (USD 9,990)
each. The new Class A Shares were issued to Global Cement Investment S.A.
Evidence of the aforementioned payment in the amount of two million two hundred and fifty thousand USD (USD
2,250,000) for the newly issued shares including the share premium has been given.
IV. According to the powers granted to the Board of Managers by article 5 of the articles of incorporation of the
Company and following the realisation of the increase of capital as decided by the Board of Managers as mentioned in
this deed and as further set out in the Board Resolutions, the first sentence of article 5 of the articles of incorporation
shall be amended to be worded as follows:
62416
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5. The subscribed share capital is set at one hundred and seven thousand one hundred and seventy USD (USD
107,170) divided into two thousand seven hundred and sixteen (2,716) Class A Shares (as defined below), eight thousand
(8,000) Class B Shares (as defined below) and one (1) Class D Share (as defined below).”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at two thousand seven hundred euro (EUR 2,700.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, this deed is worded in English, followed by a French version and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.
Follows the french version of above text
L’an deux mille quatorze, le onze février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU
Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette,
agissant en vertu des résolutions prises par le conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») de «TRG Blue Rock HBM
Holdings S.àr.l.» en date du 7 février 2014 (les «Résolutions»), après avoir été signées ne varietur par la comparante et
le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. - La société «TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l.» est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
avec siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 156.941, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25
octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 3 janvier 2011 (la «Société»),
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 29 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2412 du 30 septembre 2013.
II. - Selon l’article 5 des statuts de la Société, le capital social souscrit de la Société est fixé à cent quatre mille neuf
cent vingt dollars (104.920 $) divisé en deux mille quatre cent quatre-vingt-onze(2.491) Parts Sociales de Classe A (tel
que défini ci-dessous), huit mille (8.000) Parts Sociales de Classe B (tel que défini ci-dessous) et une (1) Part Sociale de
Classe D (tel que défini ci-dessous).
Le Conseil de Gérance est autorisé aux termes de l’article 5 des statuts à augmenter le capital de la société dans les
limites du capital autorisé. La société a un capital social autorisé de trois milliards cent millions et dix dollars (3.100.000.010
$), représenté par deux cents millions (200.000.000) parts sociales ordinaires de classe A ayant une valeur nominale de
dix dollars (10 $) chacune (les «Parts Sociales de Classe A»), cent millions (100.000.000) parts sociales privilégiées con-
vertibles de classe B ayant une valeur nominale de dix dollars (10 $) chacune (les «Parts Sociales de Classe B»), dix millions
(10.000.000) parts sociales rachetables de classe C ayant une valeur nominale de dix dollars (10 $) chacune (les «Parts
Sociales de Classe C») et une (1) part sociale privilégiée de Classe D ayant une valeur nominale de dix dollars (10 $) (la
«Part Sociale de Classe D»).
Le Conseil de Gérance est autorisé à et mandaté pour une période de cinq années à compter de la date de la publication
de la dernière modification des statuts, où l’assemblée générale des associés a donné ce pouvoir au Conseil de Gérance,
à augmenter de temps en temps, le capital social souscrit de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule
fois ou par tranches successives, par émission des nouvelles parts sociales avec ou sans prime d’émission, à condition
toutefois que toute émission de nouvelles parts sociales à une non-associé requiert l’approbation préalable des associés
représentant les trois quarts du capital social. Les nouvelles parts sociales avec ou sans prime d’émission peut être libérer
par voie de versements en espèces ou par apport en nature de titres ou d'autres actifs, dans le respect des conditions
prévues par la loi luxembourgeoise, et à condition que ces titres ou autres actifs soient conformes à l’investissement
objectifs et la stratégie de la société.
Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions
mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier les statuts afin de constater cette
modification et la gérance de la société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution
et la publication de telle modification conformément à la loi.
III. - À la suite de la réception de la somme de deux millions deux cent cinquante mille dollars (2.250.000 $), le
comparant, agissant en vertu des Résolutions ayant approuvé l’augmentation de capital mentionnée ci-dessous et enre-
gistré la souscription par le souscripteur des nouvelles parts sociales énumérées ci-dessous et émises en vertu de cette
62417
L
U X E M B O U R G
augmentation de capital, demande au notaire d’acter l’augmentation de capital de la Société d’un montant de deux mille
deux cent cinquante dollars (2.250 $) aux fins de le porter de son montant actuel de cent quatre mille neuf cent vingt
dollars (104.920 $) à cent sept mille cent soixante-dix dollars (107.920 $), par l’émission de deux cent vingt-cinq (225)
nouvelles Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale de dix dollars (10 $) avec une prime d’émission de neuf
mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars (9.990 $) chacune. Les nouvelles Parts Sociales de Classe A ont été émises à Global
Cement Investment S.A.
La preuve du paiement de la somme de deux millions deux cent cinquante mille dollars (2.250.000 $) pour les parts
sociales nouvelles incluant la prime d’émission a été fournie.
IV. Conformément à l’autorisation conférée au Conseil de Gérance par l’article 5 des statuts et suite à l’augmentation
de capital décidée par le Conseil de Gérance mentionnée ci-dessus et comme expliqué dans les Résolutions, le premier
alinéa de l’article 5 des statuts doit être modifié pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent sept mille cent soixante-dix dollars (107.170 $) divisé en deux mille
sept cent seize (2.716) Parts Sociales de Classe A (tel que défini ci-dessous), huit mille (8.000) Parts Sociales de Classe B
(tel que défini ci-dessous) et une (1) Part Sociale de Classe D (tel que défini ci-dessous).»
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en
raison du présent acte sont évalués à deux mille sept cents euros (EUR 2.700,-).
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête du même comparant, en cas de divergence entre le texte
français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2429. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014041145/145.
(140046977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
Compagnie des Artisans Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, 186, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 155.814.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014041344/10.
(140048278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Evia Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.366.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 février 2014i>
1. La démission de Messieurs Patrick Moinet et Benoit Bauduin de leur mandat de Gérants est acceptée avec effet au
15 février 2014.
2. Grégory Andre, né le 12 mars 1974 à Greenfiel Park, Canada et domicilié 95 Allée Leopold Goebel, L-1635 Lu-
xembourg est nommé Gérant de la Société pour une période indéterminée, à compter du 15 février 2014.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2014041423/14.
(140047818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62418
L
U X E M B O U R G
Borgo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Medusa Luxembourg S.à r.l.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.141.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of the month February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
(1) Blackstone Capital Partners (Cayman II) VI L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of
the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under number
WK-46064, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal.
(2) Blackstone Tactical Opportunities Fund - A (PE) (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing
under the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands
under number WK-55190, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(3) Blackstone Tactical Opportunities Fund - C (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-62604, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(4) Blackstone Tactical Opportunities Fund (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under the
laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-65343, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(5) Blackstone Tactical Opportunities Fund - G (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-69545, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(6) Blackstone Tactical Opportunities Fund - T (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-71521, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(7) Blackstone Tactical Opportunities Fund - AD (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-71522, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(8) Blackstone Tactical Opportunities Fund - L (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-72048, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(9) Blackstone Tactical Opportunities Fund - O (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-72472, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(10) Blackstone Tactical Opportunities Fund - N (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-72642, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
62419
L
U X E M B O U R G
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(11) Blackstone Tactical Opportunities Fund - S (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships of the Cayman Islands under
number WK-73950, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
(12) Blackstone Family Tactical Opportunities Investment Partnership (Cayman) SMD L.P., a limited partnership in-
corporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with Registrar of Exempted limited Partnerships
of the Cayman Islands under number WK-59703, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the officiating notary, will remain
attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties are all the shareholders (the “Shareholders”) of Medusa Luxembourg S.à r.l., (hereinafter the
“Company”) a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
originally incorporated under the name of BCP Medusa Luxembourg S.à r.l., pursuant to a deed of the officiating notary,
on February 25, 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The articles of incorporation of the Company gas been amended pursuant to a deed of the officiating notary, on 26
February 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, containing the adoption by the
Company of its current corporate name.
The appearing persons, representing the whole corporate capital, require the notary to enact the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the name of the Company from “Medusa Luxembourg S.à r.l.” to “Borgo Luxem-
bourg S.à r.l.” with immediate effect.
<i>Second Resolutioni>
As a result of the above, article 1 of the articles of association of the Company, shall now read as follows:
“ Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Borgo Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand and thirty Euros (EUR 1,030.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de février;
Pardevant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
ONT COMPARU:
(1) Blackstone Capital Partners (Cayman II) VI L.P., une limited partnership constituée et existant selon les lois des
Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro WK-46064,
ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
(2) Blackstone Tactical Opportunities Fund - A (PE) (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon
les lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-55190, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
62420
L
U X E M B O U R G
(3) Blackstone Tactical Opportunities Fund - C (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon les
lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-62604, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(4) Blackstone Tactical Opportunities Fund (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon les lois
des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-65343, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, GrandCayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(5) Blackstone Tactical Opportunities Fund - G (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon les
lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-69545, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(6) Blackstone Tactical Opportunities Fund - T (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon les
lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-71521, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(7) Blackstone Tactical Opportunities Fund - AD (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon
les lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-71522, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(8) Blackstone Tactical Opportunities Fund - L (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon les
lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-72048, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(9) Blackstone Tactical Opportunities Fund - O (Cayman) L.P. une limited partnership constituée et existant selon les
lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro WK
72472, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(10) Blackstone Tactical Opportunities Fund - N (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon
les lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-72642, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(11) Blackstone Tactical Opportunities Fund - S (Cayman) L.P., une limited partnership constituée et existant selon
les lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Îles Caïmans sous le numéro
WK-73950, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
(12) Blackstone Family Tactical Opportunities Investment Partnership (Cayman) SMD L.P., une limited partnership
constituée et existant selon les lois des Îles Caïmans, immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnerships des
Îles Caïmans sous le numéro WK-59703, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand
Cayman, Îles Caïmans,
dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Les parties comparantes sont toutes les associées (les «Associés») de Medusa Luxembourg S.à r.l., (ci-après la «So-
ciété») une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, non encore enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée originairement sous le nom de BCP Medusa Luxembourg S.à
62421
L
U X E M B O U R G
r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 25 février 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 26 février 2014, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, contenant l'adoption par la Société de la dénomination sociale
actuelle.
Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant
d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
Les Associés décident de changer avec effet immédiat le nom de la Société de «Medusa Luxembourg S.à r.l.» en «Borgo
Luxembourg S.à r.l.».
<i>Deuxième Résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'article 1 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Borgo Luxembourg
S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ mille trente euros (EUR 1.030,-).
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, statut
civil et résidence, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 06 mars 2014. LAC/2014/10484. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Référence de publication: 2014040238/200.
(140046250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
AFMH Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 6B, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 177.490.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 21 mars 2014.
Référence de publication: 2014041272/10.
(140047915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
West Africa S.A., Société Anonyme,
(anc. I.B.O., International Business Operations).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 62.066.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 mars 2014.
Référence de publication: 2014041168/10.
(140046840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
62422
L
U X E M B O U R G
Atmosphere Group (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 141.596,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 151.666.
Par résolutions signées en date du 13 mars 2014, l'associé unique a décidé de nommer Laura Spitoni, avec adresse
professionnelle au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
Référence de publication: 2014041262/13.
(140047845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Ginger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.759.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 19 mars 2014i>
L'Associé Unique de Ginger S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Damian Francis Pons en tant que gérant de la Société à partir du 12 mars 2014;
- De nommer:
* Monsieur Adam Kruszynski, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que
gérant de la Société à partir du 12 mars 2014 pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
Ginger S.à r.l.
Référence de publication: 2014042091/18.
(140048986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
Motor Reinsurance Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 103.659.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le mercredi 20 mars 2014 au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.i>
1. L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants:
- Monsieur Stéphane STOUFFLET, demeurant professionnellement au 13-15, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 Bou-
logne Billancourt Cedex, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Madame Catherine HAMON, demeurant professionnellement au 13-15, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 Boulogne
Billancourt Cedex,
- Monsieur Claude WEBER, demeurant professionnellement au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Administrateur.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015 et qui aura à statuer sur
les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014.
2. L'Assemblée nomme Ernst & Young S.A (RCS Luxembourg B 47771), ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée
Générale à tenir en 2015 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014041593/23.
(140048372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62423
L
U X E M B O U R G
Fatilu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 143.021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014042070/10.
(140048575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
Fita Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 118.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014042074/10.
(140048484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
FR Romania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 120.073.
Veuillez prendre note que l'associée, Fingen International B.V., a son siège désormais à Televisieweg 2 A, 1322AC
Almere (Pays-Bas).
Luxembourg, le 24 mars 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FR Romania S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014042082/13.
(140048580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
Alov Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 769.750,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 106.279.
EXTRAIT
En date du 12 mars 2014 le liquidateur de la Société a décidé de procéder au rachat de deux-cent trente-sept (237)
parts sociales détenues par Apax WW Nominees Limited de sorte que les parts sociales dans la Société sont désormais
détenues comme suit:
parts
sociales
Alov Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.789
Apax WW Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.790
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014041224/21.
(140046148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
62424
L
U X E M B O U R G
Norama Fund, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.064.
In the year two thousand and fourteen on the thirty-first day of January.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Géraldine NUCERA, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of managers of the general partner of “Norama Fund”, a société en
commandite par actions, with registered office at L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 171 064 (hereafter the Company),
pursuant to the resolutions taken by the board of managers of the Company's general partner (the General Partner)
on 30 January 2014 (the Resolutions).
A copy of the minutes of the Resolutions, signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing person, representing the board of managers of the General Partner pursuant to the Resolutions, has
requested the undersigned notary to record the following statements:
1. The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on
August 21
st
, 2012 published, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 2386 dated on September 25
th
, 2012.
2. Article 6 of the Articles of Incorporation reads as follows:
" 6.1. The issued and subscribed share capital of the Company is set at twelve million seven hundred and fifty one
thousand two hundred thirty-six point ninety Swedish krona (SEK 12,751,236.90.-), divided in twelve thousand seven
hundred fifty-one point two three six (12,751.236) Ordinary Shares with a par value of one thousand Swedish krona (SEK
1,000.-) each held by the Ordinary Shareholders, and one (1) General Partner's Share held by the General Partner with
a par value of one thousand Swedish krona (SEK 1,000.-).
6.2. The authorised capital is fixed at one billion one thousand Swedish krona (SEK 1,000,001,000.-) consisting of one
million (1,000,000) Ordinary Shares with a par value of one hundred Swedish krona (SEK 1,000.-) per Share and one (1)
General Partner's Share with a par value of one thousand Swedish krona (SEK 1,000.-). Shares issued in the context of
the authorised capital will be issued at a price being the highest of the par value per Share of the relevant Class or the
par value per Share of the relevant Class increased by the difference between the net asset value per Share of the relevant
Class and the par value per Share of the relevant Class.
6.3. The General Partner is authorised within the limits set forth herein to (i) realise any increase of the share capital
in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion
rights granted by the General Partner within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants
(which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar
instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new Shares, with or without share premium,
against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner, (ii) determine the
place and date of the Closing or the successive Closings, the issue price, the terms and conditions of the subscription and
payment for the new Shares and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the existing Shareholders at
the moment of the new issue, as fully described in the Memorandum.
6.4. This authorisation is valid for a period of five (5) years from the date of publication of the deed of incorporation
of the Company in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations and it may be renewed by decision of the General
Meeting.
6.5. The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving
payment for Shares representing part or all of the issue of new Shares under the authorised capital.
6.6. Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realised and duly stated in
the form provided for by the Companies Law, this Article will be modified so as to reflect the actual increase. Such
modification will be recorded in authentic form by the General Partner or by any person duly authorised and empowered
by the General Partner for this purpose.
6.7. The issued and/or authorised capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a
resolution of the General Meeting adopted at the Special Majority.
6.8. The General Partner may issue further authorised Shares of the Company within the authorised capital without
granting any preferential subscription rights to the existing Shareholders.
62425
L
U X E M B O U R G
3. 6.9. The General Partner may establish a share premium account into which any premium paid on any Share in
addition to its par value is transferred. The amount of the share premium account may be used to provide for the payment
of any Shares of any Class which the Company may repurchase from its Shareholders, to offset any net realised losses,
to make distributions to the Shareholders of whatever Class in the form of a dividend or to allocate funds to the legal
reserve."
4. The board of managers of the General Partner, in the Resolutions aforesaid, resolved to:
(i) increase within the limits of the authorised share capital, the Company's nominal share capital of seven hundred
five thousand Swedish krona (SEK 705,000.-) to raise it from its current level of twelve million seven hundred and fifty
one thousand two hundred thirty-six point ninety Swedish krona (SEK 12,751,236.90.-) to thirteen million, four hundred
and fifty six thousand, two hundred and thirty six point ninety Swedish krona (SEK 13,456,236.90.-) by issuing seven
hundred five (705) new ordinary shares with a par value of one thousand Swedish krona (SEK 1,000.-), (the New Ordinary
Shares) to such subscribers as referred to in the Resolutions (the Subscribers), the New Ordinary Shares having been
subscribed for and fully paid up in cash by the Subscribers as detailed in the Resolutions.
(i) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on
commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing sha-
reholders of the Company in respect of the issue of the New Ordinary Shares, and
(ii) appoint and empower, with full power of substitution, Géraldine NUCERA, prenamed, to appear as the represen-
tative of the board of managers of the General Partner before the undersigned notary to record the increase of share
capital of the Company so effectuated in notarial form, to amend the first paragraph of Article 6.1. of the Articles and to
do any formalities and to take any actions which may be necessary and proper in connection therewith.
4. All the seven hundred five (705) New Ordinary Shares have been subscribed and fully paid up by contribution in
cash by the Subscribers designated in the Resolutions, the seven hundred five thousand Swedish krona (SEK 705,000.-)is
at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who states it.
5. The contribution in cash so made in an amount of seven hundred five thousand Swedish krona (SEK 705,000.-)to
the Company is allocated to the nominal share capital account of the Company, discharge is given to the General Partner
to amend the register of Shareholders following the predicted increase in capital.
6. As a consequence of the above increase of the Company's nominal share capital, the first paragraph of Article 6.1
of the Articles is amended so as to have the following wording:
" 6.1. The issued and subscribed share capital of the Company is set thirteen million, four hundred fifty six thousand
two hundred thirty six point ninety Swedish krona (SEK 13,456,236.90.-) divided into thirteen thousand four hundred
fifty six point two three six (13,456.236) Ordinary Shares with a par value of one thousand Swedish krona (SEK 1,000.-)
each held by the Ordinary Shareholders (the "Ordinary Shares"), and one (1) General Partner's Share held by the General
Partner with a par value of one thousand Swedish krona (SEK 1,000.-)."
<i>Costsi>
The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred ninety euro (EUR 1,290.-).
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, whose name, civil status and residence are known to the
notary, the appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l'an deux mille quatorze, le trente-et-un Janvier.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Mademoiselle Géraldine NUCERA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant au nom et pour compte du conseil de gérance de l'associé commandité de «Norama Fund», une société en
commandite par actions avec siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171 064 (ci-après la Société),
conformément aux résolutions prises par le conseil de gérance de l'associé commandité de la Société (l'Associé Com-
mandité) en date du 30 janvier 2014 (les Résolutions).
Une copie des Résolutions, restera, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante, représentant le conseil de gérance de l'Associé Commandité de la Société conformément aux Réso-
lutions, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
62426
L
U X E M B O U R G
1. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 21
août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2386 du 25 septembre 2012.
2. L'article 6 des Statuts a la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société émis et souscrit est fixé à douze millions sept cent cinquante-un mille deux cent
trente-six virgule quatre-vingt-dix couronnes suédoises (12.751.236,90.- SEK), divisé en douze mille sept cent cinquante-
un virgule deux trois six (12.751,236) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de mille couronnes suédoises (1,000,-
SEK) chacune, détenues par les Actionnaires Commanditaires, et une (1) Action de Commandité d'une valeur nominale
de mille couronnes suédoises (1,000,- SEK), détenue par l'Associé Commandité.
6.2. Le capital autorisé est fixé à un milliard et mille couronnes suédoises (SEK 1.000.001.000) représenté par un million
(1.000.000) d'Actions Ordinaires d'une valeur nominale de mille couronnes suédoises (SEK 1.000,-) chacune et une (1)
Action de Commandité d'une valeur nominale de mille couronnes suédoises (SEK 1.000,-). Les Actions émises dans le
cadre du capital autorisé seront émise à la plus élevée de la valeur nominale par Action de la Classe concernée ou la
valeur nominale par Action de la Classe concernée augmentée de la différence entre valeur nette d'inventaire par Action
de la Classe concernée et ladite valeur nominale.
6.3. L'Associé Commandité est autorisé, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser toute aug-
mentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription et/
ou aux droits de conversion accordés par l'Associé Commandité à concurrence du capital autorisé conformément aux
conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments
similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de
nouvelles Actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de
créances de la Société, ou de toute autre manière (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives,
les conditions de la souscription et de la libération des Actions nouvelles et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel
de souscription des Actionnaires existants au moment de la nouvelle émission, de la manière décrite dans le Memorandum.
6.4. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication de cet acte au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, et pourra être renouvelée par une décision de l'Assemblée Gé-
nérale.
6.5. L'Associé Commandité peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions
et de recevoir paiement pour des Actions représentant tout ou partie de l'émission d'Actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.
6.6. A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée
dans les formes prévues par la Loi sur les Sociétés, le présent Article sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital.
Une telle modification sera constatée sous forme authentique par l'Associé Commandité ou par toute personne dûment
autorisée à cet effet par l'Associé Commandité.
6.7. Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution
de l'Assemblée Générale adoptée à la Majorité Spéciale.
6.8. L'Associé Commandité est autorisé à émettre de nouvelles Actions autorisées de la Société dans les limites du
capital autorisé, sans réserver de droits de souscription préférentiel aux Actionnaires existants.
6.9. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les
primes d'émission payées sur les Actions en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut
être utilisé pour régler le prix de rachat d'actions de toute Classe que la Société a racheté à ses actionnaires, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux Actionnaires de toute Classe ou pour affecter
des fonds à la réserve légale.»
3. Le conseil de gérance de l'Associé Commandité, dans ses Résolutions précitées, a décidé:
(i) d'augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de sept cent cinq mille couronnes suédoises
(705.000,-SEK), pour le porter de son montant actuel de douze millions sept cent cinquante-un mille deux cent trente-
six virgule quatre-vingt-dix couronnes suédoises (12.751.236,90.-SEK) à treize millions quatre cent cinquante-six mille
deux cent trente-six virgule quatre-vingt-dix couronnes suédoises (13.456.236,90.- SEK) par l'émission de sept cent cinq
(705) actions ordinaires, avec valeur nominale de mille couronnes suédoises (1.000,-SEK) chacune (les Nouvelles Actions
Ordinaires) aux souscripteurs désignés dans les Résolutions (les Souscripteurs), les Nouvelles Actions Ordinaires ayant
été souscrites et entièrement libérées par les Souscripteurs comme il est décrit dans les Résolutions,
(ii) de supprimer, dans le cadre de l'augmentation de capital ci-dessus et conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels des
actionnaires existants concernant les Nouvelles Actions, et
(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Géraldine NUCERA, prénommée, pour représenter le
conseil de gérance de l'Associé Commandité devant le notaire instrumentant afin d'acter l'augmentation de capital de la
Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l'article 6.1 des Statuts et d'effectuer toutes les formalités et de
prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmentation de capital.
62427
L
U X E M B O U R G
4. Toutes les sept cent cinq (705) Nouvelles Actions Ordinaires ont été souscrites et entièrement libérées en espèces
par les Souscripteurs désignés dans les Résolutions, sept cent cinq mille couronnes suédoises (705.000,-SEK) sont à la
disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire instrumentant, qui le constate.
5. L'apport en espèces d'un montant de sept cent cinq mille couronnes suédoises (705.000,- SEK) est porté au compte
capital social de la Société, décharge est donnée à l'Associé Commandité de modifier le registre des Actionnaires suite à
la prédite augmentation de capital.
6. En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l'article 6.1 des Statuts est
modifié pour avoir la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société émis et souscrit est fixé à treize millions quatre cent cinquante-six mille deux cent
trente-six virgule quatre-vingt-dix couronnes suédoises (13.456.236,90.- SEK), divisé en treize millions quatre cent cin-
quante-six mille deux cent trente-six (13.456.236) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de mille couronnes suédoises
(1,000.- SEK) chacune, détenues par les Actionnaires Commanditaires, et une (1) Action de Commandité d'une valeur
nominale de mille couronnes suédoises (1,000.- SEK), détenue par l'Associé Commandité.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ mille deux cent quatre-vingt-dix euros (1.290,-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. NUCERA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 04 février 2014. Relation: LAC/2014/5408. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mars 2014.
Référence de publication: 2014040261/197.
(140046283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
Falcon Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 970.800,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 118.864.
<i>Extrait des résolutions écrites des associés de la Société prises en date du 19 mars 2014i>
Les Associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de M. Eric Scussel, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg, de sa fonction de Gérant, avec effet immédiat;
- de nommer comme nouveau Gérant, avec effet immédiat, Monsieur Thomas Dewé, résidant professionnellement au
20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO C&T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Signature
<i>Employéi>
Référence de publication: 2014042069/19.
(140048557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
62428
L
U X E M B O U R G
Pimalo-Invest, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.470.300,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 171.736.
EXTRAIT
Les associés, dans leurs résolutions du 19 mars 2014, ont renouvelé les mandats des gérants.
- Monsieur Philippe GODEAU, 12, rue de Beynes, F-78640 Neauphle-le-Vieux, France, gérant de catégorie A.
- Monsieur Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, gérant de catégorie B.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.
En outre, l'un des associés de la société, à savoir Madame Nathalie GASTALDO-NIGRA, a désormais comme nom de
famille, GASTALDO GODEAU et comme nouvelle adresse, 12, rue de Beynes, F-78640 Neauphle-le-Vieux, France.
L'autre associé de la société, à savoir Monsieur Philippe GODEAU, a désormais comme nouvelle adresse, 12, rue de
Beynes, F-78640 Neauphle-le-Vieux, France.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
<i>Pour PIMALO-INVEST
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2014041008/20.
(140047464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
Play Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 183.803.
In the year two thousand fourteen, the twenty-third day of January,
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Play Holdings 2 S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 5, Rue Guillaume Kroll, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500), and not yet registered with the Luxembourg register of commerce and companies (the Company).
The Company was incorporated on January 10, 2014, pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
THERE APPEARED:
Play Holdings 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, having a share capital of
EUR 12,510, not yet registered with the Register of Commerce and Companies (the Sole Shareholder),
here represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is in Esch-
sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. that the agenda of this meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1) in order to bring the share capital
from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred
(12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to twelve thousand five hundred
and one Euro (EUR 12,501), by way of the issuance of one (1) new share, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-).
2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above by way of a contribution in kind.
3. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes
adopted under item 1 above.
62429
L
U X E M B O U R G
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company
to the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company.
5. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1) in
order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,
to twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501), by way of the issuance of one (1) new share, having a nominal
value of one Euro (EUR 1.-).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Play Holdings 1 S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one (1) newly
issued share of the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1) and to pay it up in full by way of a contribution
(i.e. a transfer of ownership) in kind consisting of ninety-six thousand nine hundred thirteen (96,913) shares that it holds
in the share capital of P4 sp. z o.o., a company incorporated under the laws of Poland, having its registered office in
Warsaw, at 7 Taœmowa street, registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the
District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, under number
KRS 0000217207 (P4) having an aggregate value of at least one billion six hundred ninety-two million euro (EUR
1,692,000,000) and representing one hundred percent (100%) of the share capital of P4 (the Shares). Such contribution
shall be allocated as follows:
(i) an amount of one Euro (EUR 1) to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) an amount of one billion six hundred ninety-one million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-
nine Euro (EUR 1,691,999,999) to the share premium account of the Company.
The evidence and valuation of the Shares is evidenced, inter alia, by a valuation certificate dated 23 January 2014 issued
by the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company (the Sole Shareholder’s
Certificate).
The Sole Shareholder’s Certificate states in essence that:
“1. The Sole Shareholder is the owner of the Shares.
2. The Shares are fully paid-up.
3. The Sole Shareholder is solely entitled to the Shares and possess the power to dispose of the Shares.
4. The Shares are encumbered with Polish registered and financial pledges established in favour of Bank Polska Kasa
Opieki S.A. as a security agent in connection with (A) the facility agreement originally dated 31 October 2006 and made
between, among others, P4 as the borrower, the entities (including China Development Bank Corporation) named therein
as lenders and Bank Polska Kasa Opieki S.A. as the facility agent and the security agent; and (B) the intercreditor agreement
originally dated 31 October 2006 and made between, amongst others, P4 as borrower, Bank Polska Kasa Opieki S.A. as
security agent and facility agent and China Development Bank Corporation, which was acceded by Alior Bank S.A. (Pled-
ges); the agreements for the establishment of the Pledges provide for the enforcement methods including, among others,
the pledgee’s right to seize or sell the Tollerton Shares.
5. None of the Shares are encumbered with, amongst others but not limited to, any pledge or usufruct, and there
exists no right to acquire, amongst others but not limited to, any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares
are subject to any attachment save for any such rights established in favour of the other shareholder in P4 which shall be
waived or released upon such shares being contributed to the Company and except for the pledges, as defined above.
6. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Shares be transferred to him save for any such rights established in favour of the other shareholder
in P4 which shall be waived or released upon such shares being contributed to the Company.
7. According to applicable law and the articles of association of the Company, the Shares are freely transferable.
8. All formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares to the Company will
be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.
9. Based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Shares is at least equal to one billion
six hundred ninety-two million Euro (EUR 1,692,000,000), and since the valuation was made no material changes have
occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.”
62430
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder’s Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at to twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501), represented by twelve
thousand five hundred and one (12,501) shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid up.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of the shareholders of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of Sole Shareholder of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by an French version. In case of discrepancies between the English and the
French texts, the English version shall prevail.
WHEREOF the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the latter signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour de janvier,
Par devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de Play Holdings 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, Grand-
Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), et non encore
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée le 10
Janvier 2014, en vertu d'un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de
Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
A COMPARU:
Play Holdings 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Luxembourg, dont le siège
social se situe au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, disposant d’un capital social de EUR 12.510.- pas encore
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (l’Associé Unique)
représentée par Sofia DA CHAO CONDE, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire
instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. que l’ordre du jour de cette assemblée est rédigé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société par un montant d’un euro (EUR 1) afin de porter le capital social de
son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à douze mille cinq cents et un
euro (EUR 12.501), par le biais de l’émission d'une (1) part sociale nouvelle, ayant une valeur nominale valeur d’un euro
(EUR 1,-).
2. Souscription et paiement de l’augmentation de capital social mentionnée au point 1 ci-dessus par voie d'apport en
nature.
3. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les changements adoptés au titre
du point 1 ci-dessus.
62431
L
U X E M B O U R G
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, agissant sous sa seule signature, de procéder au nom de la Société à l’inscription de
la nouvelle part sociale émise dans le registre des associés de la Société.
5. Divers.
III. L’Associé Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un euro (EUR 1) afin de porter le
capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à douze mille cinq
cent et un euros (EUR 12.501), par le biais de l’émission d'une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur nominale de un
euro (EUR 1,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération de l’augmentation du capital social
comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
En conséquence, Play Holdings 1 S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une
(1) part sociale nouvellement émise de la Société d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1) et de la libérer en totalité par
un apport (i.e. un transfert de propriété) en nature consistant en quatre-vingt-seize mille neuf cent treize (96.913) actions
qu'elle détient dans le capital social de P4 sp. z o.o., une société constituée en vertu des lois polonaises, ayant son siège
social à Varsovie, à 7 rue Taśmowa, enregistrée dans le registre des entrepreneurs du Registre de la Cour nationale et
conservée par le tribunal de district de la ville de Varsovie, XII Département Commercial de la Cour du Registre national,
sous le numéro KRS 0000217207 (P4) ayant une valeur totale d'au moins un milliard six cent quatre-vingt-douze millions
d’euros (EUR 1.,692.,000.,000) et représentant cent pour cent (100%) du capital social de P4 (les Actions). Cette con-
tribution doit être affectée comme suit:
(i) un montant d’un euro (EUR 1) au compte de capital social de la Société, et
(ii) un montant d’un milliard six cent quatre-vingt-onze millions neuf cent quatre-vingt-dixième mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf euro (EUR 1.691.999.999) au compte de prime d’émission de la Société.
L'existence et l’évaluation des Actions est attestée notamment par un certificat d'évaluation daté du 23 janvier 2014
émis par l’Associé Unique et reconnu et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat de l’Associé Unique).
Le Certificat de l’Associé Unique atteste en substance que:
1. L'Associé Unique est le propriétaire des actions.
2. Les Actions sont entièrement libérées.
3. L'Associé Unique est le seul habilité aux Actions et possède le pouvoir de disposer des Actions.
4. Les Actions sont grevées en gages financiers polonais enregistrés établis en faveur de la Bank Polska Kasa Opieki
S.A. comme agent de sûreté dans le cadre de (A) la convention datée initialement du 31 octobre 2006 et conclue entre,
entre autres, P4 en tant qu’emprunteur, les entités (y compris China Development Bank Corporation) qui y sont nommées
à titre de prêteurs et Bank Polska Kasa Opieki SA comme agent de l’établissement et comme agent de sûreté, et (B) la
convention inter créditeur datée initialement le 31 octobre 2006 et conclue entre, entre autres, P4 comme emprunteur,
Bank Polska Kasa Opieki SA comme agent de sûreté et agent du crédit et la China Development Bank Corporation, qui
a été accédé par Alior Bank S.A. (les Gages); les accords pour la mise en place des Gages prévoient les méthodes d'ap-
plication, y compris, entre autres, le droit du créancier de saisir ou de vendre les Actions Tollerton;
5. aucune des Actions ne sont grevées, entre autres, mais sans s’y limiter, d’un gage ou usufruit, et il n'existe pas de
droit d'acquérir, entre autres, mais sans s’y limiter, un gage ou usufruit sur les Actions et aucune des Actions ne sont
sujettes à saisie, à l’exception de tous ces droits établis en faveur de l’autre actionnaire de P4 qui doivent être levés ou
libérés sur ces actions étant apportés à la Société et ce à l’exception des gages, tel que défini ci-dessus;
6. il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne peut être autorisée à exiger
que l’une ou plusieurs des Actions ne lui soient transférées à l’exception des droits établis en faveur de l’autre actionnaire
de P4 qui doivent être levés ou libérés lorsque ces actions sont apportées à la Société;
7. Conformément à la loi applicable et les statuts de la Société, les actions sont librement cessibles.
8. Toutes les formalités requises au Luxembourg suite à l’apport en nature des Actions de la Société seront effectués
à la réception d'une copie certifiée conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.
9. Basé sur les principes comptables généralement reconnus, la juste valeur marchande des Actions est au moins égale
à un milliard six cent quatre-vingt-douze millions d’euros (EUR 1.692.000.000), et l’évaluation, aucun changement matériel
n'est intervenu qui aurait déprécié la contribution à la Société.
Le Certificat de l’Associé Unique, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré auprès des autorités de l’enregistrement.
62432
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la
Société, de sorte qu'il est désormais rédigé comme suit:
" 5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent et un euros (EUR 12.501), représenté par douze mille cinq cent
et une (12.501) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant sous sa seule signature, de procéder au nom de la
Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature que ce soit qui devront être supportés par la Société
en raison du présent acte sont estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. En cas de divergences entre les textes anglais et français, la
version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à l’année et jour précité.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le présent acte
original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: EAC/2014/1645. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014039670/223.
(140045338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.
Maxam Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 159.757.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014041579/10.
(140047881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Netaxel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 133.206.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 février 2014i>
1. L'Assemblée a réélu Monsieur René FALTZ, Monsieur Pierre-Antoine BARBOT et Monsieur Jean-Michel BARBOT
aux postes d'administrateurs de la société, pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui sera tenue en 2019.
2. La société Luxembourg Offshore Management Company S.A. en abrégé LOMAC S.A. a été réélue au poste de
commissaire aux comptes de la Société, pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui sera tenue en 2019.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014041629/16.
(140047997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62433
L
U X E M B O U R G
Venture 1 Global Equity (Luxembourg) SIF SICAV S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 167.477.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of February.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of the shareholders of VENTURE 1 GLOBAL
EQUITY (LUXEMBOURG) SIF SICAV S.A., a société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement spécialisé
under the form of a société anonyme, having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 167.477, incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg on 2
nd
March 2012 pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 771 of 23 March 2012 (the "Com-
pany").
The articles of incorporation of the Company have not been amended in the meantime.
The Extraordinary General Meeting was opened at 4.45 p.m., with Me Jonathan BURGER, Avocat à la Cour, with
professional address in Luxembourg, as chairman.
The President appoints as secretary Mrs Alexia UHL, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Me Sze-suen LI, Avocat, with professional address in Luxembourg.
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state:
I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the directors' report and of the auditor's report as at 31 December 2013;
2. Approval of the audited annual report as at 31 December 2013 and allocation of the results;
3. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
4. Appointment of Mr Christophe LENTSCHAT, born on 26
th
September 1972 in Thionville (France), with professional
address at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg as Liquidator of the Company;
5. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and,
6. Discharge of the directors of the Company for the accomplishment of their respective mandates.
II. That the shareholder represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of their shares
are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by
the board of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered
therewith.
The proxy of the represented shareholder, initialled "ne varietur" by the appearing party, will also remain annexed to
the present deed.
III. That it appears from the attendance list that thirty-one thousand (31,000.-) shares are present or represented at
the meeting, representing 100% of the shares of the Company.
100% of all the shares of the Company being present or represented, the meeting is validly constituted and may properly
resolve on the agenda.
IV. The shareholder being present or represented, it recognized itself as informed of the agenda of the meeting, the
meeting can be therefore held without prior notice.
Then the Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”), unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
After reading the reports, the General Meeting approves the directors' report and the auditor's report as at 31
December 2013.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting approved the audited annual report as at 31 December 2013 as follows:
Total Net Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 4,688,712
With the loss to be brought forward.
62434
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
In accordance with articles 141-151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”)
and in accordance with the law of February 13, 2007 related to specialised investment funds, as amended (the “SIF Law”),
the General Meeting decides to dissolve the Company and to start the voluntary liquidation proceedings.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the General Meeting decides to appoint Mr Christophe LENTSCHAT,
born on 26
th
September 1972 in Thionville (France), with professional address at 2, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg as liquidator of the Company (the “Liquidator”).
The General Meeting grants the Liquidator the following powers:
- The Liquidator has a mission to realise the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company,
after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator among the shareholders in pro-
portion to the shares held by them in the Company or in accordance with the terms of any future agreement to be made
between the Company and the shareholders in this respect.
- The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all
the acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested
by law. It may waive all real rights, liens, mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien
and mortgage registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
- The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company. It may,
under its own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem
fit, to one or several representatives.
- The Liquidator may bind the Company through its sole signature. The Company will also be bound in all circumstances
by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is only worded in English version.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.
Signé: A: UHL, S. LI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 06 mars 2014. LAC/2014/10504. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Référence de publication: 2014040440/87.
(140046316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
Lavica Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 106.354.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 mars 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Monsieur Michaël Zianveni
- Monsieur Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014042195/18.
(140048694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
62435
L
U X E M B O U R G
Alfa Gestion S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 16, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.744.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la société prises en date du 17 mars 2014i>
L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Nico Rollinger des ses fonctions d'administrateur de la Société
avec effet immédiat.
L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à quatre (4) et de nommer avec effet immédiat pour un
terme venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019 approuvant les comptes au 31
décembre 2018, les personnes suivantes:
- Monsieur Werner Würgler, né le 24 février 1948 à Zurich, Suisse, demeurant à Nadelstrasse 107, 8706 Meilen,
Suisse, comme administrateur avec pouvoir de signature A,
- Monsieur Pierre Metzler, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant au 69 boulevard de la Pétrusse, L-2320,
Luxembourg, comme administrateur avec pouvoir de signature A,
- Monsieur Nico Rollinger, né le 15 juillet 1953 à Luxembourg, demeurant au 2 rue Guillaume Stolz, L-8126 Bridel,
Luxembourg, comme administrateur avec pouvoir de signature B,
- Monsieur Serge Rollinger, né le 13 mai 1981 à Luxembourg, demeurant au 48 rue du X Octobre, L-7243 Bereldange,
comme administrateur avec pouvoir de signature B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014041284/23.
(140048194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Poerf Holdco No 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 158.002.
In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of March.
Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH, having its registered office located at
Kehrwieder 8, 20457 Hamburg Germany, registered in Hamburg, (Germany), under company number HRB 108068,
hereby represented by Mr Wayne Fitzgerald, employee, residing professionally at 40 Avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg,
by virtue of a proxy established under private seal on 5 March 2014.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
The appearing party declares being the sole shareholder, (the “Sole Shareholder”) of the private limited liability com-
pany (société à responsabilité limitée) existing under the name of “POERF HOLDCO No 1 S.À R.L.”, registered with the
Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B
158.002, with a share capital of EUR 141,418.-, having its registered office at 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 16 December
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 March 2011 under number C 483.
The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) have been amended for the last time pursuant to a deed of
Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 26 September 2013, published in the the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on 19 November 2013 under number 2909.
That the agenda of the Meeting is worded as follows:
<i>Agendai>
1. Waiver of the convening notice;
2. The creation and issuance of 100 (one hundred) new Class A5 shares each having a nominal value of EURO 1.- (one
Euro) and with a total Share Premium of EUR 9,900.- (nine thousand nine hundred Euro);
3. The creation and issuance of 100 (one hundred) new Class A6 shares each having a nominal value of EURO 1.- (one
Euro) and with a total Share Premium of EUR 9,900.- (nine thousand nine hundred Euro);
62436
L
U X E M B O U R G
4. Subscription and full payment of the new Class A5 shares and Class A6 shares and full payment of the Share Premium
by the Sole Shareholder by contribution in cash;
5. Decision to amend article 6.1 of the Articles, as follows
“The Company’s capital is set at EUR 141,618.- (one hundred and forty one thousand six hundred and eighteen Euro),
represented by 141,618 (one hundred and forty one thousand six hundred and eighteen) issued shares, with a nominal
value of EUR 1.- (one Euro) each, consisting of: (i) 12,900 (twelve thousand nine hundred) ordinary shares, with a nominal
value of EUR 1.- (one Euro) each, (individually, the “Ordinary Share”, and together the “Ordinary Shares”), and (ii) 128,418
(one hundred and twenty-eight thousand four hundred and eighteen) tracker redeemable shares, with a nominal value of
EUR 1.- (one Euro) each (the “Tracker Shares” or “T Shares”), distributed in the following classes of shares: a) 103,626
(one hundred and three thousand six hundred and twenty-six) T Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each
(the “Class T1 Shares”) b) 24,792 (twenty-four thousand seven hundred and ninety-two) T shares with a nominal value
of EUR 1.- (one Euro) each (the “Class T2 Shares”) and (iii) 300 (three hundred Class A shares) distributed in the following
classes of shares: (i) 100 (one hundred) Class A4 shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each the (the “Class
A4 shares”) and (ii) 100 (one hundred) Class A5 shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each the (the “Class
A5 shares”) and (iii) 100 (one hundred) Class A6 shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each the (the “Class
A6 shares”);
6. Approve, sign and lodge for and on behalf of the Sole Shareholder any forms or documents required for the creation
and issuance of the Class A5 shares and allocation of the Share Premium;
7. Approve, sign and lodge for and on behalf of the Sole Shareholder any forms or documents required for the creation
and issuance of the Class A6 shares and allocation of the Share Premium;
8. Approve, execute and deliver such documents and do such acts for and on behalf of the Sole Shareholder as the
Attorney deems necessary to give effect to the transactions contemplated in this power of attorney.
9. Miscellaneous
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the creation and issuance of 100 (one hundred) new Class A5 shares each
having a nominal value of EURO 1.- (one Euro) and with a total Share Premium of EUR 9,900.- (nine thousand nine hundred
Euro);
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the creation and issuance of 100 (one thousand) new Class A6 shares each
having a nominal value of EURO 1.- (one Euro) and with a total Share Premium EUR 9,900.- (nine thousand nine hundred
Euro);
<i>Fourth resolutioni>
Thereupon appeared the Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, declares to subscribe for 100 (one
hundred) Class A5 Shares and 100 (one hundred) Class A6 shares each with a par value of one Euro (EUR 1.-), to be
issued and to make payment in full for such New Shares together with a Share Premium of EUR 19,800.- (nineteen
thousand eight hundred Euro); by a contribution in cash of EUR 20,000.- (twenty thousand Euros.-), and that the Company
has from now at its disposal the total amount of EUR 20,000.- (twenty thousand Euros), evidence of which is given by a
bank certificate to the undersigned notary who expressly records this statement.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is amended
so as to read as follows:
“ 6.1. Share Capital. The Company’s capital is set at EUR 141,618.- (one hundred and forty one thousand six hundred
and eighteen Euro), represented by 141,618 (one hundred and forty one thousand one hundred and eighteen) issued
shares, with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, consisting of: (i) 12,900 (twelve thousand nine hundred) ordinary
shares, with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, (individually, the “Ordinary Share”, and together the “Ordinary
Shares”), and (ii) 128,418 (one hundred and twenty-eight thousand four hundred and eighteen) tracker redeemable shares,
with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each (the “Tracker Shares” or “T Shares”), distributed in the following classes
of shares: a) 103,626 (one hundred and three thousand six hundred and twenty-six) T Shares with a nominal value of
EUR 1.- (one Euro) each (the “Class T1 Shares”) b) 24,792 (twenty-four thousand seven hundred and ninety-two) T
shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “Class T2 Shares”) and (iii) 300 (three hundred Class A shares)
62437
L
U X E M B O U R G
distributed in the following classes of shares: (i) 100 (one hundred) Class A4 shares with a nominal value of EUR 1.- (one
Euro) each the (the “Class A4 shares”) and (ii) 100 (one hundred) Class A5 shares with a nominal value of EUR 1.- (one
Euro) each the (the “Class A5 shares”) (iii) 100 (one hundred) Class A6 shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro)
each the (the “Class A6 shares”).”
<i>Sixth resolutioni>
Any forms or documents required for the for the creation and issuance of the Class A5 shares and allocation of the
Share Premium are approved, signed and lodged for and on behalf of the Sole Shareholder.
<i>Seventh resolutioni>
Any forms or documents required for the for the creation and issuance of the Class A6 shares and allocation of the
Share Premium are approved, signed and lodged for and on behalf of the Sole Shareholder.
<i>Eighth resolutioni>
To give effect to the transactions contemplated in this power of attorney, the Attorney, as far as necessary, is instructed
to approve, execute and deliver such documents and do such acts for and on behalf of the Sole Shareholder.
<i>Declarationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version shall be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day and hour named at the beginning of this
document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, said mandatory signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung
Im Jahr zweitausendvierzehn, den siebten März.
Vor mir, Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN
IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH, mit Gesellschaftssitz in Kehrwieder 8,
20457 Hamburg, (Deutschland), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Hamburg, unter der Nummer HRB
108068,
hier vertreten durch Herrn Wayne Fitzgerald, Angestellter, mit Geschäftsadresse in L-2163 Luxemburg, 40, Avenue
Monterey,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 5. März 2014.
Die vorgenannte Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten sowie dem unterzeichnenden Notar „ne varietur" unter-
zeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde für die Einreichung bei den Registrierbehörden beigefügt.
Die erschienene Partei, die wie oben erwähnt vertreten wird, hat den unterzeichnenden Notar gebeten folgendes zu
beurkunden:
Die erschienene Partei ist der einzige Anteilinhaber der Gesellschaft "POERF HOLDCO No 1 S.À R.L." eingetragen
im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 158.002, mit einem Kapital von EUR 141.418,-, und mit Sitz in 40,
Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, gegründet durch Urkunde von Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz
in Luxemburg, vom 16. Dezember 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 483
vom 15. März 2011.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert durch Urkunden von Maître Martine SCHAEFFER, vorbenannt, am 26. Sep-
tember 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2909 vom 19. November 2013.
Die Tagesordnung lautet folgendermassen:
<i>Tagesordnungi>
1. Verzicht auf eine Einberufung.
2. Schaffung und Ausgabe von 100 (einhundert) neuen A5 Anteilen mit einem Nennwert von je einem (1,-) Euro und
mit einer totalen Ausgabeprämie von EUR 9.900,- (neuntausendneunhundert Euro),
3. Schaffung und Ausgabe von 100 (einhundert) neuen A6 Anteilen mit einem Nennwert von je einem (1,-) Euro und
mit einer totalen Ausgabeprämie von EUR 9.900,- (neuntausendneunhundert Euro),
4. Zeichnung und totale Einzahlung der neuen A5 und A6 Anteile und volle Einzahlung der Prämie durch den einzigen
Anteilinhaber durch eine Bareinlage.
62438
L
U X E M B O U R G
5. Abänderung von Artikel 6.1 der Satzung.
„Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf 141.618,- Euro (einhunderteinundvierzigtausend sechshundertachtzehn Eu-
ro), aufgeteilt in 141.618 (einhunderteinundvierzigtausend sechshundertachtzehn) ausgegebene Geschäftsanteile im
Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro); diese Geschäftsanteile setzen sich zusammen aus (i) 12.900 (zwölftausendneun-
hundert) gewöhnlichen Anteilen im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (einzeln jeweils „Gewöhnlicher Anteil“ und
zusammen „Gewöhnliche Anteile“ genannt) sowie (ii) 128.418 (einhundertachtundzwanzigtausend vierhundertachtzehn)
rückkaufbare Trackeranteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Trackeranteile“ oder „T-Anteile“ genannt),
die sich aus folgenden Klassen zusammensetzen: a) 103.626 (einhundertdreitausend sechshundertsechsundzwanzig) T-
Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse T1“) und b) 24.792 (vierundzwanzigtausend
siebenhundert zweiundneunzig) T-Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse T2“ genannt)
und (iii) 300 ( drei hunderd A Anteile) eingeteilt in folgende Klassen von Anteilen (i) 100 (einhundert) A4- Anteile im
Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse A4“ genannt) und (ii) 100 (einhundert) A5-Anteile im
Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse A5“ genannt) und (iii) 100 (einhundert) A6-Anteile im
Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse A6“ genannt)
6. Genehmigung, Zeichnung und Zuteilung für den einzigen Anteilinhaber von Dokumenten welche nötig sind für die
Schaffung und Ausgabe der Anteile der Klasse A5 und die Zuteilung der Prämie.
7. Genehmigung, Zeichnung und Zuteilung für den einzigen Anteilinhaber von Dokumenten welche nötig sind für die
Schaffung und Ausgabe der Anteile der Klasse A6 und die Zuteilung der Prämie.
8. Genehmigung, Ausführung und Ubergabe der Dokumente und Erstellung von Urkunden für den einzigen Anteilin-
haber sowie der Bevollmächtigte es für nötig findet um den Beschlüssen Wirkung zu verleihen.
9. Verschiedenes
Der einzige Gesellschafter fasst alsdann folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Da das gesamte Kapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, verzichtet der einzige Anteilinhaber auf eine
Einberufung, der einzige Anteilinhaber betrachtet sich als gültig einberufen und erklärt dass er vollkommen über die
Tagesordnung informiert ist welche ihm im Voraus mitgeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Schaffung und Ausgabe von 100 (einhundert) neuen A5 Anteilen mit einem Nennwert von je einem (1,-) Euro und
mit einer totalen Ausgabeprämie von EUR 9.900,- (neuntausendneunhundert Euro), wird beschlossen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Schaffung und Ausgabe von 100 (einhundert) neuen A6 Anteilen mit einem Nennwert von je einem (1,-) Euro und
mit einer totalen Ausgabeprämie von EUR 9.900,- (neuntausendneunhundert Euro), wird beschlossen.
<i>Vierter Beschlussi>
Daraufhin erschien der einzige Anteilinhaber, vertreten wie vorgenannt, und erklärte 100 (einhundert) neue A5 Anteile
und 100 (einhundert) neue A6 Anteile mit einem Nennwert von je einem (1,-) Euro zu zeichnen und diese neue Anteile
komplett einzuzahlen mit einer Ausgabeprämie von EUR 19.800,- (neunzehntausendachthundert Euro), durch eine Ein-
zahlung in bar von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro), sodass die Gesellschaft von nun an den Betrag von EUR 20.000,-
(zwanzigtausend Euro) zur Verfügung hat wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde durch ein
Bankzertifikat welches dieser ausdrücklich bestätigt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Infolge wird Artikel 6.1 folgenden Wortlaut haben.
“ 6.1. Gesellschaftskapital. Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf 141.618,- Euro (einhunderteinundvierzigtausend
sechshundertachtzehn Euro), aufgeteilt in 141.618 (einhunderteinundvierzigtausend sechshundertachtzehn) ausgegebene
Geschäftsanteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro); diese Geschäftsanteile setzen sich zusammen aus (i) 12.900
(zwölftausendneunhundert) gewöhnlichen Anteilen im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (einzeln jeweils „Ge-
wöhnlicher Anteil“ und zusammen „Gewöhnliche Anteile“ genannt) sowie (ii) 128.418 (einhundertachtundzwanzigtausend
vierhundertachtzehn) rückkaufbare Trackeranteile im Nennwert von je 1 Euro (einem Euro) (die „Trackeranteile“ oder
„T-Anteile“ genannt), die sich aus folgenden Klassen zusammensetzen: a) 103.626 (einhundertdreitausend sechshundert-
sechsundzwanzig) T-Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse T1“) und b) 24.792
(vierundzwanzigtausend siebenhundert zweiundneunzig) T-Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „An-
teile der Klasse T2“ genannt) und (iii) 300 (drei hunderd A Anteile) eingeteilt in folgende Klassen von Anteilen (i) 100
(einhundert) A4- Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse A4“ genannt) und (ii) 100
(einhundert) A5-Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse A5“ genannt) und (iii) 100
(einhundert) A6-Anteile im Nennwert von je 1,- Euro (einem Euro) (die „Anteile der Klasse A6“ genannt).“
62439
L
U X E M B O U R G
<i>Sechster Beschlussi>
Alle Dokumente welche nötig sind für den die Schaffung und Ausgabe der Anteile der Klasse A5 und die Zuteilung der
Prämie, werden genehmigt, unterschrieben und zugeteilt an den einzigen Anteilinhaber.
<i>Siebter Beschlussi>
Alle Dokumente welche nötig sind für den die Schaffung und Ausgabe der Anteile der Klasse A6 und die Zuteilung der
Prämie, werden genehmigt, unterschrieben und zugeteilt an den einzigen Anteilinhaber.
<i>Achter Beschlussi>
Um den Beschlüssen welche in der Vollmacht aufgeführt sind Wirkung zu verleihen, wird der Bevollmächtigte beauf-
tragt, soweit wie nötig, Dokumente und Urkunden zu genehmigen, auszuführen und zu auszuhändigen an den einzigen
Anteilinhaber.
<i>Kosten:i>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf
ungefähr eintausendEuro (EUR 1.000,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde, auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text ist der englischeText maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Fitzgerald, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 mars 2014. Relation: LAC/2014/11132. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 14. März 2014.
Référence de publication: 2014039692/222.
(140045476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.
Repass Express S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 168.703.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014041709/10.
(140048272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
National General Life Insurance Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 179.534.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014041619/14.
(140048089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62440
L
U X E M B O U R G
Alma Santa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 157.299.
By resolution of the shareholders of the Company dated March 5
th
2014:
1. The resignation of the managers Mr Ely Michel Ruimy and Mr Grégory Noyen has been acknowledged.
2. It has been resolved to appoint Ensof Services Sàrl, a private limited liability company under Luxembourg Law, having
its registered office at 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Companies Register of Luxembourg under number B 184 865 as sole manager of the company with immediate effect and
for an unlimited period of time.
This resolution has been taken in accordance with article 12 of the articles of incorporation of the Company.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
Par résolution des associés de la Société en date du 5 Mars 2014:
1. Il a été constaté la démission des gérants Mr Ely Michel Ruimy et Mr Grégory Noyen
2. Il a été résolu de nommer Ensof Services Sàrl, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont le siège social est situé 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duché de Luxembourg),
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le no B 184 865, gérant unique de la Société
avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Cette résolution a été prise en accord avec l'article 12 des statuts de la Société.
Référence de publication: 2014041287/23.
(140047839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Infigen Energy Vest Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 120.241.
In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of February.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“Infigen Energy Germany Holdings S.à r.l.”, a private limited liability company with registered office at 6, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 145788,
holder of eight hundred (800) shares,
hereby represented by Ms Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal on February 6
th
, 2014.
Such proxy after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Infigen Energy Vest
Holdings S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maitre Joseph ELVINGER, notary
residing in Luxembourg, on 21
st
September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 2198 on 24
th
November 2006, modified several times and the last time by a deed of the undersigned notary
on 16
th
January 2014, in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under the number B 120.241 (the “Company”).
The Sole Shareholder, represented as aforesaid and representing the share capital, has requested the undersigned
notary to act the following resolutions contained into the agenda:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation.
2. Appointment of one Liquidator and determination of his powers.
3. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder unanimously decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company in liquidation,
effective on the date of this meeting.
62441
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder appoints Mr. Mark HATHERLY, born on November 13
th
1965 in Auckland, New Zealand,
professionally residing at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to assume the role of liquidator of the Company (the
“Liquidator”).
The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on
commercial companies of 10 August 1915 (the "Law"). He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the
Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.
The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of
his powers which he will define and for the duration fixed by him.
The shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder of the Company, in accordance with article
148 of the Law.
When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in
accordance with article 151 of the Law.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
All the expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le treize février.
Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
«Infigen Energy Germany Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 145.788, propriétaire de huit cents (800) parts sociales,
ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 06 février 2014.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire agissant au nom de la partie comparante
et par le notaire instrumentant, demeurent annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
La partie comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique associée («l’Associée Unique») de «Infigen
Energy Vest Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 21 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2198 en date du 24
novembre 2006, modifié plusieurs fois, et la dernière temps par suivante acte devant le même notaire en date du 16
janvier 2014, dans processus de publication au Mémorial C, Recueil des Société et Associations,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 120.241 («la Société»).
L’Associée Unique, représentée comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire ins-
trumentant d’acter les résolutions suivantes contenues dans l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
2. Nomination d’un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités
3. Divers
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide de dissoudre et de mettre la société en liquidation, avec effet à ce jour.
62442
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associée Unique nomme Monsieur Mark HATHERLY, né le 13 novembre 1965 à Auckland (Nouvelle Zélande),
demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, d’assumer le rôle du liquidateur de la Société
(le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux associés de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.
Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur prépare un rapport à l’assemblée générale conformément à l’article
151 de la Loi.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cents euros
(900,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19.02.2014. Relation: LAC/2014/7879. Reçu 12.-€ (douze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 04.03.2014.
Référence de publication: 2014040153/112.
(140046083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
Global Trade Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 30, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 104.258.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014043324/10.
(140049876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.
Laubach Ferrailles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9283 Diekirch, 5, Promenade de la Sûre.
R.C.S. Luxembourg B 91.770.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014042194/14.
(140049010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
62443
L
U X E M B O U R G
Larma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 141.662.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014042193/9.
(140048997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.
IFN, L'Immobiliàire Financiaire Nautique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 185.347.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le douze mars.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Maria Rosaria SANTILLO, consultante, née le 23 septembre 1959 à Naples (Italie), demeurant au 13 Bakunin
80126 Naples (Italie).
Laquelle partie comparante a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a
requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
. - Objet - Durée - Dénomination - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").
Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura aussi pour objet l’acquisition, la construction, l’exploitation et la restructuration de l’immobilier à usage
privé et de la construction, la transformation et la restructuration de propriétés à utilité hôtelière; acquérir, déployer et
gérer des services pour la construction navale, de plates-formes et / ou des chantiers de construction, la location, l’en-
tretien et / ou d'entretien pour la navigation commerciale que celle du plaisir, tous avec leurs propres ressources ou de
recourir à des prêts et / ou des lignes de crédit.
La Société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination «L’IMMOBILIÀIRE FINANCIAIRE NAUTIQUE S.à r.l.», en abrégé «IFN».
Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur d'une commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
62444
L
U X E M B O U R G
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision d'associé(s) de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent (100%) du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital émis et/ou autorisé peut être modifié à tout moment
par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article
14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un (1) seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d'un des associés.
Titre III. Administration
Art. 12. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance et sont nommés "gérants A" et "gérants B". Le(s) gérant(s) ne doit/vent pas obligatoirement être
associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont révocable(s) ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article 12 aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un (1) gérant A et d'un (1) gérant B, tous les deux membres du conseil de gérance.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un (1) ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rému-
nération (s'il en est) de ces mandataires, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance, réuni au Luxembourg, seront adoptées, à la majorité
des gérants présents ou représentés comprenant au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B.
Si un gérant est dans l’impossibilité d'assister à une réunion du conseil de gérance, il pourra donner une procuration
écrite à un autre gérant appartenant à la même classe de gérants que lui, qui sera physiquement présent à la réunion, afin,
pour ce dernier, appartenant à la même classe de gérants, de voter en son nom à la réunion du Conseil de gérance.
Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 14. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance
seront prises par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique
seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.
S'il y a plus d'un (1), mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée
générale ou par consultation écrite à l’initiative du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.
Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié
(50%) du capital social.
L'assemblée générale annuelle des associés se tiendront au Luxembourg le dernier mercredi de juin de chaque année.
La représentation au moyen de procuration est admise.
62445
L
U X E M B O U R G
Titre V. - Exercice social - Comptes - Profits - Distributions
Art. 15. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à
l’exception de la première année qui débutera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre
2014.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, les comptes de la Société sont établis et le gérant
unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital nominal de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l’associé unique ou, le cas échéant, aux associés en proportion avec
sa/leur participation dans le capital de la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. la décision de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes sera prise par le gérant unique ou, le cas échéant,
par le conseil de gérance;
2. des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance; et
3. ces comptes intérimaires, la date desquelles ne doit pas être antérieure à trois (3) semaines de la décision du gérant
unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance y relative, font apparaître des bénéfices distribuables suffisants (y compris
les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire).
Titre VI. - Liquidation - Lois applicables
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un (1) ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, nommés par le(s) associé(s) qui déterminera(ont) leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Souscriptioni>
Toutes les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ainsi créées ont été souscrites par Madame Maria Rosaria
SANTILLO, prénommée,
laquelle a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que
la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le constate.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société en raison de sa constitution à environ mille Euros (1.000,-EUR).
<i>Décisions de l’associée uniquei>
Ensuite la comparante devenue l’associée unique et représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre de gérants étant fixé à deux (2), la Société sera par conséquent administrée par les gérants suivants:
Monsieur DIABATE Hassane, né le 04 avril 1971 à Treichville (Côte d’ivoire), demeurant professionnellement à 4
Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, en tant que gérant A.
Monsieur BETTIOL Paolo, né le 22 mars 1981 à Montebelluna (TV) (Italie), demeurant professionnellement à 4 Grand-
Rue, L-1660 Luxembourg, en tant que gérant B.
2.- L'adresse de la Société est fixée au 4, Grand-Rue L-1660 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ladite
comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.R. SANTILLO, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mars 2014. Relation: LAC/2014/11714. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 19 mars 2014.
Référence de publication: 2014040204/149.
(140046546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.
62446
L
U X E M B O U R G
NREP Transactions Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 113.112.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014041636/14.
(140047684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
NREP Transactions Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 115.472.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014041637/14.
(140047959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Nouvelle TEC-Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 39.027.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts sociales du 2 janvier 2014
que Monsieur Jean-Pierre Kutzner, retraité, né à Luxembourg, le 25/10/1948 demeurant à D-54669 Bollendorf-17
Burgstrasse, cède et transporte les deux cent cinquante (250) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Monsieur
Jacques Ryon demeurant à B-1730 Asse, Heedstraat, 58 et ce acceptant.
Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €.
que Monsieur Georges Moyen, retraité, né à Esch/AIzette, le 05/06/1949 demeurant à L-4001 Esch/AIzette -148, rue
du LUXEMBOURG, cède et transporte les trois cent soixante-quinze (375) parts sociales qu'il détient dans la prédite
société à Monsieur Jacques Ryon demeurant à B-1730 Asse, Heedstraat, 58 et ce acceptant
Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €.
que ACCORD SA HOLDING 4, rue Henri Schnadt, cède et transporte six cent vingt-cinq (625) parts sociales qu'elle
détient dans la prédite société à Monsieur Jacques Ryon demeurant à B-1730 Asse, Heedstraat, 58 et ce acceptant.
Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €.
qu'à la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:
Monsieur Jacques Ryon, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales
Fait à Kayl, le 2 janvier 2014.
NOUVELLE TEC-INTER S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2014041632/26.
(140047964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
62447
L
U X E M B O U R G
Nano Bubble Technologies (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.336.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>POUR NANO BUBBLE TECHNOLOGIES (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2014041627/11.
(140047884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
P Ro Service & Consult, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 10, rue Jean Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 170.782.
Hr. Robert Projic ist nicht mehr Anteilseigner der Pro Service & Consult SARL
ARRUBA SARL, 97, rue du Vin, L - 5445 Schengen übernimmt zu 100% die Anteile der PRO SERVICE & CONSULT
SARL
Hr. Robert Projic, 13 Marie Curie, 8231 Mamer, Luxembourg wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer ab-
bestellt.
Hr. Wilfried Scherer, wohnhaft Eichenweg 20 in 66459 Kirkel, Deutschland wird mit sofortiger Wirkung zum Ge-
schäftsführer bestellt.
Luxembourg, den 24.02.2014.
Rober Projic.
Référence de publication: 2014041865/15.
(140047337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.
GES Holding I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle Vue.
R.C.S. Luxembourg B 181.380.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 03 Mars 2014 que:
- Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
au 3, Rue Belle Vue L - 1227 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2014041474/13.
(140048216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Geslux S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 155.007.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 03 Mars 2014 que:
- Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
au 8, Avenue de la Faïencerie L - 1510 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2014041475/13.
(140048036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
62448
AFMH Architecture S.à r.l.
AI Chem (Luxembourg) Topco S.à r.l.
Alfa Gestion S.A.
Alma Santa S.à r.l.
Alov Holding Sàrl
Atmosphere Group (Lux) S.à r.l.
B&B Holding S.A.
Belfond (Luxembourg) Sàrl
Borgo Luxembourg S.à r.l.
Compagnie des Artisans Luxembourg S.à r.l.
Evia Finance S.à r.l.
Falcon Investor S.à r.l.
Fatilu S.à r.l.
Fita Investments S.à r.l.
FR Romania S.à r.l.
GES Holding I S.A.
Geslux S.A.
Ginger S.à r.l.
Global Trade Sàrl
Infigen Energy Vest Holdings S.à r.l.
International Business Operations
Larma S.A.
Laubach Ferrailles S.A.
Lavica Development S.A.
L'Immobiliàire Financiaire Nautique S.à r.l.
Maxam Holdings S.à r.l.
Medusa Luxembourg S.à r.l.
Middle East Internet (GP) S.à r.l.
Minvest & SP S.à r.l.
Motor Reinsurance Company
Nano Bubble Technologies (Luxembourg) S.A.
National General Life Insurance Europe S.A.
Netaxel S.A.
Norama Fund
Nouvelle TEC-Inter S.à r.l.
NREP Transactions Holding 1 S.à r.l.
NREP Transactions Holding 2 S.à r.l.
Pimalo-Invest
Play Holdings 2 S.à r.l.
Poerf Holdco No 1 S.à r.l.
P Ro Service & Consult
Repass Express S.à r.l.
TRG Blue Rock HBM Holdings S.à r.l.
Venture 1 Global Equity (Luxembourg) SIF SICAV S.A.
West Africa S.A.