logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1244

15 mai 2014

SOMMAIRE

Agate Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59711

Alcogro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59710

Arkum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59702

ASAP-Lipamex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59683

BE Sophia Lux II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59709

Castmetal FWI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59702

Catalyst Buyout I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

59709

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59711

C.C. Investment Group S.A.  . . . . . . . . . . . .

59709

Cooper Offshore Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

59692

CVC European Credit Opportunities (No.

8) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59694

Domus Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59693

Eaton Holding II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

59693

Eat's Time S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59709

Euphrasie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59684

Fial Industrial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59694

FR Plasco Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

59666

Gedeam Tourism S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59702

GMS Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59712

Green Farm S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59695

Guenebaut Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59712

HECF Domkaskaden S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

59692

HECF Marienstrasse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

59693

Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59703

INNCONA S.àr.l. & Cie. Quatre cent tren-

te-sixième (436.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . .

59712

Investdeutschland S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .

59684

IVG Andel 17 Immobilien GmbH  . . . . . . . .

59686

LRP Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

59684

Maguro I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59687

Mashta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59686

Max S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59689

Meridiam MC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59685

Mikrolux 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59689

Mountwise Finco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59686

Nationwide Management Services S.A.  . .

59692

Newton Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59687

OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.  . . . .

59694

Real Web S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59696

RGL16 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59695

Rhô GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59691

R-Solution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59695

Saputo Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .

59697

Sawyer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59685

SCD Property Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

59684

ScienceInvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59703

SHCO 62 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59697

Slovak Ventures Fund S.C.A., SICAR  . . . .

59666

Truss Managing Partner S.à r.l.  . . . . . . . . . .

59685

59665

L

U X E M B O U R G

FR Plasco Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2014.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014039442/12.
(140045654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

Slovak Ventures Fund S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 185.175.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of February.
Before Me Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

Neulogy Ventures S. à r.l., a company incorporated in Luxembourg as a “société à responsabilité limitée”, with regis-

tered office at 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, pending registration at the Luxembourg Trade and Company
Register,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 5 February 2014, and

Danube Ventures s.r.o., a company incorporated under the laws of Slovakia, with registered office at Bratislava (Slo-

vakia), Dunajska 25, 811 08,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 29 January 2014, and

Neulogy a.s., a company incorporated under the laws of Slovakia, with registered office at Bratislava (Slovakia), Pribi-

nova 25, 811 09,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 29 January 2014, and

Neulogy Ventures a.s., a company incorporated under the laws of Slovakia, with registered office at Bratislava (Slovakia),

Mlynská dolina, Ilkovièova 2, 841 04,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 29 January 2014, and

Ivan Stefunko, having his professional address at, Grösslingova 46, 811 09 Bratislava, (Slovakia), with Slovakian passport

number BA3001517,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 29 January 2014, and

Michaela Jacova, having her professional address at Mlynská dolina, Ilkovièova 2, 841 04 Bratislava (Slovakia), with

Slovakian ID number 826217/9244,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 29 January 2014, and

Jaroslav  Luptak,  having  his  professional  address  at  Mlynská  dolina,  Ilkovièova  2,  841  04  Bratislava  (Slovakia),  with

Slovakian ID number EB952376,

here represented by Evelyn Maher, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a

proxy given on 29 January 2014.

The said proxies, after having been initialled and signed by the representatives of the appearing parties and the un-

dersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

59666

L

U X E M B O U R G

Such appearing parties have requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of an

investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque) under the form of a corporate partnership
limited by shares (société en commandite par actions) which they declare to establish as follows:

<i>Definitions

“1915 Law” means the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
“Administrative Agent” means the entity appointed by the General Partner to carry out the central administrative

functions relating to the Company as required by Luxembourg law.

“Advisory Board” has the meaning specified in article 13, paragraph 4.
“Affiliate” or “Affiliated” means, with respect to a person, any person directly or indirectly Controlling, Controlled

by, or under common Control with such person, (including in relation to a body corporate, any subsidiary or holding
company thereof and any subsidiary of any such holding company).

“Articles of Incorporation” means these articles of incorporation of the Company, as amended from time to time.
“Auditor” means the independent auditor appointed by the General Meeting of the Company.
“Bank Business Day” means each calendar day (except for Saturdays, Sundays and national holidays in Luxembourg)

on which banks are usually open in Luxembourg to conduct business during the whole day.

“Capital Calls” has the meaning specified in article 7, paragraph 1.
“Cause Event” has the meaning specified in article 18.
“Change of Control Event” means a change of Control of either the General Partner or the Investment Advisor.
“Class” means each class of Shares issued by the Company in accordance with these Articles of Incorporation and the

PPM.

“Closing” has, in respect of a Compartment, the meaning specified in the relevant Schedule of the PPM.
“Company” means Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, a Luxembourg investment company in risk capital, incorporated

as a société en commandite par actions pursuant to the SICAR Law.

“Company Documents” means these Articles of Incorporation, the PPM, the Investment Advisory Agreement, each

Subscription Agreement, each Side Letter or any other contractual agreement with, or in respect of, the Company.

“Compartment(s)” means each segregated pool of assets of the Company established as further described in the PPM,

from time to time and in compliance with the SICAR Law.

“Compartment Shareholders Meeting” means the general meeting of the Shareholders of the relevant Compartment.
“Contributed Capital” means the aggregate amount of an Investor's Subscription Commitment drawn down.
“Control” (including with correlative meanings, the term “controlling” and “controlled”) has the meaning specified in

the PPM.

“CSSF” means the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the authority responsible for prudential super-

vision of the financial sector in the Grand Duchy of Luxembourg.

“CSSF Circular 06/241” means the CSSF Circular 06/241 on the concept of risk capital under the law of 15 June 2004

relating to the investment company in risk capital.

“Custodian” means the bank acting as the Company's custodian.
“Default Interest” has the meaning specified in article 7, paragraph 2.
“Default Price” has the meaning specified in article 7, A (i).
“Defaulted Shares” has the meaning specified in article 7, paragraph 3.
“Defaulting Date” has the meaning specified in article 7, paragraph 2.
“Defaulting Shareholder” has the meaning specified in article 7, paragraph 2.
“Draw Down Notice” has the meaning specified in article 7, paragraph 1.
“Due Date” has the meaning specified in article 7, paragraph 2.
“Eligible Investor(s)” means any person and/or entity qualifying as a well-informed investor in accordance with the

provisions of the SICAR Law and meeting the conditions set out in the PPM and of these Articles of Incorporation.

“Euribor” means the European interbank market rate for the three (3) month Euro deposits as quoted by the Financial

Times during the period in question or, if the Financial Times is not published or does not quote a rate, as quoted by a
leading bank selected by the General Partner.

“First Closing” has, in respect of a Compartment, the meaning specified in the relevant Schedule of the PPM.
“For Cause Removal” has the meaning specified in article 18.
“For Cause Removal Decision” has the meaning specified in article 18.
“General Meeting of the Company” means the general meeting of the Shareholders of the Company.
“General Partner” means the holder of the Management Share(s), for the purposes hereof being Neulogy Ventures S.

à r.l., incorporated in Luxembourg on 5 February 2014, as a “société à responsabilité limitée”, with registered office at
11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

59667

L

U X E M B O U R G

“Indemnified Person” means the General Partner, the Investment Advisor and their officers, employees, partners,

members, successors or assignees and each member of an Advisory Board, each time in respect only of their respective
roles or functions for or in relation to the Company or a Compartment under the Company Documents.

“Investment Advisor” has the meaning specified in article 13, paragraph 4.
“Investment Advisory Agreement” means the advisory agreement entered into by the Company and the General

Partner with the Investment Advisor.

“Investment Committee” has the meaning specified in article 13, paragraph 4.
“Investor” means any Eligible Investor having executed a Subscription Agreement.
"JHF" or "JEREMIE Holding Fund" means the JEREMIE Holding Fund for Slovakia, the holding fund prescribed in the

Framework Agreement entered into between EIF and the Slovak Republic on 23 December 2008, and subsequently
amended on 28 April 2010 and on 12 January 2011. Any reference to JHF or JEREMIE Holding Fund in the Company
Documents is to the JEREMIE Holding Fund for Slovakia making its Subscription Commitment to a Compartment through
Slovenský záruèný a rozvojový fond s.r.o. (hereinafter “SZRF”), represented by the EIF or other appointed successor
entity designated by the Slovak Republic at the termination of the Framework Agreement.

“Key Person/Key Persons” means any person designated as such by the General Partner as further described in the

relevant Schedule of the PPM.

“Limited Shareholder” means a registered holder of Ordinary Share(s) or Participating Shares, whose liability, vis-à-

vis the Company and any third party for any Company's undertakings is limited to the amount of her/his/its Subscription
Commitment pursuant to the relevant Subscription Agreement.

“Luxembourg GAAP” means Luxembourg generally accepted accounting principles.
“Management Fee” means, in respect of each Compartment the fee payable by the Company to the General Partner

as consideration for managing the affairs of such Compartment. The Management Fee for each Compartment is described
in the relevant Schedule.

“Management Share(s)” has the meaning given to such term in Article 5.4.
"National Authority" means an entity owned and controlled by the Slovak Republic.
“Net Asset Value” means the net asset value of each Compartment of the Company as determined in accordance with

these Articles of Incorporation and the PPM, from time to time.

“Non-Defaulting Shareholder” shall have the meaning specified in Article 7 A (ii) (a).
“Offering Period” means the period during which - with respect to the creation of a Compartment - Investors may

commit to subscribe for Shares related to that Compartment which are offered for subscription at the subscription price
in accordance with the relevant Schedule of the PPM.

“Ordinary Share(s)” has the meaning given to such term in Article 5.4.
“Participating Shares” has the meaning given to such term in Article 5.4.
“Portfolio Investment(s)” means any asset in which the Company has made an investment in accordance with the

provisions of the PPM.

“PPM” or “Private Placement Memorandum” means the legal document (including any relevant schedule thereto)

drawn up by the Company in order to provide potential investors with material information about the Company and its
securities offered for subscription, as amended from time to time.

“Preferred Ordinary Shares” shall have the meaning specified in article 18.
“Preferred Return” shall have the meaning specified in article 5.4.
“Redemption Notice” has the meaning given to such term in article 7 B (i) (a).
“Registrar Agent” means the entity designated by the General Partner as registrar agent for the Company.
"Related Entity" means any fund, collective investment vehicle, managed account or any other client or person the

assets of which are managed or advised by any of the Related Persons.

"Related Persons" means the General Partner, the Investment Advisor, the Key Persons and each of their respective

Affiliates, directors, managers, officers, employees and executives and family members as well as past and present inde-
pendent Investment Committee members.

“Schedule(s)” means each annex to the PPM assessing, describing and specifying the investment policy, features, terms

and conditions of a Compartment.

“Share(s)” means the Management Share(s), the Ordinary Shares, the Preferred Ordinary Shares and the Participating

Shares.

“Share Register” means the register of Shareholders which shall be kept by the General Partner or by the Registrar

Agent.

“Shareholder(s)” means any registered holder(s) of Shares.
“Shareholders Ordinary Resolution” means a decision of the General Meeting of the Company taken with the votes

of Shareholders (other than Defaulting Shareholders, Related Entities and Related Persons) holding in aggregate not less
than fifty percent (50%) of total Ordinary Shares provided that, in respect of each Compartment, such decision is taken

59668

L

U X E M B O U R G

with the votes of Shareholders (other than Defaulting Shareholders Related Entities, and Related Persons) holding in such
Compartment in aggregate not less than fifty percent (50%) of Ordinary Shares outstanding in that Compartment.

“Shareholders Special Resolution” means a decision of the General Meeting of the Company taken with the votes of

Shareholders (other than Defaulting Shareholders, Related Entities and Related Persons) holding in aggregate not less
than seventy-five percent (75%) of total Ordinary Shares provided that, in respect of each Compartment, such decision
is taken with the positive vote of Shareholders (other than Defaulting Shareholders, Related Entities and Related Persons)
holding in such Compartment in aggregate not less than seventy-five percent (75%) of Ordinary Shares outstanding in
that Compartment.

“SICAR” means an investment company in risk capital, incorporated in accordance with the SICAR law.
“SICAR Law” means the Luxembourg Law of 15 June 2004 relating to investment companies in risk capital, as amended

from time to time.

"Side Letter" has the meaning specified in the PPM.
“Special Return” means the return to holders of Participating Shares after payment of the Preferred Return to holders

of Ordinary Shares as more particularly described in the relevant Schedule.

“Sub-Class” means a sub-class of Ordinary Shares.
“Subscription Agreement” means the agreement executed by an Eligible Investor containing all the provisions according

to which such Eligible Investor undertakes to perform its Subscription Commitment pursuant to the terms and conditions
set forth in the PPM.

“Subscription Commitment” means the commitment of an Eligible Investor to subscribe for Shares in a Compartment

and to pay them in accordance with the terms and conditions set forth in the Company Documents and the relevant
Subscription Agreement executed by such Eligible Investor.

“Transfer of Shares” means any sale, assignment, transfer, exchange, contribution, pledge, charge, capital gains sharing

agreement, other disposition or encumbrance, or universal transfer of assets and liabilities, in any form whatsoever, of
Shares other than the Management Share(s) by a Shareholder.

“Transferee” means the purchaser, transferee or assignee of Shares as a result of a Transfer of Shares.
“Transferor” means a Shareholder willing to make a Transfer of Shares.
“Valuation Date” means each date on which the Net Asset Value is determined as further described in Section 4 of

the PPM and each Schedule.

“Without Cause Removal” shall have the meaning specified in article 18.
“Without Cause Removal Decision” shall have the meaning specified in article 18.

Art. 1 

er

 . Form, name.  Among the subscribers and all those who may become holders of Shares hereafter issued

there exists a corporation in the form of a société en commandite par actions (S.C.A.) with variable capital qualifying as
an investment company in risk capital, under the name of Slovak Ventures Fund S.C.A., SICAR which shall be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular by the SICAR Law.

The Company shall be entitled to abandon the status of SICAR only with the unanimous consent of all the Shareholders

and the prior approval of the CSSF.

Art. 2. Duration. Subject to the provisions of article 29 hereof, the Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 3. Corporate Purpose. The corporate purpose of the Company is to invest its assets in securities and other assets

representing risk capital within the meaning of article 1 of the SICAR Law and CSSF Circular 06/241, in order to provide
its Shareholders with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risks they are
incurring and in accordance with any limits and/or provisions set forth in these Articles of Incorporation and the PPM.

The Company works as an umbrella structure which means that it is one single legal entity composed of several

Compartments within the meaning of Article 3 of the SICAR Law, each of which shall consist of a fully segregated pool
of assets and liabilities. As such, the Company will establish several Compartments each of which will consist of a specific
investment programme with a specific investment policy, features, terms and conditions as determined by the General
Partner. The investment policy of each Compartment shall be provided for in detail in the PPM. Furthermore the Company
may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing its object in
accordance with the SICAR Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in 11, Avenue Emile Reuter, L-2420

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad by resolution of the General Partner. The registered office may be transferred within Luxembourg-
City by decision of the General Partner.

In the event that the General Partner determines that extraordinary, political, economic, or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be transferred abroad
temporarily until these abnormal circumstances have completely ceased to be in place; such temporary measures shall

59669

L

U X E M B O U R G

have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital, Compartments, Shares, Classes of Shares.
5.1 Capital
The capital of the Company is variable and shall be represented by Shares of no par value and shall at any time be equal

to the total net assets of the Company as determined pursuant to article 23 hereof.

The minimum capital of the Company, which shall be achieved within 12 (twelve) months after the date on which the

Company has been authorized as a SICAR under Luxembourg law, is one million Euro (EUR 1,000,000.-), calculated
including any share premium on the Shares.

The Company was incorporated with a subscribed share capital of forty two thousand and one (42,001) Euro divided

into one (1) Management Share with a subscription price of one (1) Euro, forty thousand (40,000) Ordinary Shares (issued
in the Compartment “Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”) with a subscription price of one
(1) Euro per Ordinary Share, one thousand (1,000) Participating Shares (issued in the Compartment “Slovak Venture
Fund S.C.A., SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”) with a subscription price of one Euro (1) per Participating Share and
one thousand (1,000) Participating Shares (issued in the Compartment “Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR - Slovak
Innovation Fund”) with a subscription price of one Euro (1) per Participating Share. The subscribed share capital was fully
paid up upon incorporation.

The capital consolidation currency of the Company is EUR.
The General Partner is authorised to issue Shares in accordance with the Articles of Incorporation and the terms of

the PPM at an offer price to be determined by the General Partner in accordance with the PPM, without reserving to
existing Shareholders any preferential rights to subscribe for any such Shares to be so issued.

5.2 Compartments
By way of derogation to article 2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of a given Compartment are only

available for the satisfaction of the debts, obligations and liabilities pertaining to that Compartment. Moreover, the assets
of a Compartment shall be managed to the exclusive benefit, and shall be exclusively available to satisfy the rights, of
Shareholders relevant to that Compartment.

Shareholders  of  a  Compartment  shall  not  be  entitled  to  switch  their  Shares  from  one  Compartment  to  another

Compartment of the Company and, as a result, Shares issued with respect to one Compartment cannot be converted
into Shares of another Compartment.

5.3 Shares
The Company shall issue Shares in registered form only.
The registration of the Shareholder's name in the Share Register evidences the Shareholder's ownership rights on the

number of Shares registered in her/his/its name for which the Company has received the relevant payment. As a general
rule, the Company will not issue certificates for such registration, but each Shareholder will receive a written confirmation
of his/ her/ its shareholding. The Company shall consider as Shareholder the Investor in whose name the Shares are
registered as the full owner of such Shares. As only one owner is admitted per Share, Shares are indivisible vis-à-vis the
Company. Co-owners of Shares shall appoint one representative to represent them before the Company.

Shareholders entitled to receive Shares shall provide the Company with an address and e-mail address to which all

notices and announcements related to the Company may be sent. Such address and e-mail address will be entered into
the Share Register. In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may authorise the filing
of a notice to this effect with the Share Register and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Company, or at such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another
address is provided to the Company by such Shareholder. At any time, a Shareholder may request that his/ her/ its address
and/or e-mail address resulting from the Share Register be changed, by sending a written notice by ordinary post and also
by fax to the Company at its registered office, or at such other address, notified to the Shareholders, as may be decided
by the Company from time to time.

Payments of distributions, if any, will be made to Shareholders at their respective addresses as recorded in the Share

Register.

Any transfer of registered Shares shall be entered into the Share Register.
Subject to the terms of these Articles of Incorporation (and in particular article 7 below) and the PPM each Share has

the right to one (1) vote in the General Meeting of the Company as well as in the Compartment Shareholders' Meeting
of the Compartment to which the issuance of such Share is related.

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be

entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis.

5.4 Classes of Shares
The share capital of the Company may be represented by different Classes of Shares of each Compartment.
Each Class of Shares may differ from the other Classes with respect to its cost structure, the initial investment required

or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature.

59670

L

U X E M B O U R G

The share capital of the Company shall be represented by the following Classes of Shares of no nominal value:
(i) “Management Share”: one management share which has been entirely subscribed and fully paid up by the General

Partner as unlimited shareholder (associé gérant commandité) of the Company. The Management Share grants its holder
the broadest powers in the management and operation of the Company, with the burden of bearing unlimited liability
connected thereto, in accordance with the SICAR Law, the 1915 Law and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

(ii) “Participating Shares”: a special Class of Shares which shall be subscribed by limited shareholders (associés com-

manditaires) and which entitle their holder to receive the Special Return. Participating Shares will be issued in relation to
each Compartment. The Participating Shares will only be issued to, and are exclusively reserved for subscription and
holding by, (i) Related Persons (ii) that are or were involved in the management, operation and administration of the
Company. Participating Shares carry the right to the Special Return. The number of Participating Shares in relation to a
Compartment may not be increased.

(iii) “Ordinary Shares”: an ordinary Class of Shares which shall be subscribed by limited shareholders (associés com-

manditaires) and which entitle their holders to receive a priority distribution of proceeds pursuant to the distribution
policy of the relevant Compartment (the “Preferred Return”). Within each Compartment and as more particularly des-
cribed in the relevant Schedule the General Partner may issue different classes of Shares and sub-classes of Ordinary
Shares.

(i) In particular, in order for the Company to be in a position to address investors' potential investment constraints,

the General Partner may design tracking share Sub-Classes corresponding to distinct investments of the Compartment
in order to segregate specific side investment programmes to which such tracking Sub-Classes relate with each such Sub-
Class to be described in the PPM.

The principle of different share classes tracking different target investments shall be valid for internal purposes of

geographic allocation. Towards third parties the Compartment shall be considered as one single entity.

(ii) In the event of a Without Cause Removal in accordance with article 18 below the General Partner may issue

Preferred Ordinary Shares.

Art. 6. Issuance and Subscription of Shares. Without prejudice to the rights and obligations of the Shareholders of the

Company and in accordance with the terms of the PPM, the General Partner shall be free to determine any applicable
conditions to the issue of Shares of each newly established Compartment such as, without limitation: (i) the execution
of such subscription documents and the provision of such information as the General Partner may determine to be
appropriate; (ii) the subscription price; (iii) the relevant Offering Period; (iv) a minimum subscription level; (v) the terms
for capital contributions; (vi) the relevant fees structure, and any other terms and conditions governing the offering of
such new Shares.

Any and all conditions to which the issue of Shares are to be subject shall be detailed in the relevant Schedule to the

PPM specifying the characteristics and features of the newly established Compartment to which the issue of Shares is
related.

In its absolute discretion, the General Partner may accept or reject any request for subscription for Shares. It may also

restrict or prevent any Eligible Investor - as determined by the General Partner but in accordance with the SICAR Law
- from subscribing for Shares or require any subscriber to provide the General Partner with any kind of information that
it may consider necessary for the purpose of deciding whether or not he/ she/ it is an Eligible Investor.

The General Partner may delegate to third parties the right to accept the Subscription Commitment and receive

payments for Shares

Art. 7. Capital Calls, Defaulting Shareholders. Shareholders of each Compartment shall be required to make capital

contributions (the “Capital Calls”) up to their total Subscription Commitment as needed by the investment pace and
policy of the Compartment they subscribed for. The General Partner will fix the frequency, date and amount of each
Capital Call and will send a written notice to Shareholders by registered letter to be sent also by facsimile and/or e-mail
(the “Draw Down Notice”) with at least ten (10) Bank Business Days prior notice.

If any Shareholder fails to pay the drawn down amounts due pursuant to the Draw Down Notice, on the relevant

drawdown date (the “Due Date”), the General Partner will apply an interest charge on such amounts (the “Default
Interest”), without further notice, at a rate equal to EURIBOR plus 6% per annum, until the date of full payment. The
Default Interest shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed between the relevant payment date
(inclusive) and the actual date the relevant payment is received by the Company (exclusive). If within ten (10) Bank Business
Days following the Due Date, the relevant Shareholder has not paid the full amounts due (including the Default Interest
due), (the “Defaulting Date”) this Shareholder shall automatically become a defaulting Shareholder (the “Defaulting Sha-
reholder”) and the General Partner may bring legal action in order to compel the Defaulting Shareholder to pay its portion
of the Subscription Commitment called.

After the Defaulting Date, and notwithstanding the preceding sentence, all the Shares registered in the Defaulting

Shareholder's name shall become defaulted Shares (the “Defaulted Shares”). Defaulted Shares shall have their voting rights
suspended and shall not carry any right to distributions, as long as the outstanding payment set out on the Draw Down
Notice has not been effected. Moreover, the Defaulting Shareholder will no longer have any right to participate in any
future investments of the Company, nor to benefit from the proceeds of such investments. If such Defaulting Shareholder

59671

L

U X E M B O U R G

is or has a representative on any Advisory Board it shall lose its right to participate and vote in any meeting of such
Advisory Board.

All Shares registered in the name of such Defaulting Shareholder shall be subject to the mechanisms set out in the

PPM and below and the General Partner, acting in the best interest of the Company and the relevant Compartment, will
have the obligation to exercise the first remedy set out under below within a maximum period of 30 calendar days as
from the Defaulting Date.:

A. First, Transfer of Shares
(i) In order to provide for the possibility to preserve the level of capital funding of the Company to the aggregate

Subscription Commitments remaining available for drawdown, each Shareholder agrees, for the benefit of the other
Shareholders, an irrevocable promise to sell (promesse de vente) all of its fully paid Shares (as registered in the Share
Register) to any of the Shareholders, each with the full power of substitution, if it has become a Defaulting Shareholder,
at a price per Share equal to the lesser of (i) fifty percent (50%) of the Subscription Price and (ii) fifty percent (50%) of
the latest available Net Asset Value of such Shares as at the Due Date in either case reduced by the Default Interest on
the unpaid part of the subscription amounts due, as well as administration, legal and miscellaneous costs and expenses
(including taxes) borne by or on behalf of the Company or their agents in respect of such default (the “Default Price”).

(ii) The sale process shall be brought to completion in accordance with the following rules and procedure:
(a) within five (5) Bank Business Days after the Defaulting Date, the General Partner shall deliver a notice, sent by

internationally recognized courier and by telefax, or as a scanned document attached to an e-mail with in each case
confirmation of transmission to the addressee, of such default to the Shareholders (excluding the Related Persons or
Related Entities) who are not in default under their Subscription Agreement (each a “Non-Defaulting Shareholder”)
whereby the Non-Defaulting Shareholders are offered to purchase the Defaulted Shares pro-rata to their respective
Subscription Commitment at the Default Price (the “Offering Notice”), and each Non-Defaulting Shareholder shall then
confirm in writing sent by internationally recognized courier and by telefax, or as a scanned document attached to an e-
mail with in each case confirmation of transmission to the addressee, to the General Partner, within fifteen (15) Bank
Business Days following the date of the notification from the General Partner (the “Final Acceptance Date”), their ac-
ceptance, or that they decline, to purchase such number of Shares as indicated in its acceptance confirmation;

(b) in case one or more Non- Defaulting Shareholders accept to purchase the Defaulting Shares from the Defaulting

Shareholder the sale shall be completed, and reflected as such by the General Partner in the Share Register, in proportion
to the number of Ordinary Shares held by each of the Non-Defaulting Shareholders confirming their acceptance to
purchase the Shares from the Defaulting Shareholder, it being agreed and understood that by not confirming its acceptance
of the purchase, a Non-Defaulting Shareholder increases the other Non-Defaulting Shareholders' rights for the amount
of Ordinary Shares which will not be acquired by such Non-Defaulting Shareholder;

(c) the Shareholders agree that their acceptance to purchase such number of Shares as indicated in the acceptance

confirmation shall necessarily imply that the relevant parties or assignee thereof automatically and irrevocably fully and
completely assume the proportion of the Subscription Commitments of the Defaulting Shareholder that remains outs-
tanding towards the relevant Compartment on the Shares transfer date;

(d) in case Non-Defaulting Shareholders decline the offer to purchase the Defaulting Shares the General Partner or

the Investment Advisor may, as from the Final Acceptance Date and during a period of five (5) Bank Business Days, offer
such Defaulted Shares to third parties identified as suitable purchasers either by the General Partner or the Investment
Advisor; and such third parties shall then confirm in writing sent by internationally recognized courier and by telefax, or
as a scanned document attached to an e-mail with in each case confirmation of transmission to the addressee, to the
General Partner, within fifteen (15) Bank Business Days following the date of the offer from the General Partner their
acceptance, or that they decline, to purchase such number of Defaulting Shares as indicated in its acceptance confirmation.
The third parties shall agree that their acceptance to purchase such number of Shares as indicated in the acceptance
confirmation shall necessarily imply that they automatically and irrevocably fully and completely assume the proportion
of the Subscription Commitments of the Defaulting Shareholder that remains outstanding towards the relevant Com-
partment on the Shares transfer date;

(e) The price per Share under (a) and (d) above shall be payable to Defaulting Shareholders normally in the currency

fixed by the General Partner for the payment of the Default Price of the Ordinary Shares and will be deposited for payment
to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final
determination of the Default Price following surrender of the Share certificate or certificates specified in such notice.
Upon transfer of the Shares as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Ordinary Shares or
any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the redemption
price (without interest) from such bank. The Default Price will only be payable to the extent that there is sufficient cash
available in the Company after all other Shareholders shall have received full repayment of their Subscription Commitment
and payment of the Preferred Return only at the close of the liquidation of the relevant Compartment. Any funds recei-
vable by a Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years from the date specified in
the transfer notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Company. The General Partner shall have power
from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the
Company.

59672

L

U X E M B O U R G

B. Second, Compulsory redemption:
(i) Subject to C. below, should the purchase mechanism foreseen in A. above not result in a transfer of all the Defaulted

Shares, all Shares registered in the name of such Defaulting Shareholder which have not been sold pursuant to A., shall,
in case of such default, be subject to a compulsory redemption by the Company in accordance with the following rules
and procedure:

(a) The General Partner shall send a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”) to the Defaulting Shareholder

possessing the redeemable Defaulted Shares (the “Redeemable Shares”); the Redemption Notice shall specify the Re-
deemable Shares, the price to be paid, and the place where this price shall be payable. The Redemption Notice may be
sent to the Defaulting Shareholder by recorded delivery letter to his/ her/ its last known address. The Defaulting Share-
holder in question shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificate or certificates, if there are
any, representing the Redeemable Shares specified in the Redemption Notice. From the close of business of that day
specified in the Redemption Notice, the Defaulting Shareholder shall cease to be the owner of the Redeemable Shares
specified in the Redemption Notice and the certificates representing these Shares shall be rendered null and void in the
financial and legal records of the Company and the Share Register will be amended accordingly.

(b) In such compulsory redemption, the redemption price per Share will be equal to the Default Price. The above-

mentioned redemption price will only be payable to the extent that there is sufficient cash available in the Company after
all other Shareholders shall have received full repayment of their Subscription Commitment and payment of the Preferred
Return only at the close of the liquidation of the relevant Compartment.

(c) From the date of the Redemption Notice, the total Subscription Commitments to the relevant Compartment shall

be deemed to have been reduced by an amount equal to the Subscription Commitment of the Defaulting Shareholder
and thereafter such reduced total Subscription Commitments shall apply for the purposes of these Articles of Incorpo-
ration and the PPM (in respect of the relevant Compartment).

C. Duties of the General Partner.
(i) The General Partner shall first resort to the promesse de vente option referred to in A. above and only to the

extent that this option does not result in a transfer of all Shares of Defaulting Shareholders shall the redemption option
above be utilized. Following the transfer of shares referred to in A. and its related sales process and before utilizing the
compulsory redemption referred to in B. above the General Partner may, acting in the best interests of the Company,
seek third party purchasers for the Shares of Defaulting Shareholders.

(ii) If it considers this to be in the best interests of the Company the General Partner shall bring legal actions against

the Defaulting Shareholder based on breach of its/his Subscription Agreement, subject to related extraordinary expenses
being approved by the relevant Advisory Board.

The General Partner may bring any legal actions it may deem appropriate against the Defaulting Shareholder based on

breach of its Subscription Agreement with the Company. For the avoidance of doubt, the General Partner shall be entitled,
subject to the borrowing limits laid down in the PPM, to borrow on behalf of the Company any amount as is necessary
to make up any shortfall in available funds for Portfolio Investments or any expenses (including the Management Fee) and
other liabilities.

Furthermore, the General Partner may decide to issue within ten (10) Bank Business Days from the Defaulting Date

an emergency Draw Down Notice (subject to the ten (10) Business Days prior notice applicable to all Draw Down
Notices), requiring the Non-Defaulting Shareholders of the relevant Compartment to contribute additional amounts to
cover any defaulted amounts, provided that the total Subscription Commitments of the Non-Defaulting Shareholders will
not be increased on account of such Default.

Where appropriate the Subscription Commitment of the Shareholders may be adjusted, subject to the terms of the

PPM (including, in the event of an unremedied default by a Defaulting Shareholder) to ensure compliance at all times with
any applicable rules regarding maximum percentage of Subscription Commitments to be held by a particular Shareholder,
provided that the Subscription Commitment of a Shareholder will only be increased as a result of such adjustment with
that Shareholder's prior written approval (and, in particular, the JHF and compliance with the "Maximum Ratio" set out
in the relevant Schedule(s) of the PPM).

The sanctions applied against Defaulting Shareholders described above are not exclusive of any recourse that the

General Partner may adopt in order to recover the unpaid amounts.

The General Partner and the Investment Advisor will immediately inform the Advisory Board of the relevant Com-

partment of an Investor failing to pay the drawn down amounts due pursuant to the Draw Down Notice on the Due
Date and will, on an ongoing basis, keep the Advisory Board informed of the actions and steps taken to resolve such
default (with a report on such actions and steps to be provided by the General Partner and Investment Advisor at least
on a quarterly basis to the Advisory Board).

Art. 8. Eligible Investors. In accordance with Article 2 of the SICAR Law Shares of the Company may only be subscribed

by Investors, which are institutional investors, professional investors, or any other investors meeting the following con-
ditions:

(i) such investors have confirmed in writing that they adhere to the status of wellinformed investors; and they either
(ii) invest a minimum amount of one hundred and twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-) in the Company; or

59673

L

U X E M B O U R G

(iii) have obtained an assessment by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/CE, by an investment

company within the meaning of Directive 2004/39/CE, or by a management company within the meaning of Directive
2009/65/CE, certifying their expertise, experience and knowledge in adequately appraising an investment in risk capital;
and

(iv) such investors are not persons, firms, partnerships or corporate bodies, whose participation, in the reasonable

opinion  of  the  General  Partner  pursuant  to  any  applicable  laws,  may  be  detrimental  to  the  interests  of  the  existing
Shareholders or of the Company, should it result in a breach of any law or regulation, whether of the Grand Duchy of
Luxembourg or otherwise, or if as a result of their being Shareholders the Company may become exposed to tax dis-
advantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred (for the avoidance of doubt this last paragraph
(iv) applies also to institutional and professional investors investing in the SICAR).

The conditions set forth above under items (i) to (iii) are not applicable to the General Partner or to the managers of

the General Partner and other persons who intervene in the management of the Company, including employees, if any,
of the General Partner.

Investors entitled to subscribe for Shares in the Company in application of the two foregoing paragraphs shall be

considered as Eligible Investors.

The General Partner shall decline to issue any Shares and decline to register any transfer of Shares, where it appears,

in the reasonable opinion of the General Partner, that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial
ownership of such Shares by an investor not qualifying as an Eligible Investor.

The Shares may be redeemed compulsorily if a Shareholder (other than those referred to in the preceding paragraph)

ceases to be or is found not to be an Eligible Investor within the meaning of this article 8. Such compulsory redemption
shall be made under the conditions set forth in the PPM.

Art. 9. Transfer of Shares. Any Transfer of Shares (other than the Management Share(s), which shall only be transferable

in the circumstances set out in article 18 below) by a Shareholder shall be made in accordance with the law these Articles
of Incorporation and the PPM and, in particular, subject to the restrictions provided herein below.

a) Subject to the specific provisions set out in these Articles of Incorporation or in a relevant Schedule in respect of

a Compartment, Shareholders are not entitled to make a Transfer of Shares to any third parties without the prior written
consent of the General Partner, which shall not be unreasonably withheld, taking into account the general interest of the
Compartment and/or the other Shareholders. The General Partner may decline to approve or register such Transfer of
Shares, provided however that the General Partner shall not unreasonably decline or deny or withhold its approval vis-
à-vis any Transfers of Shares to other existing Shareholders or to a company which is controlled and the majority of
whose voting rights are held, either directly or indirectly, by the Transferor. Under such circumstances, in the event the
General Partner is declining or denying or withholding its approval, the General Partner shall always specify in writing the
reasons grounding its denial;

b) Shares are only transferable or assignable provided that the Transferee qualifies as an Eligible Investor;
c) Shares are transferable or assignable provided that the Transferee fully and completely undertakes in writing to

perform any and all remaining obligations connected to the possession of Shares of the Transferor under the Subscription
Agreement entered into by the Transferor (including, without limitation, the obligation to pay in any remaining balance
of the Subscription Commitments in accordance with any Capital Call made by the General Partner);

d) The Transfer of Shares, and assignment of related Subscription Commitment, held by the JEREMIE Holding Fund to

a National Authority or any entity appointed by a National Authority is not subject to any restriction (and, in particular
is not subject to the consent of the General Partner) provided that such National Authority or entity appointed by a
National Authority is a “well-informed investor” within the meaning of article 2 of the SICAR Law.

In addition to above, each Schedule to the PPM may set forth additional provisions relating to the Transfer of Shares.
Any Transfer of Shares made in breach of the provisions of this article 9 or the PPM shall be null and void and of no

force or effect vis-à-vis the Company and the Shareholders. Transfers of Shares which are null and void and of no force
or effect shall not be recorded in the Share Register and, while no remedial action is taken, all the rights and obligations
attached to the Shares will be exercised and enforced by the Transferor holding the Shares in question, without prejudice
to any liability it may incur vis-à-vis the Company or the other Shareholders.

Art. 10. Shareholders Meetings. Any regularly constituted General Meeting of the Company shall represent the entire

body of Shareholders. Any regularly constituted Compartment Shareholders Meeting shall represent the entire body of
Shareholders of a Compartment.

Any Shareholder is entitled to attend any General Meeting of the Company.
Any Shareholder shall be able to attend any General Meeting of the Company and any Compartment Shareholders

Meeting of which they hold Shares by videoconference or audioconference. In order to do so, Shareholders shall com-
municate to the Company, at least (5) Bank Business Days before the meeting, their video or telephone numbers.

Only Shareholders holding Shares of a specific Compartment are entitled to attend the relevant Compartment Sha-

reholders Meeting. The General Partner is however entitled to attend any Compartment Shareholders Meetings.

59674

L

U X E M B O U R G

Any resolutions passed by the General Meeting of the Company affecting any of the rights belonging to Shareholders

of a specific Compartment shall be submitted to the final approval of the relevant Compartment Shareholders Meetings.

Unless differently provided for in these Articles of Incorporation and the PPM, the quorum required by law shall govern

the conduct of the General Meetings of the Company, which will be applied mutatis mutandis to any Compartment
Shareholders Meeting.

Subject to article 18 of these Articles of Incorporation and any contrary provision in the PPM any resolutions of the

General Meeting of the Company amending these Articles of Incorporation shall be adopted in accordance with the
relevant provisions of the 1915 Law.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any General Meeting of the Company or Compartment

Shareholders' Meeting by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law and/or by these Articles of Incorporation and/or the PPM, resolutions at a General

Meeting of the Company or Compartment Shareholders Meeting duly convened will be passed by a simple majority of
the cast votes, it being understood that any resolution shall be validly passed only with the approval of the General Partner
unless differently provided for in these Articles of Incorporation and/or the PPM. Cast votes shall not include votes
attached to Shares in respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned
a blank or invalid vote.

In accordance with article 68 of the law of the 1915 Law, any resolution of the General Meeting of the Company, that

changes the rights of the holders of Shares of any Class or Sub-Class vis-à-vis the rights of the holders of Shares of any
other Class or Sub-Class shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Class. The
resolutions, in order to be valid, must be adopted in compliance with the quorum and majority requirements referred
herein, with respect to each Class or Sub-Class concerned.

Notices of all General Meetings of the Company and all Compartment Shareholders Meetings setting forth the agenda

and specifying the time and place of the meeting and the conditions of admission thereto and referring to quorum and
majority requirements will be sent to the holders of registered Shares by registered mail, at least ten (10) calendar days
prior to the meeting, to their addresses as given in the Share Register and anticipated to them by telefax and/or e-mail.

If all of the Shareholders are attending or represented at a General Meeting of the Company or Compartment Sha-

reholders' Meeting, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice of call or publication.

The General Partner as well as Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the share capital of the

Company will have the right to convene a General Meeting of the Company. Such Shareholders must submit a written
request via registered mail with an indication of the agenda to the General Partner so that the General Partner is obliged
to convene a General Meeting of the Company so that such meeting is held within one (1) month of the receipt of such
written request. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company may request
in writing, by registered mail and at least five (5) calendar days prior to the holding of a General Meeting of the Company,
that one or more items be put on the agenda of any General Meeting of the Company.

The General Partner and Shareholders representing at least ten percent (10%) of the outstanding share capital of a

Compartment may convene a Compartment Shareholders' Meeting. Shareholders wishing to convene such a meeting will
follow the procedure set out in the foregoing paragraph. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the
share capital of the relevant Compartment may request in writing, by registered mail and at least five (5) calendar days
prior to the holding of a Compartment Shareholders Meeting, that one or more items be put on the agenda of any
Compartment Shareholders Meeting.

Art. 11. Annual General Meeting of the Company. The annual General Meeting of the Company will be held at the

registered office of the Company in Luxembourg at 11 a.m. on the second Monday of the month of June of each year or,
if any such day is not a Bank Business Day in Luxembourg, on the next following Bank Business Day.

Art. 12. General Partner. The Company shall be managed by the General Partner, in its capacity as unlimited Share-

holder of the Company. The General Partner shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all
liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

Art. 13. Powers of the General Partner. The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts

of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles
of Incorporation to the General Meeting of the Company shall belong to the General Partner.

The General Partner is responsible for the management and administration of the Company, including the establishment

and the determination of the investment policy of each Compartment in accordance with the PPM. The General Partner
will evaluate and make all investment and divestment decisions on behalf of the Company and/or each Compartment and
will be solely responsible for all decisions regarding investments, disinvestments, administration and general policy of the
Company. The General Partner may carry out all acts of management and administration on behalf of the Company.

The General Partner may delegate, under its responsibility and control, its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or

59675

L

U X E M B O U R G

members of its board of managers which may also create committees deliberating under such terms as the General
Partner's board of managers shall determine.

The General Partner in carrying out its management functions in relation to each Compartment may be assisted by

an investment committee (each an “Investment Committee”) and/or an advisory board (each an “Advisory Board”). The
role and composition of any Investment Committee or Advisory Board will be detailed in the relevant Schedule to the
PPM relating to the particular Compartment. In addition the General Partner may appoint one or more advisors (“In-
vestment Advisor”) to the Company in respect of any Compartment as more particularly detailed in the relevant Schedule
of the PPM relating to the particular Compartment.

Art. 14. Authorized signatures. The Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature of the General

Partner represented by its legal representatives or persons to whom such signatory powers have been delegated by the
General Partner.

Art. 15. Indemnification. The Company, out of a Compartment's assets, shall indemnify and hold the Indemnified

Persons harmless against all damages suffered or incurred by such Indemnified Persons by reason of being or having carried
out its functions with respect to the relevant Compartment in accordance with the PPM or these Articles of Incorporation,
provided that:

a) Indemnified Persons shall only be liable towards the Company and not be entitled to such indemnification with

regard to any matter resulting from fraud, gross negligence or wilful misconduct or wilful default or wilful illegal acts or
such person's breach of the terms of any Company Document; Indemnified Persons will not be entitled to the indemni-
fication with respect to any action or omission constituting a Cause Event;

b) indemnity amounts in no case will exceed the lesser of (i) 50% of the amount of Subscription Commitments to the

relevant Compartment or (ii) such amount as may be realised from the Compartment's assets;

c) in no circumstances can distributions to Investors be recalled for the purpose of indemnifying Indemnified Persons;

and

d) no indemnification will be granted in respect of claim, liability, damage, costs or expenses that are the result of (a)

a request by Shareholders exercising their rights under the terms of the Company Documents or applicable laws or (b)
a dispute between any of the Related Persons or Related Entities or (c) other disputes in relation to the internal orga-
nisation of the relevant Indemnified Person (i.e., any dispute or litigation with employees, officers, agents or directors of
such Indemnified Person).

Art. 16. Liability of the General Partner and Limited Shareholders. The General Partner shall be liable vis-à-vis any

third parties for all debts and losses of the Company which cannot be recovered from the Company's assets.

The Limited Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever

other than when exercising their rights as Shareholders in the General Meetings of the Company and/or in any Com-
partment Shareholders' Meeting and/or on the Advisory Board and shall be liable to the extent of their ownership of the
Company.

Art. 17. Delegation of powers - Agents of the General Partner. At any time, the General Partner may appoint officers

or agents of the Company as required for the affairs and management of the Company.

Art. 18. Removal of the General Partner. The General Partner may not be removed by the Company and replaced by

another general partner except under the circumstances set forth below:

A. “For Cause Removal” by decision with such notice period (if any) as such meeting shall determine of the General

Meeting of the Company taken by the Shareholders Ordinary Resolution (provided that the General Partner will not
have any veto right on such decision and Related Persons and Related Entities will not vote and not be counted for the
quorum/majority requirements on such decision) provided that such decision is taken by the positive vote of JEREMIE
Holding Fund and at least 30% of the Ordinary Shares not held by the JEREMIE Holding Fund (a For Cause Removal
Decision) upon the occurrence of any of the following events (each a Cause Event):

a. a material breach by any Related Person of its or their obligations under any Company Document (and, for the

avoidance of doubt, any breach of the priority and exclusivity provisions set out in Section 9.5 will be automatically
considered as a material breach of the Company Documents);

b. gross negligence, wilful misconduct, bad faith, reckless disregard of duties to the Company, or fraud or breach of

securities or other applicable laws (including the rules of the CSSF in Luxembourg) by any Related Person;

c. insolvency, administration, dissolution, liquidation, involuntary reorganisation or bankruptcy of any Related Person

or any application for such by any of them;

d. any order, judgment or decree of any court, arbitral tribunal or regulatory authority which prohibits or prevents

any Related Person from carrying on its/his duties or performing its obligations in respect of the Company and which is
not rectified within thirty (30) calendar days of such order, judgment or decree;

e. the conviction of any Related Person for any indictable offence or offence carrying a custodial sentence;
f. the Suspension Period is not terminated within ninety (90) calendar days of the relevant Key Person Event or Change

of Control Event;

59676

L

U X E M B O U R G

g. an Unauthorised Change of Control Event as further described in the PPM.
B. “Without Cause Removal”: at any time and with such notice period (if any) as such meeting shall decide by decision

of the General Meeting of the Company, adopted by a Shareholders Special Resolution (provided that the General Partner
will not have any veto right on such decision and Related Persons and Related Entities will not vote and not be counted
for the quorum/majority requirements on such decision) (a Without Cause Removal Decision).

Shareholders shall be entitled to require the General Partner to call a General Meeting of the Company to initiate a

vote for removal of the General Partner and the General Partner will call a General Meeting of the Company to initiate
a vote for the For Cause or Without Cause Removal if Shareholders (other than Related Persons or Related Entities)
representing at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company (excluding for that purpose Related Persons
or Related Entities' participations) so require. Such general meeting shall be held within a maximum period of one month
as from the request to that effect from Shareholders but with any subsequent penalties and date-dependent liabilities or
obligations on the General Partner, the Investment Advisor and Related Persons resulting from such meeting running
from the date of the decision.

Upon receipt by the General Partner of a request to the effect of calling a General Meeting for the purpose of voting

on a For Cause or Without Cause Removal, the Company will enter into a Suspension Period, provided that the Advisory
Board of each Compartment (if any) can approve a waiver of that Suspension Period (subject to such conditions as the
Advisory Board deems fit as the case may be).

For Cause Removal
A For Cause Removal Decision will have the following immediate effects:
i. the Investment Advisory Agreements in respect of all Compartments will terminate, without any compensation for

the Investment Adviser;

ii. the Investment Periods of each Compartment (if not already terminated) will be suspended (and will only resume

upon the replacement of the General Partner) and the General Partner will only be authorised to carry out administration
tasks and take decisions for the purpose of protecting the interest of the Company, each such decision taken by the
General Partner to be subject to the agreement of the Advisory Board up to the date of its effective replacement or of
the Company's liquidation;

iii. the Related Persons will be released from their then remaining Undrawn Commitments;
iv. the holder of the Participating Shares will lose all rights to the Special Return, and the Participating Shares will cease

to give right to the payment of any Special Return (including, for the avoidance of doubt, any accrued or vested but unpaid
Special Return) and the Company shall promptly redeem all Participating Shares at a price, to be paid to the holders of
Participating Shares, equal to the lesser of (a) the funded Commitments paid by the relevant holder of those Shares on
those Shares less any distributions to such holder (it being understood that such may not result in a price lower than
zero) or (b) the Net Asset Value per Share of the Participating Shares held by them calculated by the Administrative
Agent as at the date of the For Cause Removal Decision (with the Administrative Agent taking due account of the full
Special Return forfeiture as described above for the purpose of such calculation) (for the avoidance of doubt, the Company
may subsequently issue new Participating Shares to the replacement general partner of the Company or its Affiliates). No
compensation  (including,  for  the  avoidance  of  doubt,  any  accrued  but  unpaid  portion  of  the  Management  Fee)  shall
otherwise be payable to the Related Persons by the Company;

v. the General Partner will cease to be entitled to the Management Fee;
vi. the Investors shall procure that the General Partner is replaced by a Shareholders Special Resolution (provided that

the General Partner will not have any veto right on such decision and Related Persons and Related Entities will not vote
and not be counted for the quorum/majority requirements on such decision) and with the consent of the CSSF within
hundred and eighty (180) calendar days of the For Cause Removal Resolution, failing which the General Partner will resign
and this resignation will trigger the automatic liquidation of the Company. If a replacing general partner is appointed, the
General Partner will transfer to the new replacing general partner (if any) (or its Affiliates, officers, directors, managers
or agents) its Management Share(s) at a price equal to the lesser of (a) the funded Commitments paid by the General
Partner less any distributions to it on these Shares (it being understood that such may not result in a price lower than
zero) or (b) the Net Asset Value per Share of the Management Share(s) held by the General Partner calculated by the
Administrative Agent.

Without Cause Removal
A Without Cause Removal Decision will have the following immediate effects:
i. the Investment Advisory Agreements in respect of all Compartments will terminate, without any compensation for

the Investment Adviser;

ii. the Investment Periods of each Compartment (if not already terminated) will be suspended (and will only resume

upon the replacement of the General Partner) and the General Partner will only be authorised to carry out administration
tasks and take decisions for the purpose of protecting the interest of the Company, each such decision taken by the
General Partner to be subject to the agreement of the Advisory Board up to the date of its effective replacement or of
the Company's liquidation;

iii. the Related Persons will be released from their then remaining Undrawn Commitments;

59677

L

U X E M B O U R G

iv. the Company shall pay to the General Partner as immediate compensation an amount equal to twelve (12) months'

Management Fee in respect of each Compartment (net of any Management Fee received in advance) due as calculated
for the period immediately preceding the date of the Without Cause Removal Decision; the aforementioned compen-
sation shall be paid within thirty (30) calendar days from the date of effectiveness of the Without Cause Removal Decision
subject to the General Partner and the Investment Advisor handing over to the Company all books, records and other
assets of the Company;

v. Participating Shares in each Compartment issued prior to the date of the Without Cause Removal Decision shall

be converted into a special category of Shares having the same rights and obligations as the Ordinary Shares but conferring
upon their holders the additional right to receive the Special Return referred to below as preferred dividend (the "Pre-
ferred Ordinary Shares"). The Special Return vested on the Preferred Ordinary Shares shall be as follows:

Carry vesting

By end of

60%

2015

10%

2016

5%

2017

5%

2018

5%

2019

5%

2020

5%

2021

5%

2022

100%

- Sixty percent (60%) of total Special Return will be vested/allocated in respect of Participating Shares issued prior to

the date of removal on a linear basis and pro rata temporis on a monthly basis between the Closing or First Closing (in
respect of a Compartment with multiple closings) of the relevant Compartment and the fifth (5 

th

 ) anniversary of the

Closing or First Closing (in respect of a Compartment with multiple closings), provided that if the Investment Period
applicable to the relevant Compartment ends earlier the entire sixty percent (60%) of Special Return will immediately be
vested/allocated in respect of Participating Shares at such time. If for any reason the Investment Period is extended then
no Special Return shall be vested/allocated during the period of the extension.

- Ten percent (10%) of total Special Return will be vested/allocated in respect of Participating Shares issued prior to

the date of removal at the end of each year after the expiry of the relevant Investment Period (such yearly percentage
will be vested/allocated on a linear basis and pro rata temporis on a monthly basis), with a cap of ninety percent (90%)
of total Special Return to be vested at the conclusion of the eighth (8 

th

 ) year from Closing or First Closing (in respect

of a Compartment with multiple closings) of the relevant Compartment.

- Five percent (5%) of total Special Return will be vested/allocated in respect of Participating Shares issued prior to

the date of removal at the end of each year after the expiry of the eighth year from Closing or First Closing (in respect
of a Compartment with multiple closings) of the relevant Compartment (such yearly percentage will be vested/allocated
on a linear basis and pro rata temporis on a monthly basis) with one hundred percent 100% of the Special Return to be
vested/allocated at the conclusion of the tenth (10 

th

 ) anniversary of the Closing or First Closing (in respect of a Com-

partment with multiple closings).

vi. the non-vested portion of the Special Return shall be forfeited by the holder(s) of the Participating Shares existing

on the Without Cause Removal Decision and transferred to the new general partner (or its Affiliates, officers, directors,
managers or agents) who will have the right to receive distributions of Special Return in respect of such non-vested
portion of the Special Return through one or more newly issued Preferred Shares (the "New Preferred Shares"). The
New Preferred Shares will be issued to the new general partner (or its Affiliates, officers, directors, managers or agents)
at a price equal to the Subscription Price;

vii. the General Partner will transfer to the new replacing general partner (if any) (or its Affiliates, officers, directors,

managers or agents) its Management Share(s) at a price equal to the lesser of (a) the funded Commitments paid by the
General Partner for such Share less any distributions to the General Partner (as holder of the Management Share(s)) (it
being understood that such may not result in a price lower than zero) or (b) the Net Asset Value per Share of the
Management Share(s).

The Shareholders shall procure that the General Partner is replaced by a Shareholders Special Resolution and with

the consent of the CSSF, within hundred and eighty (180) calendar days of the Without Cause Removal, failing which the
Company will be wound up. For the purpose of this resolution, the Related Persons and Related Entities will not exercise
their voting rights and the General Partner will not have any veto right.

For the avoidance of doubt, the Company's payment obligations in respect of the Participating Shares issued prior to

removal of the General Partner (after their conversion into Preferred Ordinary Shares) and the New Preferred Shares
issued to the replacement general partner and/or its Affiliates shall in no event exceed the aggregate Special Return
payable. The payment of Special Return shall be carried out as described in “Distributions Policy” section of the relevant
Schedule of the PPM and the Special Return amount payable shall not be due at a date earlier than it would have been
without such removal.

59678

L

U X E M B O U R G

Within the context of the Without Cause Removal, the removed General Partner will undertake to do everything

which is lawful, necessary or simply useful and engages to cooperate to the extent necessary with the Company and the
new general partner so that the restructuring of the vesting schedule of the Special Return as described above becomes
fully effective.

Upon the effective replacement of the General Partner and Investment Advisor by the replacement general partner

and/or Investment Advisor, the former General Partner and Investment Advisor shall deliver to any replacement general
partner, or as it shall direct, all copies of all books of account, records, registers, correspondence and documents relating
to the affairs of or belonging to the Company in the possession of or under the control of the former General Partner,
Investment Advisor and their Affiliates and take all necessary steps at the expense of the Company to vest in the Company
or any replacement general partner and/or investment advisor any asset of the Company previously held in the name of
or to the order of the former General Partner, Investment Advisor or their Affiliates. In addition, upon termination of
the appointment of the General Partner, the General Partner shall take all necessary steps to transfer the Management
Share(s) to the replacement general partner.

As of the receipt of a request to convene a General Meeting for the purpose of resolving of the removal of the General

Partner and until the Shareholders have resolved upon the proposed removal or, in case a judicial proceeding in connection
with the proposed removal, until a final decision without leave to appeal of a competent jurisdiction has been rendered
on the proposed removal, the General Partner shall keep confidential, and shall not disclose, and shall make reasonable
efforts to ensure that every person connected with it or any of its Affiliates (including any of the Related Persons) does
not disclose to any person any information in relation to the proposed removal, unless such information is publicly available
(other than through a breach of the present section by any of the General Partner, its Affiliates or Related Persons).

If the total amount of Undrawn Commitments to a Compartment changes as a result of a removal of the General

Partner (e.g., because Related Persons are released from their then Undrawn Commitments), then all Commitments of
Shareholders  in  that  Compartment  may  be  adjusted  proportionally  such  that  the  JEREMIE  Holding  Fund  (Undrawn)
Commitment does not exceed the applicable Maximum Ratio (if any) of the aggregate (Undrawn) Commitments to the
relevant Compartment. If the release/cancellation of Undrawn Commitments from Related Persons is taken up by a new
General Partner or existing Shareholders then there will be no requirement for any adjustment in the Undrawn Com-
mitment of the JEREMIE Holding Fund to the relevant Compartment.

Art. 19. Conflict of interests. Without prejudice to the procedures for the approval of transactions involving conflicts

of interests as set forth in PPM, and subject to the other conflict-related parameters and restrictions as set forth in the
PPM, the Company will enter into all transactions on an arm's length basis. Each of the General Partner, the Investment
Advisor, the Custodian, the Administrative Agent, Related Entity and any Related Person will have regard to their res-
pective duties to the Company and other persons when undertaking any transactions where conflicts or potential conflicts
of interest may arise. In the event that such conflicts do arise, each of such persons will be requested by the General
Partner to undertake to use its reasonable endeavours to resolve any such conflicts of interest fairly (having regard to
its respective obligations and duties) and to ensure that the Company and the Shareholders are fairly treated.

Any potential or actual conflicts of interest as referred to above must be fully disclosed to the relevant Advisory Board

promptly. The General Partner and Investment Advisor shall resolve any conflicts in the manner reasonably determined
by the Advisory Board.

Actual conflicts of interest as well as the procedures used to resolve such conflicts shall be further disclosed to the

shareholders of the Company either in the notes to the audited annual accounts or in the management report.

Art. 20. Independent Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books

shall be supervised by an independent auditor (the “Auditor”) (réviseur d'entreprises agréé) and who shall carry out the
duties prescribed by the SICAR Law. The Auditor shall be appointed upon resolution of the General Meeting of the
Company.

Art. 21. Redemption of Shares. The Company is a closed-ended investment company in risk capital. Consequently,

Shares in the Company shall not be redeemable at the request of a Shareholder. The Ordinary Shares are rather (only)
redeemable at the discretion of the General Partner in the cases set out below.

The Management Share(s) may not be redeemed during the life of the Company.
The Shares - other than the Management Share(s) - of all existing Shareholders of a single Compartment may be

redeemed on a pro-rata basis exclusively in order to proceed with a distribution of dividends and/or cash proceeds related
to such Compartment (subject to the relevant distribution waterfall set out in the relevant Schedule and the terms of
the PPM).

In case of occurrence of such scenario above, the General Partner (i) shall promptly communicate to the Shareholders

the  reasons  for  the  redemption,  the  amounts  to  be  reimbursed,  the  term  provided  for  by  the  redemption  and  the
procedure to obtain the redemption and (ii) shall give to the Custodian the relevant instructions to pay the redemptions.

In addition thereto, Shares other than the Management Share(s) may be redeemed compulsorily if a Shareholder ceases

to be or is found not to be an Eligible Investor in accordance with article 8 herein or in the event they become Defaulted
Shares in accordance with article 7.

59679

L

U X E M B O U R G

The redemption price per Share (other than the Default Price) shall be paid within a period as determined by the

General Partner which shall not exceed fifteen (15) Bank Business Days from the date fixed for redemption.

Any redeemed Shares will be cancelled.

Art. 22. Valuation Date. The Net Asset Value per Share of each Compartment shall be determined by the Adminis-

trative Agent, under the responsibility of the General Partner, at least once per year as set out in the PPM.

The Net Asset Value per Share of each Compartment as of any Valuation Date shall be sent to Shareholders, as soon

as finalized and, in any event, within one hundred and eighty (180) calendar days following the relevant Valuation Date.

Art. 23. Calculation of the Net Asset Value per Share. The Net Asset Value per Share (and Class or Sub-Class of

Share) shall be expressed in the currency of the relevant Compartment and shall be determined by the Administrative
Agent, under the supervision of the General Partner, as of any Valuation Date (as set out in respect of each Compartment
in the relevant Schedule) in accordance with the rules set forth below.

The value of the net assets of the Company is equal to the difference between the value of its gross assets and liabilities

and is calculated in accordance with Luxembourg GAAP. The Net Asset Value per Share (and Class or Sub-Class of Share)
of each Compartment of the Company shall be calculated according to the present Articles of Incorporation as follows:
each Compartment participates in the Company according to the portfolio and distribution entitlements attributable to
such Compartment. The value of the total portfolio and distribution entitlements attributed to a particular Compartment
on a given Valuation Date adjusted with the liabilities relating to that Compartment on that Valuation Date represents
the total Net Asset Value attributable to that Compartment on that Valuation Date. The Net Asset Value per Share of
that Compartment on a given Valuation Date equals the total Net Asset Value of that Compartment on that Valuation
Date divided by the total number of Shares of that Compartment then outstanding on that Valuation Date. For the
avoidance of any doubt, each Compartment shall have a Net Asset Value per Share and, within each Compartment, each
Class or Sub-Class of Shares may have a different Net Asset Value per Share in order to take into account preference
rights, if any, in the distribution of income as well as to take into account different portfolio entitlements attributed to a
particular Sub-Class.

The value of all assets and liabilities not expressed in the currency of the relevant Compartment shall be converted

into such currency at the exchange rate applicable in Luxembourg on the relevant Valuation Date. If the relevant quota-
tions are not available, the exchange rate shall be determined in good faith by or under procedures established by the
General Partner.

The assets of each Compartment shall include:
a. any Portfolio Investments relevant to that Compartment;
b. any other securities held by the Company in connection with that Compartment;
c. all cash on hand or on deposit owned by the Compartment, as well as any interest accrued thereon, except to the

extent that the same is included or reflected in the principal amount of such asset;

d.  all  stock,  stock  dividends,  cash  dividends  and  cash  distributions  receivable  by  the  Compartment  to  the  extent

information thereon is reasonably available to the Company;

e. all interest accrued on deposits;
f. the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares of the Company, in

connection with that Compartment;

g. all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance, relevant to the Compartment.
The liabilities of each Compartment shall include:
a. all loans, bills and accounts payable, relevant to the Compartment;
b. all accrued interest on loans of the Compartment (including accrued fees for commitment for such loans);
c. all accrued or payable expenses of the Compartment (including but not limited to administrative expenses, mana-

gement fees, performance and incentive fees, if any, custodian fees and corporate agents' fees);

d. all, present and future, known liabilities including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company in connection with the Compartment;

e. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the General Partner, as well as any
other similar provisions (if any) as the General Partner may deem appropriate as prudent allowances in respect of any
contingent liabilities of the Company, in connection with the Compartment;

f. all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature to be taken into account in accordance with

Luxembourg GAAP. In determining the amount of such liabilities, the General Partner shall have to take into account all
expenses payable by the Company, in connection with the Compartment, including incorporation expenses, fees payable
to the General Partner or the Investment Advisors (if any), fees and expenses payable to accountants, custodians and
their respective representative agents, domiciliary, administrative, registrar and transfer agents as well as any other agents
of the Company, compensation to managers and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and rea-
sonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and
expenses connected with registering and maintaining the relevant registration of the Company with any Governmental

59680

L

U X E M B O U R G

agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing
expenses, including the cost of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda,
periodical reports or registration statements, the costs of printing share certificates and the costs of any reports to
Shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of
buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex costs. The Company may
record administrative and other expenses of a regular or recurring nature on a yearly or other specific periods accrual
basis.

The value of such assets and liabilities shall be determined at fair value as follows:
a. Portfolio Investments shall be estimated at their fair value in accordance with the updated guidelines and principles

for valuation of Portfolio Investments set out by the International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines
(the “IPEV Guidelines”), and as amended from time to time.

b. Securities which are listed on a stock exchange or dealt with on another regulated market shall be valued on the

basis of the last available published stock exchange or market value.

c. Securities which are not listed on a stock exchange nor dealt with on another regulated market, and which are not

referred to under a. above, shall be valued on the basis of their fair value prudently estimated by the General Partner.

d. The value of any cash on hand or on deposit, credit notes and accounts receivable and accounts payable, prepaid

expenses, interests, cash dividends declared or accrued, as aforesaid, and not yet received, shall be deemed to be the full
amount thereof, unless such full amount is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
determined at a discount which the General Partner may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof.

Costs not directly attributable to a particular Compartment shall be allocated to all Compartments proportionally to

the Net Asset Value of each existing Compartment calculated at the last Valuation Date, provided that any cost cap set
out in the PPM shall be respected.

The Company shall apply valuation principles on a consistent basis.
In case of valuation of assets/liabilities pertaining to the Company and not directly pertaining to a given Compartment,

the General Partner shall use Luxembourg GAAP, taking into account the IPEV Guidelines, such as amended from time
to time.

The auditors shall the calculation of the Net Asset Value at least once a year.

Art. 24. Suspension of the Calculation of the Net Asset Value. The General Partner may temporarily suspend the

calculation of the Net Asset Value per Share of one or more Compartment(s) in exceptional cases where circumstances
so require and provided that the suspension is justified having regard to the interests of Shareholders of each Compart-
ment. In particular, the General Partner may suspend the determination of the Net Asset Value per Share:

a. when any one of the principal markets or other stock exchanges on which a substantial portion of the assets of the

Company are quoted is closed (otherwise than for ordinary holidays) or during which dealings therein are restricted or
suspended over a period of seven (7) successive Bank Business Days; or

b. when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the control,

responsibility and power of the General Partner, disposal of the assets owned by the Company is not practicable without
this being seriously detrimental to the interests of Shareholders; or

c. in any other scenario as set out in the IPEV Guidelines.
Notice of any suspension and its detailed motivation shall be given to Shareholders by registered letter and/or by

electronic mail.

Art. 25. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a credit institution within the meaning

of the law of 5 April, 1993, concerning the financial sector, as amended, having its registered office in Luxembourg or
established in Luxembourg if its registered office is in another Member State of the European Union.

Art. 26. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first (1 

st

 ) day of January each year

and shall close on the thirty first (31 

st

 ) day of December of the same year, with the exception of the first accounting

year, which begins on the date of incorporation of the Company and will close on the 31 

st

 December 2014.

Art. 27. Annual Report. The Company shall publish one annual report in accordance with Luxembourg GAAP and the

SICAR Law and within the time limits provided for in the PPM.

Art. 28. Distribution Policy. The General Partner reserves the right to make distributions and pay dividends, including

interim dividends, to Shareholders when the relevant amount has become available for distribution. Distributions shall
be made by the General Partner in accordance with the terms set out in relation to distributions in the relevant Schedule
to the PPM.

All distributions shall be made net of any income, withholding and similar taxes payable by the Company, including, for

example, any withholding taxes on interest or dividends received by the Company and capital gains taxes, withholding
taxes on the Company's investments.

59681

L

U X E M B O U R G

The General Partner is not entitled to make distributions in kind of the assets belonging to a Compartment to the

Shareholders of the Compartment unless such distribution is made in the context of the liquidation of the relevant
Compartment and in accordance with article 29 below and the PPM.

Except in connection with a liquidation, the Company shall not distribute net proceeds, if as a result thereof, the

subscribed share capital together with the share premium, if any, of the Company would fall below one million euro (EUR
1,000,000) in the aggregate.

Art. 29. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved at any time upon proposition by the General

Partner, by a resolution of the General Meeting of the Company resolving with the quorum and majority required pursuant
to the 1915 Law.

Where the General Partner is removed and not replaced in accordance with the provisions of article 18, the Company

will be automatically liquidated.

The liquidation shall be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of the Company

which shall determine their powers and their compensation. Such liquidators shall be approved by the CSSF and shall
provide  all  guarantees  of  standing  and  professional  skill.  The General Partner  may be  appointed  as liquidator  of  the
Company.

After payment of all debts and charges against the Company and all expenses of liquidation, the net available assets

within each Compartment shall be distributed among the Shareholders of that Compartment according to the provisions
and the priority rules outlined in the relevant Schedule of the PPM.

As to the Compartments, each Compartment shall enter into a liquidation process according to the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg upon the expiry of its relevant term. Unless otherwise provided in the relevant Schedule any early
liquidation of a Compartment shall be approved by a Shareholders Special Resolution (provided that the General Partner
will not have any veto right on such decision and Related Persons and Related Entities will not vote and not be counted
for the quorum/majority requirements on such decision).

When liquidating a Compartment, the General Partner or, if the case may be, the liquidator of the Company shall

distribute all available assets of the Compartment according to the rules and priorities set out in the relevant Schedule
of the PPM and these Articles of Incorporation.

Each Compartment of the Company shall be separately liquidated without such separate liquidation resulting in the

liquidation of another Compartment. Only the liquidation of the last remaining Compartment shall result in the final
liquidation of the Company.

Distributions made at the occasion of the liquidation of the Company or a Compartment may be made in kind with

the consent of the relevant Shareholder, and subject to the approval of the Advisory Board of the relevant Compartment.
The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without
prejudicing the interests of the other Shareholders in the Compartment. Such distribution in kind will be valued by an
external independent valuer.

Art. 30. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the SICAR Law and the 1915 Law.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Name of Subscriber

Number of subscribed shares

Value

1.- Neulogy Ventures S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Management Share

EUR 1

2.- Danube Ventures s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500 Ordinary Shares of Compartment

”Slovak Venture Fund S.C.A.,

SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”

EUR 12,500

3.- Neulogy a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500 Ordinary Shares of Compartment

”Slovak Venture Fund S.C.A.,

SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”

EUR 12,500

4.- Neulogy Ventures a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 Participating Shares of Compartment

”Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR -

Slovak Entrepreneurs Fund”; and 1,000

Participating Shares of Compartment

“Slovak Venture Fund S.C.A.,

SICAR - Slovak Innovation Fund”

EUR 2,000

5.- Ivan Stefunko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500 Ordinary Shares of Compartment

”Slovak Venture Fund S.C.A.,

SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”

EUR 12,500

6.- Michaela Jacova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250 Ordinary Shares of Compartment

”Slovak Venture Fund S.C.A.,

EUR 1,250

59682

L

U X E M B O U R G

SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”

7.- Jaroslav Luptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,250 Ordinary Shares of Compartment

”Slovak Venture Fund S.C.A.,

SICAR - Slovak Entrepreneurs Fund”

EUR 1,250

Upon incorporation, all such Shares were fully paid-up, as it has been justified to the undersigned Notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 

st

 of December

2014.

The first general annual meeting of shareholders shall be held in 2015. The first annual report of the Company will be

dated 31 

st

 of December 2014.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately three thousand euros (EUR 3,000.-).

<i>Statements

The undersigned Notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entire subscribed

capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the Company shall be at 11 Avenue Emile Reuter, L- 2420 Luxembourg.

<i>Second resolution

The independent auditor for the Company shall be Deloitte Audit. The auditor shall remain in office until the close of

annual general meeting approving the accounts of the Company as of 31 December 2014.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
This original deed having been read to the appearing persons, known to the Notary by their name, first name, civil

status and residence, the said appearing persons signed together with us, the Notary, this original deed.

Signé: Maher, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2014. Relation: EAC/2014/2279. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014037799/998.
(140042730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

ASAP-Lipamex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 98.550.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 10 mars 2014.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2014038545/12.
(140043648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

59683

L

U X E M B O U R G

SCD Property Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 134.551.

Nous vous prions de noter que:
- Alice Management S.A. (7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg B151921);
- Béatrice Management S.A. (7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg B151931);
- Claire Management S.A. (7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg B151898)
démissionnent de ses fonctions d'administrateurs de la société SCD Property Group S.A. (7, place du Théâtre, 2613

Luxembourg; R.C.S. Luxembourg B134551) avec effet en date du 10 mars 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Alice Management S.A. / Béatrice Management S.A./ Claire Management S.A.

Référence de publication: 2014037818/16.
(140043264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

Investdeutschland S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 35.810.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014038236/10.
(140043787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

LRP Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 100.217.

<i>Extrait des résolutions du Conseil de gérance

En date du 13 mars 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15 avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants B suivant avec effet

immédiat:

Hille-Paul SCHUT, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Neela GUNGAPERSAD, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2014.

Sophie ZINTZEN
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014038289/19.
(140043672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Euphrasie S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.032.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014040728/9.
(140046808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

59684

L

U X E M B O U R G

Sawyer S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 132.862.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions écrites de l'associé unique de la Société du 31 décembre 2013

Il résulte des décisions écrites de l'associé unique de la Société (l’"Associé Unique") du 31 décembre 2013 les réso-

lutions suivantes (traduction libre):

- L'Associé Unique approuve le rapport du Commissaire à la liquidation daté du 30 décembre 2013;
- L'Associé Unique accorde pleine et entière décharge au Commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat;
- L'Associé Unique approuve les comptes à la liquidation arrêtés au 23 décembre 2013;
- L'Associé Unique prononce la clôture de la liquidation de la Société à la date des présentes résolutions et confirme

que la Société cesse d'exister à partir de la date de ce jour. Les livres et documents sociaux de la Société resteront
déposés et conservés pendant cinq ans dans les locaux de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. au 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (ou à toute autre adresse que Citco REIF Services (Luxembourg) S.A.
pourrait occuper) [...].

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2014.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014037792/25.
(140043038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

Meridiam MC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.093.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17.03.2014.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2014038953/12.
(140044692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Truss Managing Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 72.500,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 111.223.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique du 4 Mars 2014 que:
- Monsieur Alex GILLETTE a démissionné de son mandat de gérant catégorie B;
- Monsieur Cameron MACDOUGALL, ayant pour adresse professionnelle 1345 Avenue of the Americas, New York

10105, USA, est nommé gérant catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 Mars 2014.

Pour extrait conforme
Tomas Lichy
<i>Company Director

Référence de publication: 2014038457/17.
(140044001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

59685

L

U X E M B O U R G

IVG Andel 17 Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 157.038.

Das vorliegende Schriftstück wurde zu dem Zweck erstellt, die im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister

(„Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) eingetragenen Informationen zu aktualisieren.

Am 12. August 2013 wurde der alleinige Teilhaber der Gesellschaft, die IVG Austria (Lux) Verwaltungsgesellschaft S.A.,

von der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. übernommen.

Infolge dessen gestalten sich die Inhaberverhältnisse am Kapital der Gesellschaft wie folgt:
IVG Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS, eine Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und diesem unterliegend, mit Sitz in 24,
avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, eingetragen in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B150381, hält 250 Gesellschaftsanteile.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. März 2013.

IVG Andel 17 Immobilien GmbH
Unterschrift

Référence de publication: 2014038243/21.
(140044007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Mountwise Finco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 153.070.

Suite aux résolutions prises par les actionnaires de La Société en date du 14 février 2014:
Élection des personnes suivantes pour le rôle d'administrateurs de La Société avec date effective le 14 février 2014
- Monsieur Wayne Fitzgerald, né le 11 mai 1976, à Waterford, Ireland, employé privé, demeurant professionnellement

au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, pour une période déterminée de 6 années.

Suite aux résolutions prises par les actionnaires de La Société en date du 17 mars 2014:
En date du 17 mars 2014 les administrateurs suivant ont déposé leurs démissions:
- Démission de Monsieur Philip Gittins en tant qu'administrateur de La Société avec effet au 17 mars 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014038932/16.
(140044808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Mashta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 71.858.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 20 février 2014

En date du 20 février 2014, les membres du conseil d'administration ont décidé à l'unanimité des voix de:
- transférer le siège social de la Société du 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg, au 4, rue

Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec date effective au 1 

er

 mars 2014.

La nouvelle adresse professionnelle de Magali Fetique et de Jean-Marie Bettinger est la suivante: 42 rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg.

La nouvelle adresse de Veridice S.à r.l., est la suivante: 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2014.

MASHTA S.A.

Référence de publication: 2014038941/17.
(140044789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

59686

L

U X E M B O U R G

Maguro I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 136.788.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le 12 juin 2013 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>1 rue Joseph Hackin

<i>Résolutions:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateurs de la société COSAFIN SA, 1 rue Joseph Hackin

L-1746, représentée par Monsieur Jacques BORDET, 1 rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, de Monsieur Koen Lozie,
61 Grand-Rue L-8510 Redange-sur-Attert et de Monsieur Joseph Winandy pour un terme venant à échéance à l'Assemblée
Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2013.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité renouveler THE CLOVER, au poste de Commissaire aux Comp-

tes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui approuvera les comptes de l'exercice
clôturant au 31.12.2013.

Pour extrait
FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2014038938/21.
(140044229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Newton Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 179.647.

L'an deux mille treize, le trente décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme “NEWTON PARTNERS”, (la "Société"), établie

et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 24 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro * du *,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 176.647
L'assemblée est présidée par Madame Géraldine NUCERA, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, qui se désigne également comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société d’un montant de cinquante huit mille trois cent quatre vingt dix huit euros et

soixante centimes (58.398,60-EUR) pour le porter de son montant actuel cent quatre-vingt mille six cent trente-deux
euros et quarante centimes (180.632,40-EUR) représenté par soixante neuf mille quatre cent soixante quatorze (69.474)
actions d’une valeur de deux euros et soixante centimes (2,60-EUR.), à deux cent trente neuf mille et trente et un
(239.031-EUR), par l’émission de vingt deux mille quatre cent soixante et une (22.461) actions nouvelles d'une valeur
nominale de deux euros et soixante centimes (2,60-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.

2. Renonciation par des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et libération des vingt deux mille quatre cent soixante et une (22.461) actions nouvelles
4. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société.
5. Nomination de Monsieur Gérald de Roquemaurel en tant qu’administrateur de la Société; son mandat s’achèvera à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2018.6.

6. Divers.
B)  Que  les  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le  nombre  d’actions  qu’ils  possèdent,  sont  portés  sur  une  liste  de

présence; laquelle liste de présence signée «ne varietur» par les mandataires des actionnaires représentés, les membres
du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

59687

L

U X E M B O U R G

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signée

"ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et par le notaire
instrumentant.

D) Que l’intégralité du capital social étant représentée et que les actionnaires représentés déclare avoir été dûment

notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de
convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les associées, l’assemblée générale, après délibération, a pris à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale augmente le capital social à concurrence de cinquante huit mille trois cent quatre vingt dix huit

euros et soixante centimes (58.398,60-EUR) pour le porter de son montant actuel cent quatre-vingt mille six cent trente-
deux euros et quarante centimes (180.632,40-EUR) représenté par soixante neuf mille quatre cent soixante quatorze
(69.474) actions d’une valeur de deux euros et soixante centimes (2,60-EUR.), à deux cent trente neuf mille et trente et
un (239.031-EUR), par l’émission de vingt deux mille quatre cent soixante et une (22.461) actions nouvelles d'une valeur
nominale de deux euros et soixante centimes (2,60-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale accepte la renonciation des actionnaires actuelles à son leur droit de souscription préférentiel.

<i>Troisième résolution:

<i>Souscription et libération

Les vingt deux mille quatre cent soixante et une (22.461) actions nouvelles ont toutes été souscrites par «La société

CIM», une société civile de droit français, ayant son siège social au 4 square d’Alboni F-75116 Paris (France), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris (France) sous le numéro B 492 107 511 et libérées entièrement par
la prédite souscriptrice moyennant apport en nature consistant en des participations financières.

L’apport en nature est acté comme représentant un apport total minimum d’un montant de cinquante huit mille trois

cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes (58.398,60-EUR).

Cet apport en nature a fait l’objet d'un rapport descriptif établi le 17 décembre 2013 par «Compagnie Européenne de

Révision» (RCS Luxembourg B 37.039), signé par Yves Mertz, réviseur d'entreprises indépendant, demeurant profes-
sionnellement 5 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi
sur les sociétés commerciales telle que modifiée et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion:

Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse penser

que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre
en contrepartie.»

Ledit rapport, signé «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, l’as-

semblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent trente neuf mille et trente et un (239.031-EUR), représenté par quatre-

vingt onze mille neuf cent trente cinq (91.935) actions d'une valeur nominale de deux euros et soixante centimes (2,60-
EUR) chacune.»

<i>Cinquième résolution:

L’assemblée générale nomme avec effet immédiat Monsieur Gérald de Roquemaurel, directeur de sociétés, né le 27

mars 1946 à Paris 13 

ème

 (France), demeurant au 4, Square de l’Alboni, F-75016 Paris, en tant qu’administrateur de la

Société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en l’an 2018, sauf si une

assemblée générale des actionnaires en décide autrement

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

59688

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à mille cent euros (1.100,-EUR).

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. NUCERA, V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 06.01.2014. Relation: LAC/2014/621. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 14.03.2014.

Référence de publication: 2014038978/99.
(140044055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Max S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 145.082.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014038943/9.
(140044354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Mikrolux 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 181.534.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of the month of February.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

AXA LBO FUND V CORE FCPR, a fonds commun de placement à risqué, represented by ARDIAN France, a company

governed by French Law, having its registered office at 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, and registered with the
Register of Commerce and Companies of Paris under number 403 201 882 RCS Paris (the “Sole Shareholder”), being
the sole shareholder of Mikrolux 1 S.A. (the “Company”), a société anonyme with registered office at 24, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary dated 4 November 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 11 December 2013, N° 3153 and registered with
the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 181534.

The articles of association of the Company have been amended by deed of the undersigned notary on 26 November

2013, published in the Mémorial on 29 January 2014, N° 259.

The Sole Shareholder is here represented by Mrs Sophie WEGMANN, lawyer, professionally residing in Luxembourg

(the “Proxyholder”) pursuant to a proxy under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all six hundred eighty-one million two hundred thirty-four thousand three hundred ten

(681,234,310) shares of different classes in issue in the Company.

2. The Sole Shareholder hereby takes decisions on the following item:

<i>Agenda

Amendment of (i) the first sentence of the 9 

th

 paragraph of article 16 and (ii) the second paragraph of article 17 of

the articles of association of the Company, to specify the allocation and payment of dividend declarations, share premium
account distributions and liquidation proceeds payments among the different classes of shares, so as to read as follows:

- first sentence of the 9 

th

 paragraph of article 16:

“In the event of a dividend declaration, share premium account distribution or liquidation proceeds payment upon

dissolution of the Company in accordance with Article 17 below, such dividend, share premium account distribution or

59689

L

U X E M B O U R G

liquidation proceeds payment upon dissolution of the Company in accordance with Article 17 below shall be allocated
and paid as follows:”

- second paragraph of article 17:
“Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be allocated and paid to

the holders of Shares in the Company in the proportion as set out in Article 16, last paragraph of the present articles of
incorporation.”

After the foregoing was approved by the appearing party, the following resolutions were passed;

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to amend (i) the first sentence of the ninth paragraph of article 16 of the Company's

articles of association, so as to be read as follows:

Art. 16. §9. “In the event of a dividend declaration, share premium account distribution or liquidation proceeds payment

upon dissolution of the Company in accordance with Article 17 below, such dividend, share premium account distribution
or liquidation proceeds payment upon dissolution of the Company in accordance with Article 17 below shall be allocated
and paid as follows:”

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend (i) the second paragraph of article 17 of the Company's articles of association,

so as to be read as follows:

Art. 17. §2. “Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be allocated

and paid to the holders of Shares in the Company in the proportion as set out in Article 16, last paragraph of the present
articles of incorporation.”

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at nine hundred Euro (EUR 900,-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes, the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le septième jour du mois de février.
Par devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

AXA LBO FUND V CORE FCPR, un fonds commun de placement à risque représenté par ARDIAN France, une

société régie par le droit français, ayant son siège social au 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 201 882 RCS Paris (l'«Actionnaire Unique»), étant
l'actionnaire unique de Mikrolux 1 S.A. (la «Société»), une société anonyme dont le siège social est situé au 24, avenue
Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné le 4 novembre 2013, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 11 décembre 2013, N° 3153 et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181534.

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire soussigné le 26 novembre 2013, publié au Mémorial du

29 janvier 2014, N° 259.

L'Actionnaire Unique est représenté par Mme Sophie WEGMANN, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg (le «Mandataire»), en vertu d'une procuration sous seing privé (laquelle procuration restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement).

L'Actionnaire Unique a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit:
1. L'Actionnaire Unique détient toutes les six cent quatre-vingt-un millions deux cent trente-quatre mille trois cent

dix (681.234.310) actions de différentes classes émises dans la Société.

2. L'Actionnaire Unique prend par la présente des décisions sur le point suivant:

<i>Ordre du jour

Modification (i) de la première phrase du 9 

ème

 paragraphe de l'article 16 et (ii) du second paragraphe de l'article 17

des statuts de la Société, afin de spécifier l'allocation et le paiement de dividendes, les distributions du compte de prime
et les paiements du solde de liquidation parmi les différentes classes d'actions comme suit:

59690

L

U X E M B O U R G

- première phrase du 9 

ème

 paragraphe de l'article 16:

«Dans le cas, où un dividende est déclaré, d'une distribution du compte de prime ou du paiement du solde de liquidation

suite à la dissolution de la Société conformément à l'article 17 ci-dessous, le dividende, la distribution du compte de prime
ou le paiement du solde de liquidation suite à la dissolution de la Société conformément à l'Article 17 ci-dessous sera
alloué et payé comme suit:»

- second paragraphe de l'article 17:
«Une fois que toutes les dettes, charges et frais de la liquidation seront couverts, le solde éventuel sera alloué et versé

aux porteurs d'Actions de la Société dans la proportion décrite à l'Article 16, dernier paragraphe des présents statuts.»

Après approbation de ce qui précède par la partie comparante, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier (i) la première phrase du neuvième paragraphe de l'article 16 de la Société

comme suit:

Art. 16. §9. «Dans le cas, où un dividende est déclaré, d'une distribution du compte de prime ou du paiement du solde

de liquidation suite à la dissolution de la Société conformément à l'article 17 ci-dessous, le dividende, la distribution du
compte de prime ou le paiement du solde de liquidation suite à la dissolution de la Société conformément à l'Article 17
ci-dessous sera alloué et payé comme suit:»

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier (ii) le second paragraphe de l'article 17 des statuts de la Société comme

suit:

Art. 17. §2. «Une fois que toutes les dettes, charges et frais de la liquidation seront couverts, le solde éventuel sera

alloué et versé aux porteurs d'Actions de la Société dans la proportion décrite à l'Article 16, dernier paragraphe des
présents statuts.»

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à neuf

cents euros (EUR 900.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie compa-
rante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S.WEGMANN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 10 février 2014. Relation: DIE/2014/1795. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014038931/120.
(140044751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Rhô GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 105, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 64.595.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014039042/11.
(140044658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

59691

L

U X E M B O U R G

Cooper Offshore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.444.

EXTRAIT

Par décision du 18 février 2014 de l'actionnaire unique Cooper Industries Holdings (Ireland), ayant son siège social à

Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande, enregistré auprès du registre de commerce irlandais sous le numéro
499912:

- Révocation avec effet au 18 février 2014 de Madame Solange Savarinayagam de son poste de gérant de Cooper

Offshore Holdings Sàrl

- Révocation avec effet au 18 février 2014 de Monsieur Alexis Hubert de son poste de gérant de Cooper Offshore

Holdings Sàrl

- Nomination avec effet au 18 février 2014 de Monsieur Bruno Lawarée, née à Namur (Belgique) le 4 février 1975, et

ayant comme adresse professionnelle 7 route de la Longeraie, 1110 Morges (Suisse), en qualité de gérant de Cooper
Offshore Holdings Sàrl pour une durée de six années

- Nomination avec effet au 18 février 2014 de Monsieur Johannes Vosman, née à Luxembourg (Luxembourg) le 1 

er

octobre 1960, et ayant comme adresse professionnelle 12 rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg (Luxembourg), en
qualité de gérant de Cooper Offshore Holdings Sàrl pour une durée de six années

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2014.

<i>Pour Cooper Industries Holdings (Ireland)
Signature

Référence de publication: 2014038680/26.
(140044947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

HECF Domkaskaden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 213.600,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.655.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 12 mars 2014

L'Associé Unique de HECF Domkaskaden S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Mark Houston en tant que gérant B de la Société à partir du 12 mars 2014;
- De nommer:
* Monsieur Damian Pons, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant

B de la Société à partir du 12 mars 2014, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2014.

HECF Domkaskaden S.à r.l.

Référence de publication: 2014038822/18.
(140045089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Nationwide Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 45.906.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014038354/10.
(140043846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

59692

L

U X E M B O U R G

HECF Marienstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 131.700,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.433.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 12 mars 2014

L'Associé Unique de HECF Marienstrasse S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Mark Houston en tant que gérant B de la Société à partir du 12 mars 2014;
- De nommer:
* Monsieur Damian Pons, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant

B de la Société à partir du 12 mars 2014, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2014.

HECF Marienstrasse S.à r.l.

Référence de publication: 2014038825/18.
(140045092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Domus Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 150.369.

Par la présente, la société Fidu-Concept Sàrl dénonce avec effet au 17/03/2014 le siège social, 36, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg, de la société DOMUS FINANCE S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 150.369

<i>Pour Fidu-Concept Sàrl

Référence de publication: 2014038728/10.
(140044679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Eaton Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 429.900,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.077.

EXTRAIT

Par décision du 18 février 2014 de l'actionnaire unique Eaton LP, une société de partenariat enregistrée en vertu des

lois de l'Ecosse, ayant son siège social à Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, Royaumes Unis, enregistré dans
le cadre du partenariat sous le numéro de constitution SL005520:

- Révocation avec effet au 18 février 2014 de Madame Sabine Knobloch de son poste d'administrateur de Eaton Holding

II Sàrl

- Nomination avec effet au 18 février 2014 de Monsieur Johannes Vosman, née à Luxembourg (Luxembourg) le 1 

er

octobre 1960, et ayant comme adresse professionnelle 12 rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg (Luxembourg), en
qualité d'administrateur de Eaton Holding II Sàrl pour une durée de six années

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2014.

<i>Pour Eaton LP
Signature

Référence de publication: 2014038743/21.
(140044891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

59693

L

U X E M B O U R G

CVC European Credit Opportunities (No. 8) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.083.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé Unique en date du 13 mars 2014

- Monsieur Mark DeNatale, né le 09 février 1972 à New York, NY, États-Unis d'Amérique, résident professionnelle-

ment au 712 Fifth Avenue, 43 

rd

 Floor, NY 10019, New York, États-Unis d'Amérique, a été nommé gérant de catégorie

A de la Société pour une durée indéterminée.

- Le nombre de gérants de la Société a été augmenté de six (6) à sept (7).
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jonathan Bowers, gérant de catégorie A;
- Monsieur Brandon Bradkin, gérant de catégorie A;
- Monsieur Mark DeNatale, gérant de catégorie A;
- Monsieur Douglas Maccabe, gérant de catégorie B;
- Monsieur Russell Proffitt-Perchard, gérant de catégorie B;
- Monsieur Maxence Monot, gérant de catégorie B;
- Monsieur Simon Riley, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014038719/23.
(140045058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Fial Industrial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 162.623.

Il résulte des actes de la Société que l'associé Roberto Galperti Immobiliare e Finanziaria S.R.L. a changé de dénomi-

nation sociale en date du 17 février 2014. Sa nouvelle dénomination sociale est la suivante: Fial Immobiliare Finanziaria
S.R.L.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg)
Signature

Référence de publication: 2014039429/14.
(140045604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 113.115.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 28

février 2014, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à partir de la date de

la clôture de la liquidation au 43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014038556/17.
(140043738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

59694

L

U X E M B O U R G

Green Farm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4105 Esch-sur-Alzette, 10, rue Edison.

R.C.S. Luxembourg B 87.709.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée GREEN FARM, S.à r.l., avec siège social à L-4150 Esch-
sur-Alzette, 10, rue Edison, de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita Lecuit, juge, et liquidateur Maître Julie Zens, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Il a ordonné aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 4 avril 2014 au greffe de la sixième chambre

du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Maître Julie Zens
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014038551/19.
(140044090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

RGL16 S.A., Société Anonyme,

(anc. R-Solution).

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 124.412.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den sechzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch/Alzette, handelnd im Namen und für Rechnung

seines verhinderten Amtskollengen Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, erscheint der alleinige Ak-
tionär  der  Aktiengesellschaft  R-Solution,  mit  Sitz  in  9A,  rue  Gabriel  Lippmann,  L-5365  Munsbach,  gegründet  gemäß
notarieller Urkunde vom 22. Dezember 2006 des Notars Jean Seckler, veröffentlicht im Memorial, Recueil Spécial C,
Nummer 674 vom 21. April 2007, und im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 124.412 eingetragen, zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung.

Den Vorsitz der Versammlung führt Dame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Adresse in Esch/

Alzette.

Zum Schriftführer wird bestimmt Dame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, Privatbeamtin, mit Adresse in Esch/Alzette.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Dame Claudia ROUCKERT, Privatbeamtin, mit Adresse in Esch/Alzette.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist eine Anwesenheitsliste beigefügt. Diese Liste wurde von dem Aktionär, sowie von dem

Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet.

II. Da alle 10.000 (zehntausend) Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist die Versammlung ordentlich zusammenge-

setzt  und  kann  rechtsgültig  über  die  Tagesordnung  abstimmen,  die  dem  Aktionär  vor  der  Versammlung  übermittelt
worden war.

III. Diese Tagesordung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Verzicht auf Einberufungsrecht;
2. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft;
3. Benennung neuer Verwaltungsratsmitglieder; und
4. Verschiedenes.
Nach ausführlicher Beratung trifft die Versammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Es wird beschlossen, dass der alleinige Aktionär auf sein Einberufungsrecht zur dieser außerordentlichen Hauptver-

sammlung verzichtet, bestätigt ausreichend über die Tagesordnung informiert zu sein, die Versammlung als rechtsgültig
einberufen ansieht und zustimmt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen. Es wird außerdem festgestellt, dass
alle relevanten Unterlagen dem Aktionär innerhalb einer ausreichenden Zeitspanne zur Verfügung gestellt worden sind,
damit er sorgfältig jedes Dokument prüfen konnte.

59695

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss:

Es wird beschlossen die Gesellschaftsbezeichnung in "RGL16 S.A." abzuändern und dementsprechend den Artikel 1

der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht ("société anonyme") und führt die

Bezeichnung " RGL16 S.A."."

<i>Dritter Beschluss:

Es wird beschlossen folgende neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen:
- Roland Kunz, geboren am 24. März 1968, in Zürich (Schweiz), professionell wohnhaft in Sihleggstrasse 17, CH-8832

Wollerau, Schweiz;

- Josiane Jennes, geboren am 23. April 1982, in Eupen (Belgium), professionell wohnhaft in 9A, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.

Die Dauer des Mandats der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Tag der jährlichen Hauptversammlung der

Gesellschaft 2019.

Der Verwaltungsrat besteht nach dieser Ernennung aus folgende Mitglieder:
- Thomas Bernard;
- Roland Kunz; und
- Josiane Jennes.

<i>Kosten

Die Kosten, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf ungefähr

eintausend dreihundert Euro (EUR 1.300.-) geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparent, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 janvier 2014. Relation: EAC/2014/1233. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014038395/67.
(140044277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Real Web S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 136.028.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 février 2014 que:
- Les mandats de Monsieur Massimo LONGONI, administrateur et administrateur-délégué; de Monsieur Andrea PIC-

CIONI, administrateur et président du Conseil d'Administration, de Monsieur Enrico CALABRETTA et de Monsieur
Judicaël MOUNGUENGUY, administrateurs, ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2015.

Est réélu commissaire:
- Monsieur Marcel STEPHANY, demeurant professionnellement au 23, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange. Son

mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 mars 2014.

Référence de publication: 2014038396/18.
(140043788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

59696

L

U X E M B O U R G

Saputo Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.846.

Il résulte des résolutions signées de l'associé unique de la Société du 03 mars 2014 qu'il a été décidé à l'unanimité:
- d'accepter la démission de Mademoiselle Polyxeni Kotoula en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au

28 Février 2014;

- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire de classe B et pour une durée illimitée, Monsieur Jacob

Mudde, né le 14 Octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat au 03 mars 2014; et

- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Madame Louise Saint-Jean, Gérant de classe A;
* Madame Florence Rao, Gérant de classe B; et
* Monsieur Jacob Mudde, Gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2014038418/23.
(140043740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

SHCO 62 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 185.157.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the tenth day of February.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at L-1931 Luxembourg, 13-15 Avenue de la Liberté, registered with the Luxembourg
trade registry under number B 103.123,

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, professionally residing in Esch/Alzette, by

virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed

by the relevant law and the present articles.

Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to

such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.

Art. 4. The company will assume the name of
“SHCO 62 S.à r.l.” a private limited liability company.

59697

L

U X E M B O U R G

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy

of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by

12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law concerning

commercial companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the

legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely trans-
ferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the

company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers

have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or

e-mail another Manager as his proxy.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment

regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.

Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each

member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

59698

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that

the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
in accordance with the Law or these Articles.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33)
are satisfied.

<i>Transitory Disposition

The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and fourteen.

<i>Subscription and payment

The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l..
prenamed: 12.500 (twelve thousand five hundred) shares
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred

euro), so that the amount of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company.

<i>Estimate of costs

The parties estimate the value of formation expenses at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Decisions of the sole shareholder

The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at, 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg, registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.336.

2) The registered office is established at L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Intertrust (Luxembourg) S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, salariée, demeurant professionnellement à Esch/

Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

59699

L

U X E M B O U R G

La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de
«SHCO 62 S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité  avec  les  dispositions  légales  afférentes.  Dans  l'hypothèse  où  il  n'y  a  qu'un  seul  associé  les  parts  sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à
une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Lu-
xembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée
équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document
ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé. Tout gérant peut
se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou
e-mail un autre gérant comme son mandataire.

59700

L

U X E M B O U R G

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion

du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le

notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille quatorze.

<i>Souscription et libération

Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l'associé unique comme suit:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., prédésignée: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500.- (douze mille cinq

cents euros), de sorte que le montant de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Décisions de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Intertrust Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.336.

59701

L

U X E M B O U R G

2) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2425. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014037212/254.
(140042490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Gedeam Tourism S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 142.595.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2014 que Monsieur Michel Schaeffer, expert

comptable, né le 4 juillet 1975 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227
Luxembourg, a été nommé nouveau commissaire aux comptes pour terminer le mandat du commissaire sortant, I.C.
DOM-COM S.àr.l..

Luxembourg, le 5 mars 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2014038806/16.
(140044873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Castmetal FWI, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 185.211.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2014.

Référence de publication: 2014038110/10.
(140043901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Arkum, Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 87.262.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 10 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1099 du 18
juillet 2002.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARKUM
Signature

Référence de publication: 2014039932/15.
(140046397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2014.

59702

L

U X E M B O U R G

ScienceInvest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 59.637.

Il est porté à la connaissance des tiers que:
Suite à la fusion intervenue le 30 septembre 2013 entre Fides Inter-Consult S.A., ayant son siège social 62, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant que Société Absorbée, et Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A., en tant que Société
Absorbante, publiée sous la référence 2013137801/38 et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg le 2 octobre 2013, le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante
a été réalisé.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco C&amp;T (Luxembourg)

S.A. informe de la dénonciation, avec effet au 28 février 2014, de la convention de domiciliation conclue le 14 août 2007
pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

- ScienceInvest Holding S.A., ayant son siège social au 62, Avenue Victor Hugo, Luxembourg,enregistrée au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 59637; et

- Fides Inter-Consult S.A., ayant son siège social 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, enregistrée au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B.52925.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2014.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
2-8 avenue Charles De Gaulle
L-1653 Luxembourg
Signatures
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014037819/25.
(140043432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

Identitag Secondary Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 13.360.067,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 161.954.

<i>Extrait de transfert de parts sociales

1. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que J.P. Morgan Specialist Funds - J.P.

Morgan Special Opportunities Fund a cédé:

34.677 (trente-quatre mille six cents soixante-dix-sept) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à

JPEL HOLDINGS LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The
Grange, St Peter Port, Guernsey GY14BF;

34.677 (trente-quatre mille six cents soixante-dix-sept) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à

JPEL HOLDINGS LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The
Grange, St Peter Port, Guernsey GY14BF;

34.677 (trente-quatre mille six cents soixante-dix-sept) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à

JPEL HOLDINGS LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The
Grange, St Peter Port, Guernsey GY14BF;

34.677 (trente-quatre mille six cents soixante-dix-sept) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à

JPEL HOLDINGS LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The
Grange, St Peter Port, Guernsey GY14BF;

34.677 (trente-quatre mille six cents soixante-dix-sept) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à

JPEL HOLDINGS LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The
Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF.

2. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que StepStone Pioneer Capital Europe

II, L.P. a cédé:

2.421 (deux mille quatre cent vingt et une) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

2.421 (deux mille quatre cent vingt et une) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey/ avec siège social à Carinthia House/ 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

59703

L

U X E M B O U R G

2.421 (deux mille quatre cent vingt et une) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

2.421 (deux mille quatre cent vingt et une) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

2.421 (deux mille quatre cent vingt et une) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

21.093 (vingt et un mille quatre-vingt-treize) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à GMAG

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LLC une société établie sous le droit de Delaware, avec siège social à c/o Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA;

21.093 (vingt et un mille quatre-vingt-treize) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à GMAG

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LLC une société établie sous le droit de Delaware, avec siège social à c/o Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA;

21.093 (vingt et un mille quatre-vingt-treize) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à GMAG

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LLC une société établie sous le droit de Delaware, avec siège social à c/o Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA;

21.093 (vingt et un mille quatre-vingt-treize) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à GMAG

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LLC une société établie sous le droit de Delaware, avec siège social à c/o Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA;

21.093 (vingt et un mille quatre-vingt-treize) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à GMAG

SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LLC une société établie sous le droit de Delaware, avec siège social à c/o Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA;

6.993 (six mille neuf cents quatre-vingt-treize) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à HINDS-

PERKINS  CAPITAL  PARTNERS  une  société  établie  sous  le  droit  de  Texas,  avec  siège  social  à  c/o  PO  BOX  4240,
Horseshoe Bay, Texas 78657, USA;

6.993 (six mille neuf cents quatre-vingt-treize) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à HINDS-

PERKINS  CAPITAL  PARTNERS  une  société  établie  sous  le  droit  de  Texas,  avec  siège  social  à  c/o  PO  BOX  4240,
Horseshoe Bay, Texas 78657, USA;

6.993 (six mille neuf cents quatre-vingt-treize) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à HINDS-

PERKINS  CAPITAL  PARTNERS  une  société  établie  sous  le  droit  de  Texas,  avec  siège  social  à  c/o  PO  BOX  4240,
Horseshoe Bay, Texas 78657, USA;

6.993 (six mille neuf cents quatre-vingt-treize) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à HINDS-

PERKINS  CAPITAL  PARTNERS  une  société  établie  sous  le  droit  de  Texas,  avec  siège  social  à  c/o  PO  BOX  4240,
Horseshoe Bay, Texas 78657, USA;

6.993 (six mille neuf cents quatre-vingt-treize) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à HINDS-

PERKINS  CAPITAL  PARTNERS  une  société  établie  sous  le  droit  de  Texas,  avec  siège  social  à  c/o  PO  BOX  4240,
Horseshoe Bay, Texas 78657, USA;

1.358 (mille trois cents cinquante-huit) parts sociales de classe A2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Klaus

ACKERSTAFF demeurant à 80 Via Stradone, 6579 Piazzogna, Switzerland;

1.358 (mille trois cents cinquante-huit) parts sociales de classe B2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Klaus

ACKERSTAFF demeurant à 80 Via Stradone, 6579 Piazzogna, Switzerland;

1.358 (mille trois cents cinquante-huit) parts sociales de classe C2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Klaus

ACKERSTAFF demeurant à 80 Via Stradone, 6579 Piazzogna, Switzerland;

1.358 (mille trois cents cinquante-huit) parts sociales de classe D2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Klaus

ACKERSTAFF demeurant à 80 Via Stradone, 6579 Piazzogna, Switzerland;

1.358 (mille trois cents cinquante-huit) parts sociales de classe E2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Klaus

ACKERSTAFF demeurant à 80 Via Stradone, 6579 Piazzogna, Switzerland;

1.301 (mille trois cents une) parts sociales de classe A2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Daniele DELLA

LIBERA demeurant à 13 Via Lepori, 6900 Massagno, Switzerland;

1.301 (mille trois cents une) parts sociales de classe B2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Daniele DELLA

LIBERA demeurant à 13 Via Lepori, 6900 Massagno, Switzerland;

1.301 (mille trois cents une) parts sociales de classe C2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Daniele DELLA

LIBERA demeurant à 13 Via Lepori, 6900 Massagno, Switzerland;

1.301 (mille trois cents une) parts sociales de classe D2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Daniele DELLA

LIBERA demeurant à 13 Via Lepori, 6900 Massagno, Switzerland;

59704

L

U X E M B O U R G

1.301 (mille trois cents une) parts sociales de classe E2 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Daniele DELLA

LIBERA demeurant à 13 Via Lepori, 6900 Massagno, Switzerland.

3. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que DM Capital Investments Limited

a cédé:

3.002 (trois mille deux) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

3.002 (trois mille deux) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

3.002 (trois mille deux) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

3.002 (trois mille deux) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

3.002 (trois mille deux) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF.

4. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Scott D. Campbell and Sandra K.

Campbell as Trustees of The Scott and Sandra Campbell Family Trust U/T/A/DTD 4/3/09 ont cédé:

159 (cent cinquante-neuf) parts sociales de classe A1 qu'ils détenaient dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

159 (cent cinquante-neuf) parts sociales de classe B1 qu'ils détenaient dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

159 (cent cinquante-neuf) parts sociales de classe C1 qu'ils détenaient dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

159 (cent cinquante-neuf) parts sociales de classe D1 qu'ils détenaient dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

159 (cent cinquante-neuf) parts sociales de classe E1 qu'ils détenaient dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF.

5. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Monsieur Alexis Boyer a cédé:
3.731 (trois mille sept cents trente et une) parts sociales de classe A1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

3.731 (trois mille sept cents trente et une) parts sociales de classe B1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

3.731 (trois mille sept cents trente et une) parts sociales de classe C1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

3.731 (trois mille sept cents trente et une) parts sociales de classe D1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF;

3.731 (trois mille sept cents trente et une) parts sociales de classe E1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS

LIMITED une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter
Port, Guernsey GY1 4BF.

6. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Monsieur Sean Hunt a cédé:
722 (sept cents vingt-deux) parts sociales de classe A1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

59705

L

U X E M B O U R G

722 (sept cents vingt-deux) parts sociales de classe B1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

722 (sept cents vingt-deux) parts sociales de classe C1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

722 (sept cents vingt-deux) parts sociales de classe D1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

722 (sept cents vingt-deux) parts sociales de classe E1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

7. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Monsieur José-Miguel Orti a cédé:
1.059 (mille cinquante-neuf) parts sociales de classe A1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

1.059 (mille cinquante-neuf) parts sociales de classe B1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY14BF;

1.059 (mille cinquante-neuf) parts sociales de classe C1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

1.059 (mille cinquante-neuf) parts sociales de classe D1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

1.059 (mille cinquante-neuf) parts sociales de classe E1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une

société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey
GY1 4BF;

8. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que RBC Trustees (CI) Limited as

Trustee of the Vitol Employee Benefit Trust a cédé:

2.037 (deux mille trente-sept) parts sociales de classe A1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

2.037 (deux mille trente-sept) parts sociales de classe B1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

2.037 (deux mille trente-sept) parts sociales de classe C1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

2.037 (deux mille trente-sept) parts sociales de classe D1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

2.037 (deux mille trente-sept) parts sociales de classe E1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED

une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernsey GY1 4BF;

9. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Monsieur Emilio Esteban a cédé:
801 (huit cents une) parts sociales de classe A1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

801 (huit cents une) parts sociales de classe B1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

801 (huit cents une) parts sociales de classe C1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY14BF;

801 (huit cents une) parts sociales de classe D1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

59706

L

U X E M B O U R G

801 (huit cents une) parts sociales de classe E1 qu'il détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

10. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que CPL Investments Guernsey LP

a cédé:

607 (six cents sept) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

607 (six cents sept) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

607 (six cents sept) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

607 (six cents sept) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

607 (six cents sept) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à JPEL HOLDINGS LIMITED une société

établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1
4BF;

491 (quatre cents quatre-vingt une) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à SOLAIA PRIVATE

EQUITY LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road
Town, Tortola, BVI;

491 (quatre cents quatre-vingt une) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à SOLAIA PRIVATE

EQUITY LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road
Town, Tortola, BVI;

491 (quatre cents quatre-vingt une) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à SOLAIA PRIVATE

EQUITY LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road
Town, Tortola, BVI;

491 (quatre cents quatre-vingt une) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à SOLAIA PRIVATE

EQUITY LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road
Town, Tortola, BVI;

491 (quatre cents quatre-vingt une) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à SOLAIA PRIVATE

EQUITY LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road
Town, Tortola, BVI;

959 (neuf cents cinquante-neuf) parts sociales de classe A1 qu'elle détenait dans la Société à COLOGNA DATAMARS

LTD une société établie sous le droit de St. Vincent, avec siège social à Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown,
SAINT VINCENT;

959 (neuf cents cinquante-neuf) parts sociales de classe B1 qu'elle détenait dans la Société à COLOGNA DATAMARS

LTD une société établie sous le droit de St. Vincent, avec siège social à Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown,
SAINT VINCENT;

959 (neuf cents cinquante-neuf) parts sociales de classe C1 qu'elle détenait dans la Société à COLOGNA DATAMARS

LTD une société établie sous le droit de St. Vincent, avec siège social à Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown,
SAINT VINCENT;

959 (neuf cents cinquante-neuf) parts sociales de classe D1 qu'elle détenait dans la Société à COLOGNA DATAMARS

LTD une société établie sous le droit de St. Vincent, avec siège social à Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown,
SAINT VINCENT;

959 (neuf cents cinquante-neuf) parts sociales de classe E1 qu'elle détenait dans la Société à COLOGNA DATAMARS

LTD une société établie sous le droit de St. Vincent, avec siège social à Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown,
SAINT VINCENT.

11. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que JPEL Holdings Limited a cédé:
30.902 (trente mille neuf cents deux) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à J.P. MORGAN

SPECIALIST FUNDS - J.P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND une société établie sous le droit de Luxembourg,
avec siège social à 6, route de Trêves, L-2633 Senningerberg;

121.962 (cent vingt et un mille neuf cents soixante-deux) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à

STEPSTONE PIONEER CAPITAL EUROPE II, L.P. une société établie sous le droit de New York, avec siège social à 505,

th

 Avenue, 17 

th

 floor, New York NY10017, USA;

59707

L

U X E M B O U R G

2.732 (deux mille sept cents trente-deux) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à SOLAIA PRIVATE

EQUITY LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à 3076 Sir Francis Drake's Highway, Road
Town, Tortola, BVI;

5.716 (cinq mille sept cents seize) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à COLOGNA DATAMARS

LTD une société établie sous le droit de St. Vincent, avec siège social à Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown,
SAINT VINCENT;

21.001 (vingt et un mille une) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à DM CAPITAL INVESTMENTS

LIMITED une société établie sous le droit de BVI, avec siège social à Nerine Chambers, PO BOX 905, Quastisky Building,
Road Town, Tortola, BVI;

2.678 (deux mille six cents soixante-dix-huit) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à Scott D.

Campbell and Sandra K. Campbell as Trustees of THE SCOTT AND SANDRA CAMPBELL FAMILY TRUST U/T/A/DTD
4/3/09 une société établie sous le droit de Oregan, avec siège social à 7610 SE 162 

nd

 Avenue, Portland, OR 97236,

Oregon, USA;

19.403 (dix-neuf mille quatre cents trois) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Alexis

BOYER demeurant à 145 Hambalt Road, London SW4 9EL, UNITED KINGDOM;

3.623 (trois mille six cents vingt-trois) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Sean

HUNT demeurant à 9a Chesterford Gardens, London NW3 7DD, UNITED KINGDOM;

5.374 (cinq mille trois cents soixante-quatorze) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur

José-Miguel ORTI demeurant à Quai du Seujet 12,1201 Geneva, SWITZERLAND;

7.491 (sept mille quatre cents quatre-vingt-onze) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à RBC

Trustees (CI) Limited as Trustee of THE VITOL EMPLOYEE BENEFIT TRUST une société établie sous le droit de Jersey,
avec siège social à La Motte Chambers, St Helier, JERSEY JE11PB;

4.100 (quatre mille cent) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à Monsieur Emilio ESTEBAN

demeurant à Calle Toledo 172, C-28005 Madrid, SPAIN;

14.456 (quatorze mille quatre cents cinquante-six) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à CPL

INVESTMENTS GUERNSEY LP une société établie sous le droit de Guernsey, avec siège social à Carinthia House, 9-12
The Grange, St Peter Port, GUERNSEY GY1 4BF.

12. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que GMAG Special Opportunities

Fund LLC a cédé:

102.739 (cent-deux mille sept cents trente-neuf) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à J.P.

MORGAN SPECIALIST FUNDS - J.P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND une société établie sous le droit de
Luxembourg, avec siège social à 6, route de Trêves, L-2633 Senningerberg.

13. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Hinds-Perkins Capital Partners

a cédé:

34.371 (trente-quatre mille trois cents soixante-et-onze) parts sociales de classe F1 qu'elle détenait dans la Société à

J.P. MORGAN SPECIALIST FUNDS - J.P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND une société établie sous le droit
de Luxembourg, avec siège social à 6, route de Trêves, L-2633 Senningerberg.

14. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Monsieur Klaus Ackerstaff a

cédé:

6.626 (six mille six cents vingt-six) parts sociales de classe F1 qu'il détenait dans la Société à J.P. MORGAN SPECIALIST

FUNDS - J.P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND une société établie sous le droit de Luxembourg, avec siège
social à 6, route de Trêves, L-2633 Senningerberg.

15. Il résulte des cessions de parts sociales effectuées en date du 25 février 2014 que Monsieur Daniele Deila Libéra

a cédé:

6.347 (six mille trois cents quarante-sept) parts sociales de classe F1 qu'il détenait dans la Société à J.P. MORGAN

SPECIALIST FUNDS - J.P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND une société établie sous le droit de Luxembourg,
avec siège social à 6, route de Trêves, L-2633 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

<i>Pour Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2014037569/312.
(140043246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

59708

L

U X E M B O U R G

Eat's Time S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 80.810.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d'administrateur de la société EAT'S

TIME SA avec effet au 22 juin 2005.

Luxembourg, le 14/03/2014.

MONIVAS José
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014038546/12.
(140043757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

C.C. Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.782.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2014.

C.C. INVESTMENT GROUP S.A.
Geert DIRKX
<i>Administrateur unique

Référence de publication: 2014038664/13.
(140044402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

BE Sophia Lux II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.501.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 6 mars 2014

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Madame Johanna Kohvakka en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet au 1 

er

 mars 2014;

- de nommer:
* Monsieur Neil Fieming Ross, né le 16 novembre 1953 à Edinburgh, Royaume-Uni, demeurant professionnellement

au 10 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet au 1 

er

 mars 2014 et pour

une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2014.

Clémentine George
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014038647/20.
(140044727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Catalyst Buyout I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 119.578.

Il résulte des résolutions signées de l'associé unique de la Société du 13 mars 2014 qu'il a été décidé à l'unanimité:
- d'accepter la démission de Madame Florence Rao en tant que gérant de la Société avec effet au 13 mars 2014;
- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire et pour une durée illimitée, Monsieur Jacob Mudde, né le 14

Octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en tant que gérant de la Société avec effet immédiat au 13 mars 2014; et

59709

L

U X E M B O U R G

- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Jacob Mudde; et
* Monsieur Jorge Pérez Lozano.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2014038668/21.
(140044801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Alcogro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 96.922.

L'an deux mille quatorze, le quatre mars,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ALCOGRO S.A.», ayant son siège social

à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 96.922, constituée suivant acte notarié en date du 29 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1074 du 13 juillet 2002. (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 17 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 474 du 26 février 2013.

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Florent KLING, juriste, avec adresse profes-

sionnelle à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich,

qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1212

Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée désigne comme scrutatrice Madame Pascale FEYEREISEN, assistante juridique, avec adresse profession-

nelle à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich vers L-4940 Hautcharage, 2, rue

Laangwiss;

2. Modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions

qu'il détient est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire unique ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procurations de l'actionnaire unique représenté, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution:

L'assemblée générale décide le transfert du siège social de la Société de L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich vers

L-4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss et par conséquent la première phrase de l'article des statuts 2 est modifié et aura
désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

59710

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. KLING, C. GESCHWIND, P. FEYEREISEN et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2014.LAC / 2014 / 10719. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014038607/54.
(140044671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Agate Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 169.504.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2014 que:
1. Le transfert du siège social du 412F Route d'Esch, L - 2086 Luxembourg au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg, est approuvé;

2. La démission de Fin Contrôle S.A de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée;
3. La société Magister Audit Services S.à R.L., Société à Responsabilité Limitée, 45 Avenue de la Liberté, L - 1931

Luxembourg, RCS B 183.813, est nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement du Com-
missaire aux Comptes démissionnaire, pour une période statutaire de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire
appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre 2019;

4. La démission de Messieurs Daniel PIERRE, Pierre PARACHE et Olivier BEAUDOUL de leur mandat d'administrateur

de la société est acceptée;

5. Les nominations de Mr Stéphane ALLART, expert-comptable, né le 19 février 1981 à Uccle (Belgique), résidant

professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, de Mr Olivier DEDOBBELEER, employé-privé, né
le 9 avril 1983 à Namur (Belgique), résidant professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et de
Mr Pierre MESTDAGH, employé-privé, né le 21 novembre 1961 à Etterbeeck (Belgique), résidant professionnellement
au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, comme administrateurs, sont acceptées. Les Administrateurs nommés
termineront le mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2014039254/27.
(140045847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2014.

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 408.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 110.736.

Il résulte d'une lettre adressée à la Société que Madame Laurie ROMANAK a démissionné de son mandat de gérant

de la Société avec effet au 31 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2014.

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest S.à r.l.
Représentée par CBRE Global Investors Luxembourg S.à r.l.
<i>Gérant
Daniel Laurencin / Eric Binon
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2014038692/17.
(140044853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

59711

L

U X E M B O U R G

GMS Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 108.669.

<i>Rectificatif du dépôt du 13 février 2014 N°L140027738

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014038810/10.
(140044767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Guenebaut Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z.I. Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 131.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014038804/12.
(140044550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Quatre cent trente-sixième (436.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 148.549.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Gesellschafterbeschluss im Umlaufverfahren

Die Gesellschafter der INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Quatre cent trente-sixième (436.) S.e.c.s. mit dem Sitz in 05 rue

Bachergaass, L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister unter B148549 sind

1. INNCONA Management S.ar.l., mit dem Sitz in L-5444 Schengen, 05 rue Baachergaass eingetragen im Handelsre-

gister B 128812,

2. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B

129851, die beiden vorgenannten Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter und die TEMTEX Management S.
A. als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin sowie

3. TEMTEX Management S. A. mit dem Sitz in L-5444 Schengen, rue Baachergaass, eingetragen im Handelsregister B

129851, als alleinige Kommanditistin.

Dies vorausgeschickt, beschließen die Gesellschafter Folgendes:
A. Die Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist beendet.
Die Liquidation der Gesellschaft ist beendet. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.
B. Hinterlegung der Geschäftsbücher
Die Geschäftsbücher der Gesellschcft werden beim Steuerbüro BSP Steuerbera-tung UG, Roonstraße 20, D-56068

Koblenz hinterlegt.

Sämtliche Beschlüsse wurden mit den Stimmen der Gesellschafterin TEMTEX Management S. A. und damit mit einer

Mehrheit von 100% minus einer Stimme gefasst.

Schengen, am 05.12.2012.

<i>Für die TEMTEX Management S.A.
Dipl. Volkswirt J. Grote
<i>Kommanditist

Référence de publication: 2014038541/30.
(140043304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

59712


Document Outline

Agate Invest S.A.

Alcogro S.A.

Arkum

ASAP-Lipamex S.à r.l.

BE Sophia Lux II

Castmetal FWI

Catalyst Buyout I S.à r.l.

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest S.à r.l.

C.C. Investment Group S.A.

Cooper Offshore Holdings S.à r.l.

CVC European Credit Opportunities (No. 8) S.à r.l.

Domus Finance S.A.

Eaton Holding II S.à r.l.

Eat's Time S.A.

Euphrasie S.A.

Fial Industrial S.à r.l.

FR Plasco Holdings Sàrl

Gedeam Tourism S.A.

GMS Investments

Green Farm S.à r.l.

Guenebaut Lux S.à r.l.

HECF Domkaskaden S.à r.l.

HECF Marienstrasse S.à r.l.

Identitag Secondary Opportunities S.à r.l.

INNCONA S.àr.l. &amp; Cie. Quatre cent trente-sixième (436.) S.e.c.s.

Investdeutschland S.A., SPF

IVG Andel 17 Immobilien GmbH

LRP Luxembourg Holdings S.à r.l.

Maguro I S.A.

Mashta S.A.

Max S.A.

Meridiam MC S.A.

Mikrolux 1 S.A.

Mountwise Finco S.A.

Nationwide Management Services S.A.

Newton Partners

OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A.

Real Web S.A.

RGL16 S.A.

Rhô GmbH

R-Solution

Saputo Europe Holdings S.à r.l.

Sawyer S.à r.l.

SCD Property Group S.A.

ScienceInvest S.A.

SHCO 62 S.à r.l.

Slovak Ventures Fund S.C.A., SICAR

Truss Managing Partner S.à r.l.