logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1174

9 mai 2014

SOMMAIRE

Aismare Lux Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56310

B.A. Domicili S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56320

Biostime Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

56312

ColKart Investment II SCS . . . . . . . . . . . . . .

56322

Columeta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56351

Commercial Real Estate Loans SCA  . . . . .

56324

Effequatro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56352

Gubernantia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56320

Hartung Internationale Transporte

G.M.B.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56311

Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . .

56311

Lagunare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56310

LIB Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56310

Link Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56306

LINSTER-bureautique S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

56310

LINSTER-bureautique S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

56310

Logicor Holdco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56311

Logicor Pledgeco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

56312

Lunar Hereford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56306

Lunar Stretford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56307

Lux 22 Starlight GBP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

56307

Lux 30 Starlight EUR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

56307

Luxempart Capital Partners, SICAR, S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56307

Luxvalor Management S.A.  . . . . . . . . . . . . .

56312

Lyotre Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56311

Maman Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56331

Marcol Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56309

Marcol Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56309

Matrix Plymouth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56306

Medest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56309

Medest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56308

MGE Vernon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56307

Middagkrans S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56308

Mikek S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56308

MMD Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56308

Morgan Stanley Eder S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

56331

MSI Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56309

MStar Holdings Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

56312

Prologis European Holdings XXIV S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56352

Sephir Participation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

56306

Volkswagen Finance Luxemburg S.A.  . . . .

56332

56305

L

U X E M B O U R G

Matrix Plymouth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 123.098.

Suite aux résolutions prises par les actionnaires de La Société en date du 17 mars 2014:
Élection des personnes suivantes pour le rôle d'administrateurs de La Société avec date effective le 17 mars 2014:
- Monsieur Ivo Hesmondhalgh, né le 24 novembre 1956, à New York, employé privé, demeurant professionnellement

au 42 Leinster Gdns, Londres W2 3AN, Royaume Uni, pour une période déterminée de 6 années.

En date du 17 mars 2014 les administrateurs suivant ont déposé leurs démissions:
- Démission de Monsieur Philip Gittins en tant qu'administrateur de La Société avec effet au 17 mars 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014038928/15.
(140044797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2014.

Sephir Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 251.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 166.410.

En date du 16 mai 2012, l'associé unique Fondations Capital I S.C.A, SICAR, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, a transféré 582 parts sociales à NOMINOË avec siège social au 7, rue de Talleyrand, 75007 Paris,
France, qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- Fondations Capital I S.C.A, SICAR, précité, avec 250,418 parts sociales
- NOMINOË, précité, avec 582 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2014.

Référence de publication: 2014038435/16.
(140043862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Lunar Hereford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 174.260.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Référence de publication: 2014036491/10.
(140041292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Link Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 109.324.

Le bilan et le compte de pertes et profits abrégés au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire COFIGEST S.A R.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPPIN

Référence de publication: 2014036509/13.
(140041569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

56306

L

U X E M B O U R G

Lunar Stretford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 174.259.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Référence de publication: 2014036492/10.
(140041301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Lux 22 Starlight GBP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 179.499.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036494/10.
(140041750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Lux 30 Starlight EUR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 181.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036495/10.
(140041746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Luxempart Capital Partners, SICAR, S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 51.390.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036496/10.
(140041756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

MGE Vernon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 121.951.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 18 février 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1857 Luxem-

bourg, 5, rue du Kiem avec effet au 1 

er

 novembre 2013.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MGE Vernon S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014036559/14.
(140041906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

56307

L

U X E M B O U R G

MMD Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 112.326.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 mars 2014

<i>Neuvième résolution:

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 11A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Lu-

xembourg, au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MMD INVESTMENT S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014036565/14.
(140041772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Medest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 52.885.

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma démission de ma fonction d'administrateur

de votre société, MEDEST S.A.(RCS B52885), avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 mars 2014.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES &amp; PARTNERS S.A.

Référence de publication: 2014036544/11.
(140041584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Middagkrans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 184.778.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 24 février 2014 entre Exequtive Partners S.A., une société

anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce
et Société du Luxembourg sous numéro B 174367 et Saruni Invest B.V. une société constituée et existante sous les lois
des Pays-Bas, ayant son siège social au 55A, Amsterdamsestraatweg, 3744 MA Baarn, Pays-Bas et enregistrée auprès de
Dutch Kamer van Koophandel sous numéro 31040068, les 1,250,000 parts sociales de la Société sont désormais détenues
comme suit:

- Saruni Invest B.V. est l'associé unique de la Société à compter du 24 février 2014 et détient les 1,250,000 parts sociales

de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Middagkrans S.à r.l.
Joost Anton Mees

Référence de publication: 2014036530/19.
(140041313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Mikek S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 44, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.676.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014036562/10.
(140041843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

56308

L

U X E M B O U R G

Medest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 52.885.

Nous  CH  INTERNATIONAL  (Luxembourg)  SARL,  domiciliataire  de  la  société  MEDEST  S.A.  (RCS  Luxembourg

B52885) sise 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, dénonçons avec effet immédiat le siège social de la société
MEDEST S.A. (RCS Luxembourg B52885) sise 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/03/2014.

Référence de publication: 2014036547/11.
(140041925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Marcol Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.592.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

<i>Pour: MARCOL EUROPE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Christine Racot

Référence de publication: 2014036540/15.
(140041445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Marcol Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.592.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

<i>Pour: MARCOL EUROPE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Christine Racot

Référence de publication: 2014036541/15.
(140041446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

MSI Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 125.174.

Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2014.

<i>Pour MSI Alpha S.à r.l.
Représentée par M. Julien François
<i>Gérant de classe B

Référence de publication: 2014036574/13.
(140041688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

56309

L

U X E M B O U R G

Lagunare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 157.149.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036502/10.
(140041717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

LIB Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 51.507.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036507/10.
(140041815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

LINSTER-bureautique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 20, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 6.631.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036510/9.
(140041764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

LINSTER-bureautique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 20, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 6.631.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036511/9.
(140041765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Aismare Lux Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.494,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 176.544.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 1 

er

 mars 2014 que:

- Monsieur John Simmonds a démissionné de sa fonction de Gérant de classe A de la société avec effet au 1 

er

 mars

2014.

- Madame Jennifer Bingham, née le 25 août 1952 à Calcutta, Inde et résident professionnellement au 34A Station Road,

Cuffley, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 4HE, Royaume-Uni, est nommée Gérant de classe A de la société avec effet au

er

 mars 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 12 mars 2014.

Référence de publication: 2014036830/16.
(140042343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

56310

L

U X E M B O U R G

Hartung Internationale Transporte G.M.B.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 159.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014036433/10.
(140041718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 415.386.399,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 149.974.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Référence de publication: 2014036434/10.
(140041389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Logicor Holdco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.920.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire de la Société le 13 février 2014

En date du 13 février 2014, l'actionnaire de la Société a pris la résolution suivante:
- de changer de nom de Lima Logistics Pledgeco S.à r.l. à Logicor Pledgeco II S.à r.l.
L'actionnaire de la Société est désormais:
(1) Logicor Pledgeco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant

son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.919;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014036488/19.
(140041430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Lyotre Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 152.112.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 février 2014

A démissionné de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat:
- Monsieur Benoît de FROIDMONT, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxem-

bourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2017:

- Audit Lux S.à r.l., 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036519/15.
(140041715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

56311

L

U X E M B O U R G

Logicor Pledgeco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.919.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire de la Société le 13 février 2014

En date du 13 février 2014, l'actionnaire de la Société a pris la résolution suivante:
- de changer de nom de Lima Logistics Topco S.à r.l. à Logicor Topco II S.à r.l.
L'actionnaire de la Société est désormais:
(1) Logicor Topco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant

son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.917;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014036489/19.
(140041451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Luxvalor Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 142.369.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014036518/10.
(140041481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

MStar Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 168.785.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036573/10.
(140041754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Biostime Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.057.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, the twentieth of March,
Before, Maître Karine REUTER, civil law notary, residing in Petange (Luxemburg)

THERE APPEARED:

Biostime Europe Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15 rue Edward Steichen, Fourth Floor,
L-2540, Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies;

here represented by Mrs An-An SCHONG
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg.

56312

L

U X E M B O U R G

Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the

undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed,  and  be  submitted  with  this  deed  to  the  registration
authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Biostime

Luxembourg S.à r.l." (the Company). The Company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Corporate object. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in
particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other partici-
pation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities
and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may buy, sell, exchange, lease, hire, rent and manage any patents, trademarks or other intellectual

property rights of any nature or origin whatsoever which it holds from time to time.

The Company may license the use and/or the right to exploit any patents, trademarks or other intellectual property

rights of any nature or origin whatsoever which it holds from time to time.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its corporate object.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholder

(s) acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. It may be transferred within
the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad by a resolution of the manager or the

board of managers. If the manager or the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with paragraph 2 of article 15 of these Articles.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles the owner to a fraction of the corporate assets and profits of the Company

in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

56313

L

U X E M B O U R G

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Law will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect and such redemption results from a reduction of
the share capital of the Company.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply in ac-
cordance with article 15 of these Articles.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end

Art. 12. Management.  The  Company  shall  be  managed  by  a  board  of  managers  composed  of  three  (3)  managers

comprising: two (2) class A managers and one (1) class B manager. The managers need not to be shareholders. The
managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by
shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents with the consent of the class A manager. The manager, or in case of plurality of managers, the
delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of
representation and any other relevant conditions of his agency, with the consent of the class A manager.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers. All meetings of the board of managers shall
be held in Luxembourg and, except as expressly stated below, all managers shall be physically present at such meetings.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. In urgent circumstances, a manager may also participate in a meeting of the board of
managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers
taking part in the meeting to be identified and to deliberate, with such meeting being initiated and chaired in Luxembourg.
In such case, the participation by a manager in a meeting by such means of communication shall be deemed to be a
participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company
in Luxembourg. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office
of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has
been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

In urgent circumstances, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

56314

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. General meetings of the shareholder(s) may be held at such place in

Luxembourg and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by a majority in number of the

shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only
be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Law.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts shall be established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities with an annex summarising the Company’s commitments
and the debts owed by its manager[s] and shareholders to the Company.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends under the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board..

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs to be

audited  by  a  statutory  auditor  (commissaire)  if  it  has  more  than  25  (twenty-five)  shareholders.  An  external  auditor
(réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxem-
bourg law dated 19 December 2002 on the Luxembourg Register of Commerce and Companies and on the accounting
and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in these Articles.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed by Biostime Europe Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15
rue Edward Steichen, Fourth Floor, L-2540 Luxembourg.

56315

L

U X E M B O U R G

All shares have been fully paid-up by a contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five

hundred euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin on the date hereof and it shall end on 31 

st

 December 2014.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND FIFTY EUROS.

<i>Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at three (3). The following persons are appointed as managers of the Company for

an unlimited period of time:

Freddy De Petter, born on 29 August 1958 in Berchem, Belgium, whose professional address is at 15, Rue Edward

Steichen, 4 

th

 Floor, L-2540 Luxembourg, appointed as class A manager;

An-An Shong, born on 25 September 1984 in Taipei, Taiwan, whose professional address is at 15, rue Edward Steichen,

th

 Floor, L-2540, Luxembourg, appointed as class A manager; and

Patrice Gerard Marcel Malard, born on 21 January 1954 in Vincennes, France, whose residential address is at 2 Impasse

des Violettes, 31270 Cugnaux, France, appointed as class B manager.

2. The registered office is established at 15, Rue Edward Steichen, 4 

th

 Floor, L-2540 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing party, the proxyholder(s) of the appearing

party signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, en date du vingt mars,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

A COMPARU:

Biostime Europe Holdings S.à r.l., une société de droit Luxembourg, avec siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, en voie de formalisation, ici représentée par Madame An-An-SCHONG

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Biostime Luxembourg S.à

r.l." (ci-après, la Société). La société est régie par les dispositions légales luxembourgeoises, et notamment les dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, de même que par les présents
statuts.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment
acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement,
à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

56316

L

U X E M B O U R G

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements

et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.

La Société peut acquérir, vendre, échanger, louer et gérer toute sorte de brevets, licences, marques ou toute autre

sorte de droits de propriété intellectuelle de toute sorte ou origine.

Elle peut donner en licences le droit d’utiliser et/ou exploiter toute sorte de brevets, licences, marques ou toute autre

sorte de droits de propriété intellectuelle de toute sorte ou origine.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale

extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l’intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l’étranger. Cette décision

doit toutefois être prise par le gérant unique sinon par le Conseil de gérance.

Si le gérant unique ou le conseil de gérance estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, ou éco-

nomique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cent euro)

représenté par 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de

l’associé unique sinon de l’assemblée des associés, conformément au 2e paragraphe de l’article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction, proportionnelle

au nombre des parts existantes, de l’actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par

l’assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la

Loi de 1915) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose

à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants, cette détention devant résulter d’une réduction du capital
social de la société.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l’associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l’article 15 des statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de

l’associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois gérants dont deux seront désignés

en tant que gérants de classe A et un sera désigné gérant de classe B.

Les gérants n'ont pas besoin d'être associés.
Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l’assemblée générale des associés, par une résolution

adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer

le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

56317

L

U X E M B O U R G

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en

toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve
du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Tout gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc,

avec l’accord du gérant de classe A. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le gérant qui délègue déterminera
la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation
et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat, avec l’accord préalable du gérant de classe A.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance. Toutes les réunions du conseil de
gérance se tiendront à Luxembourg et, sauf dans le cas expressément prévu ci-dessous, tous les gérants devront être
physiquement présents à ces réunions.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de
l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant

comme son mandataire.

En cas de circonstances exceptionnelles, tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence

téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants
qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer, une telle réunion devant être initiée et présidée à Lu-
xembourg.  Dans  ce  cas,  la  participation  d'un  gérant  à  une  réunion  du  conseil  de  gérance  par  de  tels  moyens  de
communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social à Luxembourg. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui
sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du
conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générale des associés. Des assemblées générales de l’associé unique ou des associés peuvent être

tenues aux lieux et places, à Luxembourg, indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l’associé unique ou des associés pourront,

au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée

des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l’accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

56318

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le

conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,

déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. L'assemblée générale décide de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi de 1915, la Société

doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l’exemption prévue à l’article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en

réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par Biostime Europe Holdings S.à r.l., une société de droit Luxem-

bourg, avec siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500 EUR (douze

mille cinq cent euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.

<i>Dispositions Transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement MILLE SIX CENT CINQUANTE
EUROS (1.650,-).

<i>Assemblée Générale Constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique représentant la totalité du capital souscrit a pris

les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3). Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Freddy De Petter, né le 29 août 1958 à Berchem (Belgique), demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg,

15, Rue Edward Steichen, gérant de classe A;

An-An Shong, née le 25 septembre 1984 à Taipei (Taiwan), demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 15,

Rue Edward Steichen, gérant de classe A et

Patrice Gerard Marcel Malard, né le 21 janvier 1954 à Vincennes (France) demeurant à 2 Impasse des Violettes, 31270

Cugnaux, France, gérant de classe B.

2. Le siège social de la société est établi à 15, Rue Edward Steichen, 4 

th

 Floor, L-2540 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l’a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signés: A-A. SCHONG, K. REUTER
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 avril 2014. Relation: EAC/2014/4702. Reçu soixante-quinze euros 75,-

<i>Le Receveur (signé): M.HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME

56319

L

U X E M B O U R G

PETANGE, le 10 avril 2014.

Référence de publication: 2014052283/401.
(140059956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2014.

Gubernantia S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. B.A. Domicili S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 113.135.

L'an deux mil quatorze, le vingt-sept février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) ALTER DIRECTOR S.A., ayant son siège social au 50, Aquilino de la Guardia Streets, Plaza Banco General, Panama,

République du Panama, immatriculée au registre des sociétés de Panama sous le numéro 671433,

ici représenté par Monsieur Bruno ABBATE, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen,

en vertu d’une procuration générale délivrée pardevant notaire à Panama le 7 août 2009; et

2) Monsieur Bruno ABBATE, réviseur d’entreprises et gérant de sociétés, né le 2 septembre 1965 à Santa Maria di

Capua (I), demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-

sentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «B.A. Domicili S.àr.l.»

avec siège social au 2, Place de Strasbourg, L-2560 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.135.

- La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 644 du 29 mars 2006 dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 septembre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2066 du 21 octobre 2009.

- Le capital social de cette société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125)

parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Les Associés déclarent que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale en «GUBERNANTIA S.àr.l.»; modification correspondante de l’article 2

des statuts sociaux;

2) Modification de l’objet social et modifications correspondantes de l’article 3 des statuts sociaux afin de lui donner

désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet le conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services et

d’intermédiation en matière micro et macro-économique ainsi qu’en gestion d’entreprises et toutes prestations de ser-
vices annexes ou complémentaires à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

La Société pourra également effectuer toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente, l’échange, la location, la transformation, l’amé-

nagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non
bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays.

La Société pourra aussi exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de ses objets.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations, sans toutefois faire appel public

à l’épargne.»;

3) Modification de l’adresse du siège social afin qu’il soit désormais fixé au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen; modi-

fication correspondante de l’article 5 des statuts sociaux;

4) Autorisation de deux cessions de parts sociales;

56320

L

U X E M B O U R G

5) Divers.
Ceci ayant été déclaré, les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale à partir de ce jour, pour adopter celle de «GUBERNANTIA

S.àr.l.».

L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

« Art. 2. La Société prend la dénomination de GUBERNANTIA S.àr.l.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social, pour adopter dorénavant l’objet social suivant de sorte que

l’article 3 des statuts se lira désormais comme suit:

« Art. 3. La Société a pour objet le conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services

et d’intermédiation en matière micro et macro-économique ainsi qu’en gestion d’entreprises et toutes prestations de
services annexes ou complémentaires à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

La Société pourra également effectuer toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente, l’échange, la location, la transformation, l’amé-

nagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non
bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays.

La Société pourra aussi exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l’accomplissement de ses objets.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations, sans toutefois faire appel public

à l’épargne.».

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier à partir d’aujourd’hui l’adresse du siège social pour fixer cette dernière à

L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Strassen par simple décision du gérant.».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’autoriser une cession de parts sociales signée sous seing privé en date du 24 février

2014, par laquelle Monsieur Bruno ABBATE, préqualifié, a cédé les soixante-quatre (64) parts sociales de catégorie B qu’il
détenait dans le capital social de la Société, à la société anonyme ZUTTINI PARTECIPAZIONE S.A., avec siège social à
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 124.792.

L’assemblée générale décide d’autoriser également une cession de parts sociales signée sous seing privé en date du 24

février 2014, par laquelle la société de droit panaméen ALTER DIRECTOR S.A., préqualifiée, a cédé les soixante et une
(61) parts sociales de catégorie A qu’elle détenait dans le capital social, à la société anonyme ZUTTINI PARTECIPAZIONE
S.A., préqualifiée.

Ces cessions de parts sociales ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin,

acceptées pour la Société par son gérant Monsieur Bruno ABATTE, préqualifié.

Suite aux cessions qui précèdent, la société anonyme ZUTTINI PARTECIPAZIONE S.A., préqualifiée, devient Associé

Unique et détient toute les cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune,
de la Société.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombe à la Société ou qui est mis à sa charge à raison de ces résolutions, à environ mille six cents euros (1.600.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. Abbate et M. Schaeffer.

56321

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 mars 2014. Relation: LAC/2014/9663. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 6 mars 2014.

Référence de publication: 2014035761/113.
(140040673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

ColKart Investment II SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 185.073.

EXTRACT

Pursuant to a partnership agreement dated 25 February 2014 (i) Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg and a share capital of EUR 12,600, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 88. 540 (“Colony Luxembourg”) and (ii) Colony Retail Europe III S.à r.l. (previously ColKart Genpar S.à r.l.),
a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4 avenue
Marie-Thérèse,  L-2132  Luxembourg  and  a  share  capital  of  EUR  12,600,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies Register under number B 182.004 (“Colony Retail Europe III”) have incorporated a Luxembourg common
limited  partnership  (société  en  commandite  simple)  under  the  corporate  name  of  ColKart  Investment  II  S.C.S.  (the
“Partnership”).

- Colony Retail Europe III is the unlimited partner, jointly and severally liability for all the obligations of the Partnership.
- The corporate object of the Partnership is the following:
The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg

and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The
Partnership may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned
instruments and the financing thereof.

The Partnership may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instru-

ments convertible or not.

The Partnership may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company

as well as to other entities or persons provided that the Partnership will not enter into any transaction which would be
considered as a regulated activity without obtaining the required license. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Partnership will not enter into any transaction
which would be considered as a regulated activity without obtaining the required license. The Partnership may further
mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Partnership may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and ins-
truments designed to protect the Partnership against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other
risks.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Partnership may also invest in real estate and / or all types of real estate rights, and directly or indirectly operate

and develop them. The Partnership may sell, assign or otherwise dispose of part or all of its real estate assets or rights.

The Partnership may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable

or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

- The registered office of the Partnership is set at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- Colony Retail Europe III is the manager of the Partnership (the “Manager”).
The Manager will have the broadest powers to administer and manage the Partnership, to act in the name of the

Partnership in all circumstances, and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Partnership’s
corporate object

The Partnership shall be bound by the sole signature of the Manager.
- The Partnership was established on 25 February 2014 for an unlimited period of time.

56322

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

Par contrat social du 25 février 2014 (i) Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et un capital social de EUR
12.600, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 88.540 («Colony
Luxembourg») et (ii) Colony Retail Europe III S.à r.l. (précédemment ColKart Genpar S.à r.l.), une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et un capital
social de EUR 12.600, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B
182.004 («Colony Retail Europe III») ont constitué une société en commandite simple de droit luxembourgeois ayant
pour dénomination ColKart Investment II S.C.S. (la «Société»).

- Colony Retail Europe III est l’associé commandité de la Société, responsable indéfiniment et solidairement des en-

gagements sociaux.

- L’objet de la Société est le suivant:
L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d’autres entités, (ii) l’acquisition par
l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations,
de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l’acquisition, la propriété,
l’administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat
relatif à l’acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de dettes, de

notes et d’autres instruments convertibles ou non.

La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du

groupe ainsi qu’à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui
serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l’autorisation requise. Elle pourra également fournir des
garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu’à toute autre entité ou personne pourvu que
la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l’autorisation
requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie
de ses avoirs.

La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue

de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
tout autre risque.

De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et

de supervision et mener toute opération qu’elle jugerait utile à l’accomplissement et au développement de son objet
social.

La Société pourra aussi investir dans l’immobilier et/ou tous types de droits immobiliers, et directement ou indirec-

tement les exploiter et les développer. La Société pourra vendre, céder ou autrement disposer d'une partie ou de tous
ses avoirs ou droits immobiliers.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant

des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.

- Le siège social de la Société a été fixé au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- Colony Retail Europe III est le gérant de la Société (le «Gérant»).
Le Gérant a les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la Société, pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations en conformité avec l’objet social de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Gérant.
- La Société a été constituée le 25 février 2014 pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2014.

Colony Retail Europe III S.à r.l.
Représenté par Colony Luxembourg S.à r.l.
<i>Son gérant unique
Représentée par Pascal Leclerc / Jean-Romain Lhomme
<i>Gérant B / Gérant A

Référence de publication: 2014035792/104.
(140040862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2014.

56323

L

U X E M B O U R G

Commercial Real Estate Loans SCA, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.337.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of February.
Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms. Christel DI MARCO, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxyholder of Commercial Real Estate Loans S.C.A., a Luxembourg société en

commandite par actions, having its registered office at 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
incorporated on 30 November 2010 pursuant to a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 44 dated 10 January
2011 registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.337, whose articles
of association have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary on 13 February 2014, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"),

by virtue of the authority conferred on her by written resolutions adopted by the board of directors (the “Board”) of

Commercial  Real  Estate  Loans  General  Partner  S.A.,  a  Luxembourg  public  limited  company  (société  anonyme)  with
registered office at 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, re-
gistered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.317, acting as general partner
of the Company (the “General Partner”) on 7 January 2014, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the
appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at one hundred eighty-six million seven hundred eighty-

five thousand four hundred twenty-three Euros (EUR 186,785,423.-) divided into (i) four (4) management shares with a
value of one thousand Euros (1,000 EUR) each (the "Management Shares"), held by the General Partner, into (ii) one
hundred seventy-three million four hundred twenty-six thousand eight hundred thirty-one (173,426,831) class A ordinary
shares (the “Class A Ordinary Shares”), held by the class A limited shareholders (the “Class A Limited Shareholders”)
with  a  value  of  one  Euro  (1  EUR)  each,  (iii)  thirteen  million  three  hundred  fifty  thousand  five  hundred  ninety-two
(13,350,592) class A2 ordinary shares (the “Class A2 Ordinary Shares”), held by the Class A Limited Shareholders with
a value of one Euro (1 EUR) each and (iv) four thousand (4,000) class B ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”),
held by the General Partner, with a value of one Euro (1 EUR) each divided as follows:

Commercial Real Estate Loans SCA -CRE senior 1
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 28,271,327 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the General Partner in the respective

compartment;

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE senior 1
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 59,679,227 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the General Partner in the respective

compartment;

Commercial Real Estate Loans SCA - CRE senior 2
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 18,482,226 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 13,350,592 Class A2 Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the Genera Partner in the respective

compartment;

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE senior 2
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 66,994,051 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

56324

L

U X E M B O U R G

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the General Partner in the respective

compartment.

II. That pursuant to article 5.4 of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has

been fixed at seven hundred million Euros (EUR 700,000,000.-) divided into six hundred ninety nine million nine hundred
ninety thousand (699,990,000) redeemable Ordinary Shares of the relevant class and compartment with a nominal value
of one Euro (EUR 1.-) each and ten (10) management shares of the relevant compartment with a nominal value of one
thousand Euros (EUR 1,000) per management share and that pursuant to the same article 5.4, the General Partner of the
Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company by the creation of new redeemable
Ordinary Shares of the relevant Class and Compartment with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) per Ordinary Share.

III. That the Board of the General Partner of the Company, in the resolutions adopted on 7 January 2014, and in

accordance with the authority conferred to it pursuant to article 5 of the Company's articles of association, has decided,
subject to the confirmation by any one director of the General Partner of the receipt of the subscription monies, which
confirmation was given on 12 February 2014, as follows:

- an increase of the issued share capital of the Company by an amount of one million Euros (EUR 1,000,000.-) by the

creation and issuance of (i) five hundred eighty thousand six hundred three (580,603) new Class A Ordinary Shares, each
share having a par value of one Euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A
Ordinary Shares, and (ii) four hundred nineteen thousand three hundred ninety-seven (419,397) new Class A2 Ordinary
Shares, each share having a par value of one Euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the already existing
Class A2 Ordinary Shares.

IV. That the Board of the General Partner of the Company, in the resolutions adopted on 7 January 2014, has accepted

upon satisfactory evidence of the receipt by the Company of the relevant subscription monies, which evidence was
obtained on 12 February 2014, the subscription of:

(i) five hundred eighty thousand six hundred three (580,603) new Class A Ordinary Shares, together with a total share

premium of five million two hundred twenty-five thousand four hundred twenty-seven Euros (EUR 5,225,427.-) in respect
to the compartment Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2; and

(ii) four hundred nineteen thousand three hundred ninety-seven (419,397) new Class A2 Ordinary Shares, together

with a total share premium of three million seven hundred seventy-four thousand five hundred seventy-three Euros (EUR
3,774,573.-) in respect to the compartment Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2.

In respect to the compartment Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2 the issuance of Class A Ordinary

Shares and of Class A2 Ordinary Shares as follows:

GastroSocial Pensionskasse, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Bahnhofstrasse

86, CH-5001 Aarau, Switzerland (“GastroSocial”): the issuance of 45,872 Class A Ordinary Shares in the respective
compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 412,848.-;

Cardif Assurance Vie SA., a société anonyme governed by the laws of France, with registered office at 1 Boulevard

Haussmann F-75009 Paris, France (“Cardif”): the issuance of 131,062 Class A Ordinary Shares in the respective com-
partment with the payment of share premium for an amount of EUR 1,179,558.-;

Vivium SA., a société anonyme existing under the laws of Belgium, with registered office at Rue Royale 153, B-1210

Bruxelles, Belgium (“Vivium”): the issuance of 65,531 Class A Ordinary Shares in the respective compartment with the
payment of share premium for an amount of EUR 589,779.-;

Mutex, a company existing under the laws of France with registered office at 125 avenue de Paris F-92327 Châtillon

Cédex (“Mutex”): the issuance of 13,106 Class A2 Ordinary Shares in the respective compartment with the payment of
share premium for an amount of EUR 117,954.-;

La Mondiale, a company existing under the laws of France with registered office at 32 avenue Emile Zola, Mons en

Baroeul, F-59896 Lille, Cédex 9, France (“La Mondiale”): the issuance of 39,318 Class A2 Ordinary Shares in the respective
compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 353,862.-;

Codan Forsikring A/S, a company existing under the laws of Denmark with registered office at Gammel Kongevej 60,

DK-1790 Copenhagen, Denmark (“Codan”): the issuance of 19,659 Class A Ordinary Shares in the respective compart-
ment with the payment of share premium for an amount of EUR 176,931.-;

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, a company existing under the laws of Denmark with registered office at Gammel

Kongevej 60, DK-1790 Copenhagen, Denmark (“Forsokringsselskabet”): the issuance of 3,932 Class A Ordinary Shares
in the respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 35,388.-;

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag AB, a company existing under the laws of Sweden with registered office at Flem-

minggatan 18, SE-106 26 Stockholm, Sweden c/o Codan Forsikring A/S at Gammel Kongevej 60, DK-1790 Copenhagen,
Denmark (“Trygg-Hansa”): the issuance of 19,659 Class A Ordinary Shares in the respective compartment with the
payment of share premium for an amount of EUR 176,931.-;

RSA Insurance Ireland Limited, a company existing under the laws of Ireland with registered office at RSA House,

Dundrum Town Center, Sandyford Road, Dundrum, Dublin 5, Ireland (“RSA Ireland”): the issuance of 13,106 Class A
Ordinary Shares in the respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 117,954.-;

56325

L

U X E M B O U R G

Royal &amp; Sun Alliance Insurance PLC, a company existing under the laws of England with registered office at St Marks

Court, Chart Way, Horsham, West Sussex, RH12 1XL (“Royal &amp; Sun”): the issuance of 52,425 Class A Ordinary Shares
in the respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 471,825.-;

Caisse Centrale de Réassurance, a company existing under the laws of France with registered office at 31 rue de

Courcelles, F-75008 Paris, France (“CCR”): the issuance of 39,318 Class A2 Ordinary Shares in the respective compart-
ment with the payment of share premium for an amount of EUR 353,862.-;

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A., a company governed by the laws of France, having its registered office at 34,

rue du Wacken, F-67000 Strasbourg, France (“ACM”): the issuance of 74,705 Class A2 Ordinary Shares in the respective
compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 672,345.-;

SERENIS VIE S.A., a company governed by the laws of France, having its registered office at 34, rue du Wacken, F-67000

Strasbourg, France (“Serenis”): the issuance of 3,932 Class A2 Ordinary Shares in the respective compartment with the
payment of share premium for an amount of EUR 35,388.-;

Ageas France S.A., a company governed by the laws of France, having its registered office at 1, rue Blanche, F-75009

Paris, France (“Ageas”): the issuance of 26,212 Class A2 Ordinary Shares in the respective compartment with the payment
of share premium for an amount of EUR 235,908.-;

Aviva Vie S.A. d'Assurances Vie et de Capitalisation, a company governed by the laws of France, with registered office

at 70, avenue de l'Europe, F-92270 Bois Colombes (“Aviva”): the issuance of 131,062 Class A2 Ordinary Shares in the
respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 1,179,558.-;

Caisse de Vieillesse des Pharmaciens, a company governed by the laws of France, with registered office at 45, rue de

Caumartin, F-75441 Paris Cédex 09 (“CAVP”): the issuance of 39,318 Class A Ordinary Shares in the respective com-
partment with the payment of share premium for an amount of EUR 353,862.-.

Sogecap SA., a société anonyme governed by the laws of France, with registered office at 50 Avenue du Général de

Gaulle, F-92093 Paris La Défense Cédex, France (“Sogecap”): the issuance of 91,744 Class A2 Ordinary Shares in the
respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 825,696.-;

Caisse des Dépôts et Consignations - DFINF2, a company governed by the laws of France, with registered office at

DFINF2 (gestion taux), 56, rue de Lille, F-75006 Paris (“CDC-DFINF2”): the issuance of 58,978 Class A Ordinary Shares
in the respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 530,802.-;

Caisse des Dépôts et Consignations - Direction des Fonds d'Epargne, a company governed by the laws of France, with

registered office at 56, rue de Lille, F-75006 Paris (“CDC-DFE”): the issuance of 52,425 Class A Ordinary Shares in the
respective compartment with the payment of share premium for an amount of EUR 471,825.-;

Suravenir SA, a company governed by the laws of France, with registered office at 232 rue du Général Paulet, F-29802

Brest (“Suravenir”): the issuance of 39,318 Class A Ordinary Shares in the respective compartment with the payment of
share premium for an amount of EUR 353,862.-;

Groupama Gan Vie SA, a company governed by the laws of France, with registered office at 8/10 rue d'Astorg, F-75008

Paris (“Groupama”): the issuance of 39,318 Class A Ordinary Shares in the respective compartment with the payment
of share premium for an amount of EUR 353,862.-

That all these new Class A Ordinary Shares and Class A2 Ordinary Shares have been entirely subscribed by the

aforesaid subscribers and fully paid up, together with the share premium and actualisation interest, if any, by contributions
in cash to the Company as confirmed on 12 February 2014 in respect to the Fund's compartment CRE Senior 2, so that
the total ten million Euros (EUR 10,000,000.-) representing the amount of the above mentioned capital increase in respect
to the respective compartment for an amount of one million Euros (EUR 1,000,000.-) and comprising the payment of a
share premium in an aggregate amount of nine million Euros (EUR 9,000,000.-) has been at the free disposal of the
Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant
payments.

V. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, the first paragraph of article 5

of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

Art. 5. Share capital. The subscribed capital of the Company is fixed at one hundred eighty-seven million seven

hundred eighty-five thousand four hundred twenty-three Euros (EUR 187,785,423.-) divided into (i) four (4) Management
Shares with a value of one thousand Euros (1,000 EUR) each, into (ii) one hundred seventy-four million seven thousand
four hundred thirty-four (174,007,434) Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, into (iii) thirteen
million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred eighty-nine (13,769,989) Class A2 Ordinary Shares with a value
of one Euro (1 EUR) each and into (iii) four thousand (4,000) Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR)
each divided as follows:

Commercial Real Estate Loans SCA -CRE senior 1
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 28,271,327 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

56326

L

U X E M B O U R G

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the General Partner vin the respective

compartment;

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE senior 1
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 59,679,227 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the General Partner in the respective

compartment;

Commercial Real Estate Loans SCA - CRE senior 2
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 19,062,829 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 13,769,989 Class A2 Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the Genera Partner in the respective

compartment;

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE senior 2
- 1 Management Share at one thousand Euros (1,000 EUR) held by the General Partner in the respective compartment;
- 66,994,051 Class A Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by Class A Limited Shareholders

in the respective compartment;

- 1,000 Class B Ordinary Shares with a value of one Euro (1 EUR) each, held by the General Partner in the respective

compartment;

all Shares being fully paid up. These Ordinary Shares are redeemable in accordance with the provisions of article 49-8

of the 1915 Law and these Articles of Incorporation."

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-

mately four thousand six hundred euros (4,600.-EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze le treizième jour de février.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire, de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Madame Christel DI MARCO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Commercial Real Estate Loans S.C.A., une société en commandite par

actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, constituée le 30 novembre 2010 suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-
Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 44 en date du 10 janvier
2011, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.337, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant en date du 13 février 2014, pas encore
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»),

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par résolutions écrites adoptées par le conseil d'administration (le «Conseil»)

de Commercial Real Estate Loans General Partner S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.317, agissant en qualité d'associé commandité de la Société (l'«Associé
Commandité»), en date du 7 janvier 2014, une copie desdites résolutions, après avoir été signées "ne varietur" par le
comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier aux
formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et

constatations suivantes:

56327

L

U X E M B O U R G

I. Que le capital social émis de la Société s'élève actuellement à cent quatre-vingt-six millions sept cent quatre-vingt-

cinq mille quatre cent vingt-trois Euros (EUR 186.785.423,-), représenté par (i) quatre (4) actions de commandité (les
«Actions de Commandité») détenues par l'Associé Commandité, ayant une valeur nominale de mille Euro (EUR 1.000,-)
chacune, (ii) cent soixante-treize millions quatre cent vingt-six mille huit cent trente-et-une (173,426,831) actions ordi-
naires de classe A (les «Actions Ordinaires de Classe A») détenues par les actionnaires commanditaires de classe A (les
«Actionnaires Commanditaires de Classe A»), ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, (iii) treize millions
trois cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt-douze (13,350,592) actions ordinaires de classe A2 (les «Actions Ordi-
naires de Classe A2») détenues par les Actionnaires Commanditaires de Classe A, ayant une valeur nominale de un Euro
(EUR 1,-) chacune et (iv) quatre mille (4.000) actions ordinaires de classe B (les «Actions Ordinaires de Classe B»)
détenues par l'Associé Commandité, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, réparties comme suit:

Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 1
- 1 Action de Commandité d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), détenue par l'Associé Commandité,

relative au compartiment susmentionné;

- 28.271.327 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1,000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité, relatives au compartiment susmentionné,

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE Senior 1
- 1 Action de Commandité d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), détenue par l'Associé Commandité,

relative au compartiment susmentionné;

- 59.679.227 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité, relatives au compartiment susmentionné,

Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2
- 1 Action de Commandité d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) détenue par l'Associé Commandité,

relative au compartiment susmentionné;

- 18.482.226 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 13.350.592 Actions Ordinaires de Classe A2 d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité, relatives au compartiment susmentionné,

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE Senior 2
- 1 Action de Commandité d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), détenue par l'Associé Commandité,

relative au compartiment susmentionné;

- 66.994.051 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité, relatives au compartiment susmentionné.

II. Qu'en vertu de l'article 5.4 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à sept cent millions

d'Euros  (EUR  700.000.000,-),  divisé  en  six  cent  quatre-vingt-dix-neuf  millions  neuf  cent  quatre-vingt-dix  mille
(699.990.000) Actions Ordinaires rachetables de la classe et du compartiment concerné d'une valeur nominale de un
Euro (EUR 1,-) chacune et de dix (10) actions de commandité du compartiment concerné d'une valeur nominale de mille
Euros (EUR 1.000) par action commandité et qu'en vertu de ce même article 5.4, l'Associé Commandité de la Société
est autorisé à augmenter le capital social de la Société par la création de nouvelles Actions Ordinaires rachetables de la
classe et du compartiment concerné d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) par Action Ordinaire.

III. Que le Conseil de l'Associé Commandité de la Société, dans les résolutions adoptées le 7 janvier 2014 et en

conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 5 des statuts de la Société, a décidé, sous réserve
de la confirmation par l'un des administrateurs de l'Associé Commandité de la réception des fonds de souscription, laquelle
confirmation est intervenue le 12 février 2014:

- une augmentation du capital social émis de la Société à concurrence de un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) par la

création et l'émission de (i) cinq cent quatre-vingt mille six cent trois (580.603) nouvelles Actions Ordinaires de Classe
A, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les Actions Ordinaires
de Classe A existantes et (ii) quatre cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (419.397) nouvelles Actions
Ordinaires de Classe A2, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les Actions Ordinaires de Classe A2 existantes.

56328

L

U X E M B O U R G

IV. Que le Conseil de l'Associé Commandité de la Société, dans les résolutions adoptées le 7 janvier 2014 a accepté,

sur preuve de la réception par la Société des fonds de souscription, laquelle preuve a été donnée le 12 février 2014, la
souscription de

(i) cinq cent quatre-vingt mille six cent trois (580.603) nouvelles Actions Ordinaires de Class A, ainsi que le paiement

d'une prime d'émission totale de cinq millions deux cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-sept Euros (EUR 5.225.427,-)
concernant le compartiment Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2; et

(ii) quatre cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (419.397) nouvelles Actions Ordinaires de Classe A2,

ainsi que le paiement d'une prime d'émission totale de trois millions sept cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante
treize Euros (EUR 3.774.573,-) concernant le compartiment Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2.

Concernant le compartiment Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2, l'émission d'Actions Ordinaires de

Classe A et d'Actions Ordinaires de Classe A2 comme suit:

GastroSocial Pensionskasse, une société soumise aux lois Suisses, ayant son siège social au Bahnhofstrasse 86, CH-5001

Aarau, Switzerland (“GastroSocial”): l'émission de 45.872 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compartiment
susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 412.848,-;

Cardif Assurance Vie SA., une société anonyme soumise aux lois françaises, ayant son siège social au 1, Boulevard

Haussmann F-75009 Paris, France (“Cardif”): l'émission de 131.062 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compar-
timent susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 1.179.558,-;

Vivium SA., a une société anonyme soumise aux lois Belges, ayant son siège social au Rue Royale 153, B-1210 Bruxelles,

Belgique (“Vivium”): l'émission de 65.531 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compartiment susmentionné avec
le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 589.779,-;

Mutex, une société anonyme soumise aux lois françaises, ayant son siège social au 125 avenue de Paris F-92327 Châtillon

Cédex (“Mutex”): l'émission de 13.106 Actions Ordinaires de Classe A2 relatives au compartiment susmentionné avec
le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 117.954,-;

La Mondiale, une société soumise aux lois françaises, ayant son siège social au 32 avenue Emile Zola, Mons en Baroeul,

F-59896 Lille, Cédex 9, France (“La Mondiale”): l'émission de 39.318 Actions Ordinaires de Classe A2 relatives au com-
partiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 353.862,-;

Codan Forsikring A/S, une société soumise aux lois du Danemark, ayant son siège social au Gammel Kongevej 60,

DK-1790 Copenhagen, Denmark (“Codan”): l'émission de 19.659 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compar-
timent susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 176.931,-;

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, une société soumise aux lois du Danemark, ayant son siège social au Gammel

Kongevej 60, DK-1790 Copenhagen, Denmark (“Forsokringsselskabet”): l'émission de 3.932 Actions Ordinaires de Classe
A relatives au compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 35.388;

Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag AB, une société soumise aux lois Suèdoises, ayant son siège social au Flemminggatan

18, SE-106 26 Stockholm, Sweden c/o Codan Forsikring A/S au Gammel Kongevej 60, DK-1790 Copenhagen, Denmark
(“Trygg-Hansa”): l'émission de 19.659 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compartiment susmentionné avec le
paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 176.931,-;

RSA Insurance Ireland Limited, une société soumise aux lois de l'Irlande, ayant son siège social au RSA House, Dundrum

Town Center, Sandyford Road, Dundrum, Dublin 5, Ireland (“RSA Ireland”): l'émission de 13.106 Actions Ordinaires de
Classe  A  relatives  au  compartiment  susmentionné  avec  le  paiement  d'une  prime  d'émission  d'un  montant  de  EUR
117.954,-;

Royal &amp; Sun Alliance Insurance PLC, une société soumise aux lois du Royaume Uni, ayant son siège social au St Marks

Court, Chart Way, Horsham, West Sussex, RH12 1XL (“Royal &amp; Sun”): l'émission de 52.425 Actions Ordinaires de Classe
A relatives au compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 471.825,-;

Caisse Centrale de Réassurance, une société soumise aux lois françaises, ayant son siège social au 31 rue de Courcelles,

F-75008 Paris, France (“CCR”): l'émission de 39.318 Actions Ordinaires de Classe A2 relatives au compartiment sus-
mentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 353.862,-;

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A., une société soumise aux lois de France, dont le siège social est situé au 34, rue

du Wacken, F-67000 Strasbourg, France (“ACM”): l'émission de 74.705 Actions Ordinaires de Classe A2 relatives au
compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 672.345,-;

SERENIS VIE S.A., une société soumise aux lois de France, dont le siège social est situé au 34, rue du Wacken, F-67000

Strasbourg, France (“Serenis”): l'émission de 3.932 Actions Ordinaires de Classe A2 relatives au compartiment susmen-
tionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 35.388,-;

Ageas France S.A., une société soumise aux lois de France, dont le siège social est situé au 1, rue Blanche, F-75009

Paris, France (“Ageas”): l'émission de 26.212 Actions Ordinaires de Classe A2 relatives au compartiment susmentionné
avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 235.908,-;

Aviva Vie S.A. d'Assurances Vie et de Capitalisation, une société soumises aux lois de France, ayant son siège social

au 70, avenue de l'Europe, F-92270 Bois Colombes (“Aviva”): l'émission de 131.062 Actions Ordinaires de Classe A2
relatives au compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 1.179.558,-;

56329

L

U X E M B O U R G

Caisse de Vieillesse des Pharmaciens, une société soumises aux lois de France, ayant son siège social au 45, rue de

Caumartin, F-75441 Paris Cédex 09 (“CAVP”): l'émission de 39.318 Actions Ordinaires de Classe A relatives au com-
partiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 353.862,-;

Sogecap SA., une société anonyme soumise aux lois françaises, ayant son siège social au 50 Avenue du Général de

Gaulle, F-92093 Paris La Défense Cédex, France (“Sogecap”): l'émission de 91.744 Actions Ordinaires de Classe A2
relatives au compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 825.696,-.

Caisse des Dépôts et Consignations - DFINF2, une société soumises aux lois de France, ayant son siège social à DFINF2

(gestion taux), 56, rue de Lille, F-75006 Paris (“CDC-DFINF2”): l'émission de 58.978 Actions Ordinaires de Classe A
relatives au compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 530.802,-;

Caisse des Dépôts et Consignations - Direction des Fonds d'Epargne, une société soumises aux lois de France, ayant

son siège social au, 56, rue de Lille, F-75006 Paris (“CDC-DFE”): l'émission de 52.425 Actions Ordinaires de Classe A
relatives au compartiment susmentionné avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 471.825,-.

Suravenir SA, une société soumises aux lois de France, ayant son siège social au 232 rue du Général Paulet, F-29802

Brest (“Suravenir”): l'émission de 39.318 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compartiment susmentionné avec
le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 353.862,-;

Groupama Gan Vie SA, une société soumises aux lois de France, ayant son siège social au 8/10 rue d'Astorg, F-75008

Paris (“Groupama”): l'émission de 39.318 Actions Ordinaires de Classe A relatives au compartiment susmentionné avec
le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 353.862,-.

Que toutes les nouvelles Actions Ordinaires de Classe A et Actions Ordinaires de Classe A2 ont été entièrement

souscrites par les souscripteurs susnommés et libérées intégralement, avec une prime d'émission et des intérêts d'ac-
tualisation, le cas échéant, par des versements en numéraire à la Société, lesquels ont été confirmés le 12 février 2014
concernant le compartiment CRE Senior 2 de sorte que la somme totale de dix millions d'Euros (EUR 10.000.000,-),
représentant le montant de la susdite augmentation du capital social du compartiment cité ci-dessus pour un montant de
un million d'Euros (EUR 1.000.000,-) et incluant le paiement d‘une prime d'émission pour un montant total de neuf millions
d'Euros (EUR 9.000.000,-) se trouvait à la libre disposition de la Société, tel que démontré au notaire instrumentant par
la présentation des pièces justificatives de libération.

V. Que suite à la réalisation de l'augmentation du capital social souscrit susmentionnée, le premier alinéa de l'article

5 des Statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent quatre-vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-

cinq mille quatre cent vingt-trois Euros (187.785.423,-EUR) représenté par (i) quatre (4) Actions de Commandité ayant
une valeur nominale de mille Euros (1.000 EUR) chacune, (ii) cent soixante-quatorze millions sept mille quatre cent trente-
quatre (174.007.434) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, (iii) treize
millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (13.769.989) Actions Ordinaires de Classe A2 ayant
une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, et (iv) quatre mille (4.000) Actions Ordinaires de Classe B, ayant une
valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, réparties comme suit:

Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 1
- 1 Action de Commandité à mille Euros (1.000 EUR) détenue par l'Associé Commandité, relative au compartiment

susmentionné;

- 28.271.327 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité, relatives au compartiment susmentionné;

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE Senior 1
- 1 Action de Commandité à mille Euros (1.000 EUR) détenue par l'Associé Commandité relative au compartiment

susmentionné;

- 59.679.227 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité, relatives au compartiment susmentionné;

Commercial Real Estate Loans SCA - CRE Senior 2
- 1 Action de Commandité à mille Euros (1.000 EUR) détenue par l'Associé Commandité relative au compartiment

susmentionné;

- 19.062.829 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 13.769.989 Actions Ordinaires de Classe A2 d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité relatives au compartiment susmentionné;

56330

L

U X E M B O U R G

Commercial Real Estate Loans SCA - AXA CRE Senior 2
- 1 Action de Commandité à mille Euros (1.000 EUR) détenue par l'Associé Commandité relative au compartiment

susmentionné;

- 66.994.051 Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par les

Actionnaires Commanditaires de Classe A, relatives au compartiment susmentionné;

- 1.000 Actions Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, détenues par l'Associé

Commandité relatives au compartiment susmentionné;

toutes ces Actions étant entièrement libérées. Ces Actions Ordinaires sont rachetables en conformité avec les dis-

positions de l'article 49-8 de la Loi de 1915 et des Statuts».

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de quatre mille six cent euros (4.600.-EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. À la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses noms,

prénom usuels, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DI MARCO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2014. Relation: LAC/2014/7707. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Référence de publication: 2014036306/426.
(140041374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Maman Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.012.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 172.274.

EXTRAIT

En date du 7 mars 2014, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Monsieur Daniel Maman, résidant à Chemin de la Valleyre 26, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse, est élu nouveau

gérant de la Société avec effet au 1 

er

 janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée; et

- Monsieur Jonathan Maman, résidant à Chemin de la Valleyre 26, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse, est élu nouveau

gérant de la Société avec effet au 1 

er

 janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014036525/15.
(140041532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Morgan Stanley Eder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.078.

Il résulte des résolutions signées de l'associé unique de la Société du 03 mars 2014 qu'il a été décidé à l'unanimité:
- d'accepter la démission de Mademoiselle Xenia Kotoula en tant que gérant de la Société avec effet au 28 Février

2014;

- de nommer en remplacement du Gérant démissionnaire et pour une durée illimitée, Monsieur Jacob Mudde, né le

14 Octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat au 03 mars 2014; et

- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* TMF Corporate Services S.A.;

56331

L

U X E M B O U R G

* Monsieur Jorge Iragorri Rizo;
* Monsieur Young Chun Lee;
* Madame Patricia Anne Morrison; et
* Monsieur Jacob Mudde.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2014036572/25.
(140041744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Volkswagen Finance Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 166.745.

AND
GLOBAL VW AUTOMOTIVE B.V.

PROPOSAL FOR CROSS BORDER MERGER

PROPOSAL FOR CROSS BORDER MERGER ("Proposal") dated 5 May 2014 drawn up by the Management Board of

each of:

(1) Volkswagen Finance Luxemburg S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the

laws of Grand Duchy of Luxembourg, and its registered office at 291, Route D'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 166745
(the "Acquiring Company"); and

(2) Global VW Automotive a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid) incorporated under the laws of The Netherlands, having its seat (statutaire zetel) in Amsterdam, The Netherlands
and its office address at Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands and registered with the, Dutch Com-
mercial  Register  (Handelsregister)  under  number  34257823  (the  "Disappearing  Company"  and  together  with  the
Acquiring Company: the "Merging Companies" and each individually: a "Merging Company"):

<i>Recitals:

(A) The management boards of the Merging Companies deem a cross, border merger within the meaning of Section

2:309 in conjunction with Section 2:324 and Section 2:333b Dutch Civil Code ("DCC") and Section XIV - Mergers (Fusions)
of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Luxembourg Law") between
the Merging Companies desirable as a consequence whereof the Disappearing Company shall cease to exist and the
Acquiring Company shall acquire all assets and liabilities of the Disappearing Company under a universal title of succession,
(onder algemene titel) (the "Cross Border Merger"),

(B) The Cross Border Merger shall occur by (i) the execution of a deed of proceedings of an extraordinary general

meeting of shareholders of the Disappearing Company in which it is resolved to implement this Cross Border Merger in
front of a Dutch notary, (ii) the holding of an extraordinary general meeting of shareholders of the Acquiring Company
in front of a Luxembourg notary in which it is resolved to implement the Cross Border Merger and (iii) the publication
of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the Acquiring Company held in front of a Lu-
xembourg  notary  in  the  Memorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  the  Luxembourg  official  gazette  (the
"Memorial") (the "Completion").

(C) The Acquiring Company is the holder of all shares in the issued share capital of the Disappearing Company, as a

consequence whereof the following legal provisions do not apply to the Cross Border Merger: Sections 2:326 through
328 DCC and article 261 paragraph (2) b), c) and d), articles 265 and 266, article 267 paragraph (1) d) and e), article 274
paragraph (1) b) and article 275 of the Luxembourg Law,

(D) Neither from the shareholders' register of the Disappearing Company appears, nor the management board of the

Disappearing Company is acquainted with any pledge (pandrecht) on shares in the issued share capital of the Disappearing
Company, or any right of usufruct (recht van vruchtgebruik) created thereon. All shares in the issued share capital of the
Disappearing Company have been paid up in full.

(E) No depository receipts of shares (certificaten van aandelen) in the issued share capital of the Disappearing Company

have been issued.

(F) The Disappearing Company has not issued any shares without voting rights or profit rights.

56332

L

U X E M B O U R G

(G) None of the Merging Companies has been dissolved (ontbonden), has been declared bankrupt (in staat van fail-

lissement verkaard) or has been granted a suspension of payments (surséance van betaling); the respective management
boards of the Merging Companies are not acquainted with any intention to dissolve a Merging Company (other than by
way of the Cross Border Merger) or a pending request to declare the Merging Company bankrupt or grant a suspension
of payments.

(H) This Proposal has been approved by the supervisory board of the Acquiring Company on 5 May 2014. The Dis-

appearing Company does not have a supervisory board.

(I) None of the Merging Companies has instituted a works council or co-determination council (medezeggenschaps-

raad) and there is no association of employees, which includes amongst its members employees of the Merging Companies
or one of their subsidiaries.

<i>The management boards of the merging companies propose:

1. to effect a Cross Border Merger within the meaning of Section 2:309 in conjunction with Section 2:324 and Section

2:333b DCC and Section XIV - Mergers (Fusions) and in particular articles 278 through 280 of the Luxembourg Law
between the Merging Companies as a consequence whereof the Disappearing Company shall cease to exist and the
Acquiring Company shall acquire all assets and liabilities of the Disappearing Company under a universal title of succession;

2. to grant discharge to the current members of the management board of the Disappearing Company, Mr H.D. Pötsch

and Mr T. Fries, for their management of the Disappearing Company and the enterprise connected therewith.

Hereafter will follow the data of which Section 2:312 paragraph 2 and 4 in conjunction with Section 2:326 and Section

2:333d DCC and articles 261 and 278 of the Luxembourg Law require recording thereof in the Proposal. The Annex to
this Proposal is considered to be part of this Proposal.

(a) Legal Form, name and registered office of the Merging Companies. Acquiring Company: Volkswagen Finance Lu-

xemburg  S.A.,  a  public  limited  liability  company  (société  anonyme)  incorporated  under  the  laws  of  Grand  Duchy  of
Luxembourg having its registered office at 291, Route D'Arlon, L-1150 Luxembourg, Duchy of Luxembourg.

At Completion, the legal form, the name and the registered office of the Acquiring Company will not change.
Disappearing Company: Global VW Automotive B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of The Netherlands, having its seat (statutaire zetel) in
Amsterdam, The Netherlands and its office address at Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands.

(b) Articles of Association Acquiring Company. The articles of association of the Acquiring Company shall not be

amended in view of the Cross Border Merger. The current articles of association of the Acquiring Company are attached
to this Proposal as Annex.

(c) Rights and compensations, to be granted at the expense of the Acquiring Company pursuant to Section 2:320 DCC

and article 261 f) of the Luxembourg Law. There are (i) no persons other than shareholders, who have special rights
towards the Disappearing Company (such as a right to receive dividends or to acquire shares) (ii) no shareholders who
have special rights (other than those resulting from the articles of association) towards the Acquiring Company or the
Disappearing Company and (iii) no holders of securities other than shares in the issued capital of the Acquiring Company
and the Disappearing Company. Therefore no rights and compensation will be granted at the expense of the Acquiring
Company.

(d) Benefits which shall be attributed to the members of the management board or supervisory board of the Acquiring

Company or members of the management board of the Disappearing Company or others in connection with the Cross
Border Merger.
 No advantages shall be attributed to (i) the members of the management board or supervisory board of
the Acquiring Company (ii) the members of the management board of the Disappearing Company (iii) the independent
auditor of the Acquiring Company (iv) the auditor of the Disappearing Company or (v) others in connection with the
Cross Border Merger.

(e) Intentions related to the composition of the management board and the supervisory board of the Acquiring Com-

pany after the Cross Border Merger. The current composition of the management board of the Acquiring Company is
as follows:

- Mr. Frank Diethard Mitschke;
- Mr. Vincent Delva.
The current composition of the supervisory board of the Acquiring Company is as follows:
- Mr. Jochen Stich;
- Mrs. Gudrun Letzel;
- Mr. Albrecht Hermann Möhle.
The composition of the management board and supervisory board of the Acquiring Company will not change with

effect as from Completion.

(f) Point in time from which (i) the operations of the Disappearing Company shall be treated for accounting purposes

as being carried out on behalf of the Acquiring Company and (ii) the financial data of the Disappearing Company shall be

56333

L

U X E M B O U R G

accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company. As from 1 May 2014 the operations of the Disappearing
Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Acquiring Company and the
financial data of the Disappearing Company shall be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company.

(g) Intended measures in connection with the transition of ownership of shares in the capital of the Disappearing

Company. There is no transition of ownership of shares in the capital of the Disappearing Company, as the Acquiring
Company is the owner of all shares in the issued share capital of the Disappearing Company and the Acquiring Company
does not issue any shares in its share capital pursuant to the Cross Border Merger.

(h) Intentions relating to continuation or termination of activities. The activities of the Disappearing Company shall be

continued by the Acquiring Company as from Completion.

(i) Approval of the resolution to merge. The resolutions to implement the Cross Border Merger do not require

approval from bodies of the Acquiring Company or the Disappearing Company apart from the approval from the super-
visory board of the Acquiring Company (see recital. (H)).

(j) Influence of the Cross Border Merger on the size of the goodwill of the Acquiring Company. The size of the goodwill

of the Acquiring Company will not increase or decrease pursuant to the Cross Border Merger.

(k) Influence of the Cross Border Merger on the size of the distributable reserves of the Acquiring Company. The size

of the distributable reserves of the Acquiring Company shall increase with EUR 3,199,914,647.65.

(l) Employment consequence of the Cross Border Merger. The Cross Border Merger has no consequences for the

employees of the Acquiring Company. A letter has been sent to the employees of the Acquiring Company informing them
about the anticipated date of Completion and that the Cross Border Merger will have no impact on their employment.
The Disappearing Company has no employees.

(m) Arrangements with co-determination in the Merging Companies. Neither the Disappearing Company nor the

Acquiring Company has any arrangements with regard to co-determination as referred to in Section 1:1 (1) of the Act
on the role of Employees at the European Company and article L. 426-1 of the Luxembourg labour code.

(n) Information on the valuation of the assets and liabilities which are merged into the Acquiring Company.  The

Disappearing Company applies Dutch GAAP which will - subject to any reconciliation as may be necessary - also be the
basis for the valuation of the assets and liabilities to be merged into the Acquiring Company (which applies Luxembourg
GAAP).

(o) Rights of creditors of the Merging Companies. According to article 268 of the Luxembourg Law, creditors of the

Acquiring Company, whose claims predate the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting
of shareholders of the Acquiring Company in front of a Luxembourg notary in which it is resolved to implement the
Cross Border Merger may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two months of that publication
to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district in
which the registered office of the Acquiring Company is located and sitting as in urgency matters, to obtain adequate
safeguards of collateral for any matured and unmatured debts, where they ban credibly demonstrate that due to the Cross
Border Merger, the satisfaction of their claims is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the
Acquiring Company.

According to article 2:316 paragraph 2 DCC each creditor of the Disappearing Company may oppose the proposed

Cross Border Merger by a petition to the district court specifying the requested safeguards within one month after the
day on which the filing of this Proposal has been announced in a nationally distributed newspaper in The Netherlands and
in the Official State Gazette (Staatscourant). The district court shall disallow the request if the petitioner has not credibly
demonstrated that the financial condition of the Acquiring Company after the Cross Border Merger will provide less
safeguards for the satisfaction of his claims and that no adequate safeguards have been obtained from the Acquiring
Company.

(p) Date of the annual accounts which have been used to determine the terms and conditions of the Cross Border

Merger. The date of the annual accounts of the Acquiring Company and the Disappearing Company which have been
used to determine the terms and conditions of the Cross Border Merger is 31 December 2013.

As the Acquiring Company is the sole shareholder of the Disappearing Company no compensation will be paid pursuant

to Section 2:333h DCC and article 278 of the Luxembourg Law.

This Proposal together with any annexes referred to in it contains the entire agreement among the Merging Companies

and has been signed by all the members of the management boards of the Merging Companies and all the members of
the supervisory board of the Acquiring Company.

This Proposal shall be filed with (i) the Chamber of Commerce (Handelsregister) for Amsterdam, The Netherlands,

(ii) the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) and (iii) be held available
for inspection by shareholders at the registered offices of the Merging Companies. The filing shall be announced in a
nationally distributed newspaper in The Netherlands as well as in the Official State Gazette (Staascourant) in The Ne-
therlands and in the Mémorial in Luxembourg.

56334

L

U X E M B O U R G

Signature page belonging to the Cross Border Merger Proposal between Global VW Automotive B.V. as the Disap-

pearing Company and Volkswagen Finance Luxembourg S.A. as the Acquiring Company.

Management Board of Vollswagen Finance Luxemburg S.A.
F.D. Mitschke / V. Delva
<i>Director / Director
Management Board of Global VW Automotive B.V.
H.D. Pötsch / T. Fries
<i>Managing Director / Managing Director
Supervisory Board of Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
J. Stich / G. Letzel / A. H. Möhle
<i>Member Supervisory Board / Member Supervisory Board / Member Supervisory Board
Supervisory Board of Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
J. Stich / G. Letzel / A. H. Möhle
<i>Member Supervisory Board / Member Supervisory Board / Member Supervisory Board

VOORSTEL VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE ("Voorstel") de dato 5 mei 2014 opgesteld door de besturen

van:

Volkswagen Finance Luxemburg S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) opgericht naar het recht van

Luxemburg, met zetel (registered office) te 291, Route D'Arlon, L-1150 Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse
Registre de Commerce ei des Sociétés onder nummer B 166745 (de "Verkrijgende Vennootschap"); en

Global VW Automotive B.V., een besloten venoootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands

recht, met statutaire zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, ingeschreven in
het Handelsregister onder nummer 34257823 (de "Verdwijnende Vennootschap" en tezamen met de Verkrijgende Ven-
nootschap: de "Fuserende Vennootschappen" en elk afzonderiijk: een "Fuserende Vennootschap").

<i>Overwegingen:

De besturen van de Fuserende Vennootschappen achten het wenselijk een grensoverschrijdende fusie in de zin van

artikel 2:309 juncto artikel 2:324 en artikel 2:333b Nederlands Burgerlijk Wetboek ("BW") en Sections XIV - Mergers
(Fusions) van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 met betrekking tot commerciële vennootschappen, zoals ge-
wijzigd ("Luxemburgs Wetboek") tot stand te brengen tussen de Fuserende Vennootschappen als gevolg waarvan de
Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan en de Verkrijgende Vennootschap het vermogen van de Verdwijnende
Vennootschap onder algemene titel verkrijgt (De "Grensoverschrijdende Fusie").

De Grensoverschrijdende Fusie komt tot stand door: (i) het verlijden van een akte van proces verbaal van een bui-

tengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap waarin wordt besloten tot de
Grensoverschrijdende Fusie ten overstaan van een Nederlandse notaris (ii) het houden van een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap waarin wordt besloten tot de Grensoverschrijdende
Fusie ten overstaan van een Luxemburgse notaris en (iii) de openbaarmaking van de notulen van de buitengewone alge-
mene vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap welke werd gehouden ten overstaan van een
Luxemburgse notaris in de Staatscourant van Luxemburg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (de "Mémo-
rial") (de "Voltooiing").

De Verkrijgende Vennootschap houdt alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap,

zodat de volgende wetsbepalingen niet toepasselijk zijn op de Grensoverschrijdende Fusie: artikelen 2:326 tot en met
328 BW en artikel 261 lid (2) b), c) en d), artikel 265 en 266, artikel 267 lid (1) d) en e), artikel 274 lid (1) b) en artikel
275 Luxemburgs Wetboek.

Noch uit het register van aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap blijkt, noch het bestuur van de Verd-

wijnende Vennootschap is bekend, dat er aandelen in het geplaatste kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap bezwaard
zijn met een pandrecht of een recht van vruchtgebruik. Alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de Verdwijnende
Vennootschap zijn volgestort.

Er zijn geen certificaten van aandelen in het geplaatste kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap uitgegeven.
De Verdwijnende Vennootschap heeft geen aandelen zonder stem- of winstrechten uitgegeven.
Geen van de Fuserende Vennootschappen is ontbonden, in staat van faillissement verklaard of surséance van betaling

verleend; de respectievelijke besturen van de Fuserende Vennootschappen zijn er niet mee bekend dat er een voornemen
bestaat tot ontbinding van een Fuserende Vennootschap (anders dan als gevolg van de Grensoverschrijdende Fusie) of
dat een verzoek tot faillissementsverklaring van of tot verlening van surséance van betaling aan een Fuserende Vennoot-
schap aanhangig is.

Dit Voorstel is door de raad van commissarissen van de Verkrijgende Vennootschap goedgekeurd op 5 mei 2014. De

Verdwijnende Vennootchap heeft geen raad van commissarissen.

56335

L

U X E M B O U R G

Geen van de Fuserende Vennootschappen heeft een ondernemingsraad of medezeggenschapsraad ingesteld of werk-

nemers die lid zijn van een vereniging van werknemers die werknemers van de Fuserende Vennootschappen of een van
haar dochtermsatschappij onder haar leden telt.

<i>De besturen van de fuserende vennootschappen stellen voor:

een Grensoverschrijdende Fusie in de zin van artikel 2:309 juncto artikel 2:324 en artikel 2:333b BW alsmede Section

XIV - Mergers (Fusions) en in het bijzonder artikelen 278 tot er met 280 Luxemburgs Wetboek tot stand te brengen
tussen de Fuserende Vennootschappen als gevolg waarvan de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan en de
Verkrijgende Vennootschap het vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel verkrijgt; aan de
leden van het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap, de heer H.D. Pötsch en de heer T. Fries, decharge te verlenen
voor hun bestuur van de Verdwijnende Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Hierna volgen de gegevens waarvan artikel 2:312 leden 2 en 4 juncto artikel 2:326 en artikel 2:333d BW alsmede artikel

261 en 278 Luxemburgs Wetboek vermelding in het Voorstel voorschrijven. De Bijlage bij dit Voorstel maakt integraal
onderdeel uit van dit Voorstel.

Rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Vennootschappen. Verkrijgende Vennootschap: Volkswagen Finance

Luxemburg S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) opgericht naar het recht van Luxemburg, met zetel
(registered office) te 291, Route D'Arlon, L-1150 Luxemburg.

De rechtsvorm, naam en zetel van de Verkrijgende Vennootschap zullen bij de Voltooiing niet wijzigen.
Verdwijnende Vennootschap: Global VW Automotive B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 495, 1017 BT
Amsterdam.

Statuten Verkrijgende Vennootschap. De statuten van de Verkrijgende Vennootschap zullen in het kader van de Gren-

soverschrijdende Fusie niet gewijzigd worden. De statuten van de Verkrijgende Vennootschap zoals die thans luiden zijn
als Bijlage aan dit Voorstel gehecht.

Rechten en vergoedingen, ingevolge artikel 2:320 BW en artikel 261 f) Luxemburgs Wetboek ten laste van de Ver-

krijgende Vennootschap toe te kennen. Er zijn (i) geen personen, anderen dan aandeelhouders, die bijzondere rechten
(zoals rechten op een uitkering van winst of tot het nemen van aandelen) hebben jegens de Verkrijgende Vennootschap
(ii) geen aandeelhouders die bijzondere rechten (anders dan voorvloeiend uit de Statuten) hebben jegens de Verkrijgende
Vennootschap of de Verdwijnende Vennootschap en (iii) geen houders van effecten, niet zijnde aandelen in het geplaatste
kapitaal van de Verkrijgende en ce Verdwijnende Vennootschap. Er zullen caarom geen rechten en vergoedingen ten laste
van de Verkrijgende Vennootschap worden toegekend.

Voordelen welke in verband met de Grensoverschrijdende Fusie aan de leden van het bestuur of raad van commis-

sarissen van de Verkrijgende Vennootschap of leden van het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap of anderen
worden toegekend.
 Er worden geen voordelen in verband met de Grensoverschrijdende Fusie toegekend aan (i) de leden
van het bestuur of raad van commissarissen van de Verkrijgende Vennootschap (ii) de leden van het bestuur van de
Verdwijnende Vennootschap (iii) de onafhankelijke accountant van de Verkrijgende Vennootschap (iv) de accountant van
de Verdwijnende Vennootschap of (v) aan anderen.

Voornemens over de samenstelling na de Grensoverschrijdeiide Fusie van het bestuur en de raad van commissarissen

van de Verkrijgende Vennootschap. De huidige samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap is als
volgt:

- De heer Frank Diethard Mitschke;
- Mr Vincent Delva.
De huidige samenstelling van de raad van commissarissen van de Verkrijgende Vennootschap is als volgt:
- De heer Jochen Stich;
- Mevrouw Gudrun Letzel;
- De heer Albrecht Hermann Möhle.
De samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen zal niet wijzigen met ingang van de Voltooiing.

Tijdstip met ingang waarvan (i) de activiteiten van de Verdwijnende Vennootschap ten behoeve van financiële verant-

woording voor en namens de Verkrijgende Vennootschap worden uitgeoefend en (ii) de financiële gegevens van de
Verdwijnende Vennootschap zullen worden verantwoord in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap.
 Met
ingang  van  1  mei  2014  zullen  de  activiteiten  van  de  Verdwijnende  Vennootschap  ten  behoeve  van  financiële  verant-
woording voor en namens de Verkrijgende Vennootschap worden uitgeoefend en zullen de financiële gegevens van de
Verdwijnende Vennootschap worden verantwoord in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap.

Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de Verdwijnende Vennoot-

schap. Er is geen sprake van overgang van aandeelhouderschap in het kader van de Grensoverschrijdende Fusie, aangezien
de Verkrijgende Vennotschap alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap houdt en de
Verkrijgende Vennootschap geen aandelen in haar kapitaal zal uitgeven ingevolge de Grensoverschrijdende Fusie.

56336

L

U X E M B O U R G

Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden.  De  werkzaamheden  van  de  Verdwijnende

Vennootschap zullen met ingang van de Voltooiing worden voortgezet door de Verkrijgende Vennootschap.

Goedkeuring van het besluit tot Grensoverschrijdende Fusie. De besluiten tot Grensoverschrijdende Fusie behoeven

geen vennootschappelijke goedkeuring van organen van de Verkrijgende Vennootschap of de Verdwijnende Vennoot-
schap, behalve de goedkeuring van de raad van commissarissen van de Verkrijgende Vennootschap (zie overweging (H)).

Invloed van de Grensoverschrijdende Fusie op de grootte van de goodwill van de Verkrijgende Vennootschap. De

grote van de goodwill van de Verkrijgende Vennootschap zal niet toe- of afnemen als gevolg van de Grensoverschrijdende
Fusie.

Invloed van de Grensoverschrijdende Fusie op de grootte van de uitkeerbare reserves van de Verkrijgende Vennoot-

schap.  De  grootte  van  de  uitkeerbare  reserves  van  de  Verkrijgende  Vennootschap  zal  toenemen  met  EUR
3.199.914.647,65.

Gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie voor de werkgelegenheid.  De  Grensoverschrijdende  Fusie  zal  geen

gevolgen hebben voor de werknemers van de Verkrijgende Vennootschap. Aan de werknemers van de Verkrijgende
Vennootschap is een brief gezonden waarin zij op de hoogte zijn gebracht van de voorgenomen datum van Voltooiing en
van het feit dat de Grensoverschrijdende Fusie geen gevolgen zal hebben voor hun arbeidsverhouding. De Verdwijnende
Vennootschap heeft geen werknemers.

Regelingen met betrekking tot medezeggenschap in de Fuserende Vennootschappen. Noch de Verdwijnende Ven-

nootschap noch de Verkrijgende Vennootschap heeft enige regeling met betrekking tot medezeggenschap als bedoeld in
artikel 1:1 lid 1 van de Wet rol werknemers bij de Europese Vennootschap en artikel L.426-1 op het Luxemburgse
arbeidsrecht.

Informatie over de waardering van de activa en passiva die overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap. De Verd-

wijnende Vennootschap past Nederlandse GAAP toe hetgeen - behoudens noodzakelijke aanpassingen - ook zal dienen
voor de waardering van de activa en passiva die krachtens de fusie zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap
(welke Luxemburgsr GAAP toepast).

Rechten van de schuldeisers van de Fuserende Vennootschappen. Ingevolge artikel 268 Luxemburgs Wetboek kunnen

schuldeisers van de Verkrijgende Vennootschap wier vorderingen zijn ontstaan voor de publicatiedatum van de notulen
van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap waarin is besloten tot Grensovers-
chrijdende Fusie ten overstaan van een Luxemburgse notaris, binnen twee maanden na deze publicatiedatum de rechter
die de kamer van ce Tribunal d'Arrondissement voor handelszaken in het arrondissement waar de zetel van de Verkrij-
gende Vennootschap is gelegen bijeen in een kort geding samenstelling voorzit ondanks enige andersluidende overeen-
komst verzoeken om waarborgen te stellen voor de voldoening van vervallen en niet vervallen schulden voorzover zij
aannemelijk kunnen maken dat als gevolg van de Grensoverschrijdende Fusie de voldoening van hun vorderingen in gevaar
komt en dat van de Verkrijgende Vennootschap niet voldoende waarborgen zijn verkregen.

Ingevolge artikel 2:316 lid 2 BW kan iedere schuldeiser van de Verkrijgende Vennootschap tot een maand nadat de

nederlegging van dit Voorstel is aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad in Nederland en in de Staatscourant door
een verzoekschrift aan de rechtbank tegen de Grensoverschrijdende Fusie in verzet komen met vermelding van de waar-
borg die wordt verlangd. De rechtbank wijst het verzoek af indien de schuldeiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat de
vermogenstoestand van de Verkrijgende Vennootschap na de Grensoverschrijdende Fusie minder waarborg zal hieden
dat zijn vorderingen zullen worden voldaan, en dat van de Verkrijgende Vennootschap niet voldoende waarborgen zijn
verkregen.

Datum van de laatst vastgestelde jaarrekeningen die gebruikt zijn om de voorwaarden van de Grensoverschrijdende

Fusie vast te Stellen. De datum van de laatst vastgestelde jaarrekeningen van de Verkrigende en de Verdwijnende Ven-
nootschap die gebruikt zijn om de voorwaarden van de Grensoverschrijdende Fusie vast te stellen is 31 December 2013.

Aangezien de Verkrijgende Vennootschap enig aandeelhouder is van de Verdwijnende Vennootschap zal geen scha-

deloosstelling worden betaald als bedoeld in artikel 2:333h BW en artikel 278 Luxemburgs Wetboek.

Dit Voorstel vormt, tezamen met de daarin genoernde bijlagen, de volledige wilsovereenstemming van de Fuserende

Vennootschappen en is getekend door alle leden van het bestuur van de Fuserende Vennootschappen en alle leden van
de raad van commissarissen van de Verkrijgende Vennootschap.

Dit Voorstel zal worden neergelegd ten kantore van (i) het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Ams-

terdam, (ii) het Handels- en Vennootschapsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) te Luxemburg en (iii) ten
kantore van de Fuserende Vennootschappen ter inzage voor aandeelhouders. De neerlegging zal worden aangekondigd
in een landelijk verspreid dagblad in Nederland, alsmede in de Staatscourant in Nederland en de Mémorial in Luxembourg.

Handtekeningen pagina behorende bij het Voorstel tot Grensoverschrijdende Fusie tussen Global VW Automotive

B.V. als de Verdwijnende Vennootschap en Volkswagen Finance Luxembourg S.A. als de Verkrijgende Vennoolschap.

Bestuur van Vollswagen Finance Luxemburg S.A.
F.D. Mitschke / V. Delva

56337

L

U X E M B O U R G

<i>Director / Director
Bestuur van Global VW Automotive B.V.
H.D. Pötsch / T. Fries
<i>Managing Director / Managing Director
Raad van Commissarissen van Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
J. Stich / G. Letzel / A. H. Möhle
<i>Member Supervisory Board / Member Supervisory Board / Member Supervisory Board
Raad van Commissarissen van Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
J. Stich / G. Letzel / A. H. Möhle
<i>Member Supervisory Board / Member Supervisory Board / Member Supervisory Board

PLAN  FÜR  EINE  GRENZÜBERSCHREITENDE  VERSCHMELZUNG  (der  "Plan")  vom  5  Mai  2014  aufgestellt  vom

jeweiligen Vorstand von:

Volkswagen Finance Luxemburg S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet nach dem Recht des Groß-

herzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 291, Route D'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 166745 (die "Aufnehmende
Gesellschaft"); und

Global VW Automotive B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid), gegründet nach dem Recht der Niederlande, mit Gesellschaftssitz (statutaire zetel) in Amsterdam, die
Niederlande, und Geschäftsadresse in Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, die Niederlande, und eingetragen im nie-
derländischen  Handelsregister  (Handelsregister)  unter  der  Kummer  34257823  (die  "Absorbierte  Gesellschaft"  und
zusammen mit der Aufnehmenden Gesellschaft: die "Verschmelzenden Gesellschaften" und jeweils einzeln: eine "Ver-
schmelzende Gesellschaft").

<i>Erwägungsgründe:

Die Vorstände der Verschmelzenden Gesellschaften halten eine grenzüberschreitende Verschmelzung im Sinne von

Paragraph  2:309  in  Verbindung  mit  Paragraph  2:324  und  Paragraph  2:333b  des  niederländischen  Zivilgesetzbuches
(„NZGB“) und der Sektion XIV - Verschmelzungen (Fusions) des abgeänderten luxemburgisches Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften (das „Luxemburgische Gesetz“) zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften für er-
strebenswert. Folglich wird die Absorbierte Gesellschaft erlöschen und die Aufnehmende Gesellschaft im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge (onder algemene titel) das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Absorbierten Gesellschaft
übernehmen (die „Grenzüberschreitende Verschmelzung“).

Die Grenzüberschreitende Verschmelzung erfolgt mit (i) der Unterzeichnung eines Protokolls einer außerordentlichen

Gesellschafterversammlung der Absorbierten Gesellschaft, bei welcher die Umsetzung der Grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung vor einem niederländischen Notar beschlossen wird, (ii) dem Abhalten einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre der Aufnehmenden Gesellschaft vor einem luxemburgischem Notar, bei welcher die Umsetzung
der Grenzüberschreitenden Verschmelzung beschlossen wird, und (iii) der Veröffentlichung des Protokolls der vor einem
Luxemburger Notar abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Aufnehmenden Gesell-
schaft  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  dem  luxemburgischen  Amtsblatt  (das  „Mémorial“)  (der
„Vollzug“).

Die Aufnehmende Gesellschaft ist Eigentümerin aller ausgegebenen Anteile im Gesellschaftskapital der Absorbierten

Gesellschaft, woraus folgt, dass die folgenden Gesetzesbestimmungen keine Anwendung auf die Grenzüberschreitende
Verschmelzung finden; Paragraphen 2:326 bis 328 NZGB und Artikel 261 Absatz (2) b), c) und d), Artikel 265 und 266,
Artikel 267 Absatz (1) d) und e), Artikel 274 Absatz (1) b) und Artikel 275 des Luxemburgischen Gesetzes.

Weder ergibt sich aus dem Gesellschaftsregister der Absorbierten Gesellschaft noch hat der Vorstand der Absor-

bierten Gesellschaft Kenntnis von irgendeinem bestehenden Pfandrecht (pandrecht) bezüglich der ausgegebenen Anteile
im Gesellschaftskapital der Absorbierten Gesellschaft, oder von irgendeinem an solchen Anteilen bestellten Nießbrauch
(recht van vruchtgebruik). Sämtliche Anteile im Gesellschaftskapital der Absorbierten Gesellschaft wurden voll eingezahlt.

Es wurden keine Anteilszertifikate der Anteile (certificaten van aandelen) von der Absorbierten Gesellschaft ausge-

geben.

Die Absorbierte Gesellschaft hat keine Anteile ohne Stimmrechte oder Genussrechte ausgegeben.
Keine der Verschmelzenden Gesellschaften wurde aufgelöst (ontbonden), für insolvent erklärt (in Staat van faillisse-

ment verkaard) und keiner derselben wurde eine Zahlungseinstellung (surséance van betaling) gewährt; die jeweiligen
Vorstände der Verschmelzenden Gesellschaften haben, keine Kenntnis von irgendeinem Vorhaben zur Auflösung einer
Verschmelzenden Gesellschaft (in einer anderen Weise als über die Grenzüberschreitende Verschmelzung) oder von
einem ausstehenden Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bezüglich einer der Verschmelzenden Gesellschaften
oder zur Gewährung einer Zahlungseinstellung.

Der vorliegende Plan, wurde am 5 Mai 2014 vom Aufsichtsrat der Aufnehmenden Gesellschaft genehmigt. Die Ab-

sorbierte Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

56338

L

U X E M B O U R G

Keine der Verschmelzenden Gesellschaften hat einen Betriebsrat oder einen Mitbestimmungsrat (medezeggenschaps-

raad) gegründet und es gibt keinen Arbeitnehmervereinigung, dem Arbeitnehmer der Verschmelzenden Gesellschaften
oder einer ihrer Tochtergesellschaften angehören.

<i>Die Vorstände der verschmelzenden Gesellschaften schlagen vor:

zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften eine Grenzüberschreitende Verschmelzung, im Sinne von Paragraph

2:309 in Verbindung mit Paragraph 2:324 und Paragraph 2:333b NZGB und der Sektion XIV - Verschmelzungen (Fusions)
des Luxemburgischen Gesetzes und insbesondere die Artikel. 278 bis 280 des Luxemburgischen Gesetzes, durchzuführen.
Folglich wird die Absorbierte Gesellschaft erlöschen und die Aufnehmende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der Absorbierten Gesellschaft übernehmen;

den jetzigen Vorstandsmitgliedern der Absorbierten Gesellschaft, Herrn H.D. Pötsch und Herrn T, Fries, Entlastung

für die Leitung der Absorbierten Gesellschaft und des damit verbundenen Unternehmens zu erteilen.

Nachstehend folgen die Angaben, welche gemäß Paragraph 2:312 Absatz 2 und 4 in Verbindung mit Paragraph 2:326

und Paragraph 2:333d NZGB und den Artikeln 261 und 278 des Luxemburgischen Gesetzes in den vorliegenden Plan
aufgenommen werden müssen. Der Anhang des vorliegenden Plans bildet einen Bestandteil dieses Plans.

Rechtsform, Name und Gesellschaftssitz der Verschmelzenden Gesellschaften. Aufnehmende Gesellschaft: Volkswagen

Finance Luxemburg S.A.,. eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 291, Route D'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Nach Vollzug werden die Rechtsform, der Name, und der Gesellschaftssitz der Aufnehmenden Gesellschaft unverän-

dert bleiben.

Absorbierte Gesellschaft: Global VW Automotive B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid), gegründet nach dem Recht der Niederlande, mit Gesellschaftssitz (statutaire
zetel) in Amsterdam, die Niederlande, und Geschäftsadresse in Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, die Niederlande.

Satzung der Aufnehmenden Gesellschaft. Die Satzung der Aufnehmenden Gesellschaft soll im Zusammenhang mit der

Grenzüberschreitenden Verschmelzung nicht geändert werden. Die aktuelle Fassung der Satzung der Aufnehmenden
Gesellschaft ist dem vorliegenden Plan als Anhang angehängt.

Rechte und Ausgleichsleistungen, die gemäß Paragraph 2:320 NZGB und Artikel 261 f) des Luxemburgischen Gesetzes

zu Lasten der Aufnehmenden Gesellschaft gewährt werden müssen. Es gibt (i) keine Personen außer den Gesellschaftern,
denen Sonderrechte gegenüber der Absorbierten Gesellschaft (wie etwa ein Anspruch auf Dividendenzahlungen oder
Anteilserwerb) zustehen (ii) keine Gesellschafter, denen Sonderrechte (außer solche, die sich aus der Satzung ergeben)
gegenüber der Aufnehmenden Gesellschaft oder der Absorbierten Gesellschaft zustehen, und (iii) keine Inhaber von
anderen Wertpapieren als Anteilen im ausgegebenen Gesellschaftskapital der Aufnehmenden Gesellschaft und der Ab-
sorbierten Gesellschaft. Demnach werden keine Rechte und Ausgleichsleistung zu Lasten der Aufnehmenden Gesellschaft
gewährt.

Vorteile, welche den Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern der Aufnehmenden Gesellschaft oder den Vorstands-

mitgliedern der Absorbierten Gesellschaft oder andere in Verbindung mit der Grenzüberschreitenden Verschmelzung
gewährt werden missen.
 Im Zusammenhang mit der Grenzüberschreitenden Verschmelzung werden (i) den Vorstands-
oder Äufsichtsratsmitgliedern der Aufnehmenden Gesellschaft, (ii) den Vorstandsmitgliedern der Absorbierten Gesell-
schaft,  (iii)  den  unabhängigen  Abschlussprüfern  der  Aufnehmenden.  Gesellschaft,  (iv)  den  Abschlussprüfer  der
Absorbierten Gesellschaft oder (v) anderen Personen keine besonderen Vorteile gewährt.

Vorhaben in Bezug auf die Zusammensetzung des Vorstands und des Äufsichtsrats der Aufnehmenden Gesellschaft

nach der Grenzüberschreitenden Verschmelzung. Der Vorstand der Aufnehmenden Gesellschaft setzt sich zur Zeit wie
folgt zusammen:

- Herr Frank Diethard Mitschke;
- Herr Vincent Delva.
Der Aufsichtsrat der Aufnehmenden Gesellschaft setzt sich zur Zeit wie folgt zusammen:
- Herr Jochen Stich:
- Frau Gudrun Letzel;
- Herr Albrecht Hermann Möhle.
Die Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Aufnehmenden Gesellschaft, wird nach dem Vollzug

unverändert bleiben,

Zeitpunkt, von dem an (i) die Geschäfte der Absorbierten Gesellschaft für Zwecke der Rechnungslegung als im Namen

der Aufnehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten und (ii) die Finanzdaten der Absorbierten Gesellschaft zum Jah-
resabschluss der Aufnehmenden Gesellschaft abgerechnet werden.
  Ab  dem  1.  Mai  2014  werden  die  Geschäfte  der
Absorbierten Gesellschaft für Zwecke der Rechnungslegung als im Namen der Aufnehmenden Gesellschaft vorgenommen
gelten und die Finanzdaten der Absorbierten Gesellschaft zum Jahresabschluss der Aufnehmenden Gesellschaft abge-
rechnet werden.

56339

L

U X E M B O U R G

Beabsichtigte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Übergang des Eigentums der Anteile im Gesellschaftskapital

der Absorbierten Gesellschaft. Es gibt keine Übertragung des Eigentums der Anteile im Gesellschaftskapital der Absor-
bierten  Gesellschaft,  da  die  Aufnehmende  Gesellschaft  Eigentümerin  sämtlicher  Anteile  im  Gesellschaftskapital  der
Absorbierten Gesellschaft ist und die Aufnehmende Gesellschaft im Rahmen der Grenzüberschreitenden Verschmelzung
keine neuen Aktien in ihrem Gesellschaftskapital ausgeben wird.

Vorhaben in Bezug auf das Weiterführen oder die Beendigung der Geschäftstätigkeit. Die Geschäftstätigkeit der Ab-

sorbierten Gesellschaft wird nach dem Vollzug von der Aufnehmenden Gesellschaft weitergeführt werden.

Genehmigung des Verschmelzungsbeschlusses. Die Beschlüsse zur Umsetzung der Grenzüberschreitenden Verschmel-

zung bedürfen keiner Genehmigung der Organe der Aufnehmenden Gesellschaft oder der Absorbierten Gesellschaft, mit
Ausnahme der Genehmigung des Aufsichtsrats der Aufnehmenden Gesellschaft (siehe Erwägungsgrund (H)).

Auswirkung der Grenzüberschreitenden Verschmelzung auf den Firmenwert der Aufnehmenden Gesellschaft. Der

Firmenwert der Aufnehmenden Gesellschaft wird durch die Grenzüberschreitende Verschmelzung, weder erhöht noch
verringert.

Auswirkung der Grenzüberschreitenden Verschmelzung auf den Betrag der ausschüttungsfähigen Rücklagen der Auf-

nehmenden Gesellschaft. Der Betrag der ausschüttungsfähigen Rücklagen der Aufnehmenden Gesellschaft wird sich um
EUR 3.199.914.647,65 erhöhen.

Auswirkung der Grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Beschäftigung. Die Grenzüberschreitende Verschmel-

zung wird Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der Aufnehmenden Gesellschaft haben. Den Arbeitnehmern der Auf-
nehmenden  Gesellschaft  wurde  ein  Informationsschreiben  übermittelt,  das  sie  über  das  voraussichtliche  Datum  des
Vollzugs und darüber unterrichtet hat, dass die Grenzüberschreitende Verschmelzung keine Auswirkung auf ihre Ar-
beitsverhältnisse haben wird. Die Absorbierte Gesellschaft hat keine Arbeitnehmer.

Modalitäten für die Mitbestimmung in den Verschmelzenden Gesellschaften. Weder die Absorbierte Gesellschaft noch

die Aufnehmende Gesellschaft haben Regelungen hinsichtlich der Mitbestimmung gemäß Paragraph 1:1 (1) der Richtline
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gesellschaft und Artikel L.426-1 des luxemburgischen Ar-
beitsgesetzbuchs getroffen.

Informationen über die Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die Aufnehmende Gesellschaft übertragen

wird. Die Absorbierte Gesellschaft wendet niederländischen GAAP an, welche (vorbehaltlich irgendeiner gegebenenfalls
erforderlichen Abstimmung) auch die Grundlage für die Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens sein wird, welches
auf die Aufnehmende Gesellschaft (die luxemburgischen GAAP anwendet) übertragen wird.

Rechte der Gläubiger der Verschmelzenden Gesellschaften. Gemäß Artikel 268 des Luxemburgischen Gesetzes kön-

nen  Gläubiger  der  Aufnehmenden  Gesellschaft,  deren  Forderungen  entstanden  sind  vor  der  Veröffentlichung  des
Protokolls der vor einem Luxemburger Notar abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
Aufnehmenden Gesellschaft bei der die Umsetzung der Grenzüberschreitenden Verschmelzung beschlossen wurde, un-
geachtet  irgendeiner  gegenteiliger.  Vereinbarung,  innerhalb  von  zwei  Monaten  nach  dieser  Veröffentlichung  bei  dem
Vorsitzenden Richter des in Handelssachen tagenden Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement), in dessen Bezirk die
Aufnehmende Gesellschaft ihren Sitz hat, im Eilverfahren die Gewährung von ausreichenden Sicherheiten für ihre fälligen
und nicht fälligen Forderungen beantragen, sofern sie glaubhaft nachweisen können, dass die Grenzüberschreitende Ver-
schmelzung  die  Erfüllung  ihrer  Forderungen  gefährdet,  und  dass  die  Aufnehmende  Gesellschaft  keine  angemessenen
Sicherheiten geleistet hat.

Gemäß Artikel 2:316 Absatz 2 NZGB kann jeder Gläubiger de: Absorbierten Gesellschaft innerhalb eines Monats nach

dem Tag der Veröffentlichung der Hinterlegung des Plans in einer überregionalen Zeitung in den Niederlanden und in
dem niederländischen Amtsblatt (Staatscourant) mittels eines Antrags beim Bezirksgericht, in der die angeforderten Si-
cherheiten aufgeführt wurden, Einspruch gegen die vorgeschlagene Grenzüberschreitende Verschmelzung erheben. Das
Bezirksgericht weist den Antrag ab, wenn der Antragsteller nicht glaubhaft gemacht hat, dass nach der Grenzüberschrei-
tenden  Verschmelzung  die  Finanzlage  der  Aufnehmenden  Gesellschaft  weniger  Sicherheiten  für  die  Erfüllung  seiner
Forderungen bieten wird, und dass die Aufnehmende Gesellschaft keine angemessenen Sicherheiten geleistet hat.

Datum der Jahresabschlüsse, die für die Festlegung der Bestimmungen der Grenzüberschreitenden Verschmelzung

verwendet wurden. Das für die Festlegung der Bestimmungen der Grenzüberschreitenden Verschmelzung maßgebliche
Datum des Jahresabschlusses der Aufnehmenden Gesellschaft und des Jahresabschlusses der Absorbierten Gesellschaft
ist jeweils der 31. Dezember 2013,

Da die Aufnehmende Gesellschaft die alleinige Gesellschafterin der Absorbierten Gesellschaft ist, wird kein Ausgleich

gemäß Paragraph 2:333h NZGB und Artikel 278 des Luxemburgischen Gesetzes gezahlt.

Der vorliegende Plan stellt gemeinsam mit jeglichen darin genannten Anhängen die gesamte Vereinbarung zwischen

den Verschmelzenden Gesellschaften dar und wurde von allen Vorstandsmitgliedern der Verschmelzenden Gesellschaften
und allen Aufsichtsratsmitgliedern der Aufnehmenden Gesellschaft unterzeichnet.

Der vorliegende Plan wird hinterlegt bei (i) dem Handelsregister (Handelsregister) in Amsterdam, die Niederlande,

(ii) dem Luxemburger Handels- und Firmenregister (Registre de Commerce et des Sociétés), und (iii) am jeweiligen

56340

L

U X E M B O U R G

Gesellschaftssitz der Verschmelzenden Gesellschaften für die Aktionäre zur Einsicht bereitgehalten. Die Hinterlegung
wird in einer überregionalen Zeitung in den Niederlanden sowie im niederländischen Amtsblatt (Staatscourant) und im
Mémorial in Luxemburg veröffentlicht werden.

Signaturseite des grenzüberschreitenden Verschmelzungsplans zwischen Global VW Automotive B.V. als Absorbierte

Gesellschaft und Volkswagen Finance Luxembourg S.A. als Aufnehmende Gesellschaft.

Vorstand der Volkswagen Finance Luxembourg S.A.
F.D. Mitschke / V. Delva
<i>Director / Director
Vorstand der Global VW Automative B.V.
H.D. Pötsch / T. Fries
<i>Managing Director / Managing Director
Aufsichtsrat der Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
J. Stich / G. Letzel / A. H. Möhle
<i>Member Supervisory Board / Member Supervisory Board / Member Supervisory Board
Aufsichtsrat der Volkswagen Finance Luxemburg S.A.
J. Stich / G. Letzel / A. H. Möhle
<i>Member Supervisory Board / Member Supervisory Board / Member Supervisory Board

Annex

The articles of association of the acquiring company

Gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Francis KESSELER, mit dem Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette,

am 2. Februar 2012, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 836 vom 29. März 2012,

<i>Abänderungen

Datum

Notar

Veröffentlichung

24-05-2012 H. HELLINCKX C N°1628 vom 28-06-12
06-07-2012 H. HELLINCKX C N° 2012 vom 14-08-12
21-12-2012 H. HELLINCKX C N° 477 vom 26-02-13
21-12-2012 H. HELLINCKX C N° 490 vom 27-02-13
22-01-2013 H. HELLINCKX C N° 833 vom 09-04-13
19-04-2013 H. HELLINCKX C N° 1547 vom 28-06-13
16-10-2013 H. HELLINCKX C N° 3007 vom 28-11-13
01-04-2014 H. HELLINCKX C N°

KOORDINIERTE SATZUNG

ZUM 1. APRIL 2014

Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A.“ (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Lu-
xemburg, Insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10, August 1015 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg, Er kann durch Beschluss des

Vorstands der Gesellschaft (der Vorstand) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann durch
Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsraume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land  durch  einen  Beschluss  des  Vorstands  errichtet  werden.  Sollte  der  Vorstand  feststellen,  dass  außergewöhnliche
politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwick-
lungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaffssitz oder die Verbindung zwischen
diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Be-
endigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die Nationalität der Gesell-
schaft  wird  durch  keine  dieser  vorübergehenden  Maßnahmen  beeinflusst  sodass  die  Gesellschaft  ungeachtet  einer
vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt,

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und

56341

L

U X E M B O U R G

andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen, Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder
Art oder jeden Ursprungs Investieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben, Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt der Erträge aus
Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des
Weiteren kenn sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um Ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und Im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforder-
liche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3 Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen

effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern,

3.4 Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen In Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, weiche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lassen oder der Forderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, In-

solvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst,

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt siebzigtausendvierhundert Euro (EUR 70.400) bestehend aus dreihun-

dertdreiundfünfzig (353) gezeichneten und voll eingezahlten Stammaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro
(EUR 100,-) und aus dreihunderteinundfünfzig (351) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR
100,-) (die Aktien).

Da nichts anderes auf der Tagesordnung vorgesehen ist und niemand mehr etwas vorbringen möchte, wird die Ver-

sammlung geschlossen.

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den

vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden,

5.3 Die Aktionäre können mittels Beschlusses hinsichtlich der oben beschriebenen Aktiengattungen Jeweils eigenstän-

dige  Rücklagen  und/oder  Emissionsagiokonten  bilden.  In  Übereinstimmung  mit  dem  Gesetz,  können  Einlagen  in  die
Rücklagenkonten des Stammkapitals oder das Vorzugskapitals ohne die Ausgabe neuer Stammaktien oder Vorzugsaktion
per Beschluss der Aktionäre oder des Vorstands vorgenommen werden.

5.4 Den Inhabern von Stammaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Stammaktien

gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Stammaktien zugeordnet werden, verbunden
sind. Den Inhabern von Vorzugsaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Vorzugsaktien
gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Vorzugsaktien zugeordnet werden, verbunden
sind. Die Vorzugsaktien sind nach Maßgabe von Art. 23.3 dieser Satzung mit einem Gewinnvorzug. (Feste und Variable
Vorzugsdividende) ausgestattet.

5.5 Die Gesellschaft darf die auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich im Rah-

men des und in Übereinstimmung mit dem in Art. 3 dieser Satzung dargelegten Gesellschaftszweck für Finanzierungs-
maßnahmen der Gesellschaft verwenden. Für Zwecke dieser Satzung sind unter Finanzierungsmaßnahmen ausschließlich
jegliche  konzerninternen  Darlehensgewährungen  und  alle  anderen  Finanzierungsmaßnahmen  der  bei  der  Gesellschaft
eingerichteten, rechtlich unselbständigen Teileinheit Finanzierung (die Teileinheit Finanzierung) zu verstehen, die durch
die Vorzugsaktien finanziert werden oder hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (die Finanzierungsmaßnah-
men; sämtliche in der Teileinheit Finanzierung erwirtschafteten Aktiva und Passiva ergeben das Vermögen Teileinheit
Finanzierung). Im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, im Besonderen verbundene Unternehmen, die durch konzer-
ninterne  Darlehensgewährung  finanziert  werden.  Eine  andere  Verwendung  der  auf  die  ausgegebenen  Vorzugsaktien
eingezahlten Einlagen/Beträge ist ausgeschlossen.

5.6 Alle Vorzugsaktien werden in Form von rückzahlbaren Namensaktien emittiert. Die Rückzahlung auf die Vorzugs-

aktien kann In Übereinstimmung mit anwendbarem Luxemburger Recht (und insbesondere Art. 49-8 des Gesetzes) In
jedem Fall aber nur aus rechtlich ausschüttungsfähigem Vermögen nach Maßgabe von Art. 49-8 4) des Gesetzes i.V.m.
Art. 72-1 des Gesetzes erfolgen (d.h. insbesondere aus ausschüttungsfähigen Gewinnen, einschließlich aller von der Ge-
sellschaft LR. einer Agloemission erhaltenen und in Rücklagen eingestellten Betrage und/oder aus Einlagen, welche auf

56342

L

U X E M B O U R G

Aktien geleistet worden sind, und sofern, diese Aktien zum Zwecke der Finanzierung der Rückzahlung von Vorzugsaktien
(wie gesetzlich vorgeschrieben) auf Grundlage eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung neu ausge-
geben worden sind), Liegen alle Voraussetzungen gemäß dieser Satzung, dem Gesetz und sonstigem Luxemburger Recht,
vor, hat eine Rückzahlung auf die Vorzugsaktien nach Maßgabe der folgenden Bedingungen zu erfolgen:

(i) die Gesellschaft hat alle durch sie ausgegebenen und noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien spätestens nach

Ablauf eines festen Zeitraums von zehn (10) Jahren seit dem Tage Ihrer Emission zurückzuzahlen (der Rückzahlungszeit-
punkt). Die Gesellschaft kann die Vorzugsaktien per Beschluss des Vorstandes Jederzeit innerhalb der oben genannten
zehn (10) Jahre zurückzahlen;

(ii) der auf die noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktien entfallende Gesamtrückzahlungsbetrag entspricht der Summe

aus:

(a) dam Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls

vorhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto;
(c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach

Maßgabe von Art. 23-3 (insgesamt der Rückzahlungsbetrag).

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldweit oder durch

Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der

Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt der für das mit dem
Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, insoweit dieser niedriger ist, als der unter
(II) (a) (c) ermittelte Gesamtrückzahlungsbetrag.

Im Falle eines unterjährigen Rückzahlungszeitpunkts ist der anteilige, auf die Teileinheit Finanzierung entfallende Un-

ternehmenswert der Gesellschaft auf diesen unterjährigen Rückzahlungszeitpunkt auf Grundlage einer vom Vorstand zu
erstellenden oder In Auftrag zu gebenden Zwischenbilanz zu ermitteln.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art. 72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den

Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien in Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, ist dieser, sobald ein rechtlich
ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist unverzüglich, zuzüglich einem Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins
wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart Der Verzugszins ist
an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis
des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen
Vorzugsaktien aufzuteilen.

Zurückzuzahlende Vorzugsaktien werden nach Rückzahlung aufgrund eines Beschlusses einer über die Rückzahlung

beschließenden, außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre annulliert.

5.7  Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  von  Art.  24  dieser  Satzung  treten  Förderungen  aus  den  Vorzugsaktien  (ein-

schließlich der Förderungen auf Feste und Variable Vorzugsdividende sowie der Forderung auf Zahlung des Rückzah-
lungsbetrages) gegenüber den Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück, soweit diese nicht ebenfalls
im Sinne dieser Regelung nachrangig sind, Insbesondere im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Liqui-
dation der Gesellschaft treten die Anspruche der Inhaber von Vorzugsaktien hinter allen anderen Forderungen gegen-
wärtiger und zukünftiger Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück und werden somit erst nach vollständiger Befriedigung
aller nicht nachrangigen Gläubiger (einschließlich von Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder
Förderungen  aus  Rechtshandlungen,  die einem  solchen  Darlehen wirtschaftlich  entsprechen und der  diesen  Im Rang
vorgehenden Forderungen), jedoch vor Forderungen von Inhabern aus Stammaktien (Insbesondere Dividenden) nach
Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung bedient; der Nachrang gilt insoweit jedoch nicht für bereits bestehende oder
künftige Forderungen anderer -Gläubiger, die ebenfalls Im Sinne dieser Regelung nachrangig sind.

5.8 Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde ist der Vorstand

berechtigt

(i.) eine Erhöhung des Nennkapitals in Höhe auf bis zu insgesamt einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) durchzuführen,

welche steh auf bis zu viertausendsechshundertfünfzig (4650) Stammaktien von je einhundert Euro (EUR 100,-), welche
mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien und bis zu fünftausend (5000) Vorzugsaktien
von je einhundert Euro (EUR 100,-) belauft. Für diesen Fall sollen die Vorzugsaktien wie beschrieben ausgestaltet werden;

(ii.) eine Kapitalrücklage (Agio) auf Stammaktien und Vorzugsaktien festzulegen und einzuzahlen;
(iii.) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionäre für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu wi-

derrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu. zeichnen; und

(iv.) jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister ent-

sprechend abzuändern.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

56343

L

U X E M B O U R G

6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär

eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselbigen in das Aktienregister, einer Erklärung der

Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte
Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Art. 1690 des luxem-
burgischen Zivilgesetzes, Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen,
welche die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.
6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze Ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
6.6 Die Vorzugsaktien gewahren ihren Inhabern vorbehaltlich des Art. 6.7. des Art. 6.8 und der anderen Vorschriften

des Gesetzes, keine -Stimmrechte.

6.7 Die Inhaber von Vorzugsaktien sind berechtigt in jeder Hauptversammlung zu stimmen, welche einberufen wurde,

um über folgende Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen:

(i) die Emission neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
(ii) die Bestimmung der Festen und Variablen Vorzugsdividende, die den Vorzugsaktien anhängt;
(iii) die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien;
(iv) die Vorminderung des Stammkapitals der Gesellschaft;
(v) jede Änderung des Gesellschaftszweckes und/oder der Satzung der Gesellschaft, welche sich nachteilig auf die nach

dieser Satzung geschuldeten Vergütungen bzw. Rückzahlung der Vorzugsaktien (insbesondere nach Art. 23.3 und Art
23.4) auswirken kann;

(vi) die Emission von Wandelanleihen;
(vii) die Auflösung der Gesellschaft vor Ende der bestimmungsgemäßen Dauer, und
(viii) die Rechtsformumwandlung der Gesellschaft.
6.8 Für den Fall, dass trotz des Vorhandenseins eines Ausschüttungsfähigen Gewinns die Feste Vorzugsdividende aus

welchem Grund auch Immer für zwei aufeinanderfolgende Bilanzjahre nicht vollumfänglich bezahlt wurde und solange bis
alle Feste Vorzugsdividenden von dem/den Halter(n) von Vorzugsaktien erhalten worden sind, haben die Inhaber von
Vorzugsaktien bei allen Sitzungen die gleichen Stimmrechte wie die Halter von Stammaktien. Dies ist jedoch nicht der
Fall, wenn zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Bilanzjahre keine Variable Vorzugsdividende ausgezahlt wird.

6.9 Vorbehaltlich der Absätze 6.7 und 6.8, in denen den Inhabern von Vorzugsaktien Stimmrechte gewahrt werden,

finden  die  Vorzugsaktien  bei  der  Bestimmung  der  Erfüllung  der  Bedingungen  hinsichtlich  Quora  und  Mehrheiten  bei
Hauptversammlungen keine Berücksichtigung.

6.10 Jegliche Einberufungsbekanntmachungen, Berichte und Dokumente, welche gemäß Luxemburger Recht den Ak-

tionären  der  Gesellschaft,  geschickt  oder  bekanntgemacht  werden  müssen,  sind  gleichermaßen  den  Inhabern  von
Vorzugsaktien innerhalb der für diese Zwecke vorgeschriebenen Zeiträume zuzuschicken oder bekannt zu machen.

Verwaltung - Vertretungsmacht

Art. 7. Vorstand.
7.1 Zusammensetzung des Vorstands
(i) Solange die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat oder über ein Stammkapital von weniger als fünfhunderttau-

send Euro (EUR 500.000,-) verfügt, kann die Gesellschaft von einem (1) Vorstandsmitglied geleitet werden,

(ii) Hat die Gesellschaft mehr als einen Aktionär oder liegt das Gesellschaftskapital über fünfhunderttausend Euro (EUR

500,000,-), wird die Gesellschaft von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht

(iii) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Gesellschafter oder Mitglied des Aufsichtsrates Ist.
(iv) Der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch den Aufsichtsrat
(v) Der Aufsichtsrat ernennt das alleinige Vorstandsmitglied/die Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und be-

stimmt deren Anzahl (sofern anwendbar) und Vergütung. Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern beträgt sechs (6) Jahre.
Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grund-
sätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

(vi) Sofern eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt wird, muss diese, einen ständigen Stellvertreter (re-

présentant  permanent)  bestimmen,  welcher  dieses  in  ihrer  Funktion  als  Vorstandsmitglied  gemäß  Art.  60bis-4  des
Gesetzes vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem
Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unabhängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Per-
son, die er vertritt.

(vii) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend

einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.

(viii) Sollte das Amt eines Vorstandsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei werden, können die verbleibenden

Vorstandsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Aufsichts-

56344

L

U X E M B O U R G

ratssitzung ein neues Vorstandsmitglied ernennt. Der neue Amtsinhaber führt sodann die Amtszeit seines Vorgängers zu
Ende.

(xi) Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Ihre Amtszeit beträgt bei jeder Wiederwahl erneut sechs (6) Jahre.
7.2 Befugnisse des Vorstands
(i) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er ist befugt, die Geschäfte der Gesellschaft im weitesten

Sinne zu fuhren und alle Geschäfte vorzunehmen, weiche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich
dem Aufsichtsrat oder den Aktionären vorbehalten oder mittels Geschäftsordnung anderweitig vergeben worden sind.
Zur Ausübung dieser Funktion steht dem Vorstand die Befugnis zu, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und
zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen, Der Vorstand, oder je nachdem, das alleinige Vor-
standsmitglied ist befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw.
deren Abschluss zu veranlassen.

(ii) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft ferner gerichtlich und außergerichtlich.
(iii) Der Vorstand kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder

mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen.

(iv) Der Vorstand hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis die Gesellschaft irr

diesem  Zusammenhang  zu  vertreten,  auf  einen  oder  mehrere  Vorstandsmitglieder,  Vorstände,  Geschäftsführer  oder
andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre handelt oder
nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können, mit Ausnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats.
Sofern die Verwaltung des Saufenden Geschäftsverkehrs auf ein oder mehrere Vorstandsmitglieder übertragen ist, muss
der Vorstand der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Vor-
standsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

(v) Für verschiedene Geschäfte muss der Vorstand oder das alleinige Vorstandsmitglied (gemäß Artikel 7.1 (i)) die

vorherige Genehmigung des Aufsichtsrates einholen. Diese Geschäfte werden in der Geschäftsordnung geregelt.

7.3 Verfahren
(i) Der Vorstand muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer auswählen,

der nicht zwangsläufig ein Vorstandsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Vorstandssitzungen
zuständig ist. Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Vorstands ergeben zusammengefügt ein gültiges Sit-
zungsprotokoll. Protokolle der Sitzungen des Vorstands können durch den Vorsitzenden und den Sekretär der Sitzung
des Vorstands unterzeichnet werden oder durch eine Person, die vom Vorstand In einer Sitzung dahingehend ermächtigt
wurde.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei (2) Vorstandsmitgliedern trifft sich der Vorstand,

an einem in der Ankündigung genannten Ort grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Vorstands geht allen Vorstandsmitgliedern spätestens

eine Woche vor der Versammlung zu, es sei denn, es liegt ein dringender Fall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen sind.

(iv) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn all® Mitglieder des Vorstands bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt Ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Vorstandsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche
Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, weicher durch den Vorstand verabschiedet wurde.

(v) Ein Vorstandsmitglied kann einem anderen Vorstandsmitglied eine Vollmacht erteilen, um sich bei der Versammlung

vertreten zu lassen.

(vi) Der Vorstand ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

ist.

(vii) Ein Vorstandsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über

das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Vorstand darüber unterrichten und hierüber eine Nie-
derschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist, Das betroffene Vorstandsmitglied darf an den
Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist den Aktionären auf der nächsten
Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten.

(viii) Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die

Fortschritte und vorhersehbaren Ereignisse der Geschäfte. Der Vorstand ist desweiteren verpflichtet, den Aufsichtsrat
auf Verlangen gemäß und I.S. des Art. 60bis-12 Abs.4 des Gesetzes innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Ge-
schehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

7.4 Beschlussfassung des Vorstands
(i) Die Beschlüsse des Vorstands sind rechtswirksam, wenn sie von der Mehrheit dar Stimmen der anwesenden und

vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst werden, es sei denn die Satzung sieht etwas anderes vor. Im Falle von Stimmen-
gleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu.

(ii) Der Vorstand kann schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Vorstandsmitgliedern auf einem einzigen Dokument

oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post Email oder auf anderen Kommunika-

56345

L

U X E M B O U R G

tionswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unter-
schriften erkennen lasst oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen; stellen die Urkunde
dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten
Unterschrift Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen
und abgehaltenen Vorstandsratssitzung gefasst worden sind.

7.5 Stellvertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vor-

stande gebunden. In den Fällen des Art. 7.1

(ii) wird sie durch die Unterschrift des alleinigen Vorstands gebunden.
(iii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift eines oder mehrerer Handlungsbevoll-

mächtigten gemäß Art. 7.2 (iii) verpflichtet.

(iv) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten des täglichen Lebens im laufenden Geschäftsverkehr durch einen oder

mehrere tägliche Geschäftsführer (administrateur délégué; délégué à la gestion journalière) verpflichtet, welche gemäß
Art. 7.2 (iv) bestellt worden sind.

Art. 8. Alleiniges Vorstandsmitglied.
8.1 In den In Art. 7-1 (i) bezeichneten Fällen, kann die Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung,

welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Vorstandsmitglied verwaltet werden, In
diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Vorstand oder die Vorstandsmitglieder beziehen, auf das
alleinige Vorstandsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Transaktionen, welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen gemäß Art. 60 bis-18 des Gesetzes in

einem Entscheidungsregister protokolliert werden, wenn sich das alleinige Vorstandsmitglied In einem Interessenkonflikt
befinden körinte.

Art. 9. Haftung der Vorstandsmitglieder. Vorstandsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haltbar für

Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung, der Geschäftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften
stehen. Ungeachtet dessen sind Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft und gegen-
über jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

Aufsichtsrat

Art. 10, Anzahl der Aufsichtsräte.
10.1 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht bei mehreren Aktionären aus mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitglie-

dern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen,

10.2 Die Hauptversammlung ernennt die Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sewic

die Dauer Ihrer Mandate.

10.3 Wenn eine Rechtsperson zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese eine natürliche Person zum stän-

digen Stellvertreter (representant permanent) ernennen, welche die Rechtsperson als Aufsichtsratsmitglied gemäß Art.
51 bis des Gesetzes vertritt.

Art. 11. Innere Organisation des Aufsichtsrats.
11.1 Die Hauptversammlung kann eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erlassen.
11.2 In diesem Fall, soll die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zugleich festlegen, welche Geschäfte der vorherigen

Zustimmung der Hauptversammlung, bedürfen.

Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrats.
12.1 Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Beaufsichtigung der durch den Vorstand vorgenommenen

Geschäftsführung der Gesellschaft. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind oder die mittels Geschäftsordnung
anderweitig vergeben wurden.

12.2 Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Informationen einzu-

fordern. Hiervon umfasst ist das Recht, Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Nieder-
schriften der Gesellschaft zu nehmen.

12.3 Die Hauptversammlung beschließt einmal jährlich die Entlastung des Vorstandes.

Art. 13. Amtszeit.
13.1 Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren

bestellt.

13.2 Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Hauptversammlung, welche die Aufsichtsratsmitglieder bestellt und endet

grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

56346

L

U X E M B O U R G

13.3 Wird die Stolle eines Aufsichtsratsmitglieds Innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Auf-

sichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

13.4 Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
13.5 Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.
13.6 Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 14. Zusammensetzung und Beschlussfassung.
14.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-

zenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert Ist Sind
beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der
Sitzung.

14.2 Die Aufsichtsratssitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stell-

vertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen zweier Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorstands.

14.3 Der Aufsichtsrat tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr.
14.4 Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfallen sollen Sitzungen des Aufsichtsrats mindestens eine Woche vorher schrift-

lich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen.

14.5 Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.
14.6  Jedes  Aufsichtsratsmitglied,  das  an  der  Teilnahme  an  einer  Sitzung  verhindert  ist,  kann  ein  anderes  Mitglied

schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen, Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder e-Mail erteilt
werden, Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

14.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen, In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder
nur eine beratende Funktion,

14.8 Sofern nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden Beschlüsse des Aufsichtsrats mit einfacher Stim-

menmehrheit gefasst Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (bei Abwesenheit des Vorsitzenden
die des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden).

14.9 Der Aufsichtsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern auf einem

einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, Email oder auf
anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Doku-
ment, das alle Unterschriften erkennen lässt oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen,
stellen die Urkunde dar, weiche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das
Datum der letzten Unterschrift Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungs-
gemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden sind.

14.10 Eine Vertretung des Vorsitzenden ist nur für zuvor in der Tagesordnung angekündigte Themen zulässig.

Art. 15. Sitzungsprotokoll und Abschriften.
15.1 Die von dem Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die vom Vorsitzenden

oder einem beliebigen Aufsichtsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat zu unterschrieben sind.

15.2 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die wahrend eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden müssen vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

15.3 Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrats ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungs-

protokoll.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Dem Aufsichtsrat steht es frei, seinen Mitgliedern Spezialvollmachten für einen

Zweck oder spezifische Zwecke anzuvertrauen. Er kann ferner beschließen, Ausschüsse zu bilden, deren Zusammenset-
zung  und  Pflichten  er  bestimmen  kann  und  welche  ihre  Aufgaben  unter  seiner  Verantwortlichkeit  ausführen.  Die
Zuweisung solcher Pflichten darf allerdings nicht in der Delegierung der durch Gesetze oder die Satzung dem Aufsichtsrat
selbst vorbehaltenen Befugnisse an einen Ausschuss bestehen oder In einer Verringerung oder Begrenzung der Befugnisse
des Vorstandes resultieren.

Art. 17. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.
17.1. Gemäß der Satzung und dem Gesetz übernehmen Aufsichtsratsmitglieder oder gegebenenfalls das alleinige Auf-

sichtsratsmitglied  aufgrund  ihrer  Position  und  in  Zusammenhang  mit  Ihrer  Aufsicht  über  die  Geschäftsführung  der
Gesellschaft keine persönliche Haftung in Verbindung mit Irgendeiner gültigen Verpflichtung, Sie sind der Gesellschaft
gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und Fehler in der Aufsichtsratstätigkeit.

17.2 Ungeachtet dessen haften sie gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Jeglichem Dritten

für Verletzungen der Satzung.

Art. 18. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.
18.1 Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.

56347

L

U X E M B O U R G

18.2 Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle Im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen,

um im Vorstand mitzuwirken. Wahrend diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Auf-
sichtsratsmitglied aufgehoben.

Aktionär(e)

Art. 19. Hauptversammlung der Aktionäre.
19.1 Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen der Aktionäre verabschiedet (die Hauptversammlung).

Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen,
die mit dem Gesellschaffezweck in Einklang stehen,

(ii) Jede Stammaktie hat eine (1) Stimme. Für Vorzugsaktien finden die in den Artikeln 6.7 bis 6.10 dieser Satzung

geregelten Spezialregelungen Anwendung.

19.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Die Hauptversammlungen werden durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen und finden an dem In der

Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt,

(ii) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung

Informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

(iii) Vorsitzender der Hauptversammlung ist der Versitzende des Aufsichtsrates oder, bei dessen Verhinderung, der

stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied des Vorstands,
das von der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer sowie
einen Stimmenzahler, welche zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand darstellen und mit ihm ge-
meinsam das Protokoll der Hauptversammlung unterzeichnen.

(iv) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(v) Die Hauptversammlung kann nur durch physische Anwesenheit abgehalten werden.
(vi) Beschlüsse der Hauptversammlung können - soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist - durch einfache

Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre. entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertre-
tenen Stammkapitals.

(vii) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzung nur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals

vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen
Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht
erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem
fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Mé-
morial  und  in  zwei  luxemburgischen  Zeitungen,  einberufen  werden.  Diese  Ankündigung  muss  die  Tagesordnung  der
Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite
Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden
Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(viii) Die Hauptversammlung kann, vorbehaltlich der Angelegenheiten, die ausschließlich dem Vorstand durch das Ge-

setz  oder  die  Satzung  vorbehalten  sind,  über  alte  Angelegenheiten  der  Gesellschaft  befinden,  Ihr  sind  insbesondere
folgende Beschlüsse vorbehalten:

(a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
(b) Feststellung des Jahresabschlusses;
(c) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
(d) Entlastung der Wirtschaftsprüfer;
(e) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
(f) Satzungsänderungen;
(g) Auflösung der Gesellschaft.
(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber

der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre.

Art. 20. Alleiniger Aktionär.
20.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die

der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen.

20.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf

den alleinigen Aktionär.

20.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

56348

L

U X E M B O U R G

Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 21. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
21.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
21.2 Dar Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Be-

standsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der
Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Vorstandsmitglieder und dem satzungsmäßigen Wirtschafts-
prüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst

21.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand den satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern

Urkundenbeweise hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer erstellen da-
raufhin einen Bericht der Ihre Erkenntnisse und Vorschlage enthält.

21.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung

angegebenen Ort der Gemeinde, am zweiten Montag im Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in
Luxemburg kein Werktag, so findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

21.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Um-

standes nach der Einschätzung des Vorstands notwendig ist.

Art. 22. Wirtschaftsprüfer.
22.1 Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfern (réviseur d'entreprises)

kontrolliert

22.2 Die Hauptversammlung ernennt die externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) und bestimmt deren

Anzahl, Vergütung und Amtszeit, welche einen Zeitraum von einem (1) Jahr nicht überschreiten darf, weiche aber wie-
dergewählt werden können.

Art. 23. Gewinnausschüttung.
23.1 Gemäß Art. 72 des Gesetzes sind fünf Prozent (5%) des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten

Jahresüberschusses der Gesellschaft der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat

23.2 Die Hauptversammlung entscheidet, auf welche Art und Weise über den nach Zuführung zu den gesetzlichen

Rücklagen gemäß Art. 23.1 verbleibenden Betrag (der Ausschüttungsfähige Gewinn) zu verfügen ist. Der Ausschüttungs-
fähige Gewinn berechnet sich gemäß Art. 72-1 des Gesetzes. Vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Satzung,
insbesondere nach 23.3 und 23.4 der Satzung, kann sie in Höhe des Ausschüttungsfähigen Gewinns eine Dividendenaus-
schüttung  beschließen,  diesen  ganz  oder  teilweise  in  Rücklagenkonten  einstellen  oder  in  Übereinstimmung  mit  den
anwendbaren gesetzlichen Regelungen beschließen, diesen als Gewinn vorzutragen.

23.3 Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber einen Gewinnvorzug in Form einer Festen Vorzugsdividende und einer

Variablen Vorzugsdividende nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

(a) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber

von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich)
bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine feste Vorzugsdividende in Höhe von 0,001% p.a. ihres Nennbetrages
und damit verbundener Emissionsagios soweit vorhanden zuzüglich des Vorzugsaktien Rücklagenkontos (die Feste Vor-
zugsdividende). Eine Feste Vorzugsdividende ist jedoch nur dann zu zahlen, soweit die Gesellschaft in ihrem testierten
Jahresabschluss (Einzelabschluss), wie er sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nach Luxemburger
Recht und den für die Gesellschaft geltenden luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften ergibt, für das jeweilige
Geschäftsjahr einen Ausschüttungsfähigen Gewinn gem. Art. 23.2 In ausreichender Höhe ausweist. Reicht der Ausschüt-
tungsfähige Gewinn nicht zur vollständigen Zahlung der Festen Vorzugsdividende aus, so ist die Feste Vorzugsdividende
für das maßgebliche Geschäftsjahr lediglich in Höhe des vorhandenen Ausschüttungsfähigen Gewinns zu zahlen.

Kann die Feste Vorzugsdividende für ein Geschäftsjahr ganz oder teilweise nicht ausgezahlt werden, so sind die ent-

sprechenden Fehlbeträge festzustellen und aus ausschüttungsfähigen Gewinnens folgender Geschäftsjahren nach densel-
ben Maßstäben nachzuzahlen oder in den Rücklagen entsprechend zu erhöhen, beginnend mit der ältesten ausstehenden
Festen Vorzugsdividende. Eine Feste Vorzugsdividende bezogen auf die Nachzahlungsansprüche Wird jedoch nicht ge-
schuldet

Der  Anspruch  auf  Zahlung  der  Festen  Vorzugsdividende  wird  jeweils  einen  Bankarbeitstag  nach  der  ordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das zuvor abgelaufene Geschäfts-
jahr beschließt, für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung fällig. Nachzahlungen sind mit Ablauf des sechsten Monats
des Geschäftsjahres fällig, das auf das Geschäftsjahr folgt, in dessen Jahresabschluss erstmals entsprechender Ausschüt-
tungsfähiger Gewinn für die Nachzahlung vorhanden ist.

Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der

tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

(b) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber zudem das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen)

Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (ein-
schließlich)  bis  zum  Tag  der  Rückzahlung  (ausschließlich)  eine  variable  Vergütung,  Die  variable  Vergütung  (Variable

56349

L

U X E M B O U R G

Vorzugsdividende) bemisst sich nach dem Nettoertrag aus der Teileinheit Finanzierung vor Steuern gebucht im Jahres-
abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres nach luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften in Übereinstimmung des
Gesetzes vom 19. Dezember 2002 abzüglich der Festen Vorzugsdividende im Sinne des Artikels 23.3 (a) dieser Statuten.

In eine Formel gebracht, bedeutet dies folgendes:
Variable Vorzugsdividende: = (Nettoeinkommen aus Teileinheit Finanzierung vor Steuern Feste Vorzugsdividende)
Nettoeinkommen sind alle im Jahresabschluss verbuchten Ertrage aus der Teileinheit Finanzierung (einschließlich re-

alisierte Gewinne auf Vermögensgegenstände der Teileinheit Finanzierung) abzüglich aller im Jahresabschluss der Gesell-
schaft gebuchten Kosten, soweit diese nicht anderen Einkommensquellen direkt zurechenbar sind.

Es erfolgt keine nachträgliche Änderung der Variablen Vorzugsdividende, wenn der Jahresabschluss nachträglich ge-

ändert wird und sich unter Zugrundelegung des geänderten Jahresabschlusses eine niedrigere Variable Vorzugsdividende
ergibt Führt die nachträgliche Änderung des Jahresabschlusses zu einer höheren Variablen Vorzugsdividende, so bemisst
sich die Variable Vorzugsdividende nach diesem höheren Betrag; der entsprechende Mehrbetrag ist innerhalb von zehn
Bankarbeitstagen nach erfolgter Änderung des Jahresabschlusses fällig. Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger
als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der
Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

Neben der Festen und Variablen Vorzugsdividende hat der Inhaber von Vorzugsaktien keinen Anspruch auf Zahlung

von weiteren Dividenden,

Vorbehaltlich des Vorausgehenden, wird generell keine Dividende, weder eine Abschlags- noch Sachdividende, aus-

gezahlt oder erklärt, noch wird irgendeine andere Ausschüttung oder Rückerstattung des Stammkapitals, des Emissions-
aglos und Rücklagenkontos auf Grundlage der Stammaktien gemacht bis jegliche nach Maßgabe von Art. 23.3 zu zahlende
Feste und Variable Vorzugsdividende vollständig gezahlt wurden ist.

23.4 Ist Ausschüttungsfähiger Gewinn in ausreichender Hohe vorhanden, um eine Feste und/oder Variable Vorzugs-

dividende ganz oder teilweise zahlen zu können, und entscheidet der alleinige Aktionär, oder im Falle einer Mehrheit von
Aktionären die Hauptversammlung, keinen Ausschüttungsbeschluss bezüglich solch einer Vorzugsdividende zu erlassen,
so ist der Dividendenbetrag, der dem jeweiligen Inhaber der Vorzugsdividende zusteht, automatisch einer verteilbaren
Rücklage zuzuweisen, welche in einem Vorzugsaktien Rücklagenkonto verbucht ist.

Abschlagsdividenden können Jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Emissionsagios) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Betrage, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Vorstand innerhalb von zwei (2)

Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) in ihrem Bericht an den Vorstand müssen die externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) soweit anwend-

bar prüfen, ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

Art. 24. Auflösung und Liquidation.
24.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Sat-

zungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst, worden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei weichen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt,
ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben
die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen,

24.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten (einschließlich Fester Vor-

zugsdividenden) wird unter den Aktionären wie folgt aufgeteilt:

(i)  sofern  Vorzugsaktien  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  ausgegeben  und  noch  nicht  zurückgezahlt  sein  sollten,  ist  der

jeweilige Inhaber der Vorzugsaktie (im Verhältnis des Nennbetrages der von ihm gehaltenen Vorzugsaktien zum Ge-
samtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien) zu einem Vorzugsrecht am Liquidationserlös berechtigt Das
anteilige Vorzugsrecht erstreckt sich der Höhe nach auf den Teil des Liquidationserlöses, der sich aus der Summe der
folgenden Positionen ergibt:

(a) Gesamtnennbetrag alter noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsaglos (falls vor-

handen);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto,
(c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach

Maßgabe von Art 23,3 (insgesamt der Liquidationsbetrag)

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch

Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

56350

L

U X E M B O U R G

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der

Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt, der für das mit dem
Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, Insoweit dieser niedriger ist, als der unter
(ii) (a) - (c) ermittelte Gesamtrückzahlungsbetrag.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art.72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den

Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien In Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, Ist dieser, sobald ein rechtlich
ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist, unverzüglich, zuzüglich eines Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins
wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart, Der Verzugszins ist
an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis
des Jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen
Vorzugsaktien aufzuteilen.

(ii) jeglicher Mehrbetrag wird dem/den Inhaber(n) dar Stammaktien zugewiesen.
Als Folge der vorangehenden Bestimmungen hat/haben der/die Inhaber der Vorzugsaktien abgesehen von dem zuvor

erwähnten Vorzugsrecht kein Anrecht auf Teilnahme an«sonstigen Liquidationserlös.

Art. 25. Allgemeine Bestimmungen.
25.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden.
25.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Vorstandssitzung können von einem Vorstandsmitglied, in Obereinstimmung mit den vom Vorstand genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

25.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt.

25.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.

Luxemburg, den 9. April 2014.

FÜR GLEICHLAUTENDE SATZUNG
Henri HELLINCKX
<i>Notar

Référence de publication: 2014063797/1086.
(140073701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2014.

Columeta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 72.286.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- GROUPE MARECHAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-8287 Kehlen, 14, Zone Industrielle, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 119.267,

ici représentée par son gérant technique, Monsieur Nico MARECHAL, entrepreneur, demeurant à L-9189 Vichten, 1,

Um Knapp.

I.- Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est la

seule et unique associée de la société «COLUMETA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8184
Kopstal, 1a, rue de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 72.286, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 octobre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1009 du 29 décembre 1999, et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors notaire de résidence à Rambrouch, en
date du 5 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 707 du 2 avril 2010 (ci-après
la "Société").

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant à l'associée unique
pré-qualifiée.

III. L'associée unique pré-qualifiée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est

réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère comme dûment convoquée et a pris les résolu-
tions suivantes, qu'elle a demandé au notaire d'acter comme suit:

56351

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-8184 Kopstal, 1a, rue de Luxembourg à L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle»;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.

<i>Première résolution

L'associée unique a décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société de son adresse actuelle de

L-8184 Kopstal, 1a, rue de Luxembourg, à l'adresse suivante: L-8287 Kehlen, 10, Zone Industrielle.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier le

premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le siège de la Société est établi dans la commune de Kehlen.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Kehlen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

taire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. MARECHAL, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 janvier 2014. Relation: DIE/2014/1005. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036332/51.
(140041933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Effequatro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 65.608.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 11 mars 2014 à 16 heures.

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Sandro CAPUZZO, demeurant professionnellement

19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Benoît DESSY demeurant

professionnellement 20, Rue de la Poste - L-2346 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son
prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
EFFEQUATRO S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014036372/18.
(140041875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Prologis European Holdings XXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 164.330.

<i>Rectificatif du dépôt No L130202251 du 27/11/2013

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036619/10.
(140041454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

56352


Document Outline

Aismare Lux Holdings

B.A. Domicili S.à r.l.

Biostime Luxembourg S.à r.l.

ColKart Investment II SCS

Columeta S.à r.l.

Commercial Real Estate Loans SCA

Effequatro S.A.

Gubernantia S.à r.l.

Hartung Internationale Transporte G.M.B.H.

Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Lagunare S.A.

LIB Holdings S.A.

Link Consult S.A.

LINSTER-bureautique S.à r.l.

LINSTER-bureautique S.à r.l.

Logicor Holdco II S.à r.l.

Logicor Pledgeco II S.à r.l.

Lunar Hereford S.à r.l.

Lunar Stretford S.à r.l.

Lux 22 Starlight GBP S.à r.l.

Lux 30 Starlight EUR S.à r.l.

Luxempart Capital Partners, SICAR, S.A.

Luxvalor Management S.A.

Lyotre Property S.A.

Maman Group S.à r.l.

Marcol Europe S.A.

Marcol Europe S.A.

Matrix Plymouth S.A.

Medest S.A.

Medest S.A.

MGE Vernon S.à r.l.

Middagkrans S.à r.l.

Mikek S.à.r.l.

MMD Investment S.A.

Morgan Stanley Eder S.à r.l.

MSI Alpha S.à r.l.

MStar Holdings Lux S.à r.l.

Prologis European Holdings XXIV S.à r.l.

Sephir Participation S.à r.l.

Volkswagen Finance Luxemburg S.A.