This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1006
19 avril 2014
SOMMAIRE
Barolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48288
CORESTATE ENERGY HoldCo S.à r.l. . .
48247
Dima Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48247
Elit Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48286
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . . . .
48274
Fontgrande S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48243
Framont Investissements S.A., S.P.F. . . . .
48242
Giedo van der Garde S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
48243
Gras Savoye Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48243
Gras Savoye Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
48243
In-Soft Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48271
Jawer Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
48244
Joya-Coiffure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48244
KHS Königstraße 27 Beteiligung S.à r.l. . .
48243
Kunst & Dekoration S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
48244
mpool consulting S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48287
Raiba Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48245
Raiba Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48246
Raiba Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48244
RL LUX Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48245
Rock-It Cargo Logistics II S.à r.l. . . . . . . . . .
48246
RW Consult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48245
Ryght Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48245
Sandrina Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
48263
Sansar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48245
Sater S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48246
Savalla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48286
Serham Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48246
Shoe-Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48246
SMSC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48242
Sportv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48244
Stahl und Konstruktion S.A. . . . . . . . . . . . . .
48242
Superfund Asset Management GmbH -
Niederlassung Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
48242
Swissco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48242
48241
L
U X E M B O U R G
Swissco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 160.263.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2014031415/12.
(140034830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Superfund Asset Management GmbH - Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit
étranger.
Adresse de la succursale: L-2155 Luxembourg, 68, Mühlenweg.
R.C.S. Luxembourg B 139.530.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014031413/11.
(140033740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Stahl und Konstruktion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 165.843.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031411/9.
(140034740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
SMSC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.648.
Les comptes annuels au 28 février 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031400/9.
(140034360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Framont Investissements S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 32.256.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2014031089/13.
(140034868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
48242
L
U X E M B O U R G
Giedo van der Garde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 116.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Giedo van der Garde S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2014031098/11.
(140035056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Gras Savoye Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 24.558.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014031115/10.
(140034637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Gras Savoye Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 24.558.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014031116/10.
(140034638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Fontgrande S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 65.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031086/9.
(140034934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
KHS Königstraße 27 Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 164.385.
Berichtigung des Jahresabschlusses vom 31.12.2012 mit Referenz 13_148334 gemäß Beschluss vom 21. Februar 2014
Der berichtigte Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-
terlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Den 25.02.2014.
Compliance Partners S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2014031172/14.
(140034505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
48243
L
U X E M B O U R G
Joya-Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1731 Luxembourg, 12, rue de Hesperange.
R.C.S. Luxembourg B 137.785.
Le Bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031167/9.
(140034794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Jawer Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 118.437.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014031164/10.
(140034363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Kunst & Dekoration S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 61.411.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031176/9.
(140035007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Sportv, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.036.
Dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés initia-
lement le 17 octobre 2013 sous le numéro L130177785 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031409/11.
(140034266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Raiba Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 22.357.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25.02.2014.
<i>Für: RAIBA FINANCE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2014031339/15.
(140034565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
48244
L
U X E M B O U R G
Raiba Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 22.357.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25.02.2014.
<i>Für: RAIBA FINANCE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2014031338/15.
(140034564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
RL LUX Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 163.377.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014031347/10.
(140034310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
RW Consult, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins.
R.C.S. Luxembourg B 68.859.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031355/9.
(140034644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Ryght Europe S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 155.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031356/9.
(140034305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Sansar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 126.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
SANSAR S.A.
Référence de publication: 2014031384/11.
(140034441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
48245
L
U X E M B O U R G
Raiba Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 22.357.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25.02.2014.
<i>Für: RAIBA FINANCE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2014031340/15.
(140034566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Rock-It Cargo Logistics II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 149.772.
Le Bilan du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031333/10.
(140034975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Shoe-Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 52.830.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031392/9.
(140035054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Sater S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 169.849.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 25 février 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014031386/10.
(140034703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Serham Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 61-63, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 119.371.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014031391/10.
(140034967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
48246
L
U X E M B O U R G
CORESTATE ENERGY HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 169.729.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014030991/10.
(140034833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Dima Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 133.081.
VERSCHMELZUNGS PLAN
(§ 5 des österreichischen EU-Verschmelzungsgesetzes (das "EU-VerschG"))
(Luxemburgisches Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften idgF (das "Luxemburgische Gesetz"))
GEMEINSAMER PLAN FÜR EINE GRENZÜBERSCHREITENDE VERSCHMELZUNG
(Artikel 5 der Richtlinie 2005/56/EG)
(der "Gemeinsame Plan für eine Grenzüberschreitende Verschmelzung")
zwischen:
1. Klinger Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht, mit Sitz in Gum-
poldskirchen, Österreich, und der Geschäftsanschrift Am Kanal 8-10, 2352 Gumpoldskirchen, Österreich, eingetragen
im Firmenbuch des Landesgerichts Wiener Neustadt unter FN 408172 d (die "Übernehmende Gesellschaft"); und
2. Dima Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (Société à respon-
sabilité limitée), mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und der Geschäftsanschrift 51, Allée Scheffer, L-2520
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg (R.C.S. Luxembourg) unter
Nummer B. 133 081 (die "Übertragende Gesellschaft", gemeinsam mit der Übernehmenden Gesellschaft, die "Versch-
melzenden Gesellschaften").
<i>Präambel:i>
(i) Alleinige Gesellschafterin sowohl der Übernehmenden Gesellschaft als auch der Übertragenden Gesellschaft ist die
H.K.L. HOLDING STIFTUNG, eine Stiftung nach dem Recht von Liechtenstein, mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, und der
Geschäftsanschrift Äulestraße 74, 9490 Vaduz, eingetragen im Handelsregister des Amtes für Justiz unter
FL-0001.117.390-8 ("H.K.L").
(ii) Das ausgegebene Nennkapital der Übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 12.500. Das ausgegebene Nennkapital
der Übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 70.000. Die Verschmelzung hat daher keinen kapitalherabsetzenden Effekt.
(iii) Die Verschmelzenden Gesellschaften sind nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder Liquidationsverfahrens.
(iv) Die Übernehmende Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
(v) Keine der Verschmelzenden Gesellschaften hat Arbeitnehmer oder einen Betriebsrat.
Die Verschmelzenden Gesellschaften beabsichtigen die Durchführung einer grenzüberschreitenden Verschmelzung im
Sinne der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Versch-
melzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten und gemäß dem österreichischen EU-VerschG und
dem Luxemburgischen Gesetz, bei der
- die Übertragende Gesellschaft ohne Liquidation untergeht; und
- die Übernehmende Gesellschaft das Vermögen der Übertragenden Gesellschaft samt allen Rechten und Pflichten im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.
Es handelt sich bei dieser Verschmelzung um eine Verschmelzung zur Aufnahme.
Die Verschmelzenden Gesellschaften verpflichten sich zur Durchführung aller Rechtshandlungen in Österreich bzw.
Luxemburg und im Ausland, die zusätzlich zu diesem Gemeinsamen Plan für eine Grenzüberschreitende Verschmelzung
zur ordnungsgemäßen Übertragung des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft
zweckmäßig und notwendig sein sollten.
<i>Obligatorischer Inhalt des gemeinsamen Plans für eine grenzüberschreitende Verschmelzungi>
Die Verschmelzenden Gesellschaften stellen diesen Gemeinsamen Plan für eine Grenzüberschreitende Verschmelzung
gemäß § 5 EU-VerschG und den Artikeln 259 (1) und 278 des Luxemburgischen Gesetzes wie folgt auf:
48247
L
U X E M B O U R G
a. Rechtsform, Firma und Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften (§ 5 Abs 2 Z 1 EU-VerschG und Artikel 261 des
Luxemburgischen Gesetzes).
(i) Die Übernehmende Gesellschaft ist die Klinger Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
österreichischem Recht mit Sitz in Gumpoldskirchen, Österreich, und der Geschäftsanschrift Am Kanal 8-10, 2352 Gum-
poldskirchen, Österreich.
(ii) Die Übertragende Gesellschaft ist die Dima Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
luxemburgischem Recht (Société à responsabilité limitée), mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und der
Geschäftsanschrift 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
b. Unterbleiben der Anteilsgewährung (§ 5 Abs 2 Z 2 und 3 EU-VerschG). Da H.K.L. alleinige Gesellschafterin sowohl
der Übernehmenden Gesellschaft als auch der Übertragenden Gesellschaft ist, kann die Übernehmende Gesellschaft
gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 96 Abs 2 österreichisches GmbH-Recht iVm § 224 Abs 2 Z 1 österreichisches
Aktienrecht und Artikel 279 (2) des Luxemburgischen Gesetzes von der Gewährung von Anteilen absehen. Zusätzlich
wird H.K.L. auf die Gewährung von Anteilen verzichten.
Angaben über das Umtauschverhältnis und etwaige bare Zuzahlungen können unterbleiben.
c. Zeitpunkt, von dem an die neuen Anteile einen Anspruch auf Gewinn gewähren (§ 5 Abs 2 Z 5 EU-VerschG). Da
eine Anteilsgewährung unterbleibt, unterbleibt auch die Festlegung eines Zeitpunktes, von dem an die neuen Anteile einen
Anspruch auf Gewinn gewähren.
d. Gesellschaftsvertrag der Übernehmenden Gesellschaft (§ 5 Abs 2 Z 9 EU-VerschG). Der Gesellschaftsvertrag der
Übernehmenden Gesellschaft wird im Zuge der Verschmelzung nicht geändert. Der Gesellschaftsvertrag der Überneh-
menden Gesellschaft wurde durch Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Notariat-
saktform am 20. Dezember 2013 vor Dr. Gerhard Muckenhuber, öffentlicher Notar in Krems an der Donau, Österreich,
errichtet. Der fortlaufende Wortlaut des aktuellen Gesellschaftsvertrags der Übernehmenden Gesellschaft ist als Anlage
A angefügt.
e. Stichtag, von dem an die Handlungen der Übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der Übernehmenden Ge-
sellschaft vorgenommen gelten (§ 5 Abs 2 Z 6 EU-VerschG). Der Verschmelzung liegt der Jahresabschluss der Übertra-
genden Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 als Schlussbilanz zugrunde, der als Anlage B angefügt ist.
Der 31. Dezember 2013 gilt als Verschmelzungsstichtag nach österreichischem Recht und als Buchführungsversch-
melzungsstichtag nach luxemburgischen Recht (der "Verschmelzungsstichtag").
Mit Ablauf des Verschmelzungsstichtags gelten die Handlungen der Übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der
Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.
Mit Ablauf des Verschmelzungstags treffen daher alle Nutzungen und Lasten des übertragenen Vermögens die Über-
nehmende Gesellschaft.
Die Aktiva und Passiva der Übertragenden Gesellschaft werden mit 1. Jänner 2014 im Jahresabschluss der Überneh-
menden Gesellschaft berücksichtigt. Das letzte Geschäftsjahr der Übertragenden Gesellschaft endet daher am 31.
Dezember 2013.
Zivilrechtlich geht das Vermögen der Übertragenden Gesellschaft am Tag der Eintragung der Verschmelzung in das
österreichische Firmenbuch kraft Gesetz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Übernehmende Gesellschaft über.
f. Sonderrechte (§ 5 Abs 2 Z 7 EU-VerschG und Artikel 261 (2) f) des Luxemburgischen Gesetzes). Da es in den
Verschmelzenden Gesellschaften keine Personen gibt, welche besondere Rechte im Sinne von § 5 Abs 2 Z 7 EU-VerschG
und Artikel 261 (2) f) des Luxemburgischen Gesetzes besitzen, werden solchen Personen keine Sonderrechte gewährt
und keine Maßnahmen für solche Personen getroffen.
g. Besondere Vorteile (§ 5 Abs 2 Z 8 EU-VerschG und Artikel 261 (2) g) des Luxemburgischen Gesetzes). Weder den
Geschäftsführern der Verschmelzenden Gesellschaften, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Übernehmenden Gesell-
schaft noch anderen Personen, welche an der Verschmelzung beteiligt sind, wie insbesondere Mitglieder eines Verwal-
tungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans noch dem Abschlussprüfer oder sonstigen Prüfern der Verschmelzenden
Gesellschaften werden im Zusammenhang mit der Verschmelzung besondere Vorteile gewährt.
h. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung (§ 5 Abs 2 Z 4 EU-VerschG und Artikel
261 (3) b) des Luxemburgischen Gesetzes). Da weder die Übertragende Gesellschaft noch die Übernehmende Gesell-
schaft Arbeitnehmer beschäftigen, hat die grenzüberschreitende Verschmelzung keine Auswirkung auf Beschäftigungsve-
rhältnisse. Mangels Arbeitnehmer ist auch eine Zustellung des Verschmelzungsberichts an die Arbeitnehmer weder
erforderlich noch möglich.
i. Verfahren zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer (§ 5 Abs 2 Z 10 EU-VerschG und Artikel 261 (3) c) des Luxem-
burgischen Gesetzes). Da weder die Übernehmende Gesellschaft noch die Übertragende Gesellschaft Arbeitnehmer
beschäftigt, findet das Verfahren zur Regelung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer keine Anwendung.
j. Angaben zur Bewertung des Aktiv-und Passivvermögens, dass auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen wird
(§ 5 Abs 2 Z 11 EU-VerschG und Artikel 261 (3) d) des Luxemburgischen Gesetzes). Die Übernehmende Gesellschaft
48248
L
U X E M B O U R G
wird die Aktiva und Passiva der Übertragenden Gesellschaft in ihrer Bilanz für lokale Rechnungslegungzwecke gemäß §
202 Abs 2 Unternehmensgesetzbuch ("UGB") mit den Buchwerten ansetzen.
k. Stichtag der Jahresabschlüsse der Verschmelzenden Gesellschaften, die zur Festlegung der Bedingungen der Versch-
melzung verwendet werden (§ 5 Abs 2 Z 12 EU-VerschG und Artikel 261 (2) e) des Luxemburgischen Gesetzes). Der
Stichtag der Jahresabschlüsse, die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung verwendet wird, ist:
Übernehmende Gesellschaft:
31. Dezember 2013
Übertragende Gesellschaft:
31. Dezember 2013
I. Barabfindungsangebot für Gesellschafter (§ 5 Abs 4 EU-VerschG)
Da sich alle Anteile der Übertragenden Gesellschaft in der Hand eines einzigen Gesellschafters befinden, muss ein
Barabfindungsangebot für die der grenzüberschreitenden Verschmelzung widersprechenden Gesellschafter nicht gewährt
werden und wird daher nicht gewährt.
<i>Anwendung des Österreichischen Umgründungssteuergesetzesi>
Die Verschmelzung wird abgabenrechtlich als Verschmelzung gemäß Artikel I österreichisches Umgründungssteuer-
recht (das "UmgrStG") durchgeführt. Die Begünstigungen des UmgrStG werden angewendet.
Aus steuerlicher Sicht erfolgt die Bewertung der Aktiva und Passiva der Übertragenden Gesellschaft gemäß § 3 Abs 1
Z 2 UmgrStG mit dem gemeinen Wert.
Die Übertragende Gesellschaft besteht seit dem 8. November 2007 (Tag der Errichtung der Gesellschaft) und somit
seit mehr als zwei Jahren. Daher ist die gegenständliche Verschmelzung gemäß Artikel I (§ 6 Abs 5) UmgrStG und § 6 Abs
1 Z 3 österreichisches Kapitalverkehrsteuergesetz von den Kapitalverkehrsteuern befreit.
Die Verschmelzung wird rückwirkend zum 31, Dezember 2013 durchgeführt. Der 31. Dezember 2013 ist auch der
Verschmelzungsstichtag im Sinne von § 2 Abs 5 UmgrStG.
Die Verschmelzenden Gesellschaften und Betal Netherland Holding B.V. haben den als Anlage C angefügten Umgrün-
dungsplan gemäß § 39 UmgrStG aufgestellt.
<i>Aufschiebende Bedingungi>
Dieser Gemeinsame Plan einer Grenzüberschreitenden Verschmelzung steht unter der aufschiebenden Bedingung der
Genehmigung durch die Generalversammlung der Übernehmenden Gesellschaft.
<i>Verzichtserklärungeni>
H.K.L. als alleinige Gesellschafterin der Übernehmenden Gesellschaft sowie der Übertragenden Gesellschaft wird
- gemäß § 7 Abs 1 EU-VerschG und Artikel 278 des Luxemburgischen Gesetzes auf die Vornahme der Verschmel-
zungsprüfung bei der Übernehmenden Gesellschaft;
- gemäß Artikel 278 des Luxemburgischen Gesetzes auf die Vornahme der Verschmelzungsprüfung bei der Übertra-
genden Gesellschaft;
- auf den Verschmelzungsbericht der Geschäftsführer der Übertragenden Gesellschaft;
- gemäß § 3 Abs 2 EU-VerschG iVm § 232 Abs 2 österreichisches Aktiengesetz auf eine Prüfung der Verschmelzung
durch den Aufsichtsrat der Übernehmenden Gesellschaft;
verzichten.
Sonstige Bestimmungen
a. Positiver Verkehrswert. Die Übertragende Gesellschaft erklärt, dass das Vermögen der Übertragenden Gesellschaft
einen positiven Verkehrswert hat.
b. Liegenschaften. Die Übertragende Gesellschaft verfügt weder über Liegenschaften noch hält sie 100 % der Anteile
an einer Gesellschaft, die österreichische Liegenschaften besitzt. Aufgrund der gegenständlichen Verschmelzung werden
daher keine Erwerbsvorgänge im Sinne des österreichischen Grunderwerbsteuergesetzes verwirklicht werden.
c. Kosten und Abgaben. Alle mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung sowie der Errichtung und Durchführung
dieses Gemeinsamen Plans einer Grenzüberschreitenden Verschmelzung verbundenen Kosten und allenfalls anfallende
Steuern und sonstige Gebühren trägt die Übernehmende Gesellschaft.
d. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Gemeinsamen Plans für eine Grenzüberschreitende Versch-
melzung unwirksam, ungültig oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit, Gültigkeit oder
Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungültigkeit oder Undurch-
setzbarkeit einer Bestimmung gilt zwischen den Parteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst
nahe kommende und nicht unwirksame, ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart. Gleiches gilt für den
Fall allfälliger Vertragslücken.
48249
L
U X E M B O U R G
e. Anlagen. Die Anlagen bilden einen integrierenden Bestandteil des Gemeinsamen Plans einer Grenzüberschreitenden
Verschmelzung.
f. Formvorschriften. Um die österreichischen gesetzlichen Erfordernisse zu erfüllen, muss der Gemeinsame Plan einer
Grenzüberschreitenden Verschmelzung in der Form eines österreichischen Notariatsakts aufgestellt werden.
g. Authentische Sprache. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieses
Gemeinsamen Plans für eine Grenzüberschreitende Verschmelzung soll allein die deutsche Fassung verbindlich sein.
MERGER PLAN
(Section 5 of the Austrian EU Cross-border Merger Act (the "EU-VerschG"))
(Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Luxembourg Law"))
COMMON TERMS OF CROSS-BORDER MERGER
(Article 5 of the Directive 2005/56/EG)
(the "Common Terms of Cross-border Merger")
between:
1. Klinger Holding GmbH, a limited liability company under Austrian law (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
having its official seat in Gumpoldskirchen, Austria, and its office address at Am Kanal 8-10, 2352 Gumpoldskirchen,
Austria, registered with the commercial register of Regional Court Wiener Neustadt under FN 408172 d (the "Acquiring
Company"); and
2. Dima Holdings S.à r.l., a limited liability company under Luxembourg law (Société à responsabilité limitée), having
its official seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and its office address at 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade register in Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) under
number B. 133 081, (the "Company Ceasing to Exist", together with the Acquiring Company, the "Merging Companies").
<i>Preamble:i>
(i) Sole shareholder of the Acquiring Company as well as of the Company Ceasing to Exist is H.K.L. HOLDING
STIFTUNG, a foundation under the laws of Liechtenstein, having its official seat in Vaduz, Liechtenstein, and its office
address at Äulestraße 74, 9490 Vaduz, registered with the trade register of the department of justice under
FL-0001.117.390-8 ("H.K.L.").
(ii) The issued share capital of the Company Ceasing to Exist amounts to EUR 12,500. The issued share capital of the
Acquiring Company amounts to EUR 70,000. Therefore, the merger does not have a capital reducing effect.
(iii) The Merging Companies are not subject to insolvency proceedings or winding-up proceedings.
(iv) The Acquiring Company has a supervisory board.
(v) None of the Merging Companies has employees or a works council.
The Merging Companies contemplate to implement a cross-border merger within the meaning of the Directive
2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border
mergers of limited liability companies and pursuant to the Austrian EU-VerschG and the Luxembourg Law, as a result of
which merger
- the Company Ceasing to Exist will cease to exist without liquidation; and
- the Acquiring Company will acquire the assets of the Company Ceasing to Exist with all rights and obligations under
a universal title of succession.
This merger constitutes a cross-border merger by absorption.
The Merging Companies undertake to perform any legal actions and measures in Austria and Luxembourg respectively
and abroad, which may in addition to this Common Terms of Cross-border Merger be necessary or purposeful for the
proper transfer of the Company Ceasing to Exists assets to the Acquiring Company.
<i>Obligatory content of the common terms of cross-border mergeri>
The Merging Companies draw up this Common Terms of Cross-border Merger pursuant to Section 5 EU-VerschG
and Articles 259 (1) and 278 of the Luxembourg Law as follows:
a. Type of legal entity, name and official seat of the Merging Companies (Section 5 paragraph 2 no. 1 EU-VerschG and
Article 261 of the Luxembourg Law).
(i) The Acquiring Company is Klinger Holding GmbH, a limited liability company under Austrian law (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung), having its official seat in Gumpoldskirchen, Austria, and its office address at Am Kanal 8-10, 2352
Gumpoldskirchen, Austria.
(ii) The Company Ceasing to Exist is Dima Holdings S.à r.l., a limited liability company under Luxembourg law (Société
à responsabilité limitée), having its official seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and its office address at 51,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
48250
L
U X E M B O U R G
b. No granting of shares (Section 5 paragraph 2 no. 2 and no. 3 EU-VerschG). As H.K.L. is the sole shareholder of the
Acquiring Company as well as of the Company Ceasing to Exist, according to Section 3 paragraph 2 EU-VerschG in
connection with Section 96 paragraph 2 Austrian Limited Liability Company Act in connection with Section 224 paragraph
2 no. 1 Austrian Stock Corporation Act and Article 279 (2) of the Luxembourg Law the Acquiring Company can refrain
from granting shares. In addition, H.K.L. shall waive the granting of shares.
Particulars on the exchange ratio or additional cash payments do not have to be determined.
c. Date from which the holding of new shares will entitle the holders to share in profits (Section 5 paragraph 2 no. 5
EU-VerschG). As there will be no granting of new shares, particulars on the date from which the new shares would entitle
the holders to share in profits are not required.
d. Articles of association of the Acquiring Company (Section 5 paragraph 2 no. 9 EU-VerschG). The articles of asso-
ciation of the Acquiring Company shall not be amended in connection with the merger. The articles of association of the
Acquiring Company were drawn up by declaration of the foundation of a limited liability company in notarial deed form
executed on 20 December 2013 before Dr. Gerhard Muckenhuber, public notary in Krems an der Donau, Austria. The
consecutive wording of the current articles of association of the Acquiring Company is attached hereto as Annex A.
e. Date per which the transactions by the Company Ceasing to Exist are deemed to have been entered into on behalf
of the Acquiring Company (Section 5 paragraph 2 no. 6 EU-VerschG). The merger is based on the annual accounts of the
Company Ceasing to Exits as of 31 December 2013 as closing balance sheet, which is attached hereto as Annex B.
The 31 December 2013 constitutes the merger date according to Austrian law and the merger date from an accounting
perspective according to Luxembourg law (the "Merger Date").
With close of the Merger Date the transactions of the Company Ceasing to Exist shall be deemed as taken for the
Acquiring Company.
With close of the Merger Date any benefits and burdens of the transferred assets shall therefore inure to the Acquiring
Company.
The assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring
Company as per 1 January 2014. The last financial year of the Company Ceasing to Exist will therefore end on 31 December
2013.
In terms of civil law, the Company Ceasing to Exists assets are transferred under a universal title of succession by
operation of law to the Acquiring Company upon the registration of the merger in the Austrian commercial register.
f. Special rights (Section 5 paragraph 2 no. 7 EU-VerschG and Article 261 (2) f) of the Luxembourg Law). As there are
no persons in the Merging Companies who have special rights within the meaning of Section 5 paragraph 2 no. 7 EU-
VerschG and Article 261 (2) f) of the Luxembourg Law, no special rights will be granted and no measures are taken for
such persons.
g. Special Benefits (Section 5 paragraph 2 no. 8 EU-VerschG and Article 261 (2) g) of the Luxembourg Law). No special
benefits will be granted to the members of the management boards of the Merging Companies, the members of the
supervisory board of the Acquiring Company or any other person involved in the merger, in particular not to members
of the administrative, management, supervisory or controlling organs or to the auditor of the annual accounts or any
other auditors of the Merging Companies.
h. Likely effects of the merger on employment (Section 5 paragraph 2 no. 4 EU-VerschG and Article 261 (3) b) of the
Luxembourg Law). Since neither the Company Ceasing to Exist nor the Acquiring Company has employees the cross-
border merger has no effect on employment relationships. Due to lack of employees delivery of the merger report is
neither required nor possible.
i. Procedures for employee participation (Section 5 paragraph 2 no. 10 EU-VerschG and Article 261 (3) c) of the
Luxembourg Law). Since neither the Company Ceasing to Exist nor the Acquiring Company has employees the procedure
to regulate employee participation does not apply.
j. Information on the valuation of assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be transferred to the
Acquiring Company (Section 5 paragraph 2 no. 11 EU-VerschG and Article 261 (3) d) of the Luxembourg Law). The
Acquiring Company shall recognize in its balance sheet the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist at book
values carried-over according to Section 202 paragraph 2 Austrian Commercial Code ("UGB") for local GAAP purposes.
k. Date of the annual accounts of the Merging Companies, based on which the conditions of the merger are established
(Section 5 paragraph 2 no. 12 EU-VerschG and Article 261 (2) e) of the Luxembourg Law). The date of the annual accounts
used to establish the conditions of the cross-border merger is:
Acquiring Company:
31 December 2013
Company Ceasing to Exist:
31 December 2013
48251
L
U X E M B O U R G
I. Proposal for the level of compensation of shareholders (Section 5 paragraph 4 EU-VerschG).
As all shares In the Company Ceasing to Exist are in the hand of one shareholder, a proposal for cash compensation
to shareholders voting against the contemplated cross-border merger is not required to be granted and therefore not
granted.
<i>Application of Austrian reorganization tax acti>
The merger is treated for Austrian tax purposes as a merger pursuant to Article I of the Austrian Reorganization Tax
Act (the "UmgrStG"). The benefits of the UmgrStG shall apply.
From a tax law perspective the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist shall be recognize at fair market
values according to Section 3 paragraph 1 no. 2 UmgrStG.
The Company Ceasing to Exist has been existent since 8 November 2007 (Date of incorporation of the company),
thus, for more than two years. Therefore, this merger is exempt from capital transfer taxes pursuant to Article I (Section
6 paragraph 5) UmgrStG and Section 6 paragraph 1 no. 3 of the Austrian Capital Transfer Tax Act.
The merger shall be implemented with retroactive effect as of 31 December 2013. The 31 December 2013 also
constitutes the merger date within the meaning of Section 2 paragraph 5 UmgrStG.
The Merging Companies and Betal Netherland Holding B.V. have drawn up the reorganization plan according to Section
39 UmgrStG attached hereto as Annex C.
Condition precedent
This Common Terms of Cross-border Merger will be subject to the approval of the general assembly of the Acquiring
Company.
Waiver declarations
H.K.L. as sole shareholder of the Acquiring Company and the Company Ceasing to Exist will waive
- according to Section 7 paragraph 1 EU-VerschG and Article 278 of the Luxembourg Law to make a merger audit for
the Acquiring Company;
- according to Article 278 of the Luxembourg Law to make a merger audit for the Company Ceasing to Exist;
- to make a merger report by the managing directors of the Company Ceasing to Exist;
- according to Section 3 paragraph 2 EU-VerschG in connection with Section 232 paragraph 2 Austrian Stock Cor-
poration Act to make an audit of the merger by the supervisory board of the Acquiring Company.
Miscellaneous
a. Positive fair market value. The Company Ceasing to Exist declares that the assets of the Company Ceasing to Exist
have a positive fair market value.
b. Real estate. The Company Ceasing to Exist has neither any real estate nor a 100 % participation in an Austrian
company, which owns Austrian real estate. Therefore, no real estate transfers within the meaning of the Austrian Real
Estate Transfer Tax Act are realized because of this merger.
c. Costs and taxes. Any costs as well as any taxes and other duties incurred with this cross-border merger and the
drawing up and implementation of this Common Terms of Cross-border Merger shall be borne by the Acquiring Company.
d. Severability. If any provision of these Common Terms of Cross-border Merger is or becomes invalid or unenforce-
able, the remaining provisions shall stay valid and enforceable. In such case, the invalid or unenforceable provision shall
be replaced amicably by such valid and enforceable provision which best meets the economic intent of the invalid or
unenforceable provision. The same shall apply in the event of any contractual gap.
e. Annexes. Annexes form an integrated part of this Common Terms of Cross-border Merger.
f. Form requirements. In order to comply with Austrian legal requirements the Common Terms of Cross-border
Merger needs to be drawn up in the form of an Austrian notarial deed.
g. Authentic Language. In case of any discrepancies between the German and the English version of these Common
Terms of Cross-border Merger, the German version will prevail.
Anlage A: Aktueller Gesellschaftsvertrag Übernehmende Gesellschaft
Anlage B: Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 Übertragende Gesellschaft
Anlage C: Umgründungsplan gemäß § 39 UmgrStG
Annex A: Current articles of association Acquiring Company
Annex B: Annual accounts as of 31 December 2013 Company Ceasing to Exist
Annex C: Restructuring Plan according to Section 39 UmgrStG
Gumpoldskirchen, 14. April 2014.
Klinger Holding GmbH
48252
L
U X E M B O U R G
Mag. Peter Müller, geb. / born 06.09.1965 / Dr. Heinz Schart, geb. / born 26.11.1959
<i>Geschäftsführer / Member of the management board / Geschäftsführer / Member of the management board
i>Dima Holdings S.à r.l.
Dr. Thomas Klinger-Lohr, geb. / born 14.05.1948
<i>Geschäftsführer der Klasse A / Manager A
i>Dr. Gerhard MUCKENHUBER
<i>ÖFF. NOTARi>
Anlage A / Annex A
Dr. Gerhard MUCKENHUBER MBL öffentlicher Notar
3500 Krems, Ringstraße 20
Tel. 02732/875 95
Gesellschaftsteuerselbstbemessung
zu Erf. nr.: 10-301.431/2013
am: 23.12.2013
HG2013/137C
Geschäftszahl: 2354 erste Ausfertigung
<i>Notariatsakti>
Vor mir, Doktor Gerhard MUCKENHUBER Master of Business Law, öffentlichem Notar, mit dem Amtssitz in 3500
Krems an der Donau, Ringstraße Nummer 20, sind heute im Hause zu 2352 Gumpoldskirchen, Am Kanal 8-10, wohin
ich mich über Parteienersuchen begeben habe, erschienen die Parteien, und zwar:
die H.K.L. HOLDING STIFTUNG, mit dem Sitz in Vaduz und der Geschäftsanschrift c/o PROKURATIONS-ANSTALT
LI-9490 Vaduz, Äulestraße 74, eingetragen im Handelsregister des Amtes für Justiz, Fürstentum Liechtenstein, Register-
nummer FL-0001-117.390-8,
vertreten durch die, als mit den diesem Notariatsakt beigeschlossenen Vollmachten Beilage./A und./B ausgewiesenen
Vertreter:
a) Herrn Magister Peter MÜLLER, geboren am 06.09.1965 (sechsten September neunzehnhundertfünfundsechzig),
leitender Angestellter, 1120 Wien, Flurschützstraße 28/44, welcher mir, Notar, seine Personsidentität und sein Geburts-
datum nachweist durch seinen österreichischen Reisepass P 3608656, ausgestellt am 09.06.2009 (neunten Juni zweitau-
sendneun) von der Bezirkshauptmannschaft Reutte, und
b) Herrn Doktor Heinz SCHARL, geboren am 26.11.1959 (sechsundzwanzigsten November neunzehnhundertneu-
nundfünfzig), leitender Angestellter, 3385 Gerersdorf, Waggerlgasse 10, welcher mir, Notar, seine Personsidentität und
sein Geburtsdatum nachweist durch seinen österreichischen Reisepass P 6115160, ausgestellt am 20.02.2012 (zwanzigsten
Februar zweitausendzwölf) von der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten,
und haben vor mir zu Akt gegeben nachstehende Erklärung gemäß Paragraf drei Absatz zwei des Gesetzes über Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung (§ 3 Abs.2 GmbHG) über die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.
Erklärung
über die Errichtung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Erstens:
Rechtsform und Firma:
die H.K.L. HOLDING STIFTUNG errichtet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Die Firma der Gesellschaft lautet:
Klinger Holding GmbH
Zweitens:
Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist Gumpoldskirchen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.
Drittens.
Gegenstand des Unternehmens. Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung von Holding-Funktionen, insbeson-
dere der Erwerb und die Verwaltung von An.
<i>Vollmacht zur Gesellschaftsgründungi>
mit welcher die H.K.L. HOLDING STIFTUNG, mit dem Sitz in Vaduz und der Geschäftsanschrift c/o PROKURA-
TIONS-ANSTALT LI-9490 Vaduz Äulestraße 74, eingetragen im Handelsregister des Amtes für Justiz, Fürstentum
Liechtenstein, Registernummer FL-0001-117.390-8
Herrn Dr. Heinz SCHARL, geboren am 26.11.1959, leitender Angestellter, 3385 Gerersdorf, Waggerlgasse 10
48253
L
U X E M B O U R G
und
Herrn Mag. Peter MÜLLER, geboren am 06.09.1965,
leitender Angestellter, 1120 Wien, Flurschützstraße 28/44
jeweils selbständig und daher auch einzeln ermächtigt, namens der H.K.L. HOLDING STIFTUNG und mit Rechts-
wirksamkeit für diese einen Notariatsakt über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, an der diese
als Gesellschafterin beteiligt ist, wie folgt zu errichten:
Firma: Klinger Holding GmbH
Die Machthaber sind ermächtigt, auch jeden anderen, zur Gründung und Registrierung erforderlichen oder der H.K.L.
HOLDING STIFTUNG dienlich erscheinenden Firmawortlaut festzusetzen.
Unternehmensgegenstand:
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung von Holding-Funktionen, insbesondere der Erwerb und die Verwal-
tung von Anteilen und Anteilsrechten jeder Art, darunter Gesellschaftsanteile, Geschäftsanteile, Aktien von jeglichen
Unternehmen, welcher Rechtsform auch immer, einschließlich der Wahrnehmung deren Geschäftsführung und Verwal-
tung. Ausdrücklich ausgenommen hiervon sind Bankgeschäfte nach der Bankwesengesetz.
Stammkapital: der Gesellschaft: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 70.000,-
Für die H.K.L. HOLDING STIFTUNG zu übernehmendes Stammkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 70 000,-
hiervon sofort bar einzuzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 70.000,-
Sitz: Gumpoldskirchen
Die Machthaber sind weiters ermächtigt, Geschäftsführer, auch mit gesondertem Beschlüsse zu bestellen, einen Auf-
sichtsrat einzurichten, alle übrigen Bestimmungen der Errichtungserklärung, insbesondere die Höhe des Stammkapitals,
auch abweichend von den oben angeführten Gründungsmerkmalen für die Vollmachtgeberin zu vereinbaren, Änderungen
der Errichtungserklärung vorzunehmen, welche für die Registrierung der Gesellschaft notwendig sind, Erklärungen ab-
zugeben und entgegenzunehmen, Eingaben und sonstige Urkunden, auch in beglaubigter Form oder als Notariatsakte zu
errichten, Anträge einzubringen, Zustellungen entgegenzunehmen und überhaupt alles zu unternehmen, was zur Errich-
tung und Registrierung der Gesellschaft erforderlich ist.
Die gegenständliche Vollmacht berechtigt die Vollmachtnehmer auch zum Selbstkontrahieren.
Den Bevollmächtigten ist gestattet Stellvertreter zu bestellen.
Gumpoldskirchen, am 02.12.2013.
H.K.L. HOLDING STIFTUNG
Lic.oec.HSG Iwan Josef ACKERMANN
BRZ 2177/2013
Die Echtheit der Firmazeichnung des Herrn Lic. oec. HSG (Lizenziat oeconomicus Hochschule Sankt Gallen) Iwan Josef
ACKERMANN, geboren am 12.08.1967 (zwölften August neunzehnhundertsiebenundsechzig), Unternehmer, 9490 Va-
duz, Liechtenstein, Aeulestraße 74, als Mitglied des Stiftungsrates der H.K.L. HOLDING STIFTUNG mit dem Sitz in Vaduz
und der Geschäftsanschrift 9490 Vaduz, Liechtenstein, c/o PROKURATIONS-ANSTALT Äulestraße 74, eingetragen im
Handelsregister des Amtes für Justiz, Fürstentum Liechtenstein, Registernummer FL-0001-117.390-8, wird bestätigt.
Krems an der Donau, am 17.12.2 013 (siebzehnten Dezember zweitausenddreizehn).
Gebühr € 14,30 entrichtet.
mit welcher die H.K.L. HOLDING STIFTUNG, mit dem Sitz in Vaduz und der Geschäftsanschrift c/o PROKURAT-
TONS-ANSTALT LI-9490 Vaduz Äulestraße 74, eingetragen im Handelsregister des Amtes für Justiz, Fürstentum
Liechtenstein, Registernummer FL-0001-117.390-8
Herrn Dr. Heinz SCHARL, geboren am 26.11.1959, leitender Angestellter, 3335 Gerersdorf, Waggerlgasse 10
und
Herrn Mag. Peter MÜLLER, geboren am 06.09.1965, leitender Angestellter, 1120 Wien, Flurschützstraße 28/44
jeweils selbständig und daher auch einzeln ermächtigt, namens der H.K.L. HOLDING STIFTUNG und mit Rechts-
wirksamkeit für diese einen Notariatsakt über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, an der diese
als Gesellschafterin beteiligt ist, wie folgt zu errichten:
Firma: Klinger Holding GmbH
Die Machthaber sind ermächtigt, auch jeden anderen, zur Gründung und Registrierung erforderlichen oder der H.K.L.
KOLDING STIFTUNG dienlich erscheinenden Firmawortlaut festzusetzen.
Unternehmensgegenstand:
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung von Holding-Funktionen, insbesondere der Erwerb und die Verwal-
tung von Anteilen und Anteilsrechten jeder Art, darunter Gesellschaftsanteile, Geschäftsanteile, Aktien von jeglichen
Unternehmen, welcher Rechtsform auch immer, einschließlich der Wahrnehmung deren Geschäftsführung und Verwal-
tung. Ausdrücklich ausgenommen hiervon sind Bankgeschäfte nach den Bankwesengesetz.
48254
L
U X E M B O U R G
Stammkapital: der Gesellschaft: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 70.000,-
Für die H.K.L. HOLDING STIFTUNG zu übernehmendes Stammkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 70 000,-
hiervon sofort bar einzuzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 70.000,-
Sitz: Gumpoldskirchen
Die Machthaber sind weiters ermächtigt, Geschäftsführer, auch mit gesondertem Beschlüsse zu bestellen, einen Auf-
sichtsrat einzurichten, alle übrigen Bestimmungen der Errichtungserklärung, insbesondere die Höhe des Stammkapitals,
auch abweichend von den oben angeführten Gründungsmerkmalen für die Vollmachtgeberin zu vereinbaren, Änderungen
der Errichtungserklärung vorzunehmen, welche für die Registrierung der Gesellschaft notwendig sind, Erklärungen ab-
zugeben und entgegenzunehmen, Eingaben und sonstige Urkunden, auch in beglaubigter Form oder als Notariatsakte zu
errichten, Anträge einzubringen, Zustellungen entgegenzunehmen und überhaupt alles zu unternehmen, was zur Errich-
tung und Registrierung der Gesellschaft erforderlich ist.
Die gegenständliche Vollmacht berechtigt die Vollmachtnehmer auch zum Selbstkontrahieren.
Den Bevollmächtigten ist gestattet Stellvertreter zu bestellen.
Gumpoldskirchen, am 02.12.2013.
H.K.L. HOLDING STIFTUNG
Dr. Heinz-Jürgen STEBEL
BRZ 2178/2013
Die Echtheit der Firmazeichnung des Herrn Doktor Heinz-Jürgen STEBEL, geboren am 06.07.1937 (sechsten Juli
neunzehnhundertsiebenunddreißig), Pensionist, CH-6315 Oberägeri, Schweiz, Hauptstraße 47, als Mitglied des Stiftungs-
rates der H.K.L. HOLDING STIFTUNG mit dem Sitz in Vaduz und der Geschäftsanschrift 94 90 Vaduz, Liechtenstein, c/
o PROKURATIONS-ANSTALT Äulestraße 74, eingetragen im Handelsregister des Amtes für Justiz, Fürstentum Liech-
tenstein, Registernummer FL-0001-117.390-8, wird bestätigt
Krems an der Donau, am 17.12.2013 (siebzehnten Dezember zweitausenddreizehn).
Gebühr € 14,30 entrichtet.
Dr. Gerhard MUCKENHUBER
<i>ÖFF. NOTARi>
teilen und Anteilsrechten jeder Art, darunter Gesellschaftsanteile, Geschäftsanteile, Aktien von jeglichen Unterneh-
men, insbesonders der KLINGER Gruppe, welcher Rechtsform auch immer, einschließlich der Wahrnehmung deren
Geschäftsführung und Verwaltung, Ausdrücklich ausgenommen hiervon sind Bankgeschäfte nach dem Bankwesengesetz.
Viertens. Stammkapital.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 70.000,- (Euro siebzigtausend)
Hievon übernimmt die H.K.L. HOLDING STIFTUNG eine Stammeinlage von . . . € 70.000,- (Euro siebzigtausend)
und leistet darauf eine bare Einzahlung von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 70.000,- (Euro siebzigtausend).
Fünftens. Dauer. Die Erklärung über die Gründung der Gesellschaft wird mit Wirksamkeit vom heutigen Tage abge-
geben.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch und endet am darauffolgenden
einunddreißigsten (31.) Dezember. Die weiteren Geschäftsjahre fallen mit den Kalenderjahren zusammen. Bilanzstichtag
für den Jahresabschluss ist der einunddreißigste (31.) Dezember.
Sechstens. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen (1), zwei (2) oder mehrere Geschäftsführer. Mindestens ein
Geschäftsführer muss seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.
Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen selbständig, wenn zwei oder mehrere
Geschäftsführer bestellt sind, durch je zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch je einen Geschäftsführer in Gemein-
schaft mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Auch wenn zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt sind, kann einem
oder mehreren von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis eingeräumt werden.
Die Vertretung durch zwei Gesamtprokuristen ist mit der Einschränkung der Paragrafen neunundvierzig folgende (§§
49 ff) des Unternehmensgesetzbuches zulässig.
Die Firma der Gesellschaft wird derart gezeichnet, dass der Zeichnende dem Firmawortlaut seine Unterschrift beisetzt.
Prokuristen zeichnen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz.
Siebentens. Generalversammlung. Die Generalversammlung wird von einem Geschäftsführer durch eingeschriebene
Briefe an sämtliche Gesellschafter unter den dem Firmenbuch zuletzt bekanntgegebenen Anschriften einberufen.
Zwischen dem Tage der Aufgabe der Einberufung zur Post und dem Tage der Versammlung muss ein Zeitraum von
mindestens sieben (7) Tagen liegen.
Die Generalversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort in Inland statt, an dem ein öffentlicher
Notar seinen Sitz hat.
48255
L
U X E M B O U R G
Eine außerordentliche Generalversammlung muss außer den im Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung
genannten Fällen ohne Verzug dann einberufen werden, wenn Gesellschafter, deren Stammeinlagen mindestens den
zehnten Teil des Stammkapitals betragen, es schriftlich unter Angabe des Zweckes verlangen.
Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht zwingend etwas anderes bestimmen, durch
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Je Euro einhundert (€ 100) einer übernommenen Stammeinlage
gewähren eine Stimme, doch muss jedem Gesellschafter mindestens eine Stimme zustehen.
Die schriftliche Beschlussfassung gemäß Paragraf § 34 (vierunddreißig) des Gesetzes über Gesellschaften mit bes-
chränkter Haftung ist zulässig.
Die Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinnes ist der Generalversammlung vorbehalten. Die General-
versammlung entscheidet jährlich über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Die Gesellschafter können durch einfachen
Mehrheitsbeschluss neben der Ausschüttung des Bilanzgewinnes die Bildung von Rücklagen in angemessenem Ausmaß
ebenso wie (auch die gesamte) Thesaurierung des Gewinns (Gewinnvortrag) beschließen. Grundsätzlich ist der Bilanz-
gewinn im Verhältnis der übernommenen Stammeinlagen an die Gesellschafter auszuschütten. Durch einstimmigen
Beschluss sämtlicher Gesellschafter kann auch eine vom Verhältnis der Stammeinlage abweichende Gewinnausschüttung
an die Gesellschafter vorgenommen werden. Ein solcher Beschluss gilt immer nur für das beschlussgegenständliche Ge-
schäftsjahr, es können von den Gesellschaftern daraus keine Ansprüche für Folgegeschäftsjahre abgeleitet werden. Sofern
die Generalversammlung nichts anderes beschließt, sind zur Ausschüttung gelangende Gewinnanteile vierzehn Tage nach
Beschlussfassung über die Gewinnverteilung zur Zahlung an die Gesellschafter fällig. Die Gesellschafter können durch
einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer erlassen, in der Art und Ausmaß der zulässiger-
weise zu bildenden Rücklagen näher geregelt werden.
Achtens. Geschäftsanteile. Die Geschäftsanteile sind teilbar und übertragbar.
Die Abtretung von Geschäftsanteilen oder Teilen derselben an Personen, die der Gesellschaft noch nicht als Gesell-
schafter angehören, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Gesellschafter.
Neuntens. Aufsichtsrat. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat (Gesellschafterausschuss), der aus mindestens drei und
höchstens fünf von den Gesellschaftern zu wählenden Mitgliedern besteht.
Die Aufsichtsratmitglieder werden, falls die Generalversammlung nicht eine andere Funktionsdauer beschließt, für die
Zeit bis zur Beendigung jener Generalsversammlung gewählt, welche über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
der Wahl beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet.
Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder können wieder gewählt werden.
Der Aufsichtsrat wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Die Wahl gilt für die ganze Funk-
tionsperiode des Gewählten.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann seine Funktion unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auch ohne wichtigen
Grund durch schriftliche, an dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu richtende Erklärung niederlegen.
Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor dem Ablauf ihrer Funktionsperiode aus, so bedarf es der Einberufung einer Ge-
neralversammlung, in welcher eine Ersatzwahl erfolgt. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Funktionsperiode des
ausgeschiedenen Mitgliedes.
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder schriftlich eingeladen und wenigstens drei (3) Mitglieder, da-
runter der Vorsitzende anwesend sind.
Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates erfolgen in Sitzungen, zu denen der Vorsitzende die Mitglieder
der unter zuletzt bekanntgegebenen Anschrift einberuft; § 30i Absatz (2) GmbH-Gesetz (Paragraf dreißig i Absatz zwei
des Gesetzes über Gesellschaft mit beschränkter Haftung) bleibt unberührt. Der Vorsitzende leitet die Sitzung und bes-
timmt die Art der Abstimmung.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist,
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Leiters der Sitzung.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der
Sitzung zu unterzeichnen ist.
Jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen
Sitzung betrauen; das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Sitzung nicht
mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen kann nicht übertragen werden.
An den Sitzungen des Aufsichtsrates dürfen Personen, die weder dem Aufsichtsrat noch der Geschäftsführung ange-
hören, nicht teilnehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände
zugezogen werden. Den Sitzungen, die sich mit der Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlags für die Gewinnverteilung
und des Lageberichtes beschäftigen, ist jedenfalls der Abschlussprüfer zuzuziehen.
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates können neben dem Ersatz ihrer baren Auslagen Taggelder und eine jährliche Ver-
gütung gewährt werden. Die Festsetzung der Sitzungsgelder und einer etwaigen jährlichen Remuneration der Aufsichts-
ratsmitglieder hat die ordentliche Generalversammlung jeweils für jedes Geschäftsjahr zu beschließen.
Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates abgegeben.
48256
L
U X E M B O U R G
In dringenden Fällen kann der Aufsichtsrat (Gesellschafterausschuss) auch ohne Abhaltung einer Sitzung schriftlich,
fernschriftlich oder fernmündlich abstimmen, wenn kein Mitglied dagegen Widerspruch erhebt. Eine fernmündliche Abs-
timmung ist unverzüglich schriftlich zu bestätigen.
Für Aufsichtsrat und Geschäftsführung sind Geschäftsordnungen zu erlassen.
Folgende Geschäfte der Gesellschaft können - auch soweit sie Tochter- und Beteiligungsgesellschaften betreffen - nur
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen werden:
a) der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen und Unternehmen sowie die Stilllegung von Unternehmen und
Betrieben;
b) der Erwerb und die Veräußerung von Betrieben;
c) die Belastung von Betrieben;
d) die Errichtung und die Schließung von Zweigniederlassungen;
e) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften und Superädifikaten mit einem Kauf- oder Tauschwert von
über EUR 500.000,- (Euro fünfhunderttausend);
f) andere Investitionen, die im einzelnen einen Betrag von EUR 1,000.000,- (Euro eine Million) in einem Geschäftsjahr
einen Betrag von EUR 5,000.000,- (Euro fünf Millionen), maximal jedoch ein Drittel des Cash-flow des Vorjahres übers-
teigen; dies gilt auch für Miet- und Leasingverträge, wenn der Barwert der Zahlungsverpflichtungen für einen Zeitraum
bis zur frühesten Kündigungsmöglichkeit durch die Gesellschaft diese Grenzen übersteigt.
Soweit jedoch für das laufende Jahr ein wesentlich niedrigerer Cashflow zu erwarten ist, dürfen diese Investitionen ein
Drittel des zu erwartenden Cash-flow nicht übersteigen;
g) die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die im einzelnen einen Betrag von EUR 1,000.000,- (Euro eine
Million) und in einem Geschäftsjahr einen Betrag von EUR 5,000.000,- (Euro fünf Millionen), maximal jedoch ein Drittel
des Cash-flow des Vorjahres übersteigen.
h) die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören und den
Betrag von EUR 100.000,- (Euro hunderttausend) im Einzelfall übersteigen;
i) die Aufnahme und Aufgabe von Geschäftszweigen und Produktionsarten;
j) die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik und die Genehmigung des jährlichen Budgets;
k) die Festlegung von Grundsätzen über die Gewährung von Gewinn- und Umsatzbeteiligungen sowie Pensionszusagen
an Geschäftsführer und leitende Angestellte.
Die Vertragsparteien vereinbaren die Wertsicherung der unter litera e), f), g) und h) genannten Beträge nach dem von
der Bundesanstalt Statistik Österreich ermittelten und verlautbarten Index der Verbraucherpreise Basis 2010 = 100 durch
Vergleich des Indexstandes für den Monat Dezember 2013 mit dem Monat der dem zu treffenden Beschlussfassung
vorangehenden, zuletzt endgültig bekanntgegebenen Index. Sollte dieser Index nicht mehr verlautbart werden, ist im
Anschluss an die letzte Verlautbarung der jeweils an dessen Stelle tretende Index beziehungsweise Nachfolgeindex an-
zuwenden.
Schwankungen der Indexzahlen bis zu zehn Prozent (10 %) auf oder ab von der Vergleichsbasis werden nicht, darüber
hinaus jedoch im vollen Umfange berücksichtigt. Dies derart, dass jeweils die erste außerhalb dieser Schwankungsbreite
gelegene Indexzahl die Grundlage für die Berechnung der Veränderung und für die neue Schwankungsbreite bildet.
Unter "Cash-flow" in litera f) und g) ist der ausgewiesene Jahresgewinn zuzüglich Abschreibung, Buchwert der Anla-
genabgänge sowie die Veränderung gesetzlicher und freier Rücklagen und von Rücklagen aufgrund steuerlicher Begüns-
tigungsbestimmung zu verstehen.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung und den Geschäftsbericht zu prüfen
und der Generalversammlung darüber zu berichten.
Im übrigen gelten für den Aufsichtsrat die Bestimmungen der Paragraphen 2 9 bis 33 (neunundzwanzig bis
dreiunddreißig) des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, die Ausübung seiner Obliegenheiten durch eine Geschäftsordnung zu regeln, die mit
einfacher Stimmenmehrheit zu beschließen und für alle seine Mitglieder bindend ist.
Zehntens. Bekanntmachung. Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Gesellschafter werden durch eingeschriebene
Briefe an die dem Firmenbuch zuletzt bekanntgegebenen Anschriften vorgenommen.
Elftens. Rechtslage. Soweit durch diese Erklärung in der jeweils gültigen Fassung nichts anderes bestimmt ist, gelten
für die Gesellschaft die Vorschriften des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Zwölftens. Gründungskosten. Die mit der Errichtung und Registrierung der Gesellschaft verbundenen Kosten und
Abgaben werden bis zu einem Höchstbetrag von € 7.000,00 (Euro siebentausend) von der Gesellschaft getragen.
Die Gründungskosten sind mit der Höhe der tatsächlich aufgewendeten Beträge als Ausgaben in die erste Jahresrech-
nung einzustellen.
Ausfertigungen dieses Notariatsaktes können der Vertragspartei und der Klinger Holding GmbH auch über wiede-
rholtes Verlangen und in beliebiger Anzahl erteilt werden.
48257
L
U X E M B O U R G
Dreizehntens. Vollmacht. Die Vertragsparteien erteilen hiermit Doktor Bernhard DISTLBACHER Master of Business
Law, geboren am 22.01.1983 (zweiundzwanzigsten Jänner neunzehnhundertdreiundachtzig), Notariatskandidat, 3 500
Krems an der Donau, Ringstraße 20, die unwiderrufliche Vollmacht, unter Zugrundelegung dieses Notariatsaktes die zur
Anmeldung der gegenständlichen Gründung notwendigen Schritte zu unternehmen, allfällige vom Firmenbuch oder sons-
tigen Behörden verlangte und zweckmäßige Änderungen dieses Notariatsaktes vorzunehmen, entsprechende Urkunden,
auch in Notariatsakt form, zu errichten und zu unterfertigen sowie ergänzende Eingaben an das Firmenbuchgericht zu
verfassen und zu unterfertigen. Diese Vollmacht erlischt mit der Eintragung der gegenständlichen Gründung im Firmen-
buch.
Urkund dessen wurde dieser Notariatsakt aufgenommen, der Vertragspartei vorgelesen, von ihr als ihren Willen gemäß
erklärt und sodann von ihr vor mir, Notar, eigenhändig unterschrieben.
Gumpoldskirchen, am 20.12.2013 (zwanzigsten Dezember zweitausenddreizehn).
H.K.L. HOLDING STIFTUNG
Peter Müller e.h.
(Mag. Peter MÜLLER, geb. 06.09.1965)
Dr. Heinz Scharl e.h.
(Dr. Heinz SCHARL, geb. 26.11.1959)
(Amtssiegel) Dr. Muckenhuber e.h. ÖFF. NOTAR
Diese für die Klinger Holding GmbH bestimmte erste Ausfertigung stimmt mit der in den Akten des öffentlichen Notars
Doktor Gerhard MUCKENHUBER Master of Business Law unter der Geschäftszahl 2354 erliegenden und aus sechs
Bogen bestehenden Urschrift vollkommen überein.
Mag. Brgitte Starkl
als Substitutin des öffentlichen Notars
Dr. Gerhard Muckenhuber
3500 Krems, Ringstraße 20
Anlage B / Annex B
<i>Audited annual accounts as at December 31, 2013i>
<i>Balance sheet as at December 31, 2013i>
<i>(Expressed in Euro)i>
Notes
2013
EUR
2012
EUR
ASSETS
Fixed assets
Financial assets
Shares in affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1,3 260,000,000 260,000,000
Current assets
Debtors
becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2
6,590
3,265
Cash at bank and in hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,201,414
47,854
Total Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274,208,004 260,051,119
LIABILITIES
Capital and reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
12,500
12,500
Reserve
legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1,250
1,250
Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70,018,154
49,992,571
Result for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,357,050
20,025,583
80,388,954
70,031,904
Provisions
Provisions for taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.3
6,750
3,715
Non subordinated debts
Trade creditors
becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,300
15,500
Amounts owed to affiliated undertakings
becoming due and payable after less than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3,800,000
-
48258
L
U X E M B O U R G
becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
190,000,000 190,000,000
193,800,000 190,000,000
Total Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274,208,004 260,051,119
<i>Profit and loss account for the year ended December 31, 2013i>
<i>(Expressed in Euro)i>
Notes
2013
EUR
2012
EUR
CHARGES
Other external charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,15
19,101
Value adjustments
on formation expenses and on tangible and intangible assets . . . . . . . . . . . . . . . .
-
2,850
Interest payable and similar charges
concerning affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,800,000
4,200,000
other interest payable and similar charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452
761
3,800,452
4,200,761
Other taxes not included in the previous caption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3,340
1,705
Profit for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,357,050 20,025,583
Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,200,000 24,250,000
INCOME
Income from financial fixed assets
derived from affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
14,200,000 24,250,000
Total Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,200,000 24,250,000
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
Notes to the annual accounts as at December 31, 2013
Note 1. General information. Dima Holdings S.à r.l., ("the Company") formerly Dima Holdings Curaçao B.V., is a
Luxembourg holding company since August 17, 2007 as a "Société à responsabilité limitée" and subject to the general
company law.
The registered office of the Company is established in 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg since October 1, 2010
(16, rue Jean-Pierre Brasseur until September 30, 2010).
The Company's financial year starts on January 1st and ends on December 31 of each year.
The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever and the management of such interests. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by
any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or the
obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other
company or person.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Based on the criteria defined by Luxembourg law, the Company is exempted from the obligation to draw up consoli-
dated accounts and a consolidated management report for the year ended December 31, 2013. Therefore, in accordance
with the legal provisions, these annual accounts were presented on a non-consolidated basis for the approval of the
shareholders during the Annual General Meeting.
Note 2. Summary of significant accounting policies.
2.1 Basis of preparation
48259
L
U X E M B O U R G
The annual accounts have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements. Ac-
counting policies and valuation rules are, besides the ones laid down by the law of December 10, 2010, determined and
applied by the Board of Managers.
2.2 Comparative information
To improve the presentation of annual accounts and apply the changes under the new accounting standard, certain
reclassifications have been made at December 31, 2011. In accordance with Article 29 of the Act of December 19, 2002,
and to ensure comparability of accounts from one period to another, these reclassifications have been made on the
comparative figures for the year 2011.
2.3 Significant accounting policies
The main valuation rules applied by the Company are the following:
2.3.1 Financial assets
Shares in affiliated undertakings are valued at their purchase price including the expenses incidental thereto.
In case of durable depreciation in value according to the opinion of the Board of Managers, value adjustments are made
in respect of fixed assets, so that they are valued at the lower figure to be attributed to them at the balance sheet date.
These value adjustments are not continued if the reason for which the value adjustments were made has ceased to apply.
2.3.2 Debtors
The other debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery
is compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
2.3.3 Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts, the nature of which is clearly defined and which, at the date of the
balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or the date on
which they will arise.
Note 3. Shares in affiliated undertakings. Undertakings in which the Company holds at least 20% in their share capital
are as follows:
Undertaking's name
(legal form)
Registered
office
Ownership
%
Last
balance
sheet date
Net book
value
Net equity
at the balance
sheet date of
the company
concerned
Profit or
loss of the
financial
year
EUR
EUR
EUR
Betal Netherland Holding
B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nikkelstraat
2-4, 3067 GR
Rotterdam The
Netherlands
100%
30/11/2013 260,000,000
327,791,000
53,044,000
* figures from Unaudited Annual Report as at November 30, 2013.
In the opinion of the management of the Company, there is no impairment and, accordingly no value adjustment has
been recorded as at November 30, 2013.
Note 4. Capital and reserves. The movements of the year are as follows:
Subscribed
capital
Legal
reserve
Profit or
(loss) brought
forward
Profit or
(loss) for the
financial year
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Capital and reserves - opening balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
1,250
49,992,571
20,025,583
Additions for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,357,050
Allocation for the year* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,025,583
-20,025,583
Capital and reserves - closing balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
1,250
70,018,154
10,357,050
* in accordance with the resolution taken by the sole partner on July 22, 2013.
Note 5. Subscribed capital. The subscribed capital amounts to EUR 12,500 and is divided into 12,500 corporate units
fully paid up with a nominal value per unit of EUR 1 each.
The company has not bought any of its shares.
Note 6. Legal reserve. Luxembourg companies are required to allocate to a legal reserve a minimum of 5% of the
annual net income, until this reserve equals 10% of the subscribed share capital. This reserve may not be distributed.
Note 7. Non subordinated debts. Amounts due and payable for the accounts shown under "Non subordinated debts"
are as follows:
48260
L
U X E M B O U R G
After less
than one
year
After more
than one
year
(EUR)
(EUR)
Amounts owed to affiliated undertakings
HKL Hldg Stiftung loan 2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190,000,000
Interest HKL Hldg Stiftung loan 2% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,800,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,800,000 190,000,000
On January 14, 2014 the loan has been partially reimbursed for an amount of EUR 10,000,000. The interest has been
reimbursed at the same date. The maturity of the loan is December 2022.
Note 8. Taxes. The Company is subject to all taxes applicable to a normal commercial company in Luxembourg.
Note 9. Income. Betal Netherland Holding B.V. declared a dividend of EUR 14,200,000 received by the Company on
December 13, 2013 for EUR 13,900,000 and on December 24, 2013 for EUR 300,000.
Note 10. Gross profit or loss. Gross profit or loss account is composed by other external charges amounting to EUR
39,158.
Note 11. Advances and loans granted to the members of the administrative, managerial and supervisory bodies. As at
December 31, 2013, the Company has not granted any loans to current members of its managerial or administrative
bodies, or engaged itself in any advance on behalf of such persons.
Dr. Thomas KLINGER-LOHR.
Anlage C / Annex C
UMGRÜNDUNGSPLAN
gemäß § 39 UmgrStG zum Umgründungsstichtag 31.12.2013
abgeschlossen
zwischen
Klinger Holding GmbH (auch „KH")
(FN 408172 d)
mit dem Sitz in der politischen Gemeinde Gumpoldskirchen
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
und
Dima Holdings Sàrl („Dima")
(registriert im Luxemburgischen Handelsregister unter No B 133.081)
mit dem Sitz in Luxembourg
51, Allee Scheffer
2520 Luxembourg
und
Betal Netherland Holding BV („Betal")
(registriert im Niederländischen Handelsregister unter No 24129902)
mit dem Sitz in Rotterdam
Nikkelstraat 2-4
3067 Rotterdam
I. Präambel
Im Zuge einer umfassenden Umstrukturierung der Klinger-Gruppe sind die Parteien dieses Umgründungsplans übe-
reingekommen, mehrere Umgründungen, die dasselbe Vermögen betreffen und die auf denselben Stichtag 31.12.2013
bezogen werden, vorzunehmen.
Die geplanten Umgründungen verfolgen das Ziel, die Konzernstruktur der Klinger-Gruppe zu vereinfachen.
Der Ausgangssachverhalt stellt sich auf dem Konzernorganigramm wie folgt dar:
<ATTFORMULE>
HKL
100% / 100%
KH (AUT) / Dima (NL)
100%
48261
L
U X E M B O U R G
Betal (NL)
Zur Erreichung der oben genannten Zielsetzung beschließen die Parteien den gegenständlichen Umgründungsplan
gemäß § 39 UmgrStG wie folgt:
II. Beschreibung der Umgründungen
Die Parteien dieses Umgründungsplans legen folgende Umgründungen fest:
1. In einem ersten Schritt ist geplant, die Dima im Wege einer grenzüberschreitenden side-stream-Verschmelzung als
übertragende Gesellschaft zum Verschmelzungsstichtag 31.12.2013 auf die Klinger Holding GmbH als übernehmende
Gesellschaft zu verschmelzen.
Die übertragende Gesellschaft, Dima, wird im Wege einer Verschmelzung durch Aufnahme gemäß der Richtlinie
2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalge-
sellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten und gemäß dem Österreichischen EU-VerschG sowie dem luxemburgi-
schen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften idgF mit allen Rechten und Pflichten im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft, Klinger Holding GmbH, verschmolzen. Da die HKL (Liech-
tensteinische Stiftung) vor der Verschmelzung Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft, Dima, und der
übernehmenden Gesellschaft, Klinger Holding GmbH ist, kann die Gewährung von (zusätzlichen) Anteilen (im Wege einer
Kapitalerhöhung) an der Klinger Holding GmbH unterbleiben. Die Verschmelzung der Dima auf die Klinger Holding GmbH
hat keinen kapitalherabsetzenden Effekt.
Aus steuerlicher Sicht erfolgt die Verschmelzung unter Anwendung von Art I UmgrStG. Das Vermögen der übertra-
genden Gesellschaft, Dima, ist gemäß § 3 Abs 1 Z 2 TS 1 UmgrStG mit dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt des
Verschmelzungsstichtags (steuerneutraler step-up) anzusetzen. Zur Ermittlung des gemeinen Wertes wird ein Bewer-
tungsgutachten zum Stichtag 31.12.2013 erstellt.
Die Verschmelzung erfolgt unter Zugrundelegung der Schlussbilanz der Dima zum 31.12.2013. Zum Vermögen der
Dima gehört insbesondere der 100%-Anteil an der Betal.
2. In einem weiteren Schritt wird die Betal im Wege einer grenzüberschreitenden upstream-Verschmelzung als über-
tragende Gesellschaft zum Verschmelzungsstichtag 31.12.2013 auf ihre - nach der oben unter Schritt 1 beschriebenen
Verschmelzung - 100%-Muttergesellschaft, Klinger Holding GmbH verschmolzen.
Die übertragende Gesellschaft, Betal, wird im Wege einer Verschmelzung durch Aufnahme gemäß der Richtlinie
2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalge-
sellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten und gemäß dem österreichischen EU-VerschG sowie dem niederländischen
Bürgerlichen Gesetzbuch mit allen Rechten und Pflichten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende
Gesellschaft, Klinger Holding GmbH, verschmolzen. Da die übernehmende Gesellschaft, Klinger Holding GmbH, nach
Durchführung der Verschmelzung in Schritt 1 Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft, Betal, ist, dürfen der
übernehmenden Gesellschaft gemäß § 224 Abs 1 Z 1 AktG im Zuge der Verschmelzung keine neuen Aktien gewährt
werden. Die Verschmelzung ist daher zwingend ohne Kapitalerhöhung bei der Klinger Holding GmbH durchzuführen.
Die Verschmelzung der Betal auf die Klinger Holding GmbH hat keinen kapitalherabsetzenden Effekt.
Aus steuerlicher Sicht erfolgt die Verschmelzung unter Anwendung von Art I UmgrStG. Das übertragende Vermögen
ist gemäß § 3 Abs 1 Z 2 TS 1 UmgrStG mit dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt des Verschmelzungsstichtags (steuer-
neutraler step-up) anzusetzen. Zur Ermittlung des gemeinen Wertes wird ein Bewertungsgutachten zum Stichtag
31.12.2013 erstellt.
Die Verschmelzung erfolgt unter Zugrundelegung der Schlussbilanz der Betal zum 31.12.2013. Zum Vermögen der
Betal gehören zahlreiche Beteiligungen (siehe Anlage 1).
Danach ergibt sich somit folgendes Konzernorganigramm:
<ATTFORMULE>
HKL
100%
KH (AUT)
III. Reihenfolge der Umgründungen
Für diese Umgründungen wird folgende Reihenfolge festgelegt:
1. grenzüberschreitende Verschmelzung der Dima als übertragende Gesellschaft auf die Klinger Holding GmbH als
übernehmende Gesellschaft zum Verschmelzungsstichtag 31.12.2013;
2. grenzüberschreitende Verschmelzung der Betal als übertragende Gesellschaft auf die Klinger Holding GmbH als
übernehmende Gesellschaft zum Verschmelzungsstichtag 31.12.2013.
IV. Stichtag der Umgründungen
Stichtag für die in den Punkten II. und III. beschriebenen Verschmelzungen ist jeweils der 31.12.2013 (Verschmel-
zungsstichtag).
V. Betroffenes Vermögen
48262
L
U X E M B O U R G
Von den in den Punkten II. und III. beschriebenen Verschmelzungen ist das Vermögen der Dima (va 100%-Beteiligung an der Betal) und das
Vermögen der Betal (Beteiligungen, siehe Anlage 1) betroffen, weil diese Beteiligungen im Zuge der geplanten Umgründungsschritte auf die Klinger
Holding GmbH übertragen werden.
VI. Wirkung der Vermögensübertragungen
Die Parteien dieses Umgründungsplans legen hiermit im Sinne des § 39 UmgrStG fest, dass die beiden Vermögensü-
bertragungen (Schritte 1 und 2), die zur Gänze oder zum Teil dasselbe Vermögen betreffen mit Ablauf desselben Stichtags,
dh den 31.12.2013, als bewirkt gelten. Somit gilt für ertragssteuerliche Zwecke auch die unter Pkt III 2. dargestellte
Verschmelzung der Betal auf die Klinger Holding GmbH als mit dem Beginn des auf den ersten Umgründungsstichtag
(31.12.2013) folgenden Tag (01.01.2014) als bewirkt.
Gumpoldskirchen, am 14. April 2014.
Klinger Holding GmbH
Mag. Peter MÜLLER / Dr. Heinz SCHARL
Dima Sàrl
Dr. Thomas KLINGER-LOHR
Betal BV
Dr. Thomas KLINGER-LOHR
Référence de publication: 2014053680/882.
(140061619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2014.
Sandrina Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 184.481.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
1) Mr. Badreddine OUALI, residing at 5, rue Astarte, Carthage Hannibal 2016, Tunisia;
2) Mr. Christian CURE, residing at 8, rue Marcel Renault, 75017 Paris, France;
3) Mr. Marwan HANIFEH, residing at 49, boulevard Saint Michel 75005 Paris France; and
4) GRANITE & ARDOISE, a private limited liability company organized and existing under the laws of France, having
its registered office at 62, rue Monseigneur Tréhiou, 56000 Vannes, France, and registered with the Register of Commerce
of Vannes under number 449 939 339.
All are here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, with professional address in 12, rue Jean Engling,
L-1466 Luxembourg, by virtue of four proxies given under private seal,
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The appearing parties, represented as said before, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that Mr. Badreddine OUALI, Mr. Christian CURE, Mr. Marwan HANIFEH and the company GRANITE & ARDOISE
(the Partners), hold all the shares of Sandrina Holdings N.V., a company organized and existing under the laws of Curacao,
having its registered office at Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2
nd
Floor, P.O. Box 3889, Curacao, and registered with
the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry at Curacao under number 60245 (the Company).
II. that by resolution validly adopted by the Partners of the Company in Curacao, on December 24, 2013, acting in
accordance with the articles of association of the Company, the Company resolved to transfer its statutory seat and
principal establishment from Curacao to the city of Luxembourg as from the date hereof without the Company being
dissolved but on the contrary with corporate continuance. All formalities required under the laws of Curacao, to give
effect to that resolution have been duly performed; a copy of said resolution shall remain annexed to the present deed;
III. That it results from the balance sheet of the Company as at November 30, 2013 that the net assets of the Company
as of the date hereof correspond at least to the value of the share capital of the Company, a copy of the balance sheet
of the Company as of the 30
th
of November 2013, having been signed ne varietur by the proxyholder on behalf of the
Partners and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office and central administration of the Company from Curacao to Luxembourg, with
immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;
48263
L
U X E M B O U R G
2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with the name “Sandrina Holdings S.à r.l.” and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the
registered office and central administration of the Company to Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
3. Amendment and complete restatement of the Company's articles of incorporation so as to conform them to the
laws of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the
Luxembourg company act, with the Company having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into one thousand two hundred fifty (1,250) shares, with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each;
4. Acknowledgement of the resignation of INTERTRUST (Curaçao) B.V. in its function of statutory director of the
Company, effective as of the date hereof, and full discharge to the resigning director for the performance of its duty as
sole director of the Company from the date of its appointment until the date of its resignation;
5. Appointment of (i) Mr. Gérard MATHEIS, company director, born on December 4
th
, 1962 in Luxembourg, (ii) Mr.
Sinan SAR, company director, born on June 5
th
, 1980 in Luxembourg, both having their professional address at 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as managers B of the Company for an indefinite period; and (iii) Mr. Mr. Badreddine
OUALI, company director, born on May 20
th
1963 in Tunis, Tunesia residing at 5, rue Astarte, Carthage Hannibal 2016,
Tunisia; and (iv) Mr. Marwan HANIFEH, company director, born on June 17
th
1961 in Al Tal, Syria residing at 49, Boulevard
Saint Michel 75005 Paris France as managers A of the Company for an indefinite period;
6. Establishment of the registered office and central administration of the Company at 5, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
7. Miscellaneous.
Thereupon, the appearing parties requested the undersigned notary to record that:
<i>First resolutioni>
The Partners resolve to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Com-
pany from Curacao to Luxembourg as from the date hereof, without the Company being dissolved but on the contrary
with corporate continuance.
<i>Second resolutioni>
The Partners resolve that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) with the name “Sandrina Holdings S.à r.l.”, accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the
present deed be subject to the laws of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Partners resolve to amend and restate the articles of association of the Company so as to conform them to
Luxembourg law.
The restated articles of association of the Company will read as follows:
“ Art. 1. There is formed by those present partners and all persons and entities who may become partners in future,
a Company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an
entity as well as by present articles.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.4. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect
investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
48264
L
U X E M B O U R G
Art. 4. The Company will have the name “Sandrina Holdings S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at EUR 12.500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into one thousand two hundred
fifty (1'250) share quotas of EUR 10 (ten Euro) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of
these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Unless otherwise specified, the shares are freely transferable among partners.
They can be transferred inter vivos or mortis causa to non-partners only with the unanimous agreement of all partners.
In case of transfer to a non-partner, the remaining shareholders have a preemption right. Unless otherwise stipulated,
they must exercise such preemption right within 30 days from the date of notification of the intention to sell the shares.
Upon exercise of the right of first refusal, the redemption value of units is calculated in accordance with paragraphs 6
and 7 of Article 189 of the Law on commercial companies.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a
board of managers composed of one or more A managers and one or more B managers. The manager, or in case of
plurality, the managers do not need to be members of the Company. The manager, or in case of plurality, the managers
are appointed by the general meeting of members which determines their powers, compensation and duration of their
mandates. The general meeting of members can revoke one or more managers.
Art. 13. The board of managers will choose a chairman among the A managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting. Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-
four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature
of such circumstances shall be set forth in the minutes of that meeting. The notice of meeting may be waived by the
consent in writing or by telefax or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. Any manager
may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by e-mail another manager as
his proxy.
Votes may also be cast in writing or by telefax or by e-mail. Any manager may participate in any managers' meeting by
video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing
all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means
is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be
deemed to be held at the registered office in Luxembourg.
Circular resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at
the managers' meetings.
The board of managers may only deliberate if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting
of the board of managers.
Except for the decisions of day to day management (as defined in the following paragraph), the board of managers can
only take a decision if a majority of A and B managers present or represented vote in favor of such decision.
Decisions relating to the day to day management which do not exceed the aggregate amount of five-thousand Euro
can be taken by the B managers alone.
Art. 14. The Company shall be bound by (i) the joint signature of a A manager together with a B manager or (ii) the
signature of the sole manager or (iii) the unique or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has
been delegated to by the board of managers.
Art. 15. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, except for actions performed and/
48265
L
U X E M B O U R G
or transactions concluded by the manager and/or the board of managers outside the scope of authorization given to the
manager and/or the board of managers by the Articles of the Company.
Art. 16. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Collective decisions are only validly taken in so far as they are jointly adopted by all the partners of the Company,
representing the Company's total share capital. Resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company
may only be carried by all the partners jointly, owning the Company's total share capital.
Art. 17. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December.
Art. 18. Each year, with reference to 31
st
of December, the Company's accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.”
<i>Fourth resolutioni>
The Partners state that the one thousand two hundred fifty (1'250) share quotas are henceforth held as follows:
1) Mr. Badreddine OUALI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,147 share quotas
2) Mr. Christian CURE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 share quotas
3) Mr. Marwan HANIFEH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 share quotas
4) GRANITE & ARDOISE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 share quotas
<i>Fifth resolutioni>
The Partners resolve (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of INTERTRUST (Curaçao)
B.V. and to grant it full discharge for the performance of its duty, as statutory director of the Company and (ii) to appoint
as managers of the Company for an indefinite period:
(i) Mr. Gérard MATHEIS, company director, born on December 4
th
, 1962 in Luxembourg, with professional address
in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg as Manager B; and
(ii) Mr. Sinan SAR, company director, born on June 5, 1980 in Luxembourg, with professional address in 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg as Manager B; and
(iii) Mr. Mr. Badreddine OUALI, company director, born on May 20
th
1963 in Tunis, Tunesia residing at 5, Rue Astarte,
Carthage Hannibal 2016, Tunisia; as Manager A and
(iv) Mr. Marwan HANIFEH, company director, born on June 17
th
1961 in Al Tal, Syria residing 49, Boulevard Saint
Michel 75005 Paris France, as Manager A
<i>Sixth resolutioni>
The Partners resolve to establish the registered office and the principal establishment of the Company at 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
48266
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year will begin now and will end on December 31, 2013.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand four
hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-septième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Badreddine OUALI, demeurant au 5, rue Astarte, Carthage Hannibal 2016, Tunisie;
2) Monsieur Christian CURE, demeurant au 8, rue Marcel Renault, 75017 Paris, France,
3) Monsieur Marwan HANIFEH, demeurant au 49, boulevard Saint Michel 75005 Paris France; et
4) GRANITE & ARDOISE, une société à responsabilité limitée régie par le droit français et ayant son siège social au
62, rue Monseigneur Tréhiou, 56000 Vannes, France, et immatriculée au Registre de Commerce de Vannes sous le numéro
449 939 339.
Tous sont ici représentés Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à 12, rue
Jean Engling, L - 1466 Luxembourg, en vertu de quatre procurations délivrées sous seing privé,
lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme énoncé précédemment, ont requis le notaire instrumentant d'enregis-
trer ce qui suit:
I. que Monsieur Badreddine OUALI, Monsieur Christian CURE, Monsieur Marwan HANIFEH et la société GRANITE
& ARDOISE, (les Associés), détiennent toutes les parts sociales de la société Sandrina Holdings N.V., ayant son siège
social à Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2
nd
Floor, P.O. Box 3889, Curaçao, et immatriculée auprès du Registre du
Commerce de Chambre de Commerce et Industrie de Curaçao sous le numéro 60245 (la Société).
II. Que par résolution des Associés de la Société valablement adoptée le 24 décembre 2013 à Curaçao, agissant
conformément aux statuts de la Société, la Société a décidé de transférer son siège social et son principal établissement
de Curaçao à Luxembourg-Ville à compter de la date des présentes sans dissolution de la Société mais avec continuation
de sa personnalité juridique. Toutes les formalités requises par le droit de Curaçao, afin de réaliser cette décision ont
d'ores et déjà été accomplies; une copie de ladite résolution restera annexée au présent acte.
III. Qu'il ressort du bilan de la Société daté du 30 novembre 2013 que les actifs nets de la Société à la date des présentes
correspondent au moins à la valeur du capital social, une copie du bilan de la Société daté du 30 novembre 2013, ayant
été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des Associés et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social, du principal établissement et du lieu de gestion effective de la Société de Curaçao à
Luxembourg-Ville à compter de la date des présentes sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa per-
sonnalité juridique;
2. Adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale “San-
drina Holdings S.à r.l.” et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert de son siège social et du
principal établissement de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Modification et refonte des statuts de la Société afin de les rendre conformes au droit luxembourgeois, en consé-
quence de l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise, avec la Société ayant un capital social de douze
mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de
dix Euro (EUR 10,-) chacune;
48267
L
U X E M B O U R G
4. Acceptation de la démission de INTERTRUST (Curaçao) B.V., en sa qualité de directeur de la Société avec effet à
ladite date, et pleine décharge au directeur démissionnaire pour l'exercice de ses fonctions de directeur à partir de sa
nomination jusqu'à sa démission;
5. Nomination de (i) Monsieur Gérard MATHEIS, administrateur, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, (ii) Monsieur
Sinan SAR, administrateur, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, ayant leur adresse professionnelle au 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, comme gérants A de la société pour une durée indéterminée; (iii) Monsieur Badreddine
OUALI, administrateur, né le 20 Mai 1963 à Tunis, demeurant au 5, rue Astarte, Carthage Hannibal 2016, Tunisie et (iv)
Monsieur Marwan HANIFEH, administrateur, né le 17 Juin 1961 à Al Tal, Tunisie demeurant au 49, boulevard Saint Michel
75005 Paris France, comme gérants B de la société pour une durée indéterminée;
6. Etablissement du siège social, du principal établissement et du lieu de gestion effective de la Société au 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
7. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante a requis le notaire instrumentant d'enregistrer que:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social, le principal établissement et lieu de gestion effective de la Société
de Curaçao à Luxembourg à compter de la date des présentes, sans dissolution de la Société mais avec continuation de
sa personnalité juridique.
<i>Seconde résolutioni>
Les Associés décident que la Société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination “San-
drina Holdings S.à r.l.”, accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à compter de la date des présentes, soumise aux
lois du Grand-Duché du Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier et de reformuler les statuts de la Société pour les rendre conformes au droit
luxembourgeois.
Les statuts reformulés de la Société auront la teneur suivante:
“ Art. 1
er
. Il est formé par les associés actuels et toutes les personnes et entités qui pourront devenir associés à
l'avenir, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à ce type d'entité ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2.
2.1. La Société a pour objet l'acquisition de participations, d'intérêts et de parts au Luxembourg ou à l'étranger sous
quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société peut notamment acquérir
par voie de souscription, d'achat, d'échange ou de toute autre manière tous titres, parts sociales et autres titres de
participation, obligations, titres obligataires, certificats de dépôt et autres instruments de dette et, d'une manière plus
générale, tous titres et instruments financiers émis par des entités publiques ou privées quelles qu'elles soient.
2.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes sauf par voie d'offre publique. Elle peut émettre, par voie de
placement privé uniquement, des billets, obligations et titres obligataires et tout type de titres de créance et/ou de titres
de participation. La Société peut prêter des fonds, en ce compris ceux provenant de n'importe quels emprunts et/ou
émissions de titres de créance à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également accorder des
garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales,
sociétés affiliées et de toute autre société. La Société pourra de plus gager, transférer ou grever tout ou partie de ses
actifs ou créer d'autres types de garanties y relatives.
2.3. D'une manière générale, la Société pourra employer toutes techniques et tous instruments liés à ses investisse-
ments dans le but de leur gestion efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à protéger la Société
contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations des taux d'intérêt et d'autres risques.
2.4. La Société pourra effectuer toutes opérations commerciales et/ou financières concernant des investissements
directs ou indirects dans des biens meubles et immeubles, en ce compris sans limitation l'acquisition, la propriété, la
location, la mise en location, le crédit-bail, la prise en location, la division, l'assainissement, le défrichement, le dévelop-
pement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou l'aliénation d'une autre manière, la mise en hypothèque, le
nantissement ou le grèvement d'une autre manière de biens meubles ou meubles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société sera dénommée “Sandrina Holdings S. à r.l.”.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés de la Société statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des Statuts.
48268
L
U X E M B O U R G
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante)
parts sociales d'une valeur de EUR 10,- (dix Euro) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par décision de l'assemblée des associés, conformément à l'article
14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Vis-à-vis de la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, puisqu'un seul propriétaire est admis par
part sociale. Les copropriétaires sont tenus de nommer une seule personne pour les représenter vis-à-vis de la Société.
Art. 10. Sauf stipulations contraires, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date de notification de l'intention de céder les parts sociales, sauf en cas de stipulations contraires. En
cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des
alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, l'insolvabilité ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîneront
pas la dissolution de la Société.
Art. 12. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérants de classe A et d'un ou plusieurs gérants de classe B.
Le gérant n'a, ou, en cas de pluralité des gérants, les gérants n'ont pas besoin d'être associé. Le gérant est désigné, ou,
en cas de pluralité des gérants, les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs,
leur rémunération et la durée de leurs mandats. L'assemblée générale des associés peut révoquer un ou plusieurs gérants.
Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres gérants A un président. Le conseil se réunira sur
convocation du président ou d'un gérant au lieu indiqué sur la convocation à l'assemblée. Une convocation écrite ou
verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt quatre heures avant
l'heure fixée pour la réunion excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être
mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par
télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles
tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre
gérant par écrit ou par télécopie ou par e-mail.
Les votes peuvent aussi recueillis par écrit, téléfax ou e-mail. Tous gérant peut participer aux assemblées par vidéo-
conférence vidéo ou par d'autres moyens semblables de communication permettant l'identification de ce gérant et
permettant toutes les personnes participant à l'assemblée d'entendre et parler les uns aux autres. La participation à une
assemblée par ces moyens est équivalente à une participation en personne à une telle assemblée. On considérera une
assemblée tenue par ces moyens de communication comme étant tenue au siège social au Luxembourg.
Les résolutions-circulaires écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions
votées lors des assemblées du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer que si au moins la majorité de ses membres y est présente ou représentée.
Sauf les décisions de gestion journalière (comme définie dans le prochain paragraphe), le conseil de gérance peut
uniquement prendre une décision à la majorité des gérants A et B présents ou représentés.
Les décisions relatives à la gestion journalière qui n'excèdent pas le montant global de cinq mille Euros peuvent être
prises par les gérants B seuls.
Art. 14. La Société sera liée par (i) la signature conjointe d'un gérant classe A et de celle d'un gérant de classe B ou
(ii) la signature du gérant unique ou (iii) la signature seule ou conjointe de n'importe quelle(s) personne(s) à qui un tel
pouvoir de signature a été délégué.
Art. 15. Le ou les gérants (selon le cas) ne contracte(nt) du fait de sa/leur fonction aucune obligation personnelle en
rapport avec n'importe quel engagement valablement contracté par lui/eux au nom de la Société, à l'exception des actes
accomplis et/ou des opérations conclues par le gérant et/ou le conseil de gérance qui dépassent les limites des pouvoirs
conférés au gérant et/ou au conseil de gérance par les Statuts de la Société.
48269
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé à un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient. Chaque associé peut nommer un
mandataire pour le représenter aux assemblées.
Les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles soient collectivement adoptées par tous
les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société. Les résolutions portant sur une modi-
fication des statuts et notamment celles qui prévoient la mise en liquidation de la Société doivent être votées
collectivement par tous les associés, possédant l'intégralité du capital social de la Société.
Art. 17. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire susmentionné et du bilan.
Art. 19. Les profits bruts de la Société constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la constitution d'un fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social
nominal de la Société.
Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé/aux associés au prorata de sa/leur participation dans la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer à tout moment
des dividendes intérimaires sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des montants à affecter
à la réserve, en conformité avec la loi ou les présents Statuts.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs qui,
associés ou non, seront nommés par les associés, qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement réglé par les présents Statuts, il est fait référence à la loi.”
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés constatent que les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sont dorénavant détenues comme
suit:
1) Monsieur Badreddine OUALI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.147 parts sociales
2) Monsieur Christian CURE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 parts sociales
3) Monsieur Marwan HANIFEH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 parts sociales
4) GRANITE & ARDOISE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 parts sociales
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident (i) de constater la démission, effective à la date des présentes, de INTERTRUST (Curaçao) B.V.
en sa qualité de directeur de la Société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat en
tant que directeur de la Société et (ii) de nommer comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(i) Monsieur Gérard MATHEIS, administrateur, née le 4 décembre 1962 à Luxembourg, résidant professionnellement
au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en tant que gérant A de la société pour une durée indéterminée; et
(ii) Monsieur Sinan SAR, administrateur, né le 5 juin 1980 à Luxembourg, résidant professionnellement au 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg en tant que gérant A de la société pour une durée indéterminée; et
(iii) Monsieur Badreddine OUALI, administrateur, né le 20 Mai 1963 à Tunis, demeurant au 5, Rue Astarte, Carthage
Hannibal 2016 Tunisie en tant que gérant B de la société pour une durée indéterminée; et
(iv) Monsieur Marwan HANIFEH, administrateur, né le 17 Juin 1961 à Al Tal, Syrie, demeurant au 49, Boulevard Saint
Michel 75005 Paris France en tant que gérant B de la société pour une durée indéterminée.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident d'établir le siège social, le principal établissement et lieu de gestion effective de la Société au 5,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
48270
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille quatre cent
cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2013. LAC/2013/60475. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 14 février 2014.
Référence de publication: 2014024244/430.
(140029337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.
In-Soft Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 59.747.
L'an deux mille treize, le vingtième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Sven PEDERSEN, gérant, né le 29 novembre 1978 à Luxembourg, demeurant à L-8328 Capellen, 41, rue
du Kiem;
2. Monsieur Paul HUBERTY, expert-comptable, né le 19 janvier 1960 à Luxembourg, demeurant à L-3936 Monder-
cange, 4, Op Feileschterkeppchen;
3. Madame Marie-Elisabeth STEINBACH, comptable, née le 29 janvier 1959 à Luxembourg, demeurant à L-8395 Sept-
fontaines, 22, Arelerstrooss;
4. Monsieur Jean-Marie WILHELM, comptable, né le 21 mai 1963 à Luxembourg, demeurant à L-7248 Bereldange, 42,
rue Michel Rodange;
5. La société Fiduciaire Luxembourgeoise S.à r.l. ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen,
immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg numéro B 73.920;
ici représentée par sont gérant Monsieur Paul HUBERTY, expert-comptable, demeurant à L-3936 Mondercange, 4,
Op Feileschterkeppchen.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée "IN-SOFT Sàrl», avec siège
social à L-8440 Steinfort, 3, rue de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 59.747, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 18 juin 1997, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 529 du 26
septembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, alors
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 850 du 23 novembre 1998 (ci-après la "Société").
II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites.
<i>Cessions de parts socialesi>
III.- Il résulte d'une première cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes
et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2013, que Monsieur Paul LALOY, demeurant à
B-6700 Arlon, 12, Chemin du Peiffeschoff, a cédé et transporté, avec effet au 20 décembre 2013, ses dix (10) parts sociales,
qu'il détenait dans la Société «IN-SOFT Sàrl», à Monsieur Sven PEDERSEN, pré-qualifié, cet acceptant, au prix de cession
convenu entre parties qui est payable conformément aux délais et modalités de paiement arrêtées entre parties.
48271
L
U X E M B O U R G
Il résulte d'une seconde cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et
hors la présence du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2013, que Monsieur Paul LALOY, préqualifié, a cédé
et transporté, avec effet au 20 décembre 2013, ses dix (10) parts sociales, qu'il détenait dans la Société «IN-SOFT Sàrl»,
à Monsieur Paul HUBERTY, pré-qualifié, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties qui est payable confor-
mément aux délais et modalités de paiement arrêtées entre parties.
Il résulte d'une troisième cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et
hors la présence du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2013, que Monsieur Paul LALOY, préqualifié, a cédé
et transporté, avec effet au 20 décembre 2013, ses dix (10) parts sociales, qu'il détenait dans la Société «IN-SOFT Sàrl»,
à Madame Marie-Elisabeth STEINBACH, pré-qualifiée, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties qui est
payable conformément aux délais et modalités de paiement arrêtées entre parties.
Il résulte d'une quatrième cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes
et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2013, que Monsieur Paul LALOY, préqualifié, a
cédé et transporté, avec effet au 20 décembre 2013, ses dix (10) parts sociales, qu'il détenait dans la Société «IN-SOFT
Sàrl», à Monsieur Jean-Marie WILHELM, pré-qualifié, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties qui est
payable conformément aux délais et modalités de paiement arrêtées entre parties.
Il résulte d'une cinquième cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes
et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2013, que Monsieur Paul LALOY, préqualifié, a
cédé et transporté, avec effet au 20 décembre 2013, ses soixante (60) parts sociales, qu'il détenait dans la Société «IN-
SOFT Sàrl», à la société Fiduciaire Luxembourgeoise S.à r.l., pré-qualifiée, cet acceptant, au prix de cession convenu entre
parties qui est payable conformément aux délais et modalités de paiement arrêtées entre parties.
Les cessionnaires reconnaissent une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que
les cessions interviennent sans garantie d'actif et de passif.
Le prix des cessions convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable,
économique, financière et juridique de la Société et renoncent à toute garantie de la part des cédants.
Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales leur cédées à
partir de ce jour.
IV.- En raison des prédites cessions de parts sociales, les parts sociales de la société à responsabilité limitée IN-SOFT
Sàrl appartiennent dorénavant aux associés comme suit:
- Monsieur Sven PEDERSEN, pré-qualifié:
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
- Monsieur Paul HUBERTY, pré-qualifié:
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
- Madame Marie-Elisabeth STEINBACH, pré-qualifiée:
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
- Monsieur Jean-Marie WILHELM, pré-qualifié:
dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
- La société Fiduciaire Luxembourgeoise S.à r.l. pré-qualifiée:
soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
<i>Assemblée générale extraordinairei>
V. Les associés, prénommés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont reconnu être pleinement informés des résolutions
à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de L-8440 Steinfort, 3, rue de Luxembourg à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen et
modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société
2. Suppression de toute référence à la souscription des parts sociales par les associés au niveau de l'article 6 des statuts
de la Société et modification subséquente de l'article 6 des statuts;
3. Précision du pouvoir de signature du ou des gérants au niveau des statuts de la Société et ajout de trois nouveaux
alinéas à la suite du premier alinéa à l'article 12 des statuts de la Société;
4. Acceptation de la démission de Monsieur Paul LALOY en sa qualité de gérant technique et administratif de la Société;
5. Nomination de Monsieur Sven PEDERSEN en tant que gérant technique et de Monsieur Paul HUBERTY en tant que
gérant administratif;
6. Divers.
Après en avoir délibéré, les comparants ont pris les résolutions suivantes:
48272
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-8440 Steinfort, 3, rue de Luxembourg à L-1220
Luxembourg, 246, rue de Beggen et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.».
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de supprimer toute référence à la souscription des parts sociales au niveau de l'article 6 des
statuts de la Société et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et libérées ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.».
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de préciser le pouvoir de signature du ou des gérants au niveau des statuts de la Société en
ajoutant trois nouveaux alinéas à la suite du premier alinéa à l'article 12 des statuts de la Société.
L'article 12 des statuts de la Société aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation
de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.
La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe du
gérant technique et du gérant administratif.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés prennent connaissance et acceptent la démission de Monsieur Paul LALOY, prénommé, de son mandat
de gérant administratif et technique de la Société avec effet immédiat.
Les associés décident de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de modifier et de régler la gérance de la Société dorénavant comme suit:
a) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
b) Est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Sven PEDERSEN, gérant, né le 29 novembre 1978 à Luxembourg, demeurant à L-8328 Capellen, 41, rue
du Kiem;
c) Est nommé gérant administratif de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Paul HUBERTY, expert-comptable, né le 19 janvier 1960 à Luxembourg, demeurant à L-3936 Mondercange,
4, Op Feileschterkeppchen.
d) La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du
gérant administratif.
e) Pour des raisons d'opposabilité à la Société et aux tiers, Monsieur Sven PEDERSEN et Monsieur Paul HUBERTY,
prénommés, en leur nouvelle qualité de gérant administratif et gérant technique de la Société «IN-SOFT Sàrl», déclarent
accepter les prédites cessions de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du
Code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à mille deux cent euros (EUR 1.200,-).
48273
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. PEDERSEN, P. HUBERTY, M.-E. STEINBACH, J.-M. WILHELM, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2013. Relation: DIE/2013/15797. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 14 février 2014.
Référence de publication: 2014024729/155.
(140029461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 311.307.646,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.467.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth day of November,
before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 26, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 168.467 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of
Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on April 20, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1603 on June 26, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have
been amended for the last time on October 25, 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, in the process of
publication with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
THERE APPEARED:
1. The Energy & Minerals Group Fund II, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State
of the State of Delaware under file number 4788643;
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State
of the State of Delaware under file number 4985797;
3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, registered with the Secretary of State of the
State of Delaware under file number 4942931;
4. Jaap Meijer, born September 24,1965 in Laren, the Netherlands, with address at 6, Op der Dresch, Bridel, L-8127,
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under file number 4767471;
6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under file number 4914794;
7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4527938;
8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under file number 5084600;
9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under file number 4474856;
10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 United States of America, registered
with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 4636706;
48274
L
U X E M B O U R G
11. John T. Raymond, born on August 15,1970 in Norwalk, Connecticut, United States of America, with address at
3006 Locke Lane, Houston, Texas 77019, United States of America;
12. John G. Calvert, born on November 17,1964 in Chinchilla, Australia, with address at 6107 Desco Drive, Dallas,
Texas 75225, United States of America;
13. Stuart F. Feiner, born on August 19, 1948 in New York City, New York, United States of America, with address
at 160 Riverside Boulevard, Apartment 4S, New York, New York 10069, United States of America;
14. Jeff Ball, born on November 15,1974 in Clifton Springs, New York, United States of America, with address at 3317
Rice Boulevard, Houston, Texas 77005, United States of America;
15. MCP Baffin Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.186 and having a share
capital of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-);
16. The Richmond Fund, Ltd, a limited partnership organized under the laws of the State of Virginia, having its registered
office at 6802 Paragon Place, Suite 205, Richmond, Virginia 23230, United States of America, registered with the Secretary
of State of the State of Virginia under file number L019709-7;
17. Elk Mountain, Ltd, a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its registered office
at 100 Waugh Drive, Suite 400, Houston, Texas 77007, United States of America, registered with the Secretary of State
of the State of Texas under file number 00133974-10;
18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Texas, having its
registered office at 2001 Kirby Drive, Suite 1313, Houston, Texas 77019, United States of America, registered with the
Secretary of State of the State of Texas under file number 801524496;
19. LRMRFOF LLC, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered office
at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary of State
of the State of Delaware under file number 4763024;
20. EMG Baffin CI, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, having its registered
office at 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary
of State of the State of Delaware under file number 5136696; and
21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 132.723;
all here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/
Alzette, by virtue of twenty-one (21) powers of attorney given under private seal.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. that they are the current shareholders of the Company (the Shareholders);
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
<i>Agendai>
1 Waiver of the convening notices;
2 Increase of the share capital of the Company by an amount of thirty-three million six hundred nine thousand one
hundred and eight United States Dollars (USD 33,609,108) in order to bring the share capital of the Company from its
present amount of two hundred seventy-seven million six hundred ninety-eight thousand five hundred thirty-eight United
States Dollars (USD 277,698,538), to three hundred eleven million three hundred seven thousand six hundred forty-six
United States Dollars (USD 311,307,646) by way of the issuance of six million seven hundred twenty-one thousand eight
hundred twenty-two (6,721,822) Class A Shares, six million seven hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-
two (6,721,822) Class B Shares, six million seven hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-two (6,721,822)
Class C Shares, six million seven hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-one (6,721,821) Class D Shares
and six million seven hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-one (6,721,821) Class E Shares, with a par
value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form;
3 Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a contribution in cash;
4 Amendment to article 2.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase
specified in item 2. above; and
5 Miscellaneous.
III. Then the Shareholders, after deliberation, unanimously have taken the following resolutions:
48275
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to waive
the convening notices, as they consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-three million six
hundred nine thousand one hundred and eight United States Dollars (USD 33,609,108) in order to bring the share capital
of the Company from its present amount of two hundred seventy-seven million six hundred ninety-eight thousand five
hundred thirty-eight United States Dollars (USD 277,698,538), to three hundred eleven million three hundred seven
thousand six hundred forty-six United States Dollars (USD 311,307,646) by way of the issuance of six million seven
hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-two (6,721,822) Class A Shares, six million seven hundred twenty-
one thousand eight hundred twenty-two (6,721,822) Class B Shares, six million seven hundred twenty-one thousand eight
hundred twenty-two (6,721,822) Class C Shares, six million seven hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-
one (6,721,821) Class D Shares and six million seven hundred twenty-one thousand eight hundred twenty-one (6,721,821)
Class E Shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, in registered form.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to approve and accept the following subscriptions and payments for the newly issued
shares as set out below:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
1. The Energy & Minerals Group Fund II, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
for:
(i) Three million four hundred forty-eight thousand two hundred twenty-one (3,448,221) Class A Shares;
(ii) Three million four hundred forty-eight thousand two hundred twenty-one (3,448,221) Class B Shares;
(iii) Three million four hundred forty-eight thousand two hundred twenty-one (3,448,221) Class C Shares;
(iv) Three million four hundred forty-eight thousand two hundred twenty-one (3,448,221) Class D Shares; and
(v) Three million four hundred forty-eight thousand two hundred twenty-two (3,448,222) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of seventeen million two hundred forty-one thousand one hundred six United States Dollars (USD 17,241,106), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
for:
(i) Six hundred twenty-three thousand one hundred fifty-nine (623,159) Class A Shares;
(ii) Six hundred twenty-three thousand one hundred fifty-nine (623,159) Class B Shares;
(iii) Six hundred twenty-three thousand one hundred sixty (623,160) Class C Shares;
(iv) Six hundred twenty-three thousand one hundred fifty-nine (623,159) Class D Shares; and
(v) Six hundred twenty-three thousand one hundred fifty-nine (623,159) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of three million one hundred fifteen thousand seven hundred ninety-six United States Dollars (USD 3,115,796), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Six hundred five thousand nine hundred sixty (605,960) Class A Shares;
(ii) Six hundred five thousand nine hundred sixty-one (605,961) Class B Shares;
(iii) Six hundred five thousand nine hundred sixty (605,960) Class C Shares;
(iv) Six hundred five thousand nine hundred sixty (605,960) Class D Shares; and
(v) Six hundred five thousand nine hundred sixty (605,960) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of three million twenty-nine thousand eight hundred one United States Dollars (USD 3,029,801), which shall be allocated
to the nominal share capital account of the Company.
4. Jaap Meijer, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Eight thousand five hundred seven (8,507) Class A Shares;
(ii) Eight thousand five hundred seven (8,507) Class B Shares;
(iii) Eight thousand five hundred seven (8,507) Class C Shares;
(iv) Eight thousand five hundred six (8,506) Class D Shares; and
(v) Eight thousand five hundred six (8,506) Class E Shares,
48276
L
U X E M B O U R G
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of forty-two thousand five hundred thirty-three United States Dollars (USD 42,533), which shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company.
5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Thirteen thousand six hundred seventy-three (13,673) Class A Shares;
(ii) Thirteen thousand six hundred seventy-four (13,674) Class B Shares;
(iii) Thirteen thousand six hundred seventy-four (13,674) Class C Shares;
(iv) Thirteen thousand six hundred seventy-three (13,673) Class D Shares; and
(v) Thirteen thousand six hundred seventy-three (13,673) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of sixty-eight thousand three hundred sixty-seven United States Dollars (USD 68,367), which shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company.
6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Ten thousand nine hundred eighty-five (10,985) Class A Shares;
(ii) Ten thousand nine hundred eighty-five (10,985) Class B Shares;
(iii) Ten thousand nine hundred eighty-five (10,985) Class C Shares;
(iv) Ten thousand nine hundred eighty-six (10,986) Class D Shares; and
(v) Ten thousand nine hundred eighty-five (10,985) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of fifty-four thousand nine hundred twenty-six United States Dollars (USD 54,926), which shall be allocated to the nominal
share capital account of the Company.
7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
for:
(i) Two hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-one (222,871) Class A Shares;
(ii) Two hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-one (222,871) Class B Shares;
(iii) Two hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-one (222,871) Class C Shares;
(iv) Two hundred twenty-two thousand eight hundred seventy (222,870) Class D Shares; and
(v) Two hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-one (222,871) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of one million one hundred fourteen thousand three hundred fifty-four United States Dollars (USD 1,114,354), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Forty thousand eight hundred thirty-one (40,831) Class A Shares;
(ii) Forty thousand eight hundred thirty-one (40,831) Class B Shares;
(iii) Forty thousand eight hundred thirty-one (40,831) Class C Shares;
(iv) Forty thousand eight hundred thirty-one (40,831) Class D Shares; and
(v) Forty thousand eight hundred thirty-two (40,832) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of two hundred four thousand one hundred fifty-six United States Dollars (USD 204,156), which shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company.
9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Twenty-seven thousand eight hundred thirty (27,830) Class A Shares;
(ii) Twenty-seven thousand eight hundred thirty (27,830) Class B Shares;
(iii) Twenty-seven thousand eight hundred twenty-nine (27,829) Class C Shares;
(iv) Twenty-seven thousand eight hundred twenty-nine (27,829) Class D Shares; and
(v) Twenty-seven thousand eight hundred twenty-nine (27,829) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of one hundred thirty-nine thousand one hundred forty-seven United States Dollars (USD 139,147), which shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company.
10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Twenty-four thousand seventy-one (24,071) Class A Shares;
(ii) Twenty-four thousand seventy-one (24,071) Class B Shares;
(iii) Twenty-four thousand seventy (24,070) Class C Shares;
(iv) Twenty-four thousand seventy (24,070) Class D Shares; and
(v) Twenty-four thousand seventy-one (24,071) Class E Shares
48277
L
U X E M B O U R G
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of one hundred twenty thousand three hundred fifty-three United States Dollars (USD 120,353), which shall be allocated
to the nominal share capital account of the Company.
11. John T. Raymond, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Two hundred forty-five thousand two hundred seventy-nine (245,279) Class A Shares;
(ii) Two hundred forty-five thousand two hundred seventy-nine (245,279) Class B Shares;
(iii) Two hundred forty-five thousand two hundred eighty (245,280) Class C Shares;
(iv) Two hundred forty-five thousand two hundred eighty (245,280) Class D Shares; and
(v) Two hundred forty-five thousand two hundred eighty (245,280) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of one million two hundred twenty-six thousand three hundred ninety-eight United States Dollars (USD 1,226,398), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
12. John G. Calvert, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Eight thousand four hundred ninety-four (8,494) Class A Shares;
(ii) Eight thousand four hundred ninety-four (8,494)Class B Shares;
(iii) Eight thousand four hundred ninety-four (8,494)Class C Shares;
(iv) Eight thousand four hundred ninety-four (8,494)Class D Shares; and
(v) Eight thousand four hundred ninety-four (8,494)Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of forty-two thousand four hundred seventy United States Dollars (USD 42,470), which shall be allocated to the nominal
share capital account of the Company.
13. Stuart F. Feiner, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class A Shares;
(ii) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class B Shares;
(iii) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class C Shares;
(iv) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class D Shares; and
(v) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230), which shall be allocated to the nominal
share capital account of the Company.
14. Jeff Ball, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class A Shares;
(ii) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class B Shares;
(iii) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class C Shares;
(iv) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class D Shares; and
(v) Nine thousand two hundred forty-six (9,246) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230), which shall be allocated to the nominal
share capital account of the Company.
15. MCP Baffin Lux S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Eighty-five thousand sixty-five (85,065) Class A Shares;
(ii) Eighty-five thousand sixty-five (85,065) Class B Shares;
(iii) Eighty-five thousand sixty-five (85,065) Class C Shares;
(iv) Eighty-five thousand sixty-six (85,066) Class D Shares; and
(v) Eighty-five thousand sixty-five (85,065) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of four hundred twenty-five thousand three hundred twenty-six United States Dollars (USD 425,326), which shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company.
16. The Richmond Fund, Ltd, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230) Class A Shares;
(ii) Forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230) Class B Shares;
(iii) Forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230) Class C Shares;
(iv) Forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230) Class D Shares; and
(v) Forty-six thousand two hundred thirty United States Dollars (USD 46,230) Class E Shares,
48278
L
U X E M B O U R G
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of two hundred thirty-one thousand one hundred fifty United States Dollars (USD 231,150), which shall be allocated to
the nominal share capital account of the Company.
17. Elk Mountain, Ltd, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Fifty-one thousand thirty-nine (51,039) Class A Shares;
(ii) Fifty-one thousand thirty-nine (51,039) Class B Shares;
(iii) Fifty-one thousand forty (51,040) Class C Shares;
(iv) Fifty-one thousand thirty-nine (51,039) Class D Shares; and
(v) Fifty-one thousand thirty-nine (51,039) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of two hundred fifty-five thousand one hundred ninety-six United States Dollars (USD 255,196), which shall be allocated
to the nominal share capital account of the Company.
18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Forty-three thousand nine hundred nineteen (43,919) Class A Shares;
(ii) Forty-three thousand nine hundred eighteen (43,918) Class B Shares;
(iii) Forty-three thousand nine hundred eighteen (43,918) Class C Shares;
(iv) Forty-three thousand nine hundred eighteen (43,918) Class D Shares; and
(v) Forty-three thousand nine hundred nineteen (43,919) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of two hundred nineteen thousand five hundred ninety-two United States Dollars (USD 219,592), which shall be allocated
to the nominal share capital account of the Company.
19. LRMRFOF LLC, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) One hundred eighty-four thousand nine hundred twenty (184,920) Class A Shares;
(ii) One hundred eighty-four thousand nine hundred twenty (184,920) Class B Shares;
(iii) One hundred eighty-four thousand nine hundred twenty (184,920) Class C Shares;
(iv) One hundred eighty-four thousand nine hundred twenty (184,920) Class D Shares; and
(v) One hundred eighty-four thousand nine hundred twenty (184,920) Class E Shares
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of nine hundred twenty-four thousand six hundred United States Dollars (USD 924,600), which shall be allocated to the
nominal share capital account of the Company.
20. EMG Baffin CI, L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for:
(i) Five hundred eighty-six thousand nine hundred fifty (586,950) Class A Shares;
(ii) Five hundred eighty-six thousand nine hundred fifty (586,950) Class B Shares;
(iii) Five hundred eighty-six thousand nine hundred forty-nine (586,949) Class C Shares;
(iv) Five hundred eighty-six thousand nine hundred fifty (586,950) Class D Shares; and
(v) Five hundred eighty-six thousand nine hundred forty-nine (586,949) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of two million nine hundred thirty-four thousand seven hundred forty-eight United States Dollars (USD 2,934,748), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
for:
(i) Four hundred twenty-five thousand three hundred twenty-six United States Dollars (USD 425,326) Class A Shares;
(ii) Four hundred twenty-five thousand three hundred twenty-six United States Dollars (USD 425,326) Class B Shares;
(iii) Four hundred twenty-five thousand three hundred twenty-six United States Dollars (USD 425,326) Class C Shares;
(iv) Four hundred twenty-five thousand three hundred twenty-six United States Dollars (USD 425,326) Class D Shares;
and
(v) Four hundred twenty-five thousand three hundred twenty-five United States Dollars (USD 425,325) Class E Shares,
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and fully pays them up by way of a cash contribution
of two million one hundred twenty-six thousand six hundred twenty-nine United States Dollars (USD 2,126,629), which
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
The above cash contributions in an aggregate amount of thirty-three million six hundred nine thousand one hundred
eight United States Dollars (USD 33,609,108) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has
been given to the undersigned notary.
48279
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to amend article 2.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital
specified above.
Article 2.1 shall henceforth read as follows:
" 2.1. Capital Structure. The capital of the Company is set at three hundred eleven million three hundred seven thousand
six hundred forty-six United States Dollars (USD 311,307,646) represented by sixty-two million two hundred sixty-one
thousand five hundred thirty (62,261,530) class A shares (the "Class A Shares"), sixty-two million two hundred sixty-one
thousand five hundred thirty (62,261,530) class B shares (the "Class B Shares"), sixty-two million two hundred sixty-one
thousand five hundred twenty-nine (62,261,529) class C shares (the "Class C Shares"), sixty-two million two hundred
sixty-one thousand five hundred twenty-eight (62,261,528) class D shares (the "Class D Shares") and sixty-two million
two hundred sixty-one thousand five hundred twenty-nine (62,261,529) class E shares (the "Class E Shares" and all to-
gether referred to as the "Shares"), all in registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all
subscribed and fully paid-up. All Shares shall be identical with each other in every respect except as otherwise provided
in these Articles or in the Shareholders Agreement."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, she sign together with the notary the
present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-sixième jour du mois de novembre,
par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.467
(la Société). La Société a été constituée suivant un acte Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 20
avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1603 le 26 juin 2012. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 25 octobre 2013 suivant un acte du notaire instrumentant,
en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
ONT COMPARU:
1. The Energy & Minerals Group Fund II, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont
le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat
de l'Etat du Delaware sous le numéro 4788643;
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware,
dont le siège social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire
d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4985797;
3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., une société en a commandite régie par lois de l'Etat du Delaware, dont le siège
social est établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de
l'Etat du Delaware sous le numéro 4942931.
4. Jaap Meijer, né le 24 septembre 1965 à Laren, les Pays-Bas, dont l'adresse se situe au 6, Op der Dresch, Bridel,
L-8127, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le
siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès
du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4767471;
6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le
siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès
du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4914794;
48280
L
U X E M B O U R G
7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont
le siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès
du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4527938;
8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège
social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du
Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5084600;
9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le
siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès
du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4474856;
10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le
siège social est établi au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès
du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 4636706;
11. John T. Raymond, né le 15 août 1970, à Norwalk, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 3006 Locke
Lane, Houston, Texas 77019, Etats-Unis d'Amérique;
12. John G. Calvert, né le 17 novembre 1964, à Chinchilla, Australie, résidant au 6107 Desco Drive, Dallas, Texas
75225, Etats-Unis d'Amérique;
13. Stuart F. Feiner, né le 19 août 1948, à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 160 Riverside Boulevard,
Apartment 4S, New York, New York 10069, Etats-Unis d'Amérique;
14. Jeff Ball, né le 15 novembre 1974, à Clifton Springs, New York City, New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant
au 3317 Rice Boulevard, Houston, Texas 77005, Etats-Unis d'Amérique;
15. MCP Baffin Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, dont le siège social est établi au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.186 et disposant d'un capital social de cinquante mille
dollars américains (USD 50.000,-);
16. The Richmond Fund, Ltd, une société en commandite régie par les lois de l'Etat de Virginie, dont le siège social est
établi au 6802 Paragon Place, Suite 205, Richmond, Virginie 23230, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Se-
crétaire d'Etat de l'Etat de Virginie sous le numéro L019709-7;
17. Elk Mountain, Ltd, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Texas, dont le siège social est établi
au 100 Waugh Drive, Suite 400, Houston, Texas 77007, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat
de l'Etat du Texas sous le numéro 00133974-10;
18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Texas, dont le siège
social est établi au 2001 Kirby Drive, Suite 1313, Houston, Texas 77019, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du
Secrétaire d'Etat de l'Etat du Texas sous le numéro 801524496;
19. LRMRFOF LLC, une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est établi
au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat
de l'Etat du Delaware sous le numéro 4763024;
20. EMG Baffin CI, L.P., une société en commandite régie par les lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est
établi au 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire
d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5136696; et
21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont le siège social est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.723.
Tous ici représentés par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse profes-
sionnelle à Esch/Alzette, en vertu de vingt et une (21) procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
I. qu'ils sont les actuels actionnaires de la Société (les Actionnaires);
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trente-trois millions six cent neuf mille cent huit dollars
américains (USD 33.609.108) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de deux cent soixante-
dix-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente-huit dollars américains (USD 277.698.538), à trois
cent onze millions trois cent sept mille six cent quarante-six dollars américains (USD 311.307.646) par l'émission de six
millions sept cent vingt-et-un mille huit cent vingt-deux (6.721.822) Actions de Classe A, six millions sept cent vingt et
un mille huit cent vingt-deux (6.721.822) Actions de Classe B, six millions sept cent vingt et un mille huit cent vingt-deux
48281
L
U X E M B O U R G
(6.721.822) Actions de Classe C, six millions sept cent vingt et un mille huit cent vingt et une (6.721.821) Actions de
Classe D et six millions sept cent vingt et un mille huit cent vingt et une (6.721.821) Actions de Classe E, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative;
3. Souscription à et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en
numéraire;
4. Modification de l'article 2.1 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social mentionnée au
point 2. ci-dessus; et
5. Divers.
III. Ainsi, les Actionnaires, après délibération, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, les Actionnaires décident de
renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de d'un montant de trente-trois
millions six cent neuf mille cent huit dollars américains (USD 33.609.108) afin de porter le capital social de la Société de
son montant actuel de deux cent soixante-dix-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente-huit dollars
américains (USD 277.698.538), à trois cent onze millions trois cent sept mille six cent quarante-six dollars américains
(USD 311.307.646) par l'émission de six millions sept cent vingt et un mille huit cent vingt-deux (6.721.822) Actions de
Classe A, six millions sept cent vingt et un mille huit cent vingt-deux (6.721.822) Actions de Classe B, six millions sept
cent vingt et un mille huit cent vingt-deux (6.721.822) Actions de Classe C, six millions sept cent vingt et un mille huit
cent vingt et une (6.721.821) Actions de Classe D et six millions sept cent vingt et un mille huit cent vingt et une (6.721.821)
Actions de Classe E, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, sous forme nominative.
<i>Troisième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT d'approuver et acceptent les souscriptions suivantes et les paiements des actions nou-
vellement émises comme suit:
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
1. The Energy & Minerais Group Fund II, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent vingt et une (3.448.221) Actions de Classe A;
(ii) trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent vingt et une (3.448.221) Actions de Classe B;
(iii) trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent vingt et une (3.448.221) Actions de Classe C;
(iv) trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent vingt et une (3.448.221) Actions de Classe D; et
(v) trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent vingt-deux (3.448.222) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de dix-sept millions deux cent quarante et un mille cent six dollars américains (USD 17.241.106), qui sera
alloué au compte de capital social nominal de la Société.
2. EMG Fund II Dutch Offshore Holdings, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) six cent vingt-trois mille cent cinquante-neuf (623.159) Actions de Classe A;
(ii) six cent vingt-trois mille cent cinquante-neuf (623.159) Actions de Classe B;
(iii) six cent vingt-trois mille cent soixante (623.160) Actions de Classe C;
(iv) six cent vingt-trois mille cent cinquante-neuf (623.159) Actions de Classe D; et
(v) six cent vingt-trois mille cent cinquante-neuf (623.159) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et les libère intégralement par un apport en nu-
méraire de trois millions cent quinze mille sept cent quatre-vingt-seize dollars américains (USD USD 3.115.796), qui sera
alloué au compte de capital social nominal de la Société.
3. EMG Fund II Offshore Holdings, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) six cent cinq mille neuf cent soixante (605.960) Actions de Classe A;
(ii) six cent cinq mille neuf cent soixante et une (605.961) Actions de Classe B;
(iii) six cent cinq mille neuf cent soixante (605.960) Actions de Classe C;
(iv) six cent cinq mille neuf cent soixante (605.960) Actions de Classe D; et
(v) six cent cinq mille neuf cent soixante (605.960) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et les libère intégralement par un apport en nu-
méraire de trois millions vingt-neuf mille huit cent un dollars américains (USD 3,029,801), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
48282
L
U X E M B O U R G
4. Jaap Meijer, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) huit mille cinq cent sept (8.507) Actions de Classe A;
(ii) huit mille cinq cent sept (8.507) Actions de Classe B;
(iii) huit mille cinq cent sept (8.507) Actions de Classe C;
(iv) huit mille cinq cent six (8.506) Actions de Classe D; et
(v) huit mille cinq cent six (8.506) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de quarante-deux mille cinq cent trente-trois dollars américains (USD 42.533), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
5. Adams Street 2010 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) treize mille six cent soixante-treize (13.673) Actions de Classe A;
(ii) treize mille six cent soixante-quatorze (13.674) Actions de Classe B;
(iii) treize mille six cent soixante-quatorze (13.674) Actions de Classe C;
(iv) treize mille six cent soixante-treize (13.673) Actions de Classe D; et
(v) treize mille six cent soixante-treize (13.673) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de soixante-huit mille trois cent soixante-sept dollars américains (USD 68.367), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
6. Adams Street 2011 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) dix mille neuf cent quatre-vingt-cinq (10.985) Actions de Classe A;
(ii) dix mille neuf cent quatre-vingt-cinq (10.985) Actions de Classe B;
(iii) dix mille neuf cent quatre-vingt-cinq (10.985) Actions de Classe C;
(iv) dix mille neuf cent quatre-vingt-six (10.986) Actions de Classe D; et
(v) dix mille neuf cent quatre-vingt-cinq (10.985) Actions de Classe E.
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de cinquante-quatre mille neuf cent vingt-six dollars américains (USD 54.926), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
7. Adams Street Co-Investment Fund II, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) deux cent vingt-deux mille huit cent soixante et onze (222.871) Actions de Classe A;
(ii) deux cent vingt-deux mille huit cent soixante et onze (222.871) Actions de Classe B;
(iii) deux cent vingt-deux mille huit cent soixante et onze (222.871) Actions de Classe C;
(iv) deux cent vingt-deux mille huit cent soixante-dix (222.870) Actions de Classe D; et
(v) deux cent vingt-deux mille huit cent soixante et onze (222.871) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de un million cent quatorze mille trois cent cinquante-quatre dollars américains (USD 1.114.354), qui sera
alloué au compte de capital social nominal de la Société.
8. Adams Street 2012 US Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) quarante mille huit cent trente et un (40.831) Actions de Classe A;
(ii) quarante mille huit cent trente et un (40.831) Actions de Classe B;
(iii) quarante mille huit cent trente et un (40.831) Actions de Classe C;
(iv) quarante mille huit cent trente et un (40.831) Actions de Classe D; et
(v) quarante mille huit cent trente-deux (40.832) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de deux cent quatre mille cent cinquante-six dollars américains (USD 204.156), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
9. Adams Street 2008 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) vingt-sept mille huit cent trente (27.830) Actions de Classe A;
(ii) vingt-sept mille huit cent trente (27.830) Actions de Classe B;
(iii) vingt-sept mille huit cent vingt-neuf (27.829) Actions de Classe C;
(iv) vingt-sept mille huit cent vingt-neuf (27.829) Actions de Classe D; et
(v) vingt-sept mille huit cent vingt-neuf (27.829) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de cent trente-neuf mille cent quarante-sept dollars américains (USD 139.147), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
10. Adams Street 2009 Direct Fund, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
48283
L
U X E M B O U R G
(i) vingt-quatre mille soixante et onze (24.071) Actions de Classe A;
(ii) vingt-quatre mille soixante et onze (24.071) Actions de Classe B;
(iii) vingt-quatre mille soixante-dix (24.070) Actions de Classe C;
(iv) vingt-quatre mille soixante-dix (24.070) Actions de Classe D; et
(v) vingt-quatre mille soixante et onze (24.071) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de cent vingt mille trois cent cinquante-trois dollars américains (USD 120.353), qui sera alloué au compte de
capital social nominal de la Société.
11. John T. Raymond, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante-dix-neuf (245.279) Actions de Classe A;
(ii) deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante-dix-neuf (245.279) Actions de Classe B;
(iii) deux cent quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt (245.280) Actions de Classe C;
(iv) deux cent quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt (245.280) Actions de Classe D; et
(v) deux cent quarante-cinq mille deux cent quatre-vingt (245.280) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de un million deux cent vingt-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains (USD 1.226.398), qui
sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.
12. John G. Calvert, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8.494) Actions de Classe A;
(ii) huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8.494) Actions de Classe B;
(iii) huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8.494) Actions de Classe C;
(iv) huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8.494) Actions de Classe D; et
(v) huit mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (8.494) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de quarante-deux mille quatre cent soixante-dix dollars américains (USD 42.470), qui sera alloué au compte
de capital social nominal de la Société.
13. Stuart F. Feiner, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe A;
(ii) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe B;
(iii) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe C;
(iv) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe D; et
(v) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de quarante-six mille deux cent trente dollars américains (USD 46.230), qui sera alloué au compte de capital
social nominal de la Société.
14. Jeff Ball, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe A;
(ii) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe B;
(iii) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe C;
(iv) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe D; et
(v) neuf mille deux cent quarante-six (9.246) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de quarante-six mille deux cent trente dollars américains (USD 46.230), qui sera alloué au compte de capital
social nominal de la Société.
15. MCP Baffin Lux S.à r.l., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) quatre-vingt-cinq mille soixante-cinq (85.065) Actions de Classe A;
(ii) quatre-vingt-cinq mille soixante-cinq (85.065) Actions de Classe B;
(iii) quatre-vingt-cinq mille soixante-cinq (85.065) Actions de Classe C;
(iv) quatre-vingt-cinq mille soixante-six (85.066) Actions de Classe D; et
(v) quatre-vingt-cinq mille soixante-cinq (85.065) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de quatre cent vingt-cinq mille deux cent trente-six dollars américains (USD 425.236), qui sera alloué au compte
de capital social nominal de la Société.
16. The Richmond Fund, Ltd, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) quarante-six mille deux cent trente (46.230) Actions de Classe A;
48284
L
U X E M B O U R G
(ii) quarante-six mille deux cent trente (46.230) Actions de Classe B;
(iii) quarante-six mille deux cent trente (46.230) Actions de Classe C;
(iv) quarante-six mille deux cent trente (46.230) Actions de Classe D; et
(v) quarante-six mille deux cent trente (46.230) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de deux cent trente et un mille cent cinquante dollars américains (USD 231.150), qui sera alloué au compte
de capital social nominal de la Société.
17. Elk Mountain, Ltd, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) cinquante et un mille trente-neuf (51.039) Actions de Classe A;
(ii) cinquante et un mille trente-neuf (51.039) Actions de Classe B;
(iii) cinquante et un mille quarante (51.040) Actions de Classe C;
(iv) cinquante et un mille trente-neuf (51.039) Actions de Classe D; et
(v) cinquante et un mille trente-neuf (51.039) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de deux cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-seize dollars américains (USD 255.196), qui sera alloué au
compte de capital social nominal de la Société.
18. TMRP II Baffin Co-Investment, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) quarante-trois mille neuf cent dix-neuf (43.919) Actions de Classe A;
(ii) quarante-trois mille neuf cent dix-huit (43.918) Actions de Classe B;
(iii) quarante-trois mille neuf cent dix-huit (43.918) Actions de Classe C;
(iv) quarante-trois mille neuf cent dix-huit (43.918) Actions de Classe D; et
(v) quarante-trois mille neuf cent dix-neuf (43.919) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze dollars américains (USD 219.592), qui sera alloué au
compte de capital social nominal de la Société.
19. LRMRFOF LLC, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt (184.920) Actions de Classe A;
(ii) cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt (184.920) Actions de Classe B;
(iii) cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt (184.920) Actions de Classe C;
(iv) cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt (184.920) Actions de Classe D; et
(v) cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt (184.920) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de neuf cent vingt-quatre mille six cent dollars américains (USD 924.600), qui sera alloué au compte de capital
social nominal de la Société.
20. EMG Baffin CI, L.P., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante (586.950) Actions de Classe A;
(ii) cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante (586.950) Actions de Classe B;
(iii) cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent quarante-neuf (586.949) Actions de Classe C;
(iv) cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante (586.950) Actions de Classe D; et
(v) cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent quarante-neuf (586.949) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de deux millions neuf cent trente-quatre mille sept cent quarante-huit dollars américains (USD 2.934.748) qui
sera alloué au compte de capital social nominal de la Société.
21. Hanover Investments (Luxembourg) S.A., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
(i) quatre cent vingt-cinq mille trois cent vingt-six (425.326) Actions de Classe A;
(ii) quatre cent vingt-cinq mille trois cent vingt-six (425.326) Actions de Classe B;
(iii) quatre cent vingt-cinq mille trois cent vingt-six (425.326) Actions de Classe C;
(iv) quatre cent vingt-cinq mille trois cent vingt-six (425.326) Actions de Classe D; et
(v) quatre cent vingt-cinq mille trois cent vingt-six (425.326) Actions de Classe E,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en
numéraire de deux millions cent vingt-six mille six cent vingt-neuf dollars américains (USD 2.126.629) qui sera alloué au
compte de capital social nominal de la Société.
Les apports en numéraire ci-dessus d'un montant total de trente-trois millions six cent neuf mille cent huit dollars
américains (USD 33.609.108) sont immédiatement à la libre disposition de la Société.
48285
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Les Actionnaires DECIDENT de modifier l'article 2.1 des Statuts, afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionné ci-dessus.
L'article 2.1 aura désormais la teneur suivante:
" 2.1. Structure financière. "Le capital de la Société est fixé à trois cent onze millions trois cent sept mille six cent
quarante-six dollars américains (USD 311.307.646) représenté par soixante-deux millions deux cent soixante et un mille
cinq cent trente (62.261.530) actions de classe A (les «Actions de Classe A»), soixante-deux millions deux cent soixante
et un mille cinq cent trente (62.261.530) actions de classe B (les «Actions de Classe B»), soixante-deux millions deux
cent soixante et un mille cinq cent vingt-neuf (62.261.529) actions de classe C (les «Actions de Classe C»), soixante-deux
millions deux cent soixante et un mille cinq cent vingt-huit (62.261.528) actions de classe D (les «Actions de Classe D»)
et soixante-deux millions deux cent soixante et un mille cinq cent vingt-neuf (62.261.529) actions de classe E (les «Actions
de Classe E», qui de manière conjointe sont désignées comme les «Actions»), toutes sous forme nominative, d'une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Toutes les Actions seront
identiques les unes aux autres en tous aspects sauf s'il en est autrement stipulé dans ces Statuts ou dans le Pacte d'Ac-
tionnaires."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare ici qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, elle signe avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15964 25. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014037472/678.
(140041964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.
Elit Properties S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Savalla S.A.).
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 112.811.
L'an deux mille treize, le quatre décembre.
Par devant nous Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
S'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «Savalla S.A.»,
une société anonyme ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte
reçu par Me Jean-Joseph Wagner en date du 18 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations n° 563 du 17 mars 2006,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112 811 (la «Société»).
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mlle Diana HOFFMANN, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, qui se désigne également comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Virginie PIERRU, notary clerk, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I,- Que l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient est portés sur une liste de présence signée
«ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant pour les besoins de l'enregistrement, ainsi que la
procuration de l'actionnaire unique.
II,- Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
48286
L
U X E M B O U R G
tous les points portés à l'ordre du jour, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale en «Elit Properties S.A.», et modification subséquente de l'article 1
er
des
statuts de la Société.
2. Divers
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur le point porté à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:
<i>Unique résolution:i>
L'assemblée générale change la dénomination sociale en «Elit Properties S.A.» et, par conséquent, modifie l'article 1
er
des statuts de la Société, comme suit:
« Art. 1
er
. La Société adopte la dénomination de Elit Properties S.A.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ neuf cents euros (900,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
état et demeures, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. PIERRU, D. HOFFMANN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 05.12.2013. Relation: LAC/2013/55341. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 17.02.2014.
Référence de publication: 2014024955/52.
(140030132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.
mpool consulting S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1230 Luxembourg, 35, rue Jean Bertels.
R.C.S. Luxembourg B 138.571.
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxembourg.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft mpool consulting GmbH, mit Sitz in D-66115 Saarbrücken, Heinrich-Barth Str. 1,
hier vertreten durch Frau Danielle Kirsch, Buchhalterin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 3, rue des Foyers, auf Grund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
2) Herr Klaus Müller, wohnhaft in D-66128 Saarbrücken, Nelken Str. 22, hier vertreten durch Frau Danielle Kirsch,
vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die Erschienenen handeln in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter der mpool Consulting S.à r.l., Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung, mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss notarieller Urkunde vom 6. Mai 2008, veröf-
fentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1421 vom 10. Juni 2008. Die Satzung wurde
abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 22. Januar 2009, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 484 vom 5. März 2009.
Die Erschienenen erklären sodann sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden und fas-
sen einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Auflösung der Gesellschaft, welche fortan nur mehr für ihre Liquidation
besteht.
48287
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschluss:i>
Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:
Herrn Hermann Ziegler, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Weihereckstrasse 5, geboren in Eppelborn, am 22. Sep-
tember 1955.
Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse wie dies in den Artikeln 144-148bis des zusammengefassten Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, ohne
in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorgeschrieben
ist, zurückgreifen zu müssen.
Er kann den Hypothekenbewahrer von den Pflichteinschreibungen entbinden, auf alle reelle Rechte, Privilegien, Hy-
potheken oder Auflösungsrechte verzichten, Hypothekenlöschungen gewähren, gegen Zahlung oder ohne Zahlung.
Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft
berufen.
Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-
sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst zum Kommissar zur Liquidation zu ernennen:
Fiduciaire Comptable B+C S.à r.l., mit Sitz in L1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, RCS Luxembourg B 128554.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Woh-
nort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. KKIRSCH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 février 2014. Relation: LAC/2014/5458. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 19. Februar 2014.
Référence de publication: 2014025782/52.
(140031597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.
Barolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 183.547.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 janvier 2014i>
- Monsieur François REMY, né le 20 mars 1962 à F- Réole, Directeur Général Pays, demeurant professionnellement
au 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg et Monsieur Olivier BARBRY, né le 23 septembre 1967 à F - Armen-
tières, Directeur du Contrôle de gestion Auchan France, ayant son adresse professionnelle au 200, rue de la Recherche,
à F 59650 Villeneuve d'Ascq sont nommés administrateurs.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.
- La démission de Monsieur Thierry DELBECQ de son mandat d'administrateur est acceptée.
- Monsieur Xavier PREVOST, né le 28 janvier 1964 à B - Mouscron, Directeur des organisations systèmes et infor-
mations et Supply Chain d'Auchan E-commerce, résidant professionnellement à Auchan E-commerce, 40 rue de la vague,
F -59650 Villeneuve d'Ascq est nommé administrateur en son remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.
- La démission de Monsieur Marc-Antoine ROBLETTE de son mandat de commissaire est acceptée.
- Monsieur Thierry DELBECQ, né le 22 mars 1964 à Lille (France), Directeur Financier, avec adresse professionnelle
au 5 rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg est nommé commissaire en son remplacement pour une durée d'un
(1) an avec effet à compter de ce jour.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2014030915/24.
(140034827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
48288
Barolux S.A.
CORESTATE ENERGY HoldCo S.à r.l.
Dima Holdings S.àr.l.
Elit Properties S.A.
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.
Fontgrande S.A.
Framont Investissements S.A., S.P.F.
Giedo van der Garde S.à r.l.
Gras Savoye Luxembourg
Gras Savoye Luxembourg
In-Soft Sàrl
Jawer Luxembourg S.A.
Joya-Coiffure S.à r.l.
KHS Königstraße 27 Beteiligung S.à r.l.
Kunst & Dekoration S.A.
mpool consulting S.à.r.l.
Raiba Finance S.A.
Raiba Finance S.A.
Raiba Finance S.A.
RL LUX Holding S.à r.l.
Rock-It Cargo Logistics II S.à r.l.
RW Consult
Ryght Europe S.A.
Sandrina Holdings S.à r.l.
Sansar S.A.
Sater S.à r.l.
Savalla S.A.
Serham Sàrl
Shoe-Lux S.àr.l.
SMSC Holdings S.à r.l.
Sportv
Stahl und Konstruktion S.A.
Superfund Asset Management GmbH - Niederlassung Luxemburg
Swissco S.A.