This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 910
9 avril 2014
SOMMAIRE
Almond S.àr.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43635
Alysea Luxembourg Les Soins S.A . . . . . . .
43634
Atos Medical S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43634
Bauerenhaff, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43634
BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43666
Belfe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43634
Best Products International . . . . . . . . . . . . .
43635
Biolaser Technologies et Finances S.A. . . .
43635
Castle 47 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43655
Centenario S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43637
Centre d'Isolation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
43635
Concept 4 Depollution . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43636
CPI Holding Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
43638
Delphi Financial Services Luxembourg Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43642
Edoreric S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43637
Edoreric S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43637
EUR-HYP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43638
Growth Capital Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . .
43638
Hair Connection S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
43636
Hentou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43640
HEQJ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43640
Hit Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43639
HPMC2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43639
HPMC2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43639
HPMC2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43639
IBT Consulting Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43637
Immobilière DELLI ZOTTI S.à r.l. . . . . . . .
43636
Immobilière du Rhin S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
43638
Immobilière WAGNER & WAGNER S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43639
Intabulis SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43636
Intelligent QualyCloud S.A. . . . . . . . . . . . . .
43640
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43641
Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43642
Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF . . . . .
43677
Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l. . . . . . . .
43641
Matthias RUPPERT GmbH . . . . . . . . . . . . .
43641
MA.ZA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43641
Mohé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43641
Natalfin S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43640
Obbos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43671
Prorealim S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43679
Sacha Rénovations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
43679
Sazele S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43673
ZBI Opportunity Real Estate S.C.A., . . . . .
43666
43633
L
U X E M B O U R G
Alysea Luxembourg Les Soins S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange.
R.C.S. Luxembourg B 159.837.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 7 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 octobre 2013 que:
1. Administrateur, démissionnaire avec effet immédiat:
Monsieur Bruno BEERNAERTS
162 rue de Reckenthal
L-2410 STRASSEN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 18 février 2014.
Référence de publication: 2014025106/16.
(140030494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Atos Medical S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 104.334.
<i>Extrait de la décision de l'associé unique prise au Luxembourg le 13 décembre 2013i>
1. L'associé unique décide de nominer Monsieur Claes Johan Geijer, né le 15 juin 1957 à Stockholm, Suède, ayant son
adresse au 31, rue Franz Clement, L-1345 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe A
de la Société avec effet au 1
er
janvier 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Atos Médical S.à r.l
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014025109/15.
(140030582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Belfe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.325.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2014.
Belfe S.A.
Johannes de Zwart
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014025146/14.
(140030298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Bauerenhaff, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, Reidenerwee.
R.C.S. Luxembourg B 117.090.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025160/9.
(140030928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43634
L
U X E M B O U R G
Best Products International, Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 170.646.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025167/9.
(140030948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Biolaser Technologies et Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 128.849.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025168/9.
(140030845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Centre d'Isolation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 67.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025177/10.
(140030819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Almond S.àr.l.., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 155.175.
Durch Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12. Februar 2014 wurden folgende Personen
mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:
- Frau Sibylle Schröder-Castendyck, geb. 19.03.1958 in D-Hamburg, geschäftsansässig in 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg;
- Herr Michael Schröder-Castendyck, geb. 30.10.1950 in D-Hamburg, geschäftsansässig in 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg;
- Herr Volker Becker, geb. 10.07.1970 in D-Wadern, geschäftsansässig in 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
Herr Patrice Gallasin wurde mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer abberufen.
Dann wurde beschlossen, den Sitz und die Geschäftsanschrift der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung an folgende
Adresse zu verlegen:
- 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
Außerdem wurde die Geschäftsführung beauftragt, bei der Veröffentlichung der Beschlüsse im Handels- und Firmen-
register Luxemburgs die Angaben hinsichtlich Rechtsform und Geschäftsanschrift der Gesellschafterin Chiltern S.A.
(vormals Chiltern S.à r.l, RCS Luxembourg B 164.063, gemäß Aktionärsbeschluss vom 20.12.2013 zu aktualisieren.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 18.02.2014.
<i>Für die Gesellschaft
i>Volker Becker
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2014025104/26.
(140030844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43635
L
U X E M B O U R G
Intabulis SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 184.464.
STATUTS
<i>Extraiti>
L'an deux mille quatorze, le 6 février.
Il a été constitué suivant acte sous seing privé une société en commandite spéciale (la "Société").
1. Raison sociale: La dénomination de la société est Intabulis SCSp.
2. Siège social: Le siège social de la Société est établi en la commune de Luxembourg.
3. Durée: La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Objet social: La Société a pour objet la prestation de mandats d'administrateur, directeur, gérants ou toutes positions
similaires pour tout type d'entités financières ou commerciale au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La Société
pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.
Les douze parts d'intérêt commanditées ont été souscrite par:
Intabulis L.P., Luxembourg Branch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 183.907, succursale d'Intabulis LP, inscrite au Registre de Commerce d'Ecosse sous le numéro SL15345: six parts, et
Edisseri S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.920: six parts.
6. Gérance: La Société est gérée par les associés commandités, qui peuvent par déléguer la gérance à deux ou plusieurs
gérants. La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCÈRE
Signatures
Référence de publication: 2014025075/26.
(140029097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.
Concept 4 Depollution, Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 171.260.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025218/9.
(140030865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Hair Connection S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 71, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 33.104.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2014.
Référence de publication: 2014025353/10.
(140030668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Immobilière DELLI ZOTTI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R.C.S. Luxembourg B 7.069.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025373/9.
(140030740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43636
L
U X E M B O U R G
Centenario S.A.H., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.981.
La société ECOGEST S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société CENTENARIO S.A.H., inscrite au
R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 103.981.
A dater de ce jour, la société CENTENARIO S.A.H. n'est plus autorisée à fixer son siège au 4, rue Henri Schnadt à
L-2530 Luxembourg
Luxembourg, le 30 décembre 2013.
<i>Pour ECOGEST S.A.
i>Jean-Paul FRANK / Steve KIEFFER
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014025207/14.
(140030436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Edoreric S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 122.368.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025267/9.
(140031016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Edoreric S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 122.368.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 5 février 2014i>
Il résulte dudit procès-verbal, que
- les mandats d'administrateur de Monsieur Jean-Marie BODEN, expert-comptable, demeurant 45-47, route d'Arlon,
L-1140 Luxembourg, de Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant 45-47, route d'Arlon, L-1140 Lu-
xembourg, et de Monsieur Romain WAGNER, expert-comptable, demeurant 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
ont été prolongés jusqu'à l'assemblée générale statutaire, qui se tiendra en 2018;
- la démission de la société Kartheiser Management S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes, a été accepté, avec
effet immédiat;
- la nomination de la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l., ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140,
en tant que Commissaire aux Comptes a été accepté jusqu'à l'assemblée générale statutaire, qui se tiendra en 2018;
Luxembourg, le 5 février 2014.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014025266/19.
(140030373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
IBT Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 43.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2014025391/12.
(140030939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43637
L
U X E M B O U R G
EUR-HYP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.076.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 17 février 2014 les
résolutions suivantes:
L’Assemblée prend acte de la démission de:
- Audiex S.a. en tant que Commissaire aux comptes.
L’Assemblée décide de nommer en son remplacement et pour une durée de 6 ans:
- Benoy Kartheiser Management, ayant son siège social, 47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, inscrite auprès du RCS
Luxembourg sous le numéro B 33 849.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014025274/17.
(140030832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Growth Capital Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 126.702.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire de Janvier 2014i>
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé, né le 7 mai 1974 à Strasbourg (France), domicilié professionnelle-
ment au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, est nommé en tant qu'Administrateur de catégorie B en remplacement
de Monsieur Alain Renard, Administrateur de catégorie B. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de 2018.
Luxembourg, le 17 février 2014.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GROWTH CAPITAL INVEST S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2014025343/16.
(140030399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
CPI Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 149.373.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025224/9.
(140030525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Immobilière du Rhin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 94.197.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels rectifiés et clôturés au 31 décembre 2010, rectificatif du dépôt n° L140010088 du 17/01/2014,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025398/12.
(140030597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43638
L
U X E M B O U R G
Hit Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.850.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014025360/14.
(140030275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
HPMC2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 133.786.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025365/10.
(140030686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
HPMC2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 133.786.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025367/10.
(140031056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
HPMC2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 133.786.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025368/10.
(140031066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Immobilière WAGNER & WAGNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 59, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 60.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
12, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg
Référence de publication: 2014025374/10.
(140030904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43639
L
U X E M B O U R G
HEQJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 157.921.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025356/10.
(140030696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Hentou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 18, rue d'Eschdorf.
R.C.S. Luxembourg B 96.511.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2012i>
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société HENTOU S.A., tenue en date du 20 décembre 2012, les
actionnaires ont pris les décisions suivantes:
- Mademoiselle Solenne PELLO, née le 3 juillet 1988 à Le Mans (France) et demeurant professionnellement à L-9650
ESCH-SUR-SÛRE, 18 rue d'Eschdorf, est nommée administrateur de la société pour un nouveau mandat de six ans. Son
mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Référence de publication: 2014025355/15.
(140030761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Intelligent QualyCloud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 165.727.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2014025377/11.
(140030376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Natalfin S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 134.154.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 février 2014i>
1) L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs ci-dessous jusqu'à l'assemblée devant se tenir en
2019:
- Maître Michaël DANDOIS,
- Maître Antoine MEYNIAL, et
- Monsieur Stéphane WARNIER.
2) L'assemblée renouvelle également le mandat du Commissaire aux Comptes CHESTER & JONES Sàrl, RCS Luxem-
bourg B 120.602 jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2019 et prend note de son changement d'adresse au 14 rue Bernard
Haal, L-1711 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2014025539/18.
(140030280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43640
L
U X E M B O U R G
Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 12, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 91.551.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014025510/9.
(140030822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
MA.ZA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4048 Esch-sur-Alzette, 13, rue Helen Buchholtz.
R.C.S. Luxembourg B 158.884.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025507/10.
(140030416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Mohé, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 174.113.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025505/10.
(140031030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Matthias RUPPERT GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 43.509.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014025497/10.
(140031021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 317.925,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 130.841.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 13 février 2014i>
1. L'Associé unique accepte la démission avec effet immédiat de ses fonctions de gérant Mr Mark James CARRINGTON.
2. L'Associé unique nomme en remplacement du gérant Mr Thomas Lafargue, avec adresse professionnelle 7a, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014025432/15.
(140030857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
43641
L
U X E M B O U R G
Delphi Financial Services Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 183.852.
En date du 19 décembre 2013, la société Delphi International Holdings LLP, une société de droit anglais, ayant son
siège social à Mitre House, 160 Aldersgate Street, London EC1A 4DD, immatriculée auprès du Registre des Sociétés
d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro OC349101, a cédé 12.297 parts sociales de classe 1 à Delphi Global
Investments LLP, une société de droit anglais, ayant son siège social à Mitre House, 160 Aldersgate Street, London EC1A
4DD, immatriculée auprès du Registre des Sociétés d' Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro OC389341 (DGI
LLP).
En date du 20 décembre 2013, DGI LLP a alloué l'ensemble des 16.000 parts sociales de classe 1 et des 4.000 parts
sociales de classe 2 à Delphi Global Investments LLP, Luxembourg Branch, sa succursale luxembourgeoise, ayant son
adresse Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 182.904 (DGI LLP Luxembourg).
DGI LLP Luxembourg devient ainsi l'associé unique de la Société.
Luxembourg, le 17 février 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014025774/22.
(140030445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 173.650.
In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of December.
before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A S.à r.l. (hereinafter
the "Company"), a societe à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 12 December 2012, published in the Memorial C Recueil des Sociétés et Associations
on 6 February 2013 under number 286, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B
173650,
The articles of incorporation have not been amended yet.
The meeting opened with Mr Régis Galiotto, employee, professionally residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman designated as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Solange Wolter-Schieres, employee,
professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declare and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to change the language of the articles of association of the Company from German to English followed by
a German translation and decision that the English version shall prevail;
2. Decision to change the Company's corporate object which shall read as follows:
"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company may directly or through
one or more subsidiaries or otherwise invest in, hold, manage or control intellectual property or similar rights as well as
real estate located in Luxembourg or abroad.
43642
L
U X E M B O U R G
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a
general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.";
3. Decision to fully restate the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed
to this deed.
III. That pursuant to the attendance list, all of the share capital is present or represented and all the shareholders
present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree
to waive any further notice requirements.
IV. That the present meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate on all the items of the agenda.
The extraordinary general meeting of shareholders has requested the undersigned notary to record the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders unanimously decides to change the language of the articles of
association of the Company from German to English followed by a German translation. The English version of the articles
of association of the Company shall prevail.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders unanimously decides to change the Company's corporate object
in order to read as follows:
"The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company may directly or through
one or more subsidiaries or otherwise invest in, hold, manage or control intellectual property or similar rights as well as
real estate located in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a
general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.".
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to fully restate the articles of association of the Company
in order to implement the above resolutions
which shall henceforth read as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name Köln, Breite Straße
103-105 Beteiligung A S.à r.l. (the "Company") exists between the current shareholder(s) and all persons who will become
shareholders thereafter. The Company is governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company may directly or
through one or more subsidiaries or otherwise invest in, hold, manage or control intellectual property or similar rights
as well as real estate located in Luxembourg or abroad.
43643
L
U X E M B O U R G
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a
general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven, Grand-Duchy of
Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality of Niederanven by decision of the
manager or as the case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers
Art. 5. Share capital and Shareholders. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares each with a nominal value of one Euro
(EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the articles of association and as may be agreed in an shareholders,
frame work or like agreement between the Shareholders (if any) (an “Arrangement”). The capital of the Company may
be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these
articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Reserved Matters. The following matters shall always require the prior authorisation or approval by the general
meeting of shareholders resolving as set forth in Article 14 para 4 (ii):
(a) any changes to the articles of association including any capital measures;
(b) unless already provided for in these articles of association, in particular pursuant to Article 17.2, any implementation
of disproportionate distribution rights where profits are to be distributed among the shareholders disproportionate to
the shareholders' equity participation in the Company;
(c) any transformation of the Company including any merger, change of legal form, spin-offs consolidation, or other
business combination, by means of any transaction or series of related transactions;
(d) the liquidation or dissolution of the Company;
(e) repurchases or redemption of shares or other equity instruments of the Company; and
(f) consent to any affiliation and/or domination agreements under which the Company agrees to be dominated by
another entity, to transfer all or substantially all of its profits to another entity or to reimburse another company for
losses incurred by such other company, provided that this does not apply for respective agreements between the Com-
pany and its subsidiaries.
Art. 7. Transfer of Shares. Any transfer of shares shall be subject to the prior approval of the general meeting and the
provisions of an Arrangement (if any).
Decisions of the general meeting to approve any transfer of shares of the Company shall only be validly adopted if
approved by all shareholders representing all (100%) of the issued share capital, provided, however, that any transfer of
shares requires only the approval by shareholders representing at least three quarters (75%) of the issued share capital,
if Article 9 and Article 10 below have been observed.
Any transfer of shares not done in accordance with the provision of the articles and the relevant Arrangement (if any)
shall not be valid or effective and shall not be recognised.
Art. 8. Drag-Along Right.
Art. 8.1. If a shareholder or several shareholders jointly holding fifty percent (50%) or more of the issued share capital
wish(es) to sell and transfer all or parts of its/their shares to a bona fide third party, i.e. not a party that is an affiliated
company according to article 309 of the law of 10
th
August, 1915, as amended, on commercial companies (“Third Party
Purchaser”, any such sale a “Drag Trigger Sale” and each shareholder so wishing to effect such Drag Trigger Sale the
43644
L
U X E M B O U R G
“Proposing Shareholder”), the Proposing Shareholder shall have the right to require by way of a written notice to the
other shareholders (each a “Drag Shareholder”) duly signed by the Proposing Shareholder prior to completion of the
Drag Trigger Sale to also sell and transfer all or the same percentage of their shares, respectively, as the Proposing
Shareholder to the Third Party Purchaser (the “Drag Disposal Notice”) within a time period of at least ten (10) bank
working days (a “Bank Working Day“ meaning a day on which banks in Frankfurt am Main, Germany, are regularly open
to public) following receipt of the Drag Disposal Notice by all other shareholders.
Art. 8.2. The sale and transfer of the shares to be sold by the Drag Shareholder pursuant to the Drag Disposal Notice
shall be effected to the same Third Party Purchaser and on the same terms and conditions, including the price per share
(such terms and conditions to be set out in the Drag Disposal Notice) as is the Drag Trigger Sale, provided that the Drag
Shareholder (i) shall not be obliged to give any representations or warranties other than customary representations and
warranties with respect to authority and title in the shares to be sold pursuant to the Drag Disposal Notice, (ii) shall not
be subject to any non-compete or non-solicitation obligations in connection with the sale, (iii) shall not be jointly liable
with any other party to the relevant sale of shares, and (iv) shall in no event be liable for an amount higher than the
proceeds from the sale actually received by the relevant Drag Shareholder.
Art. 8.3. The Drag Shareholder's obligation to sell and transfer its shares pursuant to the Drag Disposal Notice shall
terminate if the relevant sale and transfer is not completed within 90 days following the receipt of the Drag Disposal
Notice by all other shareholders (120 days if regulatory approval is required).
Art. 9. Tag-Along Right.
Art. 9.1. If a shareholder (the “Disposing Shareholder”) sells shares (any such sale a “Tag Trigger Sale”), such Disposing
Shareholder shall procure that (i) the other shareholders of the Company (each a “Tag Shareholder”) can sell their shares
in the Company on a pro-rata basis at a price per share equal to the price per share under the Tag Trigger Sale and
otherwise at conditions no more onerous to the Tag Shareholder than are the conditions to the Disposing Shareholder
under the Tag Trigger Sale (any sale so to be made by any Tag Shareholder a “Tag Sale“), and (ii) the purchase price to
be paid under the Tag Sale to the Tag Shareholder is then fully paid provided that the Tag Shareholder (A) shall not be
obliged to give any representations or warranties other than customary representations and warranties with respect to
authority and title in the Shares to be sold, (B) shall not be subject to any non-compete or non-solicitation obligations in
connection with the sale, (C) shall not be jointly liable with any other party to the relevant sale of shares, and (D) shall
in no event be liable for an amount higher than the proceeds from the sale actually received by it.
Art. 9.2. The obligations of the Disposing Shareholder under this Article 9 shall fall away in relation to the relevant
Tag Trigger Sale, if within four (4) weeks of the Tag Shareholder having been notified of the above prerequisites having
been met and the purchase price to apply, it has not notified the Disposing Shareholder that it wishes to effect the Tag
Sale.
Art. 10. Right of First Refusal.
Art. 10.1. Any shareholder wishing to transfer shares shall first deliver to the other shareholder a written notice of
its desire to do so (the “Transfer Notice”). The Transfer Notice shall at least contain the following information:
(a) number of shares to be transferred;
(b) purchase price and/or other consideration for the intended transfer;
(c) due date of the purchase price and/or other consideration; and
(d) representations, warranties, indemnities etc. to be given by the transferring shareholder.
Art. 10.2. If a shareholder has delivered a Transfer Notice to the other shareholder, such other shareholder shall be
entitled to purchase the shares offered by the transferring shareholder on the same terms and conditions as stated in the
Transfer Notice within a time period of 4 (four) weeks after receipt of the Transfer Notice (the “Right of First Refusal”).
The Right of First Refusal shall be exercised by notice to the transferring shareholder.
Art. 10.3. If (i) the procedures as set forth in Article 9 and in this Article 10 have been observed properly by the
relevant transferring shareholder, (ii) the other shareholder has not purchased the offered shares and (iii) no transfer
restrictions according to the provisions of the Arrangement apply, the relevant transferring shareholder may within the
following two (2) months sell and transfer, subject to Article 8 and Article 9, the shares to a purchaser on conditions not
more favourable for the purchaser than those notified in the Transfer Notice.
Art. 10.4. In order to ensure compliance with the procedures as set forth in this Article 10, the relevant transferring
shareholder shall submit a certified copy of the executed share purchase agreement to the other shareholders.
Art. 11. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be sha-
reholders.
They are appointed and removed from office by a decision of the general meeting of shareholders (adopted by sha-
reholders representing more than half (50%) of the Company's share capital), which determines their powers and the
43645
L
U X E M B O U R G
term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers
may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers eight (8) days at least in advance
of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several
similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar
means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively signed, certified or an extract thereof may
be issued under the joint signature of any two managers.
Art. 12. Management Powers, Binding signature. Subject to article 6, the sole manager or as the case may be the board
of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform
all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by
the law or by the articles of association to the general meeting or as may be provided in an Arrangement (if any), and
subject to article 6, shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to
act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided in an
Arrangement (if any), or as may be provided herein (including article 6).
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the signature of any two managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person
or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only a sole manager),
or the board of managers or by any two managers (including by way of representation).
Art. 13. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares in the issued share capital he owns and may validly act at any meeting of shareholders
through a special proxy.
Art. 14. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail or overnight courier service to shareholders
to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date
of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without
prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days in advance of the effective date of
the resolution (subject to the required majority having been obtained) by registered mail or overnight courier service.
The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions
but at the earliest eight (8) days after having been sent to all shareholders (or if later, subject to the satisfaction of the
majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without
prior notice.
Except if a higher majority is required by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved
by shareholders representing more than half of the issued share capital; provided that (ii) decisions to approve or authorise
a reserved matter pursuant to article 6 shall only be validly adopted if approved by all shareholders representing all (100%)
of the issued share capital, provided however, that this shall not apply in relation to such measures listed in Annex 1 to
these articles of association which shall form part of these articles of association.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first
Tuesday of the month of June at 11:00 of each year. If such day is not a Bank Working Day, the meeting shall be held on
the immediately following Bank Working Day.
43646
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on the last day of the month
of December of the same year.
Art. 16. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 17. Distributions.
Art. 17.1. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases
to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 17.2. Dividends and other distributions shall be made pro rata to the proportion of the shareholders' shares in
the issued share capital. If and as far as, however, a shareholder has contributed to the Company more equity (other than
the subscribed issued share capital) than the other shareholders (e.g. by share premium, payments into the capital reserve,
contributions in kind to the Company or subsidiaries, etc.) (“Investment”), all dividends and other distributions shall be
made primarily to such shareholder until his Investments have been completely compensated.
Art. 18. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
After all debts and liabilities of the Company are fully paid or duly provisioned for, any surplus assets may be distributed
to the shareholders under application of the principles set forth in Article 17.2 which shall apply mutatis mutandis to the
distribution of any liquidation proceeds.
Art. 19. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915, as amended, on
commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 20. Applicable Law. For anything not dealt with in the articles of association, the shareholders refer to the relevant
legislation.
Art. 21. Arbitration. All disputes between the shareholders arising out of or in connection with these articles of
association, its completion or implementation shall be conclusively decided pursuant to the rules of arbitration of the
International Chamber of Commerce (ICC), Paris, in its respective applicable version at that point in time, with the
exclusion of recourse to the courts of law. The location of the arbitration proceedings shall be Zurich, Switzerland. The
arbitrators shall be appointed in accordance with the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce
(ICC), Paris. The language of the arbitration proceedings shall be English, although means of evidence may be presented
also in German. The arbitrators have no authority to award punitive damages or any other damages not measured by the
prevailing party's actual damages, and may not, in any event, make any ruling, finding or award that does not conform to
the terms and conditions of this articles of association and the Arrangement (if any).
As far as compulsory statutory law requires the decision upon a matter out of or in connection with this Agreement
or its execution by a court of law, the exclusive place of jurisdiction shall be Luxembourg.
Art. 22. Interpretation. In case of any different interpretation of the articles of association in German and English
language, the English wording shall prevail.
Annex 1
The following matters shall not require the prior authorisation or approval by the general meeting of shareholders
pursuant to Article 6(c):
1. Any sale, lease, transfer or other disposition (in a single transaction or series of related transactions) of (i) the real
estate owned by the Company or hereditary building rights, (ii) any line of business or operations (whether by sale of
assets or otherwise), (iii) all or substantially all of the property or assets of the Company, or (iv) any sale of a stake in a
subsidiary of the Company, provided that such action is implemented after 7 September 2015.
2. Any approval or modification of the annual capital and operating budget of the Company.
43647
L
U X E M B O U R G
3. Any acquisition by the Company (in a single transaction or a series of related transactions) of (i) any assets or
property with an aggregate value in excess of EUR 2,000,000, or (ii) any company, line of business or operations (whether
by purchase of shares, merger or otherwise), to the extent such acquisitions are related to the existing business of the
Company.
4. (i) The creation, incurrence or assumption of any indebtedness in excess of EUR 2,000,000 and (ii) any loans or
advances to, guarantees for the benefit of, or other investments in any other person (other than a wholly owned subsidiary
of the Company), other than in the ordinary course of business or provided for in the budget or to secure liquidity for
the ordinary business operation.
5. File a voluntary petition in bankruptcy, or a petition or an answer seeking reorganization or an arrangement with
creditors, or to take advantage of any bankruptcy, reorganization, insolvency, readjustment of debt, dissolution or liqui-
dation laws or statutes, or an answer admitting the material allegations of a petition filed against the Company, as the
case may be, in any proceeding under any such law, unless such action is required under mandatory applicable law.
6. Engage in any business other than (i) the current business of the Company or (ii) a natural extension thereof.
7. Make any material change in accounting policies or reporting practices, except as required by generally accepted
accounting principles as in effect in the Company's jurisdiction from time to time, consistently applied.
8. Enter into any agreement materially restricting the right of the Company to conduct business, other than in the
ordinary course of business.
9. Enter into any agreement or arrangement described in Nos. 1 through 8 above.
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said proxyholders of the persons appearing signed together with the notary the
present deed.
A German translation follows:
Im Jahr zweitausenddreizehn, den sechzehnten Dezember.
Vor uns Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Amtssitz im Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Wird abgehalten, eine außerordentliche Gesellschaftergeneralversammlung der Köln, Breite Straße 103-105 Beteili-
gung A S.à r.l. (fortan, die "Gesellschaft"), eine societe à responsabilité limitée, gegründet und bestehend unter den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR
12,500) mit Gesellschaftssitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch
Urkunde des Notars Maitre Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 12. Dezember
2012, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 6. Februar 2013 unter Nummer 286, ein-
getragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 173650.
Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.
Die Versammlung wurde unter Vorsitz von Herrn Régis Galiotto, Beamter, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende ernannte als Sekretär und die Versammlung bestimmte als Stimmzähler Frau Solange Wolter-Schieres,
Beamtin, beruflich ansässig in Luxemburg.
Die Versammlung demnach ordnungsgemäß zusammengesetzt, ersucht der Vorsitzende dem Notar folgende Erklä-
rungen darzulegen:
I. Dass die Tagesordnung der Versammlung folgende ist:
<i>Agendai>
1. Entscheidung die Sprache der Satzung der Gesellschaft von Deutsch auf Englisch gefolgt von einer deutschen Über-
setzung zu ändern und Entscheidung, dass die englische Fassung Vorrang haben soll;
2. Entscheidung den Gesellschaftszweck der Gesellschaft abzuändern und fortan wie folgt zu lauten:
"Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form, in Luxemburg und im Ausland, oder
von anderen Unternehmen, der Erwerb durch Kauf, durch Zeichnung oder auf eine andere Art sowie die Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder auf eine andere Art und Weise von Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen
und anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung, Entwicklung und das Management des Portfolios
der Gesellschaft. Die Gesellschaft darf auch Beteiligungen an Personengesellschaften halten und ihr Geschäft durch lu-
xemburgische oder ausländische Niederlassungen führen. Die Gesellschaft darf direkt oder durch eine oder mehrere
Tochtergesellschaften oder auf eine andere Art und Weise in geistiges Eigentum oder ähnliche Rechte sowie in Grund-
stucke, die in Luxemburg oder im Ausland gelegen sind, investieren, sowie diese halten, managen oder kontrollieren.
43648
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft darf auf jegliche Art und Weise Anleihen und Schuldscheine übernehmen und Anleihen und Schuld-
scheine durch privates Platzieren ausgeben. Die Gesellschaft darf auf übliche Weise (durch Darlehen, Vorauszahlungen,
Sicherheiten, Wertpapiere oder auf andere Weise) Gesellschaften oder andere Unternehmen, an denen sie beteiligt ist
oder die Teil der Gruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, unterstützen (dies beinhaltet auch Mutter- und Schwes-
tergesellschaften), Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und alle Handlungen vornehmen, die sie für die
Erreichung und Entwicklung ihrer Zwecke als nützlich erachtet.
Die Gesellschaft darf zudem alle kommerziellen, technischen und finanziellen oder anderen Maßnahmen vornehmen,
die direkt oder indirekt mit den Bereichen zusammenhängen, um die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen.";
und
3. Entscheidung die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen;
4. Verschiedenes.
II. Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die Vollmachtträger der vertretenen Gesellschafter und die
Anzahl ihrer Anteile in einer Anwesenheitsliste gezeigt werden. Diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaftern, den
Vollmachtträgern der vertretenen Gesellschafter und durch das Büro der Versammlung unterschrieben, werden dieser
Urkunde beigefügt und mit dieser gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden hinterlegt.
Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden "ne varietur" von den erschienenen Parteien initialisiert und
werden dieser Urkunde ebenfalls beigefügt.
III. Dass nach Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital bei der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder
vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass sie eine ordnungsgemäße Mitteilung
erhalten haben und Kenntnis der Tagesordnung vor dieser Versammlung hatten und keine weiteren Einberufungsforma-
litäten notwendig waren.
IV. Dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß begründet ist und demnach über alle Punkte der Tagesordnung
gültig beraten kann.
Die Gesellschaftergeneralversammlung hat den unterzeichnenden Notar ersucht folgende Beschlüsse aufzunehmen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaftergeneralversammlung beschließt einstimmig die Sprache der Satzung der Gesellschaft von Deutsch
auf Englisch gefolgt von einer deutschen Übersetzung abzuändern. Die englische Fassung der Satzung der Gesellschaft soll
Vorrang haben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaftergeneralversammlung beschließt einstimmig den Gesellschaftszweck der Gesellschaft abzuändern;
dieser lautet fortan wie folgt:
"Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form, in Luxemburg und im Ausland, oder
von anderen Unternehmen, der Erwerb durch Kauf, durch Zeichnung oder auf eine andere Art sowie die Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder auf eine andere Art und Weise von Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen
und anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung, Entwicklung und das Management des Portfolios
der Gesellschaft. Die Gesellschaft darf auch Beteiligungen an Personengesellschaften halten und ihr Geschäft durch lu-
xemburgische oder ausländische Niederlassungen führen. Die Gesellschaft darf direkt oder durch eine oder mehrere
Tochtergesellschaften oder auf eine andere Art und Weise in geistiges Eigentum oder ähnliche Rechte sowie in Grund-
stucke, die in Luxemburg oder im Ausland gelegen sind, investieren, sowie diese halten, managen oder kontrollieren.
Die Gesellschaft darf auf jegliche Art und Weise Anleihen und Schuldscheine übernehmen und Anleihen und Schuld-
scheine durch privates Platzieren ausgeben. Die Gesellschaft darf auf übliche Weise (durch Darlehen, Vorauszahlungen,
Sicherheiten, Wertpapiere oder auf andere Weise) Gesellschaften oder andere Unternehmen, an denen sie beteiligt ist
oder die Teil der Gruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, unterstützen (dies beinhaltet auch Mutter- und Schwes-
tergesellschaften), Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und alle Handlungen vornehmen, die sie für die
Erreichung und Entwicklung ihrer Zwecke als nützlich erachtet.
Die Gesellschaft darf zudem alle kommerziellen, technischen und finanziellen oder anderen Maßnahmen vornehmen,
die direkt oder indirekt mit den Bereichen zusammenhängen, um die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen.".
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaftergeneralversammlung beschließt einstimmig die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu fassen
und die vorangegangen Beschlüsse umzusetzen. Die Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:
Art. 1. Bezeichnung. Die derzeitigen und die künftigen Gesellschafter haben sich zu einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A S.à r.l. (die "Ge-
sellschaft") zusammengeschlossen. Die Gesellschaft unterliegt dieser Satzung sowie den einschlägigen Rechtsvorschriften.
Art. 2. Unternehmensgegenstand. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeglicher Form, in Lu-
xemburg und im Ausland, oder von anderen Unternehmen, der Erwerb durch Kauf, durch Zeichnung oder auf eine andere
Art sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf eine andere Art und Weise von Aktien, Anleihen, Schuld-
43649
L
U X E M B O U R G
verschreibungen, Schuldscheinen und anderen Wertpapieren jeglicher Art, und der Besitz, die Verwaltung, Entwicklung
und das Management des Portfolios der Gesellschaft. Die Gesellschaft darf auch Beteiligungen an Personengesellschaften
halten und ihr Geschäft durch luxemburgische oder ausländische Niederlassungen führen. Die Gesellschaft darf direkt
oder durch eine oder mehrere Tochtergesellschaften oder auf eine andere Art und Weise in geistiges Eigentum oder
ähnliche Rechte sowie in Grundstücke, die in Luxemburg oder im Ausland gelegen sind, investieren, sowie diese halten,
managen oder kontrollieren.
Die Gesellschaft darf auf jegliche Art und Weise Anleihen und Schuldscheine übernehmen und darf Anleihen und
Schuldscheine durch privates Platzieren ausgeben. Die Gesellschaft darf auf übliche Weise (durch Darlehen, Vorauszah-
lungen, Sicherheiten, Wertpapiere oder auf andere Weise) Gesellschaften oder andere Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist oder die Teil der Gruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, unterstützen (dies beinhaltet auch Mutter- und
Schwestergesellschaften), Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und alle Handlungen vornehmen, die sie für
die Erreichung und Entwicklung ihrer Zwecke als nützlich erachtet.
Die Gesellschaft darf zudem alle kommerziellen, technischen und finanziellen oder anderen Maßnahmen vornehmen,
die direkt oder indirekt mit den Bereichen zusammenhängen, um die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz darf
durch einen Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschafter an einen anderen Ort in
dem Großherzogtum Luxemburg verlegt werden, wobei die Vorgaben, die für Änderungen der Satzung vorgesehen sind,
beachtet werden müssen.
Die Geschäftsanschrift des Sitzes darf innerhalb der Gemeinde Niederanven durch eine Entscheidung des Geschäfts-
führers bzw. des Geschäftsführungsrates verlegt werden.
Die Gesellschaft darf Büros und Zweigniederlassungen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.
Für den Fall, dass der oder die Geschäftsführer feststellen sollten, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche
oder soziale Entwicklungen eingetreten sind oder drohen, die die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Kommunikation zwischen dem betreffenden Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen werden, darf der Sitz
vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese ungewöhnlichen Umstände vollständig beendet sind; solche vorü-
bergehenden Maßnahmen dürfen keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft haben, die, ungeachtet der
vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Maßnahmen
werden von dem oder den Geschäftsführer(-n) ergriffen und von ihm/ihnen allen Interessenten gegenüber bekannt ge-
macht.
Art. 5. Gesellschaftskapital und Gesellschafter. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölf-
tausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und ist eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile mit
einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1). Die Rechte und Verpflichtungen aus den Gesellschaftsanteilen bestimmen
sich nach der Satzung und nach den zwischen den Gesellschaftern in einer Gesellschaftervereinbarung, einem Rahmen-
vertrag oder einem vergleichbaren Vertrag getroffenen Vereinbarungen (sofern solche getroffen wurden) (eine “Schuld-
rechtliche Vereinbarung“). Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft darf durch einen Beschluss der Gesellschafter, der
den Anforderungen für eine Satzungsänderung entspricht, erhöht oder herabgesetzt werden.
Jegliches verfügbares Agio ist ausschüttungsfähig.
Art. 6. Zustimmungspflichtige Geschäfte. Die folgenden Maßnahmen bedürfen immer der vorherigen Einwilligung oder
der Genehmigung der Gesellschafterversammlung, in Form eines Beschlusses gemäß Artikel 14 Abs. 4 (ii):
(a) jede Änderung der Satzung, einschließlich Änderungen des Stammkapitals;
(b) jede Einführung von nicht verhältniswahrenden Gewinnverteilungsrechten, bei denen die Gewinne unter den Ge-
sellschaftern nicht proportional zu ihrer Kapitalbeteiligung in der Gesellschaft verteilt werden sollen, sofern dies nicht
bereits in dieser Satzung, insbesondere gemäß Artikel 17.2, vorgesehen ist;
(c) jede Umwandlung der Gesellschaft, einschließlich einer Verschmelzung, Formwechsel, Abspaltungen oder andere
Verbindungen von Unternehmen, durch eine oder mehrere zusammenhängende Transaktionen;
(d) die Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;
(e) der Rückerwerb oder die Einziehung von Anteilen oder anderen Eigenkapitalmaßnahmen der Gesellschaft; und
(f) die Zustimmung zu Unternehmens- und/oder Beherrschungsverträgen, durch die die Gesellschaft verpflichtet wird,
von einer anderen Gesellschaft beherrscht zu werden, alle oder alle wesentlichen Gewinne der Gesellschaft an eine andere
Gesellschaft abzuführen oder die Verluste einer anderen Gesellschaft auszugleichen; dies gilt jedoch nicht für derartige
Verträge zwischen der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften.
Art. 7. Übertragungen von Anteilen. Anteilsübertragungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung und der Beachtung der Bestimmungen von Schuldrechtlichen Vereinbarungen (sofern solche getroffen
wurden).
Zustimmende Gesellschafterbeschlüsse zur Übertragung von Gesellschaftsabteilen sind nur wirksam, wenn alle Ge-
sellschafter, die 100% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals repräsentieren, zugestimmt haben. Abweichend hiervon
43650
L
U X E M B O U R G
benötigen Anteilsübertragungen nur der Zustimmung von Gesellschafter, die mindestens 75% des ausgegebenen Gesell-
schaftskapitals repräsentieren, wenn die Bestimmungen der Artikel 9 und Artikel 10 eingehalten sind.
Jede Übertragung von Gesellschaftsanteilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Satzung oder
den Bestimmungen einer Schuldrechtlichen Vereinbarung (sofern solche getroffen wurden) erfolgt, ist unwirksam und ist
nicht zu berücksichtigen.
Art. 8. Mitveräußerungspflicht.
Art. 8.1. Wenn ein oder mehrere Gesellschafter, der oder die gemeinsam mehr als 50% des ausgegebenen Gesell-
schaftskapitals hält bzw. halten, sämtliche oder einen Teil seiner bzw. ihrer Gesellschaftsanteile an eine Partei, die nicht
ein verbundenes Unternehmen gemäß des Artikel 309 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in
der jeweils geltenden Fassung ist („Dritterwerber“), verkaufen und übertragen möchte(-n) (jeder solche Verkauf ein
„Mitveräußerungspflicht-Verkauf“ und der bzw. die Gesellschafter, der bzw. die einen solchen Mitveräußerungspflicht-
Verkauf vornehmen möchte(-n) jeweils ein „Anbietender Gesellschafter“), hat der Anbietende Gesellschafter das Recht,
von den übrigen Gesellschaftern („Mitveräußerungspflicht-Gesellschafter“) mittels schriftlicher Mitteilung („Mitveräuße-
rungspflicht-Mitteilung“) vor Vollzug des Mitveräußerungspflicht-Verkauf zu verlangen, dass diese binnen 10 Bankarbeits-
tagen (ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag an dem die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, planmäßig für das Publikum
geöffnet sind) nach Erhalt der Mitveräußerungspflicht-Mitteilung durch alle Gesellschafter ebenso sämtliche ihrer Gesell-
schaftsanteile oder einen Anteil ihrer Geschäftsanteile im gleichen Verhältnis (pro rata) wie der Anbietende Gesellschafter
an den Dritterwerber verkaufen und übertragen.
Art. 8.2. Der Verkauf und die Übertragung der von dem Mitveräußerungspflicht-Gesellschafter gemäß Mitveräuße-
rungspflicht-Mitteilung zu veräußernden Gesellschaftsanteile hat an denselben Dritterwerber und zu denselben Konditi-
onen, einschließlich des Verkaufspreises pro Gesellschaftsanteil (die Konditionen sind in der Mitveräußerungspflicht-
Mitteilung zu benennen), wie in der Mitveräußerungspflicht-Mitteilung genannt zu erfolgen, jedoch mit der Maßgabe, dass
der Mitveräußerungspflicht-Gesellschafter (i) nicht verpflichtet ist, andere als übliche Gewährleistungspflichten oder Ga-
rantien zu Eigentum und Verfügungsbefugnis hinsichtlich der gemäß Mitveräußerungspflicht-Mitteilung zu verkaufenden
Gesellschaftsanteile zu übernehmen, (ii) im Zusammenhang mit dem Verkauf keinen Wettbewerbs- oder Abwerbebe-
schränkungen unterliegt, (iii) mit keiner anderen am Verkauf beteiligten Partei gesamtschuldnerisch haftet, und (iv) unter
keinen Umständen mit einem höheren Betrag haftet, als mit den tatsächlich vom Dritterwerber erhaltenen Verkaufser-
lösen.
Art. 8.3. Die Verpflichtung des Mitveräußerungspflicht-Gesellschafters, seine Gesellschaftsanteile gemäß der Mitver-
äußerungspflicht-Mitteilung zu verkaufen und zu übertragenen, wenn der jeweilige Verkauf und die jeweilige Übertragung
nicht binnen 90 Tagen (bzw. 120 Tagen wenn eine Kartellfreigabe erforderlich ist) nach Erhalt der Mitveräußerungspflicht-
Mitteilung durch alle Gesellschafter vollzogen wurde.
Art. 9. Mitveräußerungsrecht.
Art. 9.1. Wenn ein Gesellschafter seine Gesellschaftsanteile veräußert (ein veräußernder Gesellschafter „Veräußernder
Gesellschafter“, eine solche Veräußerung „Mitveräußerungsrecht-Verkauf“), hat der Veräußernde Gesellschafter dafür
Sorge zu tragen, dass (i) die übrigen Gesellschafter der Gesellschaft („Mitveräußerungsrecht-Gesellschafter“) ihre Ge-
sellschaftsanteile im gleichen Verhältnis mitveräußern können, zu einem Verkaufspreis pro Gesellschaftsanteil wie der
Verkaufspreis gemäß dem Mitveräußerungsrecht-Verkauf und im Übrigen zu Bedingungen, die nicht nachteiliger für den
Mitveräußerungsrecht-Gesellschafter sind als für den Veräußernden Gesellschafter gemäß dem Mitveräußerungsrecht-
Verkauf (jeder Verkauf in diesem Sinne ein „Mitveräußerungsverkauf“), (ii) der Kaufpreis, der gemäß dem Mitveräuße-
rungsverkauf an den Mitveräußerungsrecht-Gesellschafter zu zahlen ist, vollständig geleistet wird, vorausgesetzt, dass der
Mitveräußerungsrecht-Gesellschafter (A) nicht verpflichtet ist, andere als übliche Gewährleistungspflichten oder Garan-
tien zu Eigentum und Verfügungsbefugnis hinsichtlich der zu verkaufenden Gesellschaftsanteile zu übernehmen, (B) im
Zusammenhang mit dem Verkauf keinen Wettbewerbs- oder Abwerbebeschränkungen unterliegt, (C) mit keiner anderen
am Verkauf beteiligten Partei gesamtschuldnerisch haftet, und (D) unter keinen Umständen mit einem höheren Betrag
haftet, als mit den tatsächlich erhaltenen Verkaufserlösen.
Art. 9.2. Die Verpflichtungen des Veräußernden Gesellschafters gemäß diesem Artikel 9 entfallen in Bezug auf den
jeweiligen Mitveräußerungsrecht-Verkauf, wenn innerhalb von vier (4) Wochen, ab dem Tag, an dem der Mitveräuße-
rungsrecht-Gesellschafter von dem Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen sowie dem tatsächlichen Verkaufspreis
erfahren hat, den Veräußernden Gesellschafter nicht informiert hat, dass er den Mitveräußerungsverkauf ausüben möchte.
Art. 10. Vorkaufsrecht.
Art. 10.1. Ein Gesellschafter, der Gesellschaftsanteile veräußern möchte, hat dies den anderen Gesellschaftern vorher
schriftlich mitzuteilen („Verkaufsmitteilung“). Die Verkaufsmitteilung muss mindestens die folgenden Informationen ent-
halten:
(a) Anzahl der zu übertragenden Gesellschaftsanteile;
(b) Verkaufspreis bzw. sonstige Gegenleistung;
(c) Fälligkeit für den Verkaufspreis bzw. sonstige Gegenleistungen;
43651
L
U X E M B O U R G
(d) die vom veräußernden Gesellschafter zu übernehmenden Gewährleistungen, Garantien, Freistellungserklärungen
und ähnlichen Verpflichtungen.
Art. 10.2. Hat ein Gesellschafter eine Verkaufsmitteilung an die anderen Gesellschafter übersandt, so sind die anderen
Gesellschafter berechtigt, binnen vier (4) Wochen nach Erhalt der Veräußerungsmitteilung die vom veräußernden Ge-
sellschafter angebotenen Geschäftsanteile zu denselben Konditionen zu erwerben, wie in der Veräußerungsmitteilung
mitgeteilt („Vorkaufsrecht“). Das Vorkaufsrecht wird durch Mitteilung gegenüber dem veräußernden Gesellschafter aus-
geübt.
Art. 10.3. Wenn (i) die Bestimmungen gemäß Artikel 9 und Artikel 10 eingehalten wurden, (ii) das Vorkaufsrecht nicht
ausgeübt wird und (iii) keine Verfügungsbeschränkungen gemäß Bestimmungen der Schuldrechtlichen Vereinbarungen zur
Anwendung kommen, ist der die Veräußerung beabsichtigenden Gesellschafter berechtigt, vorbehaltlich der Regelungen
des Artikel 8 und Artikel 9, die betreffenden Gesellschaftsanteile innerhalb von zwei (2) Monaten an den in der Ver-
kaufsmitteilung genannten Erwerber zu Konditionen, die für den Verkäufer nicht günstiger sind als die in der Verkaufs-
mitteilung genannten Bestimmungen, zu verkaufen und zu übertragen.
Art. 10.4. Um die Einhaltung der Bestimmung dieses Artikel 10 zu gewährleisten, ist der veräußernde Gesellschafter
verpflichtet, den anderen Gesellschaftern jeweils eine beglaubigte Abschrift der Veräußerungsurkunde zu übergeben.
Art. 11. Geschäftsführer. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter der Ge-
sellschaft sein müssen.
Sie werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen (der Beschluss muss von
Gesellschaftern, die mindestens 50% des Gesellschaftskapitals repräsentieren, gefasst werden); dieser Beschluss legt auch
die Rechte der Geschäftsführer und Laufzeit der Bestellung fest. Sofern keine Amtszeit bestimmt wird, werden die Ge-
schäftsführer auf unbestimmte Zeit bestellt. Die Geschäftsführer dürfen wiederbestellt werden; ihre Bestellung darf jedoch
mit oder ohne Grund (ad nutum) jederzeit widerrufen werden.
Sofern es mehr als einen Geschäftsführer gibt, bilden die Geschäftsführer gemeinsam den Geschäftsführungsrat. Jeder
Geschäftsführer darf an jedem Treffen des Geschäftsführungsrates mittels einer Konferenzschaltung oder einer ver-
gleichbaren Kommunikationsart teilnehmen, die es allen Teilnehmern des Treffens ermöglicht, sich gegenseitig zu hören
und miteinander zu kommunizieren. Ein Treffen darf auch nur mittels Telefonkonferenz abgehalten werden. Die Teilnahme
an oder das Abhalten einer Versammlung auf dem vorgenannten Weg steht einer persönlichen Teilnahme an oder dem
Abhalten einer persönlichen Versammlung gleich. Geschäftsführer dürfen sich bei einem Treffen des Geschäftsführungs-
rates durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, wobei die Anzahl der Vollmachten und Stimmen, die einem
Geschäftsführer gewährt werden, nicht beschränkt ist.
Eine schriftliche Mitteilung jedes Treffens des Geschäftsführungsrates muss den Geschäftsführern spätestens acht (8)
Tage vor dem für das Treffen vorgesehenen Tag übermittelt werden, abgesehen von Notfällen, bei denen der Grund des
Notfalls und der Anlass in der Mitteilung anzugeben sind. Auf die Mitteilung darf verzichtet werden, sofern alle Ge-
schäftsführer schriftlich, telegrafisch, durch Telegramm, Telex, E-Mail oder Fax oder auf einem anderen vergleichbaren
Kommunikationswege zustimmen. Einer besonderen Einberufung bedarf es nicht, wenn das Treffen des Geschäftsfüh-
rungsrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die in einem früheren Beschluss des Geschäftsführungsrates
bestimmt worden sind.
Entscheidungen des Geschäftsführungsrates werden wirksam mit Zustimmung der Mehrheit der Geschäftsführer der
Gesellschaft (einschließlich durch Vertretung) getroffen. Der Geschäftsführungsrat darf auch einstimmig Beschlüsse auf
einem oder mehreren Dokumenten im Umlaufverfahren fassen, sofern die Zustimmung schriftlich, telegrafisch oder per
Fax oder auf einem vergleichbaren Kommunikationswege zum Ausdruck gebracht wird. Die Gesamtheit ordnungsgemäß
ausgefertigter und zirkulierter Dokumente stellen den Beweis für den Beschluss dar.
Beschlüsse der Geschäftsführer, einschließlich im Umlaufverfahren, können in schlüssiger Form unterzeichnet, bestätigt
oder Auszüge davon ausgefertigt werden durch gemeinsame Zeichnung von zwei Geschäftsführern.
Art. 12. Geschäftsführung, Vertretungsbefugnis. Vorbehaltlich der Regelungen des Artikel 6, ist/sind der oder die
Geschäftsführer mit umfassender Befugnis ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu führen und alle Verfügungen und
alle Verwaltungshandlungen zu genehmigen und/oder vorzunehmen, die im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft
stehen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich vom Gesetz oder von der Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen oder die in einer Schuldrechtlichen Vereinbarung (sofern eine solche getroffen wurde) geregelt sind, sind,
vorbehaltlich der Regelungen des Artikel 6, dem Geschäftsführer bzw. dem Geschäftsführungsrat zugewiesen. Gegenüber
Dritten verfügt der Geschäftsführer bzw. der Geschäftsführungsrat über weiteste Befugnisse im Namen der Gesellschaft
in allen Fällen zu handeln und alle Handlungen und Maßnahmen betreffend die Gesellschaft vorzunehmen, ihnen zuzu-
stimmen und sie zu genehmigen, sofern diese nicht durch Gesetz oder Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
oder in einer Schuldrechtlichen Vereinbarung (sofern eine solche getroffen wurde) oder hierin geregelt sind (dies bein-
haltet auch Artikel 6).
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, und im Falle eines Geschäftsführungsrates
durch die Unterschrift zweier Geschäftsführer vertreten. Die Gesellschaft wird auch wirksam durch die Unterschrift einer
oder mehrerer Personen vertreten, denen die Befugnis zur Unterschrift durch den alleinigen Geschäftsführer (sofern es
43652
L
U X E M B O U R G
nur einen Geschäftsführer gibt) oder durch den Geschäftsführungsrat oder durch zwei Geschäftsführer (einschließlich im
Wege der Stellvertretung) übertragen worden ist.
Art. 13. Stimmrechte. Jeder Gesellschafter ist befugt, an gemeinsamen Entscheidungen mitzuwirken. Die Stimmrechte
eines Gesellschafters entsprechen der Anzahl der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile am ausgegebenen Gesell-
schaftskapital. Ein Gesellschafter kann sich in Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.
Art. 14. Gesellschafterversammlungen. Entscheidungen der Gesellschafter werden schriftlich (soweit das Gesetz dies
gestattet) oder in Versammlungen in der Form und mit solchen Mehrheiten gefasst, wie sie das luxemburgische Gesell-
schaftsrecht vorsieht. Jede ordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft oder jeder wirksame schriftliche
Beschluss repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.
Versammlungen sind durch eine Einberufungsmitteilung einzuberufen, die per Einschreiben oder Übernacht-Kurier den
Gesellschaftern an ihre Adresse, wie sie in der von der Gesellschaft geführten Gesellschafterliste steht, mindestens acht
(8) Tage vor dem Tag der Versammlung zuzustellen ist. Die Gesellschafterversammlung kann auch ohne Einberufung
abgehalten werden, wenn das gesamte Gesellschaftskapital in der Gesellschafterversammlung vertreten ist.
Im Falle einer schriftlichen Beschlussfassung ist der Wortlaut der Beschlüsse den Gesellschaftern an ihre jeweilige
Adresse, wie sie in der von der Gesellschaft geführten Gesellschafterliste steht, mindestens acht (8) Tage vor dem Tag
der Wirksamkeit des Beschlusses (vorbehaltlich einer Annahme durch die erforderliche Mehrheit) per Einschreiben oder
Übernacht-Kurier zu übersenden. Nach der Zustimmung mit der erforderlichen Mehrheit werden die Beschlüsse so wie
sie das Gesetzt für Kollektiventscheidungen vorsieht, wirksam, frühestens jedoch acht (8) Tage nachdem die Beschlüsse
an alle Gesellschafter übersandt worden sind (oder, wenn später, an dem Tage, den der Beschluss vorsieht). Einstimmige
schriftliche Beschlüsse dürfen jederzeit ohne vorherige Mitteilung gefasst werden.
Sofern nicht das Gesetz eine höhere Mehrheit vorsieht, (i) werden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung wirksam
getroffen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals repräsentieren, zustimmen,
wobei (ii) Beschlüsse, die ein zustimmungspflichtiges Geschäft nach Artikel 6 gestatten, nur wirksam gefasst werden, wenn
alle Gesellschafter, die 100% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft repräsentieren, zustimmen, wobei
dies nicht für die in Annex 1 zu dieser Satzung aufgeführten Maßnahmen gilt; Annex 1 ist Teil dieser Satzung.
Für den Fall und solange die Gesellschaft mehr als 25 Gesellschafter hat, soll eine jährliche Gesellschafterversammlung
an dem ersten Dienstag im Juni um 11 Uhr eines jeden Jahres stattfinden. Sofern dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, soll
die Versammlung an dem darauf folgenden Bankarbeitstag stattfinden.
Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jedes Jahres und endet am letzten Tag des Monats
Dezember desselben Jahres.
Art. 16. Jahresabschlüsse. Nach jedem Ende eines Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss durch den Geschäftsführer
bzw. den Geschäftsführungsrat aufgestellt.
Der Jahresabschluss steht den Gesellschaftern in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 17. Erlösverteilungen.
Art. 17.1. Aus dem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) in das gesetzliche Rücklagenkonto gebucht. Diese Rückla-
genpflicht endet, sobald die auf dem gesetzlichen Rücklagenkonto verbuchten Mittel 10 Prozent (10%) des ausgegebenen
Gesellschaftskapitals betragen.
Die Gesellschafter können über Ausschüttung von Zwischendividenden auf der Basis von seitens des Geschäftsführers
bzw. des Geschäftsführungsrates erstellten Zwischenabschlüssen, die ausreichende Mittel zur Ausschüttung vorsehen,
entscheiden, wenn der auszuschüttende Betrag nicht denjenigen Betrag übersteigt, der sich errechnet aus dem tatsäch-
lichen Gewinn des vergangenen Geschäftsjahres zuzüglich Gewinnvorträgen sowie ausschüttungsfähigen Rücklagen und
abzüglich Verlustvorträgen sowie auf gesetzliche Rücklagenkonten zu buchenden Mitteln.
Guthaben kann aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Agiorücklage kann an die Gesellschafter aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann bestimmen, dass Beträge aus der Agiorücklage in das gesetzliche Rückla-
genkonto zu buchen sind.
Art. 17.2. Gewinne und sonstige Ausschüttungen sind an die Gesellschafter anteilig nach ihren Anteilen am ausgege-
benen Geschäftskapital auszuschütten. Soweit aber ein Gesellschafter der Gesellschaft über die Zeichnung der Gesell-
schaftsanteile hinaus mehr Eigenkapital zur Verfügung gestellt hat als die übrigen Gesellschafter (z.B. in Form von Agio,
Einzahlungen in Rücklagen, Sacheinlagen in die Gesellschaft und in Tochtergesellschaften, etc.) („Investitionen“) sind Ge-
winne und sonstige Ausschüttungen solange vorrangig an diesen Gesellschafter zu leisten, bis seine Investitionen
vollständig zurückgeführt sind.
Art. 18. Auflösung. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen Liquidator oder mehrere
Liquidatoren durchgeführt, bei denen es sich um Gesellschafter handeln kann, aber nicht muss, und die von der Gesell-
schafterversammlung bestellt werden, die auch dessen/deren Befugnisse und Vergütung festlegt.
43653
L
U X E M B O U R G
Nachdem alle Schulden und sonstigen Verpflichtungen der Gesellschaft vollständig erfüllt sind oder für deren Erfüllung
Vorsorge getroffen wurde, werden alle verbleibenden Mittel an die Gesellschafter verteilt unter Berücksichtigung der in
Artikel 17.2. festgelegten Grundsätze, die auf Liquidationserlöse entsprechend anzuwenden sind.
Art. 19. Einziger Gesellschafter. Wenn und solange ein einziger Gesellschafter sämtliche Gesellschaftsanteile hält, be-
steht die Gesellschaft als Alleingesellschafter-Gesellschaft gemäß Artikel 179(2) des Gesetzes über Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung; in diesem Fall sind, unter anderem, Artikel 200-1 und 200-2 dieses
Gesetzes anwendbar.
Art. 20. Anwendbares Recht. Soweit nicht in dieser Satzung geregelt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 21. Schiedsvereinbarung. Alle Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern, die sich aus oder im Zusammenhang
mit dieser Satzung, ihrem Zustandekommen oder ihrer Durchführung ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung
der Internationalen Handelskammer (ICC), Paris, in ihrer jeweils geltenden Fassung unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtsweges endgültig entschieden. Der Ort des schiedsgerichtlichen Verfahrens ist Zürich, Schweiz. Die Schiedsrichter
werden gemäß den Regelungen der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handeiskammer (ICC), Paris ernannt.
Das schiedsgerichtliche Verfahren wird in englischer Sprache durchgeführt, wobei Beweismittel auch in deutscher Sprache
vorgelegt werden dürfen. Die Schiedsrichter sind nicht berechtigt, Strafschadensersatz oder anderen Schadensersatz, der
über den tatsächlichen Schaden der obsiegenden Partei hinausgeht, zuzusprechen, oder eine Entscheidung, eine Feststel-
lung oder einen Schiedsspruch zu treffen, die nicht im Einklang mit dieser Satzung oder der Schuldrechtlichen Vereinbarung
(sofern eine solche getroffen wurde) stehen.
Verlangt zwingendes Recht die Entscheidung einer Angelegenheit aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder
seiner Durchführung durch ein ordentliches Gericht, ist der Gerichtsstand Luxemburg.
Art. 22. Auslegung. Im Falle unterschiedlicher Auslegung der vorstehenden Texte in deutscher und in englischer Spra-
che, ist die englische Fassung maßgeblich.
Annex 1
Die folgenden Beschlussgegenstände bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht eines Gesellschafterbeschlusses nach Artikel
6(c):
1. Verkauf, Vermietung, Übertragung oder andere Verfügung (als Einzelmaßnahme oder einer Mehrzahl von zusam-
mengehörenden Geschäften) von: (i) Grundbesitz oder Erbbaurechten, (ii) Geschäftsbereichen (im Wege der Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen oder in anderer Weise) oder (iii) aller oder aller wesentlichen Vermögensgegenstände,
oder (iv) jeder Verkauf von Anteilen an Tochtergesellschaften, sofern eine solche Maßnahme jeweils nach dem 7. Sep-
tember 2015 durchgeführt wird.
2. Jede Genehmigung oder Änderung des jährlichen Kapitals und des Jahresbudgets der Gesellschaft.
3. Erwerb (als Einzelmaßnahme oder einer Mehrzahl von zusammengehörenden Geschäften) von (i) Vermögensge-
genständen mit einem Wert von zusammengenommen mehr als EUR 2.000.000 oder (ii) Gesellschaften oder Geschäfts-
bereichen (gleich ob durch Anteilserwerb, Umwandlungsmaßnahme oder in anderer Weise), soweit ein solcher Erwerb
in Zusammenhang mit dem bestehenden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft steht.
4. (i) Die Eingehung oder Übernahme von Verbindlichkeiten über EUR 2.000.000 und (ii) Darlehen oder Vorleistungen
an, Sicherheiten zugunsten von oder andere Investitionen für Dritte (nicht im Alleineigentum stehende Tochtergesell-
schaften der Gesellschaft), außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs oder außerhalb der im Budget vorgesehenen
Mittel oder nicht zur Absicherung von Liquidität für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb.
5. Stellung eines freiwilligen Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Reorganisationsverfahrens oder Gläubi-
gervereinbarungen, oder Erlangung eines Vorteils aus Vorschriften betreffend Insolvenzverfahren, Reorganisationsmaß-
nahmen, Anpassungen von Verbindlichkeiten, Auflösung oder Liquidation, oder Einlassungen zu Behauptungen gemäß
einer Antragstellung gegenüber der Gesellschaft, je nach Fall, im Verfahren nach solchen Vorschriften, sofern nicht das
zwingende Recht eine bestimmte Maßnahme vorsieht.
6. Vornahme jeder anderen als (i) der gegenwärtigen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder (ii) einer Ausweitung
der Geschäftstätigkeit.
7. Wesentliche Änderung der Bilanzierung oder Veröffentlichungspraxis, außer diese sind nach allgemein anerkannten
Bilanzierungspraktiken der für die Gesellschaft geltenden Rechtsordnung von Zeit zu Zeit erforderlich.
8. Jede außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs getroffene Vereinbarung, welche die Befugnis der Gesellschaft
zur Vornahme ihrer Geschäftstätigkeit einschränkt.
9. Eingehung einer Verpflichtung zur Vornahme einer Handlung gemäß Nr. 1 bis 8.
Da sämtliche Punkte der Tagesordnung abgehandelt sind, ist die Versammlung demnach geschlossen.
Worüber die vorliegende Urkunde, in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde
erwähnt wird.
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der
erschienenen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; auf Anfrage
43654
L
U X E M B O U R G
der erschienenen Parteien und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Fassung, soll die
englische Fassung maßgeblich sein.
Das Dokument wurde den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen, dem Notar durch Name, Vorname,
zivilrechtlichen Status und Ansässigkeit bekannt, die besagten Bevollmächtigten der erschienenen Parteien unterzeichne-
ten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.
Gezeichnet: R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60129. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 12. Februar 2014.
Référence de publication: 2014022811/720.
(140027609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.
Castle 47 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 184.338.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of January;
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
BSREP International I(A) Holdings L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, company number MC-73329;
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name "Castle 47 S.à
r.l." (the Company), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and the present articles of association (the Articles).
Art. 2. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company, any assistance, loans, advances or guarantees, including a pledge of a subsidiary's securities to a subsidiary's
lenders; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
43655
L
U X E M B O U R G
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 4. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 5. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 6. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
II. Capital - Shares
Art. 7.1. The Company's capital is set thirteen thousand five hundred Euro (EUR 13,500), represented by two (2)
classes of shares as follows: twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (hereinafter referred to as the Or-
dinary Shares) and one thousand (1,000) mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend shares (hereinafter
referred to as the Mandatory Redeemable Preferred Shares, and together with the Ordinary Shares shall be referred to
as the Shares), with a par value of one Euro (EUR 1) each. The respective rights and obligations attached to each class of
Shares are set forth below. All Shares will be issued in registered form. Ordinary shares will generally be vested with
voting rights. Mandatory Redeemable Preferred Shares will not carry any voting rights to the extent permitted by the
Law and only as long as the Company has a sole shareholder. In case the Company has more than one shareholder, the
Mandatory Redeemable Preferred Shares will have one vote per share in the same manner as the Ordinary shares.
7.2. All the Shares are fully paid up.
7.3. In addition to the contributions to the Company in the form of corporate capital as set forth in the above section
7.1, new shareholders or existing shareholders may subscribe to shares by payments made to the corporate capital and
as the case may be also through payments made to the share premium account linked to the newly issued shares.
7.4. The shareholder(s) owning Ordinary Shares will be exclusively entitled on a prorate basis amongst them to any
and all rights attached to the share premium paid for the subscription of Ordinary Shares. The shareholder(s) owning
Mandatory Redeemable Preferred Shares will be exclusively entitled on a prorate basis amongst them to any and all rights
attached to the share premium paid for the subscription of Mandatory Redeemable Preferred Shares.
7.5.1. Share premium paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in specific
share premium accounts, as follows:
- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an ordinary shares’ share premium account (hereinafter
referred to as the Ordinary Shares’ Share Premium Account) and such share premium shall remain attached to the
Ordinary Shares upon which the share premium was paid;
- any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a mandatory redeemable
preferred shares’ share premium account (hereinafter referred to as the Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Share
Premium Account) and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares upon
which the share premium was paid.
7.5.2. Special equity reserve (account 115) paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall
be booked in specific special equity reserve accounts, as follows:
- any special equity reserve paid on Ordinary Shares shall be booked in an ordinary shares’ special equity reserve
account (hereinafter referred to as the Ordinary Shares’ Special Equity Reserve Account) and such special equity reserve
shall remain attached to the Ordinary Shares upon which the special equity reserve was paid;
- any share special equity reserve paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a mandatory
redeemable preferred shares’ special equity reserve account (hereinafter referred to as the Mandatory Redeemable
Preferred Shares’ Special Equity Reserve Account) and such special equity reserve shall remain attached to the Mandatory
Redeemable Preferred Shares upon which the special equity reserve was paid.
7.6. All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of redeemable shares within the meaning of
Article 49-8 of the Law. Without prejudice to the conditions set forth in Article 49-8 of the Law (including, without
limitation, the fact that the redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares can only be made by means of
sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law) (distributable funds, inclusive of the extraordinary
reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or proceeds of a new issue made for the
redemption purpose), Mandatory Redeemable Preferred Shares will be redeemed pursuant to the following terms and
conditions:
43656
L
U X E M B O U R G
(i) if the Mandatory Redeemable Preferred Shares are neither converted or retracted, the Company shall redeem all
Mandatory Redeemable Preferred Shares then in issue upon expiry of a ten (10) years period from the date on which
the relevant Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued (hereinafter referred to as the Final Mandatory Re-
demption Date);
(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, a holder of Mandatory
Redeemable Preferred Shares is entitled to request (in one or several occasions) in writing the Company to redeem all
or part of its Mandatory Redeemable Preferred Shares; and
(iii) a holder of any Mandatory Redeemable Preferred Shares, that has been redeemed, is entitled to receive a payment
in cash or in kind per redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares (hereinafter referred to as the Redemption
Price) equal to:
1. the par value of the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares; plus
2. all and any accrued and unpaid dividends that the holder of redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares is
entitled to receive at the time of the redemption; plus
3. an amount corresponding to a portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Share Premium Account
and/or the Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Special Equity Reserve Account equal to the balance of the Man-
datory Redeemable Preferred Shares’ Share Premium Account and/or the Mandatory Redeemable Preferred Shares’
Special Equity Reserve Account divided by the number of outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares imme-
diately prior to the redemption; plus
4. an amount corresponding to the portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account (as
defined in article 7.10 below) divided by the number of outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares immediately
prior to the redemption.
Redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after redemption and through the
extraordinary general meeting of shareholders resolving upon such redemption.
7.7. All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares.
Mandatory Redeemable Preferred Shares may be converted by the Company, subject to resolutions taken by the ex-
traordinary general meeting of shareholders, into Ordinary Shares pursuant to the following terms and conditions:
(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, a holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares may
at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part
of the Mandatory Redeemable Preferred Shares;
(ii) the Mandatory Redeemable Preferred Shares will be converted into a fixed number of Ordinary Shares with a fair
market value corresponding to the respective Mandatory Redeemable Preferred Shares par value, accrued and unpaid
dividends, attached Mandatory Redeemable Share Premium Account, Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Special
Equity Reserve Account and Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. No decimal of Ordinary Shares
will be available. The number of Ordinary Shares will be rounded down to the closest appropriate number of Ordinary
Shares, with any surplus being booked as share premium in the Ordinary Shares’ Share Premium Account.
Converted Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after conversion.
7.8. Each holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will be entitled, in priority to the payment of dividends
to the holders of Ordinary Shares, to (i) an annual cumulative dividend equal to 0,5% of the par value of the Mandatory
Redeemable Preferred Shares held by such a holder (which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 days year),
attached share premium (if any), booked as share premium in the Mandatory Redeemable Preferred Shares' Share Pre-
mium Account, and attached special equity reserve (if any), booked as special equity reserve in the Mandatory Redeemable
Preferred Shares' Special Equity Reserve Account and (ii) a variable rate equal to the net income derived by the Company
from any loans (or participations in the economic rights of any loans) granted to other entities (including, but not limited
to, interest income and the difference between the acquisition price of those loans and their repayment value, in the cases
where the repayment value is higher) and financed by Mandatory Redeemable Preferred Shares or income derived from
Mandatory Redeemable Preferred Shares, less the fixed rate set out in (i) and less a margin.
7.9. Fixed and preferred dividends will only be payable to each holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares
provided that the Company has sufficient liquid assets available, after each dividend payment is made to cover its current
expenses immediately after the payment of the dividend and one of the following three (3) events has occurred:
(i) the distribution of a dividend payment is approved; or
(ii) Mandatory Redeemable Preferred Shares are redeemed by the Corporation or retracted by the holder of Man-
datory Redeemable Preferred Shares; or
(iii) the Company is wound-up.
7.10. Should the profits be sufficient to distribute a dividend, in whole or in part, and the shareholder, or in case of
plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, decides to make no distribution resolution with respect
to such dividend, the amount of the dividend that should and could have been distributed to the holder of the Mandatory
Redeemable Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Mandatory Redee-
mable Preferred Shares reserve account (hereinafter referred to as the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve
Account).
43657
L
U X E M B O U R G
7.11. In case of dissolution of the Company, payment rights in respect of Mandatory Redeemable Preferred Shares will
rank junior to all other debts incurred by the Company but will rank senior to payment rights in respect of Ordinary
Shares as set forth in article 17 below.
Art. 8. Each Ordinary Share confers an identical voting right at the time of decisions taking. The Mandatory Redeemable
Preferred Shares do not carry voting rights, subject to the provisions of article 7.1 of these Articles.
Art. 9. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
III. Management - Representation
Art. 10. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The Board of Managers is composed of at least two managers. The manager(s) need not
to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers or two managers acting jointly, may sub-
delegate his/their powers for specific tasks to one or several agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers or two managers acting jointly, will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
Towards third parties, the Company is validly bound by (i) the sole signature of the manager, or, in case of plurality
of managers, the joint signatures of any two managers or (ii) the sole or joint signature(s) of any agent(s) to which powers
have been delegated in accordance with this article 10 of the Articles.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 12. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
43658
L
U X E M B O U R G
IV. General meetings of shareholders
Art. 13. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the Articles must be taken by a majority vote of shareholders
representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the Law on sociétés á responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
V. Accounting year
Art. 15. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
VI. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 16.1. The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each accounting year and will
be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 16.2. Out of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve
account. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve has reached an amount to ten per cent (10%)
of the corporate capital of the Company.
This allocation should again become compulsory if the legal reserve falls below ten (10%) per cent of the corporate
capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of managers, will determine the allocation
of the annual net profits, subject to the provisions of articles 7.8., 7.9., 7.10. and 7.11. of the present Articles.
Interim dividends may be distributed, at any time, subject to the provisions of articles 7.8., 7.9., 7.10. and 7.11. of the
present Articles, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. these accounts show a profit, including profits carried forward,
3. the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers of the Company, and
4. the payment is made only when the rights of the significant creditors of the Company are not threatened.
VII. Dissolution - Liquidation
Art. 17.1. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders in charge of such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 17.2. The power to amend the Articles, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the general
meeting of shareholders.
Art. 17.3. The power of the board of managers will end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment
of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount will be
paid first in priority and on a prorate basis to the holders of Mandatory Redeemable Preferred Shares according to the
par value of such shares increased by any accrued but unpaid dividends, any Mandatory Redeemable Preferred Shares’
Share Premium Account, Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Special Equity Reserve Account and Mandatory Re-
deemable Preferred Shares Reserve Account. Holders of Ordinary Shares will then be entitled to the remaining available
amount (if any) on a pro rata basis, according to the number of shares held in the Company’s capital by the holders of
such shares.
If the surplus available for distribution among the shareholders is insufficient to make payment of the above liquidation
right in full to the holder(s) of the Mandatory Redeemable Preferred Shares, then such a surplus shall be distributed among
such holder(s), ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.
VIII. Applicable law
Art. 18. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
43659
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2014.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon BSREP International I(A) Holdings L.P., pre-named and represented as stated above, declared to subscribe
to (i) the twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares, and (ii) the one thousand (1,000) Mandatory Redeemable
Preferred Shares, all in registered form and with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by
way of a contribution in cash amounting to thirteen thousand five hundred Euro (13,500).
The amount of thirteen thousand five hundred Euro (13,500) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Andrew O’Shea, born on August 13, 1981 in Dublin (Ireland), professionally residing at 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Mr. Luc Leroi, born on October 26, 1965 in Rocourt (Belgium), with private address at 13A, rue de Clairefontaine,
L-8460 Eischen, Luxembourg; and
- Mr. Damien Warde, born on February 19, 1950 in Galway (Ireland), professionally residing at 26, Boulevard Royal,
L-2449, Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, he signed together with the undersigned notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le seize janvier;
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
A COMPARU:
BSREP International I(A) Holdings L.P., une société existante selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, numéro de société MC-73329;
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, sous la dénomination «Castle 47 S.à r.l.» (la
Société), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations et d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre
manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société
jugera appropriés, et plus généralement les détenir, les gérer, les développer, les vendre ou en disposer, en totalité ou
en partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
43660
L
U X E M B O U R G
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales, tous concours, prêts, avances ou garanties comprenant une garantie
sur les actions détenues dans les filiales et sur les prêts accordés aux filiales; d'emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toute opération
se rattachant directement ou indirectement à son objet social. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune
activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
La Société peut réaliser toutes les opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités décrites ci-dessus aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 3. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire de ses associés statuant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social pourra être transférée dans la commune par décision du conseil de gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux et succursales, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité d'un des associés ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, exiger l'apposition de scellés sur les actifs et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
des assemblées.
II. Capital - Parts Sociales
Art. 7.1. Le capital de la Société est fixé à treize mille cinq cents Euro (EUR 13.500), représenté par deux (2) classes
de parts sociales comme suit: douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (ci-après désignées comme les
Parts Sociales Ordinaires) et mille (1.000) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables à dividende fixe et variable
(ci-après désignées comme les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables), et ensemble avec les Parts Sociales
Ordinaires elles seront désignées comme les Parts Sociales), d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1) chacune. Les droits
et obligations respectifs attachés à chaque classe de Parts Sociales sont exposés ci-dessous. Toutes les Parts Sociales
seront émises sous forme nominative. Généralement, les Parts Sociales Ordinaires seront acquises avec des droits de
vote. Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne confèreront aucun droit de vote dans la limite prévue
par la Loi et seulement tant que la Société a un associé unique. En cas de pluralité d’associés, les Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables donneront droit à un vote par part sociale de la même manière que les Parts Sociales
Ordinaires.
7.2. Toutes les Parts Sociales sont entièrement libérées.
7.3. Outre les apports effectués à la Société sous la forme de capital social tel qu'indiqué à la section 7.1 ci-dessus, les
nouveaux associés ou associés existants peuvent souscrire aux parts sociales en effectuant des paiements au capital social
et selon le cas ils peuvent également souscrire aux parts sociales par le biais de paiements au compte de prime d’émission
lié aux parts sociales nouvellement émises.
7.4. Le(s) Associé(s) qui détiennent les Parts Sociales Ordinaires auront droit exclusivement au prorata parmi eux à
tous les droits attachés à la prime d’émission versée pour la souscription des Parts Sociales Ordinaires. Le(s) Associé(s)
qui détiennent les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables auront droit exclusivement au prorata parmi
eux à tous les droits attachés à la prime d’émission versée pour la souscription des Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables.
7.5. 1. La prime d’émission versée pour les Parts Sociales Ordinaires ou les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables sera imputée sur des comptes de prime d’émission spécifiques, comme suit:
- toute prime d’émission versée pour les Parts Sociales Ordinaires sera imputée sur un compte de prime d’émission
des parts sociales ordinaires (désigné ci-après comme le Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires) et
cette prime d’émission restera annexée aux Parts Sociales Ordinaires pour lesquelles la prime d’émission a été versée;
- toute prime d’émission versée pour les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera imputée sur un
compte de prime d’émission des parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables (désigné ci-après comme le
Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables) et cette prime d’émission
43661
L
U X E M B O U R G
restera annexée aux Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables pour lesquelles la prime d’émission a été
versée.
7.5. 2. La réserve spéciale (compte 115) versée pour les Parts Sociales Ordinaires ou les Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables sera imputée sur des comptes de réserve spéciale spécifiques, comme suit:
- toute réserve spéciale versée pour les Parts Sociales Ordinaires sera imputée sur un compte de réserve spéciale des
parts sociales ordinaires (désigné ci-après comme le Compte de Réserve Spéciale des Parts Sociales Ordinaires) et cette
réserve spéciale restera annexée aux Parts Sociales Ordinaires pour lesquelles la réserve spéciale a été versée;
- toute réserve spéciale versée pour les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera imputée sur un
compte de réserve spéciale des parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables (désigné ci-après comme le Compte
de Réserve Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables) et cette réserve spéciale restera annexée
aux Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables pour lesquelles la réserve spéciale a été versée.
7.6. Toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts sociales
rachetables au sens de l’Article 49-8 de la Loi. Sans préjudice des conditions stipulées à l’Article 49-8 de la Loi (en ce
compris, notamment, le fait que le rachat des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne peut être effectué
que par les sommes disponibles pour une distribution en vertu de l’Article 72-1 de la Loi) (fonds distribuables, comprenant
la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la Société en tant que prime d’émission) ou les produits d’une
nouvelle émission réalisée pour le rachat), les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront rachetées
en vertu des modalités et conditions suivantes:
(i) Si les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne sont pas converties ni rachetées, la Société rachè-
tera la totalité des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables alors émises dès expiration du délai de dix (10)
ans à compter de la date à laquelle les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables concernées sont émises
(désignée ci-après comme la Date de Rachat Obligatoire Finale);
(ii) Nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale et à tout moment avant cette date, un détenteur de Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables est autorisé à demander (à une ou plusieurs reprises) par écrit à la Société le
rachat de la totalité ou d’une partie de ses Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables; et
(iii) un détenteur de toutes Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, qui ont été rachetées, est autorisé
à percevoir un paiement en numéraire ou en nature par Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables rachetées
(désigné ci-après comme le Prix de Rachat) qui sera égal à:
1. la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables; plus
2. tous les dividendes courus et impayés que le détenteur des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables
est autorisé à recevoir au moment du rachat; plus
3. un montant correspondant à une partie du Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables et/ou du Compte de Réserve Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables
égal au solde du Compte de Prime d’Emission Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables et/ou du Compte
de Réserve Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables divisé par le nombre de Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables en circulation immédiatement avant le rachat; plus
4. un montant correspondant à une partie du Compte de Reserve des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables (comme défini à l’article 7.10 ci-dessous) divisé par le nombre de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables en circulation immédiatement avant le rachat.
Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront annulées immédiatement après le rachat et par le
biais d’une assemblée générale extraordinaire des associés appelée à se prononcer sur ce rachat.
7.7. Toutes les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts sociales
convertibles en Parts Sociales Ordinaires. Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables peuvent être con-
verties par la Société, sous réserve des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des associés, en Parts
Sociales Ordinaires en vertu des modalités et conditions suivantes:
(i) Nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale, un détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Ra-
chetables peut à tout moment avant cette date, demander (à une ou plusieurs reprises) par écrit la conversion de la
totalité ou d’une partie des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables en Parts Sociales Ordinaires;
(ii) Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront converties en un nombre fixe de Parts Sociales
Ordinaires avec une juste valeur marchande correspondant à la valeur nominale respective des Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables, aux dividendes courus et impayés, au Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables, au Compte de Réserve Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables et au Compte de Réserve des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables. Le nombre de Parts
Sociales Ordinaires ne sera pas exprimé en décimales. Le nombre de Parts Sociales Ordinaires sera arrondi au nombre
approprié inférieur le plus proche de Parts Sociales Ordinaires, et tout surplus sera comptabilisé en tant que prime
d’émission sur le Compte de Prime d’Emission des Parts Sociales Ordinaires.
Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables Converties seront annulées immédiatement après la con-
version.
43662
L
U X E M B O U R G
7.8. Chaque détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera autorisé, en priorité par rapport
au paiement des dividendes aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, (i) à un dividende annuel cumulatif égal à 0,5%
de la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables détenues par ce détenteur (qui s'accu-
mulera quotidiennement et sera calculé sur la base d'une année de 365 jours), à la prime d'émission liée (le cas échéant),
imputée en tant que prime d'émission sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement
Rachetables et la réserve spéciale liée (le cas échéant), imputée en tant que réserve spéciale au Compte de Réserve
Spéciale des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, et (ii) à un taux variable égal au revenu net obtenu
par la Société des prêts (ou participations aux droits économiques de tout prêt) accordés à d’autres entités (y compris,
mais non limité à, un revenu d’intérêt et la différence entre le prix d’acquisition des prêts et leur valeur à remboursement,
dans les cas où la valeur à remboursement est plus élevée) et financés au moyen de Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables ou de revenu dérivé des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, moins le taux fixe
indiqué sub. (i) et moins une marge.
7.9. Les dividendes fixes et privilégiés ne seront exigibles à chaque détenteur de Parts Sociales Privilégiées Obligatoi-
rement Rachetables qu'à condition que la Société ait des liquidés disponibles suffisantes, après que chaque paiement de
dividende soit effectué afin de couvrir ses dépenses courantes immédiatement après le paiement du dividende et que l’un
des trois (3) évènements suivants se soit produit:
(i) La distribution d’un versement de dividendes est approuvée; ou
(ii) Les Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont rachetées par la Société ou rachetées par le
détenteur des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables; ou
(iii) La Société est dissoute.
7.10. Si les bénéfices sont suffisants pour distribuer un dividende, en totalité ou en partie, et l’associé, ou en cas de
pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés, décide de ne pas faire de résolution quant à la distribution de ce
dividende, le montant du dividende qui aurait dû et aurait pu être distribué au détenteur des Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables sera automatiquement affecté à une réserve distribuable imputée au compte de réserve des
Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables (désigné ci-après comme le Compte de Réserve des Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables).
7.11. En cas de dissolution de la Société, les droits au paiement en ce qui concerne les Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables seront secondaires par rapport à toutes les autres dettes encourues par la Société mais
seront prioritaires par rapport aux droits de paiement en ce qui concerne les Parts Sociales Ordinaires comme stipulé à
l’article 17 ci-dessous.
Art. 8. Chaque Part Sociale Ordinaire confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. Les Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont dépourvues de droits de vote, sous réserve des dispositions de l’article 7.1
des présents Statuts.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à des non-associés ne peut être effectuée sans l’accord donné par les
membres représentant au moins les trois quarts du capital social en assemblée générale.
Pour le reste, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
III. Gérance - Représentation
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil
de gérance. Le Conseil de Gérance est composé d'au moins deux gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés qui
détiennent la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social et à condition que les
termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ou deux gérants agissant conjointement, peuvent
subdéléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ou deux gérants agissant conjointement, détermi-
neront les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de ce mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes
autres conditions pertinentes de son mandat.
La Société est valablement engagée envers les tiers par (i) la signature unique du gérant, ou, en cas de pluralité de
gérants, par les signatures conjointes de deux gérants ou (ii) par la signature unique ou les signatures conjointes de tous
mandataire(s) auxquels des pouvoirs ont été délégués en vertu de cet article 10 des Statuts.
43663
L
U X E M B O U R G
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance seront tenues valablement si la majorité des gérants
est présente.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L'utilisation du matériel de visioconférence et de la conférence téléphonique sera autorisée à condition que chaque
membre participant du Conseil de Gérance soit en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres membres
participants, qui utilisent ou non ce type de technologie, et chaque membre participant du Conseil de Gérance sera
considéré comme ayant été présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote par vidéo ou par téléphone.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés à une date ultérieure en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'il aura encourus par suite de sa comparution en tant que défendeur
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui lui auront été intentées de par ses fonctions
actuelles ou anciennes de gérant de la Société, ou à la demande de la Société, ou de toute autre société dans laquelle la
Société est associé ou créancier et que de ce fait il n’a pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où il aurait
été déclaré coupable pour négligence grave ou pour avoir manqué à ses devoirs envers la Société; en cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les sujets couverts par l'arrangement transactionnel et uniquement
dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à
ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour la personne susnommée d'autres
droits auxquels elle pourrait prétendre.
Art. 12. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme ou télex un autre gérant comme son mandataire pour le représenter.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants, produiront le même effet que les résolutions
prises à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, transmises par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou
autre moyen de télécommunication.
IV. Décisions des associés
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales des associés.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre d’associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, la gérance peut décider que chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou des décisions
à prendre, expressément formulées par écrit, transmis par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopie.
Art. 14. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification statutaire doivent être prises à la majorité des voix des
associés représentant les trois-quarts du capital.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde
assemblée par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que les gérants détermineront de temps à autre.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Section
XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
V. Exercice social
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
VI. Comptes annuels et Affectation des bénéfices
Art. 16.1. Les comptes annuels sont établis par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la
disposition des associés au siège social de la Société.
43664
L
U X E M B O U R G
Art. 16.2. Il sera prélevé cinq pour cent (5 %) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.
Cette affectation redeviendra obligatoire si le montant de la réserve légale devient inférieur à dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.
L’assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, décidera de l’affectation des bénéfices
annuels, sous réserve des dispositions des articles 7.8., 7.9., 7.10. et 7.11. des présents Statuts.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, sous réserve des dispositions des articles 7.8.,
7.9., 7.10. et 7.11. des présents Statuts, aux conditions suivantes:
1. Les comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes indiquent un bénéfice, en ce compris les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des acomptes sur dividendes est prise par le conseil de gérance de la Société, et
4. le paiement est effectué uniquement lorsque les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.
VII. Dissolution - Liquidation
Art. 17.1. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des associés appelée à se
prononcer sur cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 17.2. L’assemblée générale des associés a le pouvoir de modifier les Statuts, si les besoins de la liquidation l’exigent.
Art. 17.3. Le pouvoir du conseil de gérance cessera dès la nomination du/des liquidateur(s). Après le paiement de
toutes les dettes et obligations de la Société ou le dépôt de tous fonds à cet effet, le montant restant disponible sera payé
en premier lieu en priorité et au prorata aux détenteurs des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables selon
la valeur nominale de ces parts sociales augmentée par tous dividendes accumulés mais impayés, tout Compte de Prime
d’Emission des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, Compte de Réserve Spéciale des Parts Sociales
Privilégiées Obligatoirement Rachetables et Compte de Réserve des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rache-
tables. Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront alors le droit de percevoir le montant restant disponible (le
cas échéant) au prorata, en fonction du nombre de parts sociales détenues dans le capital social par les détenteurs de ces
parts sociales.
Si le surplus disponible pour une distribution parmi les associés est insuffisant afin de réaliser le paiement intégral du
droit de liquidation ci-dessus à(aux) associé(s) des Parts Sociales Privilégiées Obligatoirement Rachetables, alors ce surplus
sera distribué parmi ce(s) détenteur(s), de façon proportionnelle aux montants totaux qu'ils auraient eu autrement le
droit de percevoir respectivement.
VIII. Loi applicable
Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, BSREP International I(A) Holdings L.P., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare
souscrire à (i) douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires et (ii) mille (1.000) Parts Sociales Privilégiées
Obligatoirement Rachetables, toutes sous forme nominative et avec une valeur nominale d’un Euro (EUR 1) chacune, et
les libérer entièrement par un apport en numéraire de treize mille cinq cents Euro (EUR 13.500).
La somme de treize mille cinq cents Euro (EUR 13.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (1.500.-
EUR).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Andrew O’Shea, né le 13 août 1981 à Dublin (Irlande), résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- M. Luc Leroi, né le 26 octobre 1965 à Rocourt (Belgique), avec adresse privée au 13A, rue de Clairefontaine, L-8460
Eischen, Luxembourg; et
43665
L
U X E M B O U R G
- M. Damien Warde, né le 19 février 1950 à Galway (Irlande), résidant professionnellement au 26, Boulevard Royal,
L-2449, Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire instrumentant
le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 janvier 2014. Relation: LAC/2014/3142. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 février 2014.
Référence de publication: 2014022005/610.
(140026731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.
ZBI Opportunity Real Estate S.C.A.,, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 127.856.
Il est porté à la connaissance des tiers que le General Partner (associé commandité) de la Société, ZBI OPPORTUNITY
REAL ESTATE FUND MANAGEMENT S.A., a changé de dénomination sociale avec effet au 1
er
janvier 2014 comme
suit:
ZBI Opportunity Real Estate GP S.A.
Luxembourg, le 18 février 2014.
Marcus PETER
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014025754/13.
(140030719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.
BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.212.300,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.587.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of January.
Before Maître Francis Kesseler, notary established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
BBA Aviation S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its
registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies' Register under number B 159849 (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Eschsur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of “BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à r.l.”, a Luxembourg private
limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B 155 587 (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Francis Kesseler, prenamed dated
26 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) dated 29 October
2010 number 2329. The Company’s articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary dated 21 December 2012, published in the Mémorial dated 28 February 2013, number 493.
43666
L
U X E M B O U R G
II.- That the 450 (Four Hundred Fifty) shares of the Company with a nominal value of USD 100 (One Hundred United
States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 18,167,300 (Eighteen Million One Hundred Sixty-
Seven Thousand Three Hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 45,000 (Forty-
Five Thousand United States Dollars) to USD 18,212,300 (Eighteen Million Two Hundred and Twelve Thousand Three
Hundred United States Dollars) by the issue of 181,673 (One Hundred Eighty-One Thousand Six Hundred Seventy-Three)
new shares with a nominal value of USD 100 (One Hundred United States Dollars) each, subject to the payment of a
share premium amounting to USD 163,506,596.90 (One Hundred Sixty-Three Million Five Hundred and Six Thousand
Five Hundred and Ninety-Six United States Dollars and Ninety Cents), the whole to be fully paid up through contributions
in kind;
3. Subscription and payment by BBA Aviation S.à r.l., of the new shares by way of contributions in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8 paragraph 1 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 18,167,300 (Eighteen Million One
Hundred Sixty-Seven Thousand Three Hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD
45,000 (Forty-Five Thousand United States Dollars) to USD 18,212,300 (Eighteen Million Two Hundred and Twelve
Thousand Three Hundred United States Dollars) by the issuance of 181,673 (One Hundred Eighty-One Thousand Six
Hundred Seventy-Three) new shares with a nominal value of USD 100 (One Hundred United States Dollars) each (the
“New Shares”), subject to the payment of a share premium amounting to USD 163,506,596.90 (One Hundred Sixty-
Three Million Five Hundred and Six Thousand Five Hundred and Ninety-Six United States Dollars and Ninety Cents) (the
“Share Premium”), the whole to be fully paid by contributions in kind made by the Sole Shareholder (the “Contributions”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share
Premium through the Contributions as described below.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by
virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The issue of the New Shares is
also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid
up by the Sole Shareholder through the Contributions as described below.
<i>Description and valuationi>
The Contributions made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of
the Share Premium, are composed of:
- a certain claim held by the Sole Shareholder against BBA U.S. Holdings, Inc. in an aggregate amount of USD 181,672,171
(One Hundred Eighty-One Million Six Hundred Seventy-Two Thousand One Hundred Seventy-one United States Dol-
lars); and
- 172,590 (One Hundred Seventy-Two Thousand Five Hundred Ninety) ordinary shares held by the Sole Shareholder
in BBA INVESTMENT AVIATION LIMITED, a company incorporated in Ireland with registered number 488710 and
having its registered office at SFS Hangar, Shannon, Co. Clare, Ireland ("BBA Ireland"), with a nominal value of USD 1,000
(One Thousand United State Dollars) each, partly paid-up for an amount of USD 0.01 (One Cent of United State Dollars)
per share, having an aggregate amount of USD 1,725.90 (One Thousand Seven Hundred and Twenty-Five United States
Dollars), including all the rights and obligations connected thereto.
43667
L
U X E M B O U R G
The value of the Contributions amounts in the aggregate to USD 181,673,896.90 (One Hundred Eighty-One Million
Six Hundred Seventy-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Six United States Dollars and Ninety Cents).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 10 January 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contributions’ existencei>
A proof of the existence of the Contributions has been given.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Daniel Vincent MARCINIK, manager, professionally residing at 45 Maplevale Rd, East Kingston, NH 03827, United
States of America;
b) Michael LANGE, manager, professionally residing at 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg; and
c) Iain MACLEOD, manager, professionally residing at Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above
statement contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contributions, expressly agree with the description of the Contributions, with their valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- BBA Aviation S.à r.l.: 182,123 (One Hundred Eighty-Two Thousand One Hundred Twenty-Three) shares.
The notary acts that the 182,123 (One Hundred Eighty-Two Thousand One Hundred Twenty-Three) shares, repre-
senting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution
to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it
is resolved to amend article 8 paragraph 1 of the Company’s articles of association so that it reads as follows:
“ Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 18,212,300 (Eighteen Million Two Hundred and Twelve Thousand
Three Hundred United States Dollars) represented by 182,123 (One Hundred Eighty-Two Thousand One Hundred
Twenty-Three) shares, with a nominal value of USD 100 (One Hundred United States Dollars) each.”
No other amendment is to be made to this article.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de janvier.
Par devant, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
BBA Aviation S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège
social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159849 (l’«Associé Unique»).
Ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant sa résidence professionnelle au 5 rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé.
43668
L
U X E M B O U R G
Ladite procuration ayant été donnée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l’en-
registrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter comme suit:
I. La partie comparante est l’Associé Unique de “BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à r.l.”, une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 155 587 (la "Société"), constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire soussigné en date du 26 août
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") en date du 29 octobre 2010 numéro
2329. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 21 décembre
2012, publié au Mémorial numéro 493 daté du 28 février 2013.
II. Que les 450 (quatre cent cinquante) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars
Américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée
peut valablement délibérer sur tus les points figurant à l’ordre du jour, dont l’Associé Unique reconnaît expressément
avoir été dûment informé au préalable.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 18.167.300 USD (dix-huit millions cent soixante-sept
mille trois cents Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 45.000 USD (quarante cinq mille Dollars
Américains) à 18.212.300 USD (dix-huit millions deux cent douze mille trois cents Dollars Américains) par l’émission de
181.673 (cent quatre-vingt un mille six cent soixante-treize) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD
(cents Dollars Américains) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission de 163.506.596.90 USD (cent soixan-
te-trois millions cinq cent six mille cinq cent quatre vingt-seize Dollars Américains et quatre vingt dix cents), l’intégralité
devant être libérée par voie d’apports en nature;
3. Souscription et paiement par BBA Aviation S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apports en nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la société;
5. Modification subséquente de l’article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférent à cette assemblée
générale; l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère être valablement
convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. De plus, il a
été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui
permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 18.167.300 USD (dix-huit millions cent soixante-
sept mille trois cents Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 45.000 USD (quarante cinq mille
Dollars Américains) à 18.212.300 USD (dix-huit millions deux cent douze mille trois cents Dollars Américains) par
l’émission de 181.673 (cent quatre-vingt un mille six cent soixante-treize) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d’une prime
d’émission globale de 163.506.596.90 USD (cent soixante-trois millions cinq cent six mille cinq cent quatre vingt-seize
Dollars Américains et quatre vingt dix cents) (la «Prime d’Emission»), le tout étant payé intégralement par la voie d’apports
en nature de l’Associé Unique (les «Apports»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime
d'Emission par voie des Apports tel que décrits ci- dessous.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une
procuration donnée sous seing-privé, lequel déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.L’émission des Nouvelles Parts
Sociales est soumise au paiement de la Prime d’Emission. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d’Emission ont été
entièrement payées par l’Associé Unique par voie des Apports, comme décrits ci-dessous.
43669
L
U X E M B O U R G
<i>Description et Evaluationi>
Les Apports faits par l’Associé Unique, en échange de l’émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la
Prime d’Emission, sont composés de:
- une certaine créance détenue par l’Associé Unique à l’encontre de BBA U.S. Holdings, Inc. d’une valeur totale de
181.672.171 USD (cent quatre-vingt un million six cent soixante douze mille cent soixante et onze Dollars Américains);
et
- 172.590 (cent soixante douze mille cinq cent quatre vingt dix) parts sociales détenues par l'Associé Unique dans BBA
INVESTMENT AVIATION LIMITED, une société constituée en Irlande, enregistrée sous le numéro 488710 et ayant son
siège social situé au SFS Hangar, Shannon, Co. Clare, Irlande ("BBA Ireland"), d'une valeur nominale de 1,000 USD (mille
Dollars Américains) chacune, libérée à concurrence d'un montant de 0,01 USD (un cent de Dollar Américain) par part
sociale, représentant un montant total de 1.725,90 USD (mille sept cent vingt-cinq Dollars Américains et quatre vingt dix
cents), incluant tous droits et obligations en rapport avec ces parts sociales.
La valeur des Apports s’élève au total à 181.673.896.90 USD (cent quatre vingt-un millions six cent soixante treize
mille huit cent quatre vingt seize Dollars Américains et quatre-vingt dix cents).
Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur d’apport en
date du 10 janvier 2014, qui restera annexée à ce présent acte afin d’être soumise avec celui-ci aux formalités d’enregis-
trement.
<i>Preuve de l’existence des apportsi>
Une preuve de l’existence des Apports a été donnée.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont ensuite intervenus:
Daniel Vincent MARCINIK, gérant, résidant professionnellement à 45 Maplevale Rd, East Kingston, NH 03827, Etats-
Unis d'Amérique;
Iain MACLEOD, gérant, résidant professionnellement à Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duché de Luxem-
bourg; et
Michael LANGE, gérant, résidant professionnellement à 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;
tous sont représentés ici par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, agissant en vertu d’une procuration
incluse dans la déclaration de valeur d’apport mentionnée ci-dessus.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité et être légalement tenus en tant
que gérants de la Société en raison des Apports en nature, acceptent expressément la description de des Apports, avec
leur évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’actionnariat de la Société est maintenant composé de:
- BBA Aviation S.à r.l.: 182.123 (cent quatre-vingt deux mille cent vingt- trois) parts sociales.
Le notaire témoigne que les 182.123 (cent quatre-vingt deux mille cent vingt- trois) parts sociales représentant la
totalité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l’assemblée peut valablement décider de la
résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et les Apports ayant été totalement réalisés, il est décidé
de modifier l’article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 18.212.300 USD (dix huit millions deux cent douze mille trois
cents Dollars Américains), représenté par 182.123 (cent quatre vingt deux mille cent vingt trois) parts sociales d'une
valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune.»
Aucune autre modification n’est faite à cet article.
<i>Estimation des fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).
Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été clôturée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
43670
L
U X E M B O U R G
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assem-
blée, le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente,
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 janvier 2014. Relation: EAC/2014/998. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021979/245.
(140026734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.
Obbos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 8, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 184.334.
STATUTS
L'an deux mil quatorze, le trente janvier.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur De Angeli Romain, commercial, né à Strasbourg (F), le 10 juillet 1987, demeurant à Seremange-Erzange,
1, rue des Lilas F-57290,
2. Madame De March Catherine, employée privée, née à Hayange (F) le 18 mars 1963, demeurant à Luxembourg, 8,
rue Jean L'Aveugle L-1148.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”).
Art. 2. La société a pour objet de réaliser toutes opérations immobilières, se rattachant soit directement à des biens
immobiliers, bâtis ou non, soit à des parts de sociétés immobilières ou à tout autre titre conférant des droits de propriété
immobilière, incluant
- l'achat, la vente, la location, l'échange, et de manière générale toute opération se rattachant directement ou indirec-
tement à l'exploitation et à l'activité d'une agence immobilière
- la gérance, la gestion, l'administration, et de manière générale toute opération se rattachant directement ou indi-
rectement à l'exploitation et à l'activité d'une société Syndic de Copropriété / Administrateur de biens;
- la création, la transformation, la rénovation, l'acquisition, l'aliénation, la mise en valeur et la promotion et de manière
générale toute opération se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation et à l'activité d'une société de
promotion immobilière
- de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles,
financières ou non, luxembourgeoises ou étrangères, destinées à favoriser son exploitation et le développement de ses
activités
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “OBBOS S.à r.l.”
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
43671
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par CINQ CENTS
(500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. L'associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêtés les Statuts de la Société, les parties comparantes ici représentées comme
indiqué ci-dessus, ont déclaré souscrire comme suit:
- Monsieur De Angeli Romain, prénommé, CENT (100.-) parts sociales,
- Madame De March Catherine, prénommée, QUATRE CENTS (400.-) parts sociales,
Total: CINQ CENTS (500.-) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la société a maintenant à sa disposition
la somme de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros)
43672
L
U X E M B O U R G
Preuve d'un paiement de douze mille cinq cents euros (12.500 euros) a été donnée au notaire soussigné qui constate
que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont
été observées.
<i>Fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ neuf cents EUROS (900-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2), à savoir un gérant technique et un gérant administratif.
2) Est nommée gérant technique à durée indéterminée: Madame De March Catherine, précitée.
3) Est nommé gérant administratif à durée indéterminée: Monsieur De Angeli Romain, précité.
La Société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
4) L'adresse de la Société est fixée au 8, rue Jean L'Aveugle, L-1148 Luxembourg.
<i>Remarque:i>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. De Angeli, C. De March, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4915. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2014.
Référence de publication: 2014022314/122.
(140026664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.
Sazele S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 156.987.
En l’année deux mille treize, le deux décembre,
Devant Nous Francis Kesseler, notaire, résidant à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de “SAZELE S.A.”, une société anonyme, ayant son siège social
au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg
section B, sous le numéro 156.987, constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, en date
du 22 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°25 du 6 janvier 2011.
Les Statuts de la Société ont été modifies en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire
résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 15 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n°372 du 24 février 2011.
L’Assemblée est présidée par Madame Johanna SCHADECK, ayant son adresse professionnelle au 15 rue Astrid L-1143
Luxembourg.
Le président a nommé Madame Annabelle GIOVANARDI, ayant son adresse professionnelle au 15 rue Astrid L-1143
Luxembourg, comme secrétaire et scrutateur.
Le président déclare et requiert le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires représentés et le nombre de leurs actions ont été repris sur la liste de présence, signée «ne
varietur» par le(s) mandataire(s) des actionnaires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.
Ladite liste restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
43673
L
U X E M B O U R G
II. Qu'il ressort de la liste de présence que les six cent soixante-dix-huit mille sept cents (678.700) actions en circulation,
entièrement détenues par les actionnaires et représentant l’intégralité du capital social de la Société, actuellement établi
à dix-neuf millions cent vingt-sept mille euros (EUR 19.127.000,-), entièrement libéré, sont représentées à la présente
assemblée, si bien que l’assemblée peut valablement statuer sur tous les points repris à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour est la modification des articles 5, 16 et 17 des statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée générale décide de remplacer l’alinéa 1 de l’article 5 des statuts par le texte suivant:
« Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf millions cent vingt-sept mille euros (EUR 19.127.000,-) consistant en six
cent soixante-dix-huit mille sept cents (678.700) actions sans désignation de valeur nominale, numérotées un (1) à six
cent soixante-dix-huit mille sept cents (678.700).»
La traduction anglaise du texte de l’alinéa 1 de l’article 5 est la suivante:
«The share capital is set at nineteen million one hundred and twenty-seven thousand euros (EUR 19.127.000,-) divided
into six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678.700) shares without par value, numbered from one (1)
to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678.700).»
L’Assemblée générale décide de remplacer l’article 16 des Statuts par un nouvel article 16 ayant la teneur suivante:
« Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social, tel que prévu à l’article 5 des Statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022, en cas de distribution du bénéfice annuel net, les détenteurs
des actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)
bénéficieront, prioritairement à toute autre distribution de bénéfice, du paiement d’un dividende annuel correspondant
à la somme des deux composantes suivantes:
- Composante 1:
90% (quatre-vingt-dix pourcents) du bénéfice net positif réalisé par la Société sur la cession d’actions pendant l’exercice.
Le bénéfice net s’entend pour un exercice donné comme la somme des plus et moins-values sur les actions réalisées
au cours de l’exercice suite à tout acte de disposition par la Société ainsi qu'au rachat d’actions propres par toute société
dont les titres sont détenus ou à la liquidation de celles-ci.
Les plus et moins-values réalisées se déterminent en prenant la différence entre le prix d’achat et le prix de vente.
Si dans un exercice le résultat découlant de la vente d’actions est négatif, les détenteurs d’actions numérotées trente-
trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)
n’auront droit à 90% (quatre-vingt-dix pourcents) du bénéfice net, calculé comme décrit ci-avant, qu'après apurement
de la perte par des plus-values positives.
- Composante 2:
4% (quatre pourcents) ou, s’il est inférieur, le taux moyen EURIBOR à 12 mois du troisième trimestre de l’année qui
précède l’exercice concerné augmenté de 3,2% (trois virgule deux pourcents), appliqué au pair comptable des actions
numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille septs cent (678.700)et au montant
total des bénéfices liés aux actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit
mille sept cents (678.700) des années précédentes non encore distribués, tel qu'il résulte de l’addition des deux compo-
santes, pour autant que ces montants soient reflétés dans les fonds propres comptables de la Société.
Si un exercice a une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le pourcentage déterminé comme décrit ci-avant
est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de l’exercice et le dénominateur est
égal à trois cent soixante-cinq.
Le dividende résultant de cette deuxième composante est plafonné au rendement net des valeurs mobilières et avoirs
en banque détenus par la Société et correspondant à la différence entre le rendement brut total des valeurs mobilières
et avoirs en banque, et les frais en relation économique directe avec ces avoirs (notamment: frais de gestion, droits de
garde, intérêts de la dette finançant l’investissement).
Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022, toute distribution de dividende supplémentaire par la
Société se fera uniquement au porteur d’actions numérotées un (1) à trente-trois mille neuf cent trente-cinq (33.935) en
proportion de sa participation dans la portion de capital de la société représenté par ces actions, les porteurs d’actions
numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)n’auront
pas droit à une autre distribution de dividende en dehors du dividende prévu à l’alinéa 4.
Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022, si la Société n’est pas en mesure de distribuer des dividendes
pour une année donnée ou dans l’hypothèse où les bénéfices annuels nets n’auraient pas été entièrement distribués aux
43674
L
U X E M B O U R G
porteurs d’actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents
(678.700)conformément à l’alinéa 4, les bénéfices correspondants seront reportés aux années comptables ultérieures
jusqu'à leur distribution effective et se cumuleront avec les dividendes devant être distribués au profit des détenteurs
d’actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)
en application de l’alinéa 4.
Une fois la date de maturité atteinte (à savoir le 31 décembre 2022), l’assemblée générale se prononcera sur le sort
à réserver aux droits économiques privilégiés des actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à
six cent septante huit mille sept cents (678.700) et décidera soit de procéder à leur rachat au pair comptable (plus, le cas
échéant, les dividendes accumulés et non entièrement payés qui leur seraient encore dus sur base de l’alinéa 4), soit de
les reconduire pour une nouvelle période de dix ans; cette décision sera prise aux conditions requises pour la modification
des statuts.
A défaut pour l’assemblée générale de prendre une décision concernant le rachat ou la reconduction des droits éco-
nomiques privilégiés des actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille
sept cents (678.700)à compter de leur maturité, les droits économiques privilégiés de ces dernières seront automati-
quement éteints pour les profits futurs de la Société et les actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six
(33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)participeront alors au bénéfice annuel de la Société réalisé à
partir de l’année 2023.
En cas de distribution de dividendes, de rachat ou de liquidation, malgré cette extinction des droits économiques
privilégiés concernant les profits réalisés à partir de l’année 2023, les actions numérotées trente-trois mille neuf cent
trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)conserveront leurs droits aux profits réalisés au
cours des années 2013 à 2022 en exécution de l’alinéa 4 du présent article et qui n’auraient pas été distribués.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de
ces actions.»
La traduction anglaise du texte de l’article 16 est la suivante:
«From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This
allocation shall cease to be required as soon as and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share
capital of the Company as stated in article 5 of the by-laws.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profit will be disposed of.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022, upon distribution of the annual net profit, the holders of shares
numbered thirty-three thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven
hundred (678,700) will be entitled, before any other distribution of profit, to the payment of an annual dividend corres-
ponding to the sum of the following elements:
- First element:
90% of the positive net profit realized by the Company on the transfer of shares during the financial year.
The net profit is to be defined, for a given financial year, as the sum of the capital gains and capital losses realized on
the shares during the financial year, further to any disposal by the Company, as well as further to a share buy back by the
company whose shares are held as portfolio or further to the liquidation of the latter.
The capital gains and losses are determined as the difference between the sale price and the acquisition price of the
shares.
In case of negative result realized in relation with the sale of shares during a financial year, the holders of shares
numbered thirty-three thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven
hundred (678,700)will have right to 90% of the net profit as determined above only once these losses realized on such
assets have been offset by positive capital gains realized on such assets.
- Second element:
4% or, in case it would be lower, the average rate of the EURIBOR 12 months applicable during the third quarter of
the year preceding the financial year concerned, increased by 3,2%, applied to the par value of the shares numbered thirty-
three thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700)
plus the total amount of undistributed preferred dividends resulting from the addition of the first and second elements,
provided these amounts are recorded in the Company’s accounting equity.
If a financial year is shorter or longer than twelve months, then the percentage determined as above will be multiplied
by a fraction where the numerator is equal to the total number of days of the financial year and where the denominator
is equal to three hundred and sixty-five.
The dividend resulting from this second element cannot exceed the net yield of the transferrable securities and assets
held on the bank account realized by the Company, which corresponds to the gross return of the transferrable securities
and assets held on the bank account, minus all the expenses in direct connection with these assets (e.g.: management
fees, banking fees, interest of the debt financing the investment).
43675
L
U X E M B O U R G
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022, any additional dividend distribution by the Company will only benefit
to the holders of shares numbered One (1) to thirty-three thousand nine hundred and thirty-five (33,935), proportionally
to their participation in the portion of the share capital such as represented by these shares. The holders of shares
numbered thirty-three thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven
hundred (678,700)will not be entitled to any other dividend distribution than the dividend provided by paragraph 4 thereof.
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022, if the Company was not able to distribute dividends for a given
year or if the dividends were not entirely distributed to the holders of shares numbered thirty-three thousand nine
hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700) in accordance with
paragraph 4 thereof, the latter dividends would be carried forward to the following accounting year until their effective
distribution and would be added to any other dividends to which the holders of shares numbered thirty-three thousand
nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700)are entitled,
based on the paragraph 4 thereof.
Once the maturity date is reached (i.e. on December 31
st
2022), the general meeting of the shareholders will have
to take a decision regarding the preferred economic rights of the shares numbered thirty-three thousand nine hundred
and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700)and will decide either to buy
them back at the par value (plus the dividends accumulated and not fully paid that would still be due based on the paragraph
4 thereof, if any), or to renew them for a new ten-year period; this decision will be subject to the conditions required
for the modification of the by-laws.
If no decision is taken by the general meeting regarding the buy-back or renewal of the preferred economic rights
linked to the shares numbered thirty-three thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-
eight thousand seven hundred (678,700)before their maturity, the preferred economic rights of the latter will automati-
cally be cancelled for the future, so that the shares numbered thirty-three thousand nine hundred and thirty-six (33,936)
to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700)will share annual net profit of the Company as from
2023.
In the event of a dividend distribution, buy-back or liquidation, despite the cancellation as from 2023 of the preferred
economic rights to the profit realized by the Company, the shares numbered thirty-three thousand nine hundred and
thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700)will keep their right to the profit
realized from 2013 until 2022 in accordance with paragraph 4 thereof and that would not have been distributed yet.
In the event of shares partially paid-up, the dividends will be payable proportionally to the amount of the paid-up
shares.»
L’Assemblée générale décide de compléter l’article 17 des Statuts en y ajoutant les deux paragraphes suivants:
«Le capital social et le montant de la prime d’émission, si elle existe, qui seraient remboursés pendant la période du
1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022 (voire au 31/12/2032 en cas de reconduction), seront en priorité payés au détenteur
des actions trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept cents (678.700)puis, pari
passu, aux détenteurs d’actions numérotées un (1) à trente-trois mille neuf cent trente-cinq (33.935)Pour la période du
1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022 (voire au 31/12/2032 en cas de reconduction), le boni de liquidation résultant de
la dissolution de la Société, après que celle-ci se soit acquittée de l’intégralité de ses dettes et des profits non distribués
aux détenteurs d’actions numérotées trente-trois mille neuf cent trente-six (33.936) à six cent septante huit mille sept
cents (678.700) par application de l’alinéa 4 de l’article 16, sera distribué aux seuls détenteurs d’actions numérotées un
(1) à trente-trois mille neuf cent trente-cinq (33.935) proportionnellement à leur participation dans le capital de la So-
ciété.»
La traduction anglaise des deux paragraphes ajoutés à l’article 17 est la suivante:
«The share capital and the share premium, if any, that would be repaid from January 1
st
2013 until December 31
st
2022 (or until December 31
st
2032 in case of renewal), will be first repaid to the holder of shares numbered thirty-three
thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-eight thousand seven hundred (678,700)and
then, pari passu, to the holders of shares numbered One (1) to thirty-three thousand nine hundred and thirty-five (33,935)
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022 (or until December 31
st
2032 in case of renewal), the liquidation
bonus arising from the liquidation of the Company after payment of all the Company’s debts and undistributed dividends
to the holders of shares numberedthirty-three thousand nine hundred and thirty-six (33,936) to six hundred and seventy-
eight thousand seven hundred (678,700)in accordance with article 16 paragraph 4 thereof, will be distributed only to the
holders of shares numbered One (1) to thirty-three thousand nine hundred and thirty-five (33,935) in proportion to their
shareholding in the Company’s share capital.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
43676
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom et prénom, état et demeure,
ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Schadeck, Giovanardi, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16113. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014022401/208.
(140026428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.
Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 152.733.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of January
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, (hereafter referred to as the
"Company"), a société en commandite par actions having its registered office at 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf,
qualifying as an investment company with variable share capital, fonds d’investissement spécialisé. The articles of asso-
ciation have been amended for the last time pursuant to a deed of the notary Marc LECUIT on 19 September 2011,
published in the Mémorial C, number 2826 on 18 November 2011.
The meeting was opened under the chairmanship of Gudrun Wolf, employee, with professional address in Luxembourg,
who appointed as secretary Andreas Hess, employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Eric Wadlé, employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- The extraordinary general meeting has been convened by convening notices setting forth the agenda of the meeting
published in the Mémorial of 20 December 2013 number 3244 and of 8 January 2014 number 59 and for the same dates
in the newspapers “Luxemburger Wort” and “Tageblatt”.
II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.
III.- It appears from the attendance list that out of 6,993.108 shares in circulation, 1 share is present or represented
at the present extraordinary general meeting.
A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as
the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on 16 December 2013 and could not validly decide on
the items of the agenda for lack of the legal quorum.
According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take
resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of registered office of the Company from 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf to 26, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxemburg and subsequent amendment of Article 4 “Registered office” of the articles of association of the Com-
pany.
2. Amendment of the denomination of the general partner (associé gérant commandité) of the Company from Lux
Capital Fund Management S.à r.l. to Lux Wealth S.à r.l. and subsequent amendment of Article 18 “General Partner” of
the articles of association of the Company.
3. Insertion of the possibility for the general partner of the Company to appoint an alternative investment fund manager
(“AIFM”) and to enter into an agreement with the AIFM in Article 19 “Powers of the General Partner” of the articles of
association of the Company.
4. Deletion in Article 24 “General meetings of the company” of the articles of association of the Company of the
necessity to obtain the CSSF’s approval in case where the third Thursday of the month of February, on which the annual
43677
L
U X E M B O U R G
general meeting of the shareholders shall be held, is not a banking day in Luxembourg and the meeting shall therefore be
held on the next banking day.
5. Deletion in Article 26 “Termination and amalgamation of Sub-Funds or classes of shares” of the articles of association
of the Company of the clause pursuant to which the assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the
implementation of the redemption of shares will be deposited with the depositary of the Company for a period of six (6)
months thereafter and updating of the reference to the law dated 20 December 2002 concerning undertakings for col-
lective investment to a reference to the law dated 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment.
6. Clarification in Article 29 “Auditor” of the articles of association of the Company that the auditor has to be an
“approved statutory” auditor.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf,
Grand-Duchy of Luxembourg to L-1930 Luxembourg, 26, Avenue de la Liberté, and to amend the first paragraph of
Article 4 “Registered office” of the articles of association so as to read as follows:
“ Art. 4. Registered office. The registered office of the Company shall be in the city of Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the General Partner. Within the same borough, the registered office may be transferred trough
simple resolution of the General Partner.”
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend the first paragraph of Article 18 “General Partner” of the articles of association in order
to reflect the name change of the general partner of the Company so as to read as follows:
“ Art. 18. General Partner. The Company shall be managed by Lux Wealth S.à r.l. in its capacity as general partner of
the Company (associé gérant commandité), a company incorporated under the laws of Luxembourg.”
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to insert a new sixth paragraph after the fifth paragraph of Article 19 “Powers of the General
Partner” of the articles of association which shall read as follows:
“The General Partner may appoint an alternative investment fund manager (“AIFM”) and enter into an agreement with
such AIFM for the provision of its services, the delegation of powers to it and the determination of its remuneration to
be borne by the Company.”
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to delete the half-sentence referring to the necessity to obtain the CSSF’s approval in the second-
last sentence of the sixth paragraph of Article 24 “General meetings of the company” of the articles of association.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to amend the third paragraph of Article 26 “Termination and amalgamation of Sub-Funds or
classes of shares” of the articles of association so as to read as follows:
“Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be de-
posited with the caisse de consignation on behalf of the persons entitled thereto in compliance with applicable legal and
regulatory requirements.”
and to replace the reference to the law dated 20 December 2002 concerning undertakings for collective investment
by a reference to the law dated 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment in the fourth
paragraph of Article 26 “Termination and amalgamation of Sub-Funds or classes of shares” of the articles of association.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 29 “Auditor” of the articles of association by introducing the term “approved
statutory” into the references to the auditor of the Company.
All the foregoing resolutions have been taken with the approval of the General Partner.
There being no further business the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English only.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Findel-Golf, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: G. WOLF, A. HESS, E. WADLÉ et H. HELLINCKX.
43678
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4557. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 février 2014.
Référence de publication: 2014022846/102.
(140027320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.
Prorealim S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4440 Soleuvre, 125A, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 93.085.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique prise en date du 31 janvier 2014i>
L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Résolution 1i>
Le siège social de la société est transféré à l'intérieur de la Commune de SANEM.
<i>Résolution 2i>
L'adresse du siège social est fixée à L-4440 SOLEUVRE, 125 A, rue d'Esch.
<i>Résolution 3i>
Les pouvoirs du ou des gérants, en cas de pluralité de gérants, sont arrêtés comme suit:
La société est représentée et/ou engagée en toutes circonstances par la seule signature individuelle d'un des gérants.
Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire moyennant sa seule signature individuelle tout acte d'admi-
nistration et/ou de disposition y compris les pouvoirs d'ouvrir et de clôturer des comptes en banques et ceux qui
consistent à accorder des hypothèques ou donner main levée d'hypothèque.
Chaque gérant est autorisé individuellement à négocier pour le compte de la société et signer seul tout contrat ou
convention en vue d'engager valablement la société par sa seule signature individuelle.
Chaque gérant a également le pouvoir pour acquérir et/ou à aliéner des biens mobiliers ou immobiliers, corporels,
incorporels, financiers ou dérivés.
Chaque gérant peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir, délégué ou mandataire quelconque. Il peut leur
conférer les pouvoirs qu'il jugera nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.
Chaque gérant est autorisé à conclure moyennant sa seule signature individuelle des contrats et/ou tout autre enga-
gement au nom de la société avec d'autres sociétés dont il assure la gestion respectivement est membre de l'organe de
gérance et/ou avec soi-même.
Soleuvre, le 31 janvier 2014.
Pour extrait conforme
La société
Référence de publication: 2014023645/31.
(140028127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.
Sareno, Sacha Rénovations S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3672 Kayl, 70, rue de Tetange.
R.C.S. Luxembourg B 162.569.
L'an deux mil quatorze, le vingt-neuvième jour de janvier.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Karl Helmut Reuter, maître-peintre, né le 29 octobre 1940 à Trèves (Allemagne), demeurant à D-54293
Trier, 117, Biewerer Strasse;
2.- Monsieur Aleksandar Markovic, décorateur mural, né le 18 avril 1978 à Vitkovici Bratunac (Yougoslavie), demeurant
à L-7260 Bereldange, 4, rue Adolphe Weis.
Les comparants, prénommés, requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils sont les seules associés de la société
à responsabilité limitée „Sacha Rénovations S.à r.l.“en abrégé „Sareno“de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
L-3926 Mondercange, 27A, Grand Rue, immatriculée auprès de registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
section B numéro 162.569, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 juillet 2011, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 27 septembre 2011 numéro 2291 (la «Société».),
43679
L
U X E M B O U R G
- que la Société a un capital social fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cent
cinquante euros (EUR 150,-) chacune, entièrement libérées.
Le comparant sous 1°, Monsieur Karl Helmut Reuter, déclare céder soixante-quatorze (74) parts sociales qu'il détient
dans la Société „Sacha Rénovations S.à r.l.“en abrégé „Sareno“, à Monsieur Aleksandar Markovic, prénommé sous 2°, ici
présent et ce acceptant, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.
Ensuite, Monsieur Karl Helmut Reuter, prénommé sous 1°, agissant en sa qualité de gérant technique de la Société et
Monsieur Aleksandar Markovic, prénommé sous 2°, agissant en sa qualité de gérant administratif déclarent ratifier la
susdite cession de parts sociales au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil.
Les associés acceptent expressément cette cession de parts sociales conformément à l'article 6 des statuts.
Sur ce qui précède, Monsieur Aleksandar Markovic, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à la cession de parts sociales précédente, les cent parts sociales de la Société sont désormais détenues comme
suit:
1° Monsieur Aleksandar Markovic, prénommé, cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL: CENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la cession de parts et de la résolution qui précède, l'associé unique décide d'adapter les statuts de la Société à
ceux d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle et de modifier en conséquence l'article 11 qui sera lue comme
suit:
Art. 11. «Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des
associés par la loi ou par les présents statuts.
Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L3926 Mondercange, 27A, Grand Rue, à L-3672
Kayl, 70, Rue de Tetange.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts
de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. (premier alinéa). "Le siège social de la Société est établi dans la commune de Kayl."
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de son assemblée générale extraordinaire s'élève approximativement à mille deux
cents euros (1.200.-EUR).
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et/ou employés de l'Étude du notaire
soussigné, pouvant agir individuellement, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état civil et demeure, lesdits comparants
ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: Karl Helmut Reuter, Aleksandar Markovic, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 février 2014. LAC / 2014 / 5484. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 February 2014.
Référence de publication: 2014022972/68.
(140027204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
43680
Almond S.àr.l..
Alysea Luxembourg Les Soins S.A
Atos Medical S.à.r.l.
Bauerenhaff, s.à r.l.
BBA Aviation Luxembourg Holdings S.à r.l.
Belfe S.A.
Best Products International
Biolaser Technologies et Finances S.A.
Castle 47 S.à r.l.
Centenario S.A.H.
Centre d'Isolation S.A.
Concept 4 Depollution
CPI Holding Luxembourg S.A.
Delphi Financial Services Luxembourg Sàrl
Edoreric S.A.
Edoreric S.A.
EUR-HYP S.A.
Growth Capital Invest S.A.
Hair Connection S.à r.l.
Hentou S.A.
HEQJ S.à r.l.
Hit Participations S.A.
HPMC2 S.à r.l.
HPMC2 S.à r.l.
HPMC2 S.à r.l.
IBT Consulting Sàrl
Immobilière DELLI ZOTTI S.à r.l.
Immobilière du Rhin S.A.
Immobilière WAGNER & WAGNER S.A.
Intabulis SCSp
Intelligent QualyCloud S.A.
KEV Germany Fuhrbergerstrasse S.à r.l.
Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A S.à r.l.
Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF
Marbrerie Tom Gelhausen S.à r.l.
Matthias RUPPERT GmbH
MA.ZA S.à r.l.
Mohé
Natalfin S.A
Obbos S.à r.l.
Prorealim S. à r.l.
Sacha Rénovations S.à r.l.
Sazele S.A.
ZBI Opportunity Real Estate S.C.A.,