logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 899

8 avril 2014

SOMMAIRE

Blue Eagle Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

43136

Blue Hawk Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

43143

Capital NL Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

43117

Germa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43110

GP Canada Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

43109

Grohe Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43129

ILCAV Capital Investment S.A.  . . . . . . . . .

43109

Ivaldi Multi-Strategy Fund GP  . . . . . . . . . . .

43109

IVG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

43111

La Croisette Property S.A. . . . . . . . . . . . . . .

43113

La Croisette Property S.A. . . . . . . . . . . . . . .

43112

Limba Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43110

Limba Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43111

LuxES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43112

Lux Insulation Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

43112

Luxlait Développement S.A.  . . . . . . . . . . . .

43112

L.W.A. Financial Engineering SPF, S.A.  . .

43111

Mami SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43108

Mandrinvest Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

43109

Margaux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43113

Marley Tile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43110

MEA SPF, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43108

M.E. Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43113

Merlen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43150

MFA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43108

Michel Euro Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

43107

Mine Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43107

Nade Luxco 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43106

Nade Luxco 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43106

Nade Luxco 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43107

Nigricolis Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

43106

Nuti Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43106

Okaidi Luxe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43152

Opéra Finance International S.A.  . . . . . . . .

43115

Opera Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43116

Opera Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43116

Orion III European 22 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

43114

Orion III European 23 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

43114

OT LUX G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43117

Paradis Night Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43115

Pemberton Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43106

PSPFINLUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43107

PSPFINLUX II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43117

Roosevelt International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

43108

Tesa Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43116

Titan SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43114

TP Façades S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43115

VECTIS Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43152

43105

L

U X E M B O U R G

Pemberton Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 35.250,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.752.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014024204/10.
(140028833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Nuti Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 181.676.

Les statuts coordonnés au 16 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024179/11.
(140029199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Nigricolis Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert Ier.

R.C.S. Luxembourg B 74.224.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014024181/11.
(140028725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Nade Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.583.

Les statuts coordonnés au 16 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024173/11.
(140029128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Nade Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.513.

Les statuts coordonnés au 16 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024172/11.
(140029235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43106

L

U X E M B O U R G

Nade Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.621.

Les statuts coordonnés au 16 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024174/11.
(140029175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Michel Euro Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 85.480.

Par  décision  de  l'assemblée  générale  ordinaire  du  5  février  2014,  les  mandats  des  administrateurs  Monsieur  Guy

BAUMANN, Monsieur Guy KETTMANN et Monsieur Jean BODONI, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT
TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
de 2019.

Luxembourg, le 14 février 2014.

<i>Pour: MICHEL EURO FINANCE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014024161/17.
(140028826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Mine Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MINE HOLDING S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014024164/12.
(140028702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

PSPFINLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 163.030.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue le 13 février 2014

Il a été décidé:
de remplacer Monsieur Pierre Gibeault en qualité de gérant de Catégorie A par Monsieur Raymond Granger, né le 29

juillet 1958 à Montréal, Directeur en chef, Investissements Immobiliers, demeurant 6 chemin de Hombourg, Lorraine,
Québec, J6Z 4N2.

Extrait certifié conforme
Signatures

Référence de publication: 2014024228/14.
(140029306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43107

L

U X E M B O U R G

MFA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 148.568.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024160/9.
(140028631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

MEA SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 166.734.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 24 janvier 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Andrea Giovanni Carini, résidant profes-

sionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur
l'exercice clôture au 31 décembre 2016;

-  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  de  son  adresse  actuelle  du  19-21  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724

Luxembourg vers le 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MEA SPF, S.A.
Société anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Signatures

Référence de publication: 2014024157/17.
(140029114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Mami SCI, Société Civile.

Siège social: L-5511 Remich, 12, rue des Bateliers.

R.C.S. Luxembourg E 641.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2014024154/12.
(140029203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Roosevelt International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.593.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
13 février 2014 à 11h00
a été nommé gérant unique Monsieur Gerardus H. M. OSSEVOORT, né le le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas et

demeurant professionnellement à 117 Val des Bons Malades

L-2121 Luxembourg, Luxembourg.
à effet du 13 février 2014
en remplacement de Monsieur Lambertus Hermanus SAK

ROOSEVELT INTERNATIONAL SARL

Référence de publication: 2014024240/16.
(140028571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43108

L

U X E M B O U R G

ILCAV Capital Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 162.456.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024075/14.
(140029167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

GP Canada Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.583.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 30 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2014024050/11.
(140029044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Ivaldi Multi-Strategy Fund GP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 164.006.

Les statuts coordonnés au 13/02/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 14/02/2014.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024087/12.
(140029296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Mandrinvest Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 172.480.

EXTRAIT

<i>Modification au dépôt n°L140022341 du 04.02.2014

- Prime Directors Ltd a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat.
- Monsieur Christian Bühlmann, né à Etterbeek, le 1 

er

 mai 1971, résidant professionnellement au 127 rue de Müh-

lenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé en date du 27 janvier 2014 administrateur de la Société jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle de 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MANDRINVEST FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024146/17.
(140029225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43109

L

U X E M B O U R G

Marley Tile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 112.377.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013

(...)
L'assemblée prend acte de la démission le 31 juillet 2013 de Monsieur Frédéric Deslypere, en tant qu'administrateur

de la société.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Jean-Pierre Hanin, domicilié à 1180 Bruxelles,

Avenue Hamoir 64, à partir du 1 

er

 septembre 2013 pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2019, statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
(...)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2013.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Karin DUBOIS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014024147/21.
(140028814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Germa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 44.327.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 20 décembre

<i>2013 à 11.00 heures

L’assemblée renouvelle jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2019 les mandats des administrateurs

suivants:

Madame Daniela PERLI, née le 22.07.1973 à Bressanone (I), demeurant à D - 54294 Trèves, 10, Kordelstrasse
Monsieur Paolo LEONI, né le 15.1.1965 à Fralienfeld (CH), demeurant à D - 54294 Trèves, 10, Kordelstrasse
Le mandat de Monsieur Valerio BERTI n’est plus renouvelé.
Il sera remplacé par Madame Irene PERLI, née le 03.06.1971 à Brixen (I), demeurant à I - 39049 Wiesen/Pfitsch (BZ),

Bahnhofstrasse 31

Le mandat du commissaire aux comptes la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy est également renouvelé jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale de l’an 2019.

Luxembourg, le 26 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014024045/22.
(140029152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Limba Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 178.839.

Les statuts coordonnés au 14 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024119/11.
(140029062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43110

L

U X E M B O U R G

L.W.A. Financial Engineering SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 165.775.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 24 janvier 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Antonio Forte, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 17 décembre 2013;

- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Andrea Giovanni Carini, résidant profes-

sionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur;

-  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  de  son  adresse  actuelle  du  19-21  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724

Luxembourg vers le 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L.W.A. FINANCIAL ENGINEERING SPF, S.A.
Société anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Signatures

Référence de publication: 2014024115/18.
(140028889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Limba Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 178.880.

Les statuts coordonnés au 14 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014024120/11.
(140029096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

IVG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 150.381.

<i>Auszug aus der Schriftlichen Beschlussfassung des Alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 11.02.2014

Am 11.02.2014 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgenden Beschluss gefasst:
- Ernennung von Herrn Mag. Andreas Rosenberger, geboren am 24. Februar 1970 in Amstetten, Österreich, mit

beruflicher Adresse bei der IVG Austria AG, Riemergasse 14/16, 1010 Wien, Österreich, als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft mit sofortiger Wirkung und dies für eine unbestimmte Zeit.

Infolge des vorliegenden Beschlusses wird sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft fortan wie folgt zusammense-

tzen:

- Herr Bernhard Berg;
- Herr Dr. Matthias Eder;
- Frau Irmgard Linker;
- Herr Mag. Andreas Rosenberger;
- Herr Osman Saritaria; und
- Herr Cyril Arnos Schelling.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11.02. 2014.

IVG Luxembourg S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2014024099/25.
(140029002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43111

L

U X E M B O U R G

Lux Insulation Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 174.226.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 30 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2014024123/11.
(140028988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

LuxES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Marie-Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 169.357.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024127/10.
(140029104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

La Croisette Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 163.614.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LA CROISETTE PROPERTY S.A.

Référence de publication: 2014024128/10.
(140028929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Luxlait Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7759 Roost,

R.C.S. Luxembourg B 62.101.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société LUXLAIT DÉVELOPPEMENT S.A. qui

s’est tenue le 21 octobre 2013, les nominations suivantes pour les postes des personnes chargées du contrôle des comp-
tes:

<i>Première et unique résolution:

«L’Assemblée désigne les sociétés
i) Audit and Trust Services S.à. r.l., ayant son siège au 6, Jos Seylerstross, L-8522 Beckerich, Luxembourg, représentée

par Madame Zoé MAKA, et

ii) Audit &amp; Consulting Services S.à. r.l., ayant son siège au 9-11, Rue Louvigny, L-1946 Luxembourg-Ville, Luxembourg,

représentée par Monsieur Olivier CAGIOULIS, comme réviseurs d’entreprises pour l’exercice de l’année 2013.

Leur mandat prendra ainsi fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2014.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Roost, le 22 octobre 2013.

<i>Pour LUXLAIT DÉVELOPPEMENT S.A.
Claude STEINMETZ
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014024141/23.
(140029174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43112

L

U X E M B O U R G

La Croisette Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 163.614.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 janvier 2014

A démissionné de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat:
- Monsieur Benoît de FROIDMONT, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxem-

bourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2019:

- Audit Lux S.à r.l., 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024129/15.
(140028964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

M.E. Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9278 Diekirch, 9, rue Sauerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 158.891.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024144/10.
(140029155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Margaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 124.633.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 6 février 2014 que:
- le siège social de la société a été transféré du 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 7, route d'Esch, L-1470

Luxembourg avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2014.

- la démission de Monsieur Benoît Lejeune de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet immédiat.
- a été nommée administrateur de la société avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2014, la société AYAM HOLDING

SA SPF avec siège social au 7, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B
174.073 représentée par Madame Isabelle Hamer, demeurant professionnellement à Bohey 36, L-9647 Doncols. Son
mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.

- a été ratifiée la nomination par cooptation en date du 14 janvier 2014 de la société MALIBARO SA SPF avec siège

social au 36, Bohey, L-9647 Doncols, inscrite auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B 134.992 représentée par
Madame Marie Rose Hartman demeurant professionnellement au 36, Bohey, L-9647 Doncols, en qualité d'administrateur
de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2020.

Le conseil d'administration se compose désormais des membres suivants:
- Monsieur Moyse Dargaa
- la société AYAM HOLDING SA SPF représentée par Madame Isabelle Hamer
- la société MALIBARO SA SPF représentée par Madame Marie Rose Hartman
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MARGAUX S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014024155/29.
(140028708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43113

L

U X E M B O U R G

Orion III European 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 184.430.

EXTRAIT

En date du 12 février 2014, Orion Master III Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-140853, alors associé unique de Orion III European 22 S.à r.l., a cédé
la totalité de ses quinze mille (15,000) parts sociales qu'elle détenait dans Orion III European 22 S.à r.l. à Orion III European
24 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184
434.

Suite à cette cession, Orion III European 24 S.à r.l. est devenue l'associé unique de Orion III European 22 S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion III European 22 S.à r.l.

Référence de publication: 2014024189/19.
(140029183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Orion III European 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 184.433.

EXTRAIT

En date du 13 février 2014, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de M. Anthony Halligan en

tant que gérant avec effet au 13 février 2014.

En conséquence, le conseil de gérance est dorénavant composé comme suit:
- M. Nicolas Brimeyer;
- M. Christopher Jenner;
- M. Ronald de Koning; et
- M. Olivier de Nervaux.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orion III European 23 S.à r.l.

Référence de publication: 2014024190/18.
(140029181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Titan SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 83.613.

EXTRAIT

IL RESULTE D'UNE DECISION PRISE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2014
QUE SONT REELUS AUX POSTES D'ADMINISTRATEUR, LEURS MANDATS SE TERMINANT LORS DE L'ASSEM-

BLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L'EXERCICE 2016

- MADAME MARIE-PAUL VAN WAELEM, née le 05.01.1950 à Uccle (B), demeurant au 11A Boulevard Joseph II, L -

1840 Luxembourg

- MADAME MARIE JOSEPH RENDERS, née le 17.10.1948 à Halle (B), demeurant au 11A Boulevard Joseph II, L - 1840

Luxembourg

- FIDIGA S.A.
inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro B 23 598, avec siège social 30 Boulevard Grande

Duchesse Charlotte L - 1330 Luxembourg et dont le représentant légal est Madame Marie Joseph Renders, demeurant
au 11A Boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg

43114

L

U X E M B O U R G

QU'EST ELU AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, EN REMPLACEMENT DE EWA REVISION S.A., SON

MANDAT SE TERMINANT LORS DE L'ANNEE 2017

- FIRELUX S.A.
Inscrite au Registre de Commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 84 589 avec siège social au 45 Avenue

J.F. Kennedy L - 9053 Ettelbrück

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014023752/26.
(140028043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Paradis Night Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 61, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 75.936.

<i>Résolution des associés prise en date du 03 février 2014

Il résulte d’une résolution des associés de la société PARADIS NIGHT prise en date du 03 février 2014
1. que Madame VASQUEZ Maria de Los Angeles, épouse LOPES GARCIA Luis Antonio, née le 08 octobre 1953 à

Moca, demeurant à L-1243 Luxembourg, 30, Rue Felix de Blochausen est révoquée de ses fonctions de gérante technique
avec effet immédiat,

2. que Madame Rachel DOHM, née le 07 mars 1983, demeurant à L-2230 Luxembourg, 61 Rue du Fort Neipperg est

nommée comme nouvelle gérante technique pour une durée indéterminée avec effet immédiat,

3. que la société sera valablement engagée par la seule signature de la gérante technique.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024217/17.
(140028798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Opéra Finance International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 103.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024197/10.
(140029079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

TP Façades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 7, An der Griecht.

R.C.S. Luxembourg B 139.518.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le trente janvier.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Paulo Sergio DA COSTA TECEDEIRO, dirigeant de société, demeurant à L-3390 Peppange, 7, An der

Griecht.

Le comparant expose ce qui suit:
1) Il est propriétaire de la totalité des parts de la société "TP FACADES S.àr.l." établie et ayant son siège social à L-3390

Peppange, 7, An der Griecht, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139.518, constituée
suivant acte du notaire Aloyse BIEL de Esch-sur-Alzette en date du 16 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C, Numéro 1713 du 11 juillet 2008 et dont le capital social est fixé à douze mille quatre cents
euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR
124,-) chacune, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.

43115

L

U X E M B O U R G

3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, il prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Il se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la

Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin, par
rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, il assume irrévocablement
l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

5) L'actif restant est attribué à l'associé unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.
9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'actionnaire actuel est le bénéficiaire économique

de l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: DA COSTA TECEDEIRO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: LAC / 2014 / 4903. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): THILL

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Référence de publication: 2014023759/42.
(140028386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Opera Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 93.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024198/10.
(140029078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Opera Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 93.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024199/10.
(140029082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Tesa Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 136.275.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2011 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2014024299/11.
(140029301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

43116

L

U X E M B O U R G

OT LUX G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 22, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 139.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024200/9.
(140029160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

PSPFINLUX II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 181.580.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue le 13 février 2014

Il a été décidé:
de remplacer Monsieur Pierre Gibeault en qualité de gérant de Catégorie A par Monsieur Raymond Granger, né le 29

juillet 1958 à Montréal, Directeur en chef, Investissements Immobiliers, demeurant 6 chemin de Hombourg, Lorraine,
Québec, J6Z 4N2.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014024229/15.
(140029320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Capital NL Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 184.271.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of the month of January.
Before Us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1) HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with

registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London SE1 2AP,
United Kingdom and registered under number LP014211,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given in London (United Kingdom), on 23 January 2014,
2) HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with

registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV (Non-US) LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London
SE1 2AP, United Kingdom and registered under number LP014367,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in London (United Kingdom), on 23 January 2014;
3) HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with

registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV (US) LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London SE1
2AP, United Kingdom and registered under number LP014212,

here represented by Mrs Fantine Jeannon, prenamed, by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on 23

January 2014;

4) HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with

registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV (B) LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London SE1
2AP, United Kingdom and registered under number LP014213,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

43117

L

U X E M B O U R G

by virtue of a proxy under private seal given in London (United Kingdom), 23 January 2014;
Said proxies after being signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed the present deed for registration authorities.

The appearing parties, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Capital NL Topco S.à r.l.” (the “Company”). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and these articles of incorpo-
ration (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions pre-
scribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries and any affiliated companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those
of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of
doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand five-hundred euro (EUR 12,500.-) divided into

one hundred and twenty-five thousand (125,000) class A shares (the “Class A Shares”), one hundred and twenty-five
thousand (125,000) class B shares (the “Class B Shares”), one hundred and twenty-five thousand (125,000) class C shares
(the “Class C Shares”), one hundred and twenty-five thousand (125,000) class D shares (the “Class D Shares”), one
hundred and twenty-five thousand (125,000) class E shares (the “Class E Shares”), one hundred and twenty-five thousand
(125,000) class F shares (the “Class F Shares”), one hundred and twenty-five thousand (125,000) class G shares (the “Class
G Shares”), one hundred and twenty-five thousand (125,000) class H shares (the “Class H Shares”), one hundred and
twenty-five thousand (125,000) class I shares (the “Class I Shares”), one hundred and twenty-five thousand (125,000)
class J shares (the “Class J Shares”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (together referred to as the “Shares”
and each a “Share”), all of which are fully paid up.

43118

L

U X E M B O U R G

5.2. The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by

the Articles (especially as regards the rights with respect to the Distributions (as defined below) or by the Law).

5.3. In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share

in addition to its nominal value is transferred.

Subject to the conditions set by the Law and in compliance with the foregoing provisions, the manager(s) or, as the

case may be, the Board may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The manager(s) or, as the
case may be, the Board determine(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

5.4 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accor-

dance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one (1) or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. By a resolution of the shareholders, the appointed managers can be classified as category A
and category B managers. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the “Board”).
8.1. Powers of the Board
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one (1) or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda

for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written
notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by
the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers' Circular Resolutions”) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation

43119

L

U X E M B O U R G

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of a manager. In case the shareholders

have resolved to classify the appointed managers as category A and category B managers, the Company is bound towards
third parties in all matters by the joint signature of at least one (1) category A and one (1) category B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board of the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the “General Meeting”) or by

way of circular resolutions (the “Shareholders' Circular Resolutions”) to the extent permitted by the Law.

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Distributions - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

43120

L

U X E M B O U R G

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Allocation of profit.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the shareholders must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and
(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 15. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half (1/2) of the shareholders

holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) to the extent and in consideration of such classes of Shares
which are still in issue at the time of the liquidation, according to the rules set in article 5 of these Articles.

VII. General provisions

Art. 16.
16.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31 

st

 , 2014.

<i>Subscription and Payment

The Articles of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed

and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred per cent
(100%) paid in cash as follows:

Shareholders

subscribed

capital

number of shares amount paid-in

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account

720890, acting as Nominee for Montagu IV LP . . . . . . . .

EUR 10,867.20

108,672 Class A Shares

108,672 Class B Shares

108,672 Class C Shares

EUR 10,867.20

43121

L

U X E M B O U R G

108,672 Class D Shares

108,672 Class E Shares

108,672 Class F Shares

108,672 Class G Shares
108,672 Class H Shares

108,672 Class I Shares
108,672 Class J Shares

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account
720890, acting as nominee for Montagu IV (Non-US)
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 416.60

4,166 Class A Shares

4,166 Class B Shares

4,166 Class C Shares

4,166 Class D Shares

4,166 Class E Shares

4,166 Class F Shares

4,166 Class G Shares
4,166 Class H Shares

4,166 Class I Shares
4,166 Class J Shares

EUR 416.80

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account
720890, acting as nominee for Montagu IV (US) LP . . . .

EUR 235.40

2,354 Class A Shares

2,354 Class B Shares

2,354 Class C Shares

2,354 Class D Shares

2,354 Class E Shares

2,354 Class F Shares

2,354 Class G Shares
2,354 Class H Shares

2,354 Class I Shares
2,354 Class J Shares

EUR 235.40

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account
720890, acting as nominee for Montagu IV (B) LP . . . . .

EUR 980,80

9,808 Class A Shares

9,808 Class B Shares

9,808 Class C Shares

9,808 Class D Shares

9,808 Class E Shares

9,808 Class F Shares

9,808 Class G Shares
9,808 Class H Shares

9,808 Class I Shares
9,808 Class J Shares

EUR 980.80

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12,500.-

125,000 Class A Shares

125,000 Class B Shares

125,000 Class C Shares

125,000 Class D Shares

125,000 Class E Shares

125,000 Class F Shares

125,000 Class G Shares
125,000 Class H Shares

125,000 Class I Shares
125,000 Class J Shares

EUR 12,500.00

The amount of twelve thousand five hundred euro (12'500.- EUR) was thus as from that moment at the disposal of

the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided
for in article 183 of the aw of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses and Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000).

<i>Resolutions taken by the shareholders

The aforementioned appearing parties, representing the whole of the subscribed share capital, have adopted the fol-

lowing resolutions:

1. the number of managers is set at 3 (three), divided in category A and category B managers. The signing power of

the Company is described by the joint signature of any category A plus any category B manager.

2. Are appointed as managers of the Company, for an unlimited period of time:

43122

L

U X E M B O U R G

(i) Mr Graham HISLOP, director, with professional address at 2 More London Riverside, SE1 2AP London, United

Kingdom, as category manager A of the Company;

(ii) Ms Fantine JEANNON, employee, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as category

manager B of the Company; and

(iii) Mr. Christoph KOSSMANN, employee, with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as

category manager B of the Company.

3. the registered office is established at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above named

parties, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing parties, in
case of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the date

mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by her surname,

name, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Follows the german translation of the foregoing text:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierundzwanzigsten Tag des Monats Januar.
Vor Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

sind erschienen:

1) „HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach

britischem Recht -, mit Gesellschaftssitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, Grossbritanien, eingetragen unter der
Nummer  228660,  als  Vertreter  für  Montagu  IV  LP,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  und  bestehend  nach
britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 2 More London Riverside, London SE1 2AP, Großbritannien, eingetragen bei
der “Companies House London“ unter der Nummer LP014211,

hier vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, Angestellter, geschäftsansässig in Bad-Mondorf,
aufgrund einer ihm, am 23. Januar 2014, in London (Großbritannien) erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
2) „HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach

britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien, eingetragen unter der
Nummer 228660, als Vertreter für Montagu IV (Non-US) LP, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und bestehend
nach britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 2 More London Riverside, London SE1 2AP, Grossbritanien, eingetragen
bei der “Companies House London“ unter der Nummer LP014367,

hier vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, vorgenannt,
aufgrund einer ihm, am 23. Januar 2014, in London (Großbritannien) erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
3) „HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach

britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien, eingetragen unter der
Nummer 228660, als Vertreter für Montagu IV (US) LP, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und bestehend nach
britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 2 More London Riverside, London SE1 2AP, Grossbritanien, eingetragen bei
der “Companies House London“ unter der Nummer LP014212,

hier vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, vorgenannt,
aufgrund einer ihm, am 23. Januar 2014, in London (Großbritannien) erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
4) „HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited Account 720890“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach

britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 8 Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien, eingetragen unter der
Nummer 228660, als Vertreter für Montagu IV (B) LP, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und bestehend nach
britischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 2 More London Riverside, London SE1 2AP, Grossbritanien, eingetragen bei
der “Companies House London“ unter der Nummer LP014213,

hier vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, vorgenannt,
aufgrund einer ihm, am 23. Januar 2014, in London (Großbritannien) erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
Diese Vollmachten werden nach Zeichnung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten vorliegender

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, die wie oben angegeben vertreten werden, haben den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt zu beurkunden

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Der Name der Gesellschaft lautet „Capital NL Topco S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großher-
zogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in
seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

43123

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-

schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde
verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter, in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen über die Satzungsänderung, an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.1 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Wenn der Geschäftsführungsrat feststellt, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung  zwischen  diesem  Gesellschaftssitz  und  Personen  außerhalb  behindern  können,  kann  der  Gesellschaftssitz
vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind.
Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer
vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt, die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten an ihre Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in
Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder
auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesell-
schaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder
Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung
reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3.  Die  Gesellschaft  ist  befugt  sich  jeglicher  Verfahren  und  Mittel  zu  bedienen,  um  ihre  Investitionen  effizient  zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug

auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschafts-
zweck beziehen lassen oder diesen fördert.

Art 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2.  Die  Gesellschaft  wird  nicht  aufgrund  eines  Todesfalles,  der  Aufhebung  von  Bürgerrechten,  Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), bestehend aus einhun-

dertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse A Stammanteilen (die „A Stammanteile“), einhundertfünfundzwanzigtausend
(125.000) Klasse B Stammanteilen (die „B Stammanteile“), einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse C Stamm-
anteilen (die „C Stammanteile“), einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse D Stammanteilen (die „D Stamm-
anteile“), einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse E Stammanteilen (die „E Stammanteile“), einhundertfün-
fundzwanzigtausend  (125.000)  Klasse  F  Stammanteilen  (die  „F  Stammanteile“),  einhundertfünfundzwanzigtausend
(125.000) Klasse G Stammanteilen (die „G Stammanteile“), einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse H Stamm-
anteilen (die „H Stammanteile“), einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse I Stammanteilen (die „I Stamman-
teile“) und einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse J Stammanteilen (die „J Stammanteile“), (jede einzelne
„Stammanteil“, alle zusammen die „Stammanteile“), alle in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem
Cent (EUR 0,01), alle Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Alle an die Stammanteile gebundenen Rechte und Pflichten sind identisch, sofern nichts Anderes in diesem Artikel

bestimmt ist (und besonders für die Verteilungsrechte wie hierrunter erklärt)

5.3. Die Gesellschafter können beschließen, dass die Gesellschaft eine spezielle Kapitalrücklage bilden kann, wobei ein

Betrag oder Wert, welcher dieser speziellen Kapitalrücklage zugeführt werden soll, in Übereinstimmung mit dem Gesetz,
als Kapitalrücklage der Gesellschaft ausschüttbar ist.

43124

L

U X E M B O U R G

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit diesem Artikel, können die Ge-

schäftsführer oder kann der Verwaltungsrat die Entscheidung einer Vorausdividendenzahlung an die Anteilseigner treffen.
Die Geschäftsführer oder der Verwaltungsrat werden (wird) den Betrag und das Datum der Zahlung bestimmen.

5.4. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Geschäftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen (inter vivos) an Dritte

der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
vertreten müssen.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte aufgrund eines Todesfalles, bedarf der Zustimmung der Gesellschaf-

ter, welche drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss

der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung  können  die  ernannten  Geschäftsführer  in  Kategorie  A  Geschäftsführer  und  Kategorie  B  Geschäftsführer
unterteilt werden. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2 Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen

werden.

Art. 8. Geschäftsführungsrat.  Wurden  mehrere  Personen  zum  Geschäftsführer  ernannt,  so  bilden  diese  den  Ge-

schäftsführungsrat (der „Rat“).

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i)  Sämtliche  Befugnisse,  welche  nicht  ausdrücklich  per  Gesetz  oder  durch  die  Satzung  dem/den  Gesellschafter(n)

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen
und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere

Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen.

8.2. Verfahren
(i) Auf Antrag eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates statt, an dem in der Ankündigung

genannten Ort, welcher sich grundsätzlich in Luxemburg befindet.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlungen des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

43125

L

U X E M B O U R G

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-

nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die „Zirkularbeschlüsse der Ge-

schäftsführer“), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers

gebunden. Falls die Gesellschafter die Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer
unterteilt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Kategorie A Geschäftsführer und ein
Kategorie B Geschäftsführer gemeinsam unterzeichnen.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausge-

statteten Personen gebunden.

Art. 9. Einzelner Gesellschaftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede Referenz, welche sich auf den

Geschäftsführungsrat bezieht, soweit möglich, sinngemäß auch auf den einzelnen Geschäftsführer anzuwenden.

9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzelnen Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift von Personen gebunden, denen der

einzelne Geschäftsführer Spezialvollmachten erteilt hat.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für

Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie dem Gesetz stehen.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder

durch Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter (die „Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter“) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welche das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen, sind genauso
gültig und verbindlich als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wor-
den.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage

im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen  Gesellschafter  erklären,  dass  ihnen  die  Tagesordnung  bekannt  ist  und  sie  sich  selbst  als  ordnungsgemäß
einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich um einen Gesellschafter handeln kann oder nicht,

eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

43126

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Alleingesellschafter.
12.1 Sofern die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus,

welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden

Jahres.

13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer

Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt, mit einem Anhang, welcher alle Verpflichtungen
der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft
zusammenfasst.

13.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von

Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-

lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Agio) zur Ausschüttung

zur Verfügung stehen; wobei es sich hierbei versteht, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorher-
gehenden  Geschäftsjahres  erzielten  Gewinne,  soweit  vorhanden,  für  welches  die  Jahresabschlüsse  bereits  bewilligt
wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und auszuschüttenden Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen
Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)

Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft werden durch die Zwischenausschüttung in Anbetracht der Vermö-

genswerte der Gesellschaft nicht gefährdet; und (v) falls die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen
Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den Betrag, welcher
den ausschüttbaren Gewinn übersteigt, zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

Art. 15. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder
mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zur Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter,
haben die Liquidatoren die Befugnis, die Vermögenswerte zu realisieren und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen.

VII. Allgemeine Bestimmungen

Art. 16.
16.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-

beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder
jeder anderen Form von elektronischem Kommunikationsmittel dokumentiert werden.

16.2. Vollmachten können in jeder der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit

einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten
Bedingungen erteilt werden.

16.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt diese

erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse zur Anerkennung als handschriftliche Unterschrift. Unterschriften auf Zirkularbe-
schlüssen der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen
desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

43127

L

U X E M B O U R G

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden

Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung, die
die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung der Gesellschaft wurde hiermit durch den Notar aufgenommen, die gezeichneten Gesellschaftsanteile und

der Nominalwert dieser Anteile, sowie die spezielle Kapitalrücklage, falls vorhanden, wurden einhundert Prozent (100%)
wie folgt bar eingezahlt:

Anteilseigner

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl Anteile

Gesamter

Betrag

eingezahlt

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
Account 720890, als Nominee für Montagu IV LP . . .

EUR 10,867.20

108,672 A Stammanteile

108,672 B Stammanteile

108,672 C Stammanteile

108,672 D Stammanteile

108,672 E Stammanteile

108,672 F Stammanteile

108,672 G Stammanteile
108,672 H Stammanteile

108,672 I Stammanteile
108,672 J Stammanteile

EUR 10,867.20

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
Account 720890, als Nominee für Montagu IV
(Non- US) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 416.60

4,166 A Stammanteile

4,166 B Stammanteile

4,166 C Stammanteile

4,166 D Stammanteile

4,166 E Stammanteile

4,166 F Stammanteile

4,166 G Stammanteile
4,166 H Stammanteile

4,166 I Stammanteile
4,166 J Stammanteile

EUR 416.80

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
Account 720890, als Nominee für Montagu IV (US)
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 235.40

2,354 A Stammanteile

2,354 B Stammanteile

2,354 C Stammanteile

2,354 D Stammanteile

2,354 E Stammanteile

2,354 F Stammanteile

2,354 G Stammanteile
2,354 H Stammanteile

2,354 I Stammanteile
2,354 J Stammanteile

EUR 235.40

HSBC Global Custody Nominees (UK) Limited
Account 720890, als Nominee für Montagu IV (B)
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 980,80

9,808 A Stammanteile

9,808 B Stammanteile

9,808 C Stammanteile

9,808 D Stammanteile

9,808 E Stammanteile

9,808 F Stammanteile

9,808 G Stammanteile
9,808 H Stammanteile

9,808 I Stammanteile
9,808 J Stammanteile

EUR 980.80

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12,500.- 1,250,000 A Stammanteile

1,250,000 B Stammanteile

1,250,000 C Stammanteile

1,250,000 D Stammanteile

1,250,000 E Stammanteile

1,250,000 F Stammanteile

1,250,000 G Stammanteile

EUR 12,500.00

43128

L

U X E M B O U R G

1,250,000 H Stammanteile

1,250,000 I Stammanteile
1,250,000 J Stammanteile

Ein Betrag von zwölftausandfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) steht der Gesellschaft, gemäß dem Notar weitergeleiteten

Nachweis, zur Verfügung. Der Notar kann hierbei bestätigen, dass alle Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes von
10. August 1915 für gewerbliche Unternehmen, in seiner geänderten Fassung, respektiert wurden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Ge-

sellschaft aus Anlass des vorliegenden Aktes entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000).

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

Die vorgenannten und wie oben angegeben vertretenen Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftska-

pital vertreten, fassen die folgenden Beschlüsse:

1. die Zahl der Geschäftsführer wird auf 3 (drei) festgelegt, die in Geschäftsführern der Kategorie A und der Kategorie

B  eingeteilt  werden.  Die  Zeichnungsberechtigung  der  Gesellschaft  ist  durch  die  gemeinsame  Unterschrift  eines  Ge-
schäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B festgelegt.

2. die folgenden Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft für eine unbegrenzte Zeit ernannt:
(i) Herr Graham HISLOP, Direktor, geschäftsansässig in 2 More London Riverside, UK-SE1 2AP London, Grossbri-

tannien, als Kategorie A Geschäftsführer;

(ii) Frau Fantine JEANNON, Angestellte, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, als Kategorie B

Geschäftsführer; und

(iii) Herr Christoph KOSSMANN, Angestellter, geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, als Kate-

gorie B Geschäftsführer.

3. der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg festgelegt.
Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Parteien die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Parteien ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fas-
sung die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde, Augenommen in Luxemburg, am oben genannten Datum.
Nachdem der Text dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, dessen Vor- und Nachname, Status

und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigten der
Erschienenen gemeinsam mit uns, dem Notar, unterzeichnet.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 30 janvier 2014. REM/2014/289. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021363/686.
(140025492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Grohe Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.086.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of January,
before us Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Grohe Group S.à r.l., a société à responsabilité limitée go-

verned by the laws of Luxembourg, with registered office at 5C, rue Eugène Ruppert, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a notarial deed of 18 May 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 637 of 21 June 2004 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 101.086 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following
a notarial deed of 23 April 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1617 of 6
July 2013.

The meeting was declared open at 5.00 p.m.,
by Me Nicolas Gauzès, lawyer, with professional address in Luxembourg, in the chair,

43129

L

U X E M B O U R G

who appointed as secretary Me Alessandro Sorcinelli, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Florence Forster, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To amend article 13 of the articles of incorporation of the Company in order to grant individual signature authority

to the chairman of the board of managers of the Company;

2 To amend article 14 of the articles of incorporation of the Company in order to provide, among other items, for a

board of managers, the appointment of a chairman of the board of managers having a casting vote, a vice chairman, a
senior vice chairman and a secretary and to restate the quorum and majority rules for meetings of the board of managers;

3 To amend article 18 of the articles of incorporation of the Company in order to provide for a list of shareholders’

reserved matters requiring the board of managers to obtain the express consent of the general meeting of the share-
holders;

4 To acknowledge the resignation of managers of the Company and appoint new managers of the Company.
(ii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iii) That pursuant to the attendance list, shareholders representing one hundred per cent (100%) shares out of a total

of fifty-seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven (57,142,857) shares are present or re-
presented and declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their
right to be formally convened.

(iv) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(v) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company which shall read as

follows:

“ Art. 13. The Company is managed by one or several managers (each a "Manager"), which do not need to be share-

holders.

The Manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
The Managers may be dismissed freely at any time without there having to exist a legitimate reason and without

compensation.

The Managers or the Board of Managers, as the case may be, may grant special powers by authentic proxy or power

of attorney by private instrument.

The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the signature of at least two Managers or

by the sole signature of the Chairman.”

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to amend article 14 of the articles of incorporation of the Company which shall read as

follows:

“ Art. 14. In dealings with third parties, the management shall have the most extensive powers to act in the name of

the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object subject to the
rights reserved to the shareholders.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The general meeting of the shareholders shall appoint one member of the Board of Managers as chairman and CEO

(the “Chairman” or “CEO”). The Board of Managers may appoint a secretary, who need not be a Manager himself and
who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman or by two (2) Managers.
Notice of any meeting of the Managers must be given in writing (including by email or any other form of communication

of a written text) to the Managers forty-eight (48) hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. A
special convocation will not be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the Managers.

The meetings of the Managers or the Board of Managers, as applicable, shall be held in Luxembourg or at such other

place as the Managers or the Board of Managers, as applicable, may from time to time determine.

43130

L

U X E M B O U R G

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers. The Chairman may appoint another member

of the Board of Managers to represent him in his absence and preside the relevant meeting of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office.

Any Manager may act at any meeting by appointing in writing (including by email or any other form of communication

of a written text) another Manager as his proxy. Any Manager may represent more than one of his colleagues.

Any Manager may participate in any meeting by conference-call, videoconference or by other similar means of com-

munication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The minutes of any meeting shall be signed by the
Chairman at such meeting.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at a meeting. In case of a

tie, the Chairman will have a casting vote.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.”

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to amend article 18 of the articles of incorporation of the Company which shall read as

follows:

“ Art. 18.
18.1 A certain amount of shares of the company might be held by Cai GmbH, a German law governed company with

limited liability, having its registered office at WinterstraBe 4-8, 22765 Hamburg, Germany, (herein "Cai GmbH"), which
in tum shall be wholly-owned by the Cai family composed of Mr. Cai, Jianshe and Mr. Cai, Jilin (the "Cai Family").

The  following  items  shall  require  the  approval  of  the  general  meeting  of  shareholders  and  none  of  the  following

decisions shall be adopted by the general meeting of shareholders without the express approval and positive vote of Cai
GmbH:

- any capital increase (unless in the context of an IPO) or decrease of the Company;
- any redemption of shares of the Company;
- any change of the corporate purpose of the Company; and
- the dissolution and liquidation of the Company.
"IPO" shall mean an initial public offering for sale or subscription of equity securities, issued by the Company, to be

admitted for trading at a Stock Market, such initial public offering to include a share capital increase component regarding
the Company in line with the proposal of the underwriting bank(s) for such capital increase amount, the consortium of
underwriters to include at least one of the leading global investment banks defined as having been among the top ten
equity underwriters (global equity issuance volume) over a period of two years prior to the commencement of the initial
public offering, provided that, based on the lower end of the bookbuilding range as agreed in the price range agreement,
Grohe Group's enterprise value shall amount to not less than six times of Grohe Group's adjusted EBITDA in the full
financial year preceding the initial public offering. "Stock Market" shall mean a regulated market within the meaning of the
EU Markets in the Financial Instruments Directive (MiFID) or equivalent markets outside of the EU.

The veto rights of Cai GmbH as set forth in this Article 18 shall terminate on the earlier of (i) a decision of an

extraordinary general meeting of shareholders of the Company to increase the share capital of the Company in the
context of an IPO, resolving in accordance with the majority as required for amendments to the articles of association
according to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, or (ii) the closing of a sale of the majority
of shares in, or other change of Control with respect to, the Company, whereas the shares of the acquirer are traded
at a Stock Market and the consideration for such sale or change of Control payable to Cai GmbH consists of shares of
the acquirer admitted for trading at a Stock Market, or (iii) Cai GmbH holding less than five million (5,000,000) shares in
the Company, or (iv) the date where the Cai Family shall cease to hold, directly or indirectly, all the shares and the voting
rights of Cai GmbH. "Control" shall mean the ownership of more than 50 percent of the issued share capital/voting rights
or the legal power to direct, or cause the direction of, the management and policies of a Person, directly or indirectly,
whether through the ownership of securities or partnership or other ownership interests and/or voting rights, by contract
or otherwise. "Person" shall be broadly interpreted to mean a natural person, or any trust, corporation, partnership,
limited liability company or any other legal entity.

In case of termination of the veto rights, any of the decisions listed in the second paragraph above of this Article 18.1

shall be adopted in accordance with the terms of the present articles of association without any restriction.

18.2 The following items shall require the approval of the general meeting of shareholders and none of the following

decisions shall be adopted by the Managers or the Board of Managers, as applicable, without the express approval of the
general meeting of the shareholders with the majority set out in article 17 first (1 

st

 ) paragraph:

- the approval of the business plan (original and revisions) of the Company;

43131

L

U X E M B O U R G

- any corporate re-organization of the Company including merger with its majority shareholder and corporate splits;
- the nomination and dismissal of the Company’s Managers;
- the approval of yearly financial statements for the Company and associated net profit &amp; loss distribution;
- any action of the Company which could materially affect its enterprise value;
- the approval of the quarterly financial statements of the Company;
- the approval of the capital expenditures exceeding five million Euro (EUR 5,000,000) by the Company and the group

companies (including Joyou);

- the granting of loans (or other debt financing) exceeding seven million Euro (EUR 7,000,000) by the Company and

the group companies (including Joyou);

- the approval of any formula of foreign exchange hedge exceeding seven million Euro (EUR 7,000,000) by the Company

and the group companies (including Joyou);

- the establishment of a legal entity with share capital equal to or exceeding seven million Euro (EUR 7,000,000) as a

direct or indirect subsidiary of the Company;

- the assumption of new debt of third parties (parties not affiliated with Grohe Group SARL) or provision of guarantee

for third parties exceeding one Million Euro (EUR 1,000,000) in a single case or five Million Euro (EUR 5,000,000) p.a. in
aggregate;

- any material organizational change of the Company and the group companies (including Joyou) resulting in a change

of the responsibilities of the Company's Managers or those other senior executives of the group companies directly
reporting to the CEO;

- any material change in the by-laws of the Company, Grohe Holding GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH, Grohe AG,

Joyou Grohe Holding AG and Joyou AG (each, excluding the Company, a “Key Subsidiary”);

- the nomination or dismissal of the corporate bodies ("Organe") of the Company or a Key Subsidiary;
- any other matter as determined by the general meeting of the shareholders.
As regards Joyou Grohe Holding AG and its direct and indirect subsidiaries, including Joyou AG, (collectively "Joyou"),

the above-mentioned approval and consent requirement shall only apply subject to the limitations under German stock
corporation law, in particular regarding the rights and powers of the management board and supervisory board of Joyou
Grohe Holding AG and Joyou AG under applicable law.”

<i>Forth resolution

The Shareholders acknowledged the resignation of the following managers:
- Malte Janzarik
- Charles Pieper
- John Lancaster Oliver
- Stephen Peel
- Kenneth Lohsen
- Colin Taylor
- Jean-Paul Gennari
- Pedro-Emanuel Gouveia Fernandes das Neves
and resolved to appoint or renew the appointment with immediate effect the following persons as managers of the

Company for an unlimited duration:

- Mr David Haines, born on 10 May 1960 in Pontypool, Great Britain with professional address at Feldmühleplatz 15,

40545 Düsseldorf, Germany, as Chairman,

- Mr Jilin Cai, born on 8 October 1977 in Nan’an, Fujian Province, China, with professional address at Joyou Industrial

Park, Luncang Town, Na'an City, Fujian Province, China,

- Mr Takashi Okuda, born on 22 March 1963 in Shizuoka, Japan, with professional address at 2-1-1, Ojima, Koto-ku,

J-136-8535 Tokyo, Japan,

- Rainer Mues, born on 22 December 1972 in Olsberg, Germany with professional address at Feldmühleplatz 15, 40545

Düsseldorf, Germany,

- Gerald Mulvin, born on 24 April 1966 in Dublin, Ireland with professional address at Feldmühleplatz 15, 40545

Düsseldorf, Germany,

- Detlef Schmitz, born on 16 January 1963 in Essen, Germany, with professional address at Feldmühleplatz 15, 40545

Düsseldorf, Germany.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 5.20 p.m..

43132

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the German texts, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und vierzehn, den einundzwanzigsten Januar,
vor dem unterzeichneten Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad Mondorf, Groβherzogtum Luxemburg,
wurde eine außerordentliche Gesellschafterversammlung von Grohe Group S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. Mai 2004, und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, unter der Nummer 637 am 21. Juni 2004 veröffentlicht, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 101.086 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal
durch eine notarielle Urkunde vom 23. April 2013 geändert, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
unter der Nummer 1617 vom 6. Juli 2013 veröffentlicht worden ist.

Die Gesellschafterversammlung wurde eröffnet um 17.00 Uhr von Maître Nicolas Gauzès, Rechtsanwalt, mit berufli-

cher Anschrift in Luxembourg, der Vorsitzende,

welcher als Schriftführer Maître Alessandro Sorcinelli, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxembourg ernannt

hat.

Die Generalversammlung hat Maître Florence Forster, Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift in Luxembourg, als

Stimmzähler ernannt.

Das Büro der Gesellschafterversammlung ist somit zusammengestellt, der Vorsitzende erklärte und hat den unter-

zeichneten Notar gebeten folgendes festzuhalten:

(i) Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung ist folgende:

<i>Tagesordnung

1 Abänderung von Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft, um dem Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates der

Gesellschaft Einzelunterschriftenbefugnis zu gewähren;

2 Abänderung von Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft, um, unter anderem, den Vorsitzenden des Geschäftsfüh-

rungsrates, den Schriftführer, die Regeln der Beschlussfähigkeit und die Mehrheitsregeln des Geschäftsführungsrates zu
bestimmen;

3 Abänderung von Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft, die eine Liste mit Themen beinhaltet, welche die Ge-

schäftsführer von einer Gesellschafterversammlung absegnen lassen müssen;

4 Kenntnisnahme des Rücktritts von Geschäftsführern und Bestellung von neuen Geschäftsführern.
(ii) Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, unterzeichnet durch die Vollmachtnehmer, das Büro der Gene-

ralversammlung und dem unterzeichneten Notar, bleiben der vorliegenden notariellen Urkunde beigefügt.

(iii) Die Anwesenheitsliste bestätigt, dass hundert Prozent (100%) der Gesellschafter der siebenundfünfzig Millionen

einhundertzweiundvierzig Tausend achthundertsiebenundfünfzig (57.142.857,-) Gesellschaftsanteile des Gesellschaftska-
pital bei der Gesellschafterversammlung präsent oder vertreten, erklärten dass sie rechtzeitig benachrichtigt wurden und
Kenntnis von der Tagesordnung vor der Generalversammlung hatten und auf ihr Recht in förmlicher Weise einberufen
worden zu sein verzichten.

(iv) Die Gesellschafterversammlung wurde somit regulär konstituiert und konnte ordnungsgemäß über alle Punkte der

Tagesordnung beraten.

(v) Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter, jedes Mal einstimmig, nahmen folgende Beschlüsse an:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, Artikel 14 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ Art. 13. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern (der (die) „Geschäftsführer“), welche

keine Gesellschafter sein müssen, geführt.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt die Dauer des

Mandates.

Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt, ohne Angabe von Gründen und ohne Entschädigung aus ihren Funk-

tionen entlassen werden.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können durch einen Geschäftsführungsrat, sofern ein Geschäftsfüh-

rungsrat existiert, unter authentischem oder privatschriftlichem Dokument an eine oder mehrere Personen ausgestellt
werden.

43133

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift von mindestens zwei Geschäftsführern, oder durch die alleinige

Unterschrift des Vorsitzenden, verpflichtet.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, Artikel 14 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ Art. 14. Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht zu Handlungen

im Namen der Gesellschaft und zur Genehmigung von Geschäften und Handlungen, die mit dem Gesellschaftszweck in
Einklang stehen, vorbehaltlich der Rechte der Gesellschafter.

Werden zwei Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“) gegründet.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter wird ein Mitglied des Geschäftsführungsrates als Vorsitzenden benennen

(der „Vorsitzende“ oder „CEO“). Der Geschäftsführungsrat kann einen Schriftführ benenne, welcher selbst kein Ge-
schäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden oder von zwei (2) Geschäftsführern zusammen.
Ein Einberufungsschreiben muss mindesten achtundvierzig (48) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung

an jeden Geschäftsführer schriftlich erteilt werden (durch Email oder jede andere schriftliche Kommunikation), außer im
Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben an-
gegeben werden müssen. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen der Geschäftsführer,
die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss der Geschäftsführer festge-
setzt wurden.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-

führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor. Der Vorsitzende kann einen anderes

Mitglied des Geschäftsführungsrates benennen, der ihn in seiner Abwesenheit vertreten kann und den Vorsitz der Sitzung
übernimmt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner

amtierenden Mitglieder.

Jeder Geschäftsführer kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich (durch Email oder jede andere schriftliche

Kommunikation) erteilten Vollmacht durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann
mehrere andere Geschäftsführern vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass jeder Teilnehmer an der Sitzung alle anderen verstehen
kann. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die
Protokolle der Sitzungen werden von vom Vorsitzenden, der in der Sitzung den Vorsitz hält unterzeichnet.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-

schäftsführungsrates gefasst.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.“

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschafter hat beschlossen, Artikel 18 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ Art. 18.
18.1 Eine gewisse Anzahl von Anteilen der Gesellschaft kann von der Cai GmbH, eine unter deutschem Recht beste-

hende Gesellschaft mit beschrankter Haftung, mit Sitz in Winterstrasse 4-8, 22765 Hamburg, Deutschland (nachstehend
die "Cai GmbH") gehalten werden, eine Gesellschaft die im Gegenzug vollständig von der Familie Cai gehalten wird, d.h.
von Herrn Jianshe Cai und Herrn Jilin Cai (die "Cai Familie").

Folgende Punkte benötigen die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter und keine der folgenden Ent-

scheidungen soll durch die Hauptversammlung angenommen werden können, ohne die ausdrückliche Zustimmung der
Cai GmbH:

- jede Kapitalerhöhung (außer dem Fall eines ersten öffentlichen Zeichnungsangebotes) oder eine Kapitalherabsetzung

der Gesellschaft;

- jede Rücknahme der Gesellschaftsanteile der Gesellschaft;
- jede Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft; und
- die Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft.
"IPO" bedeutet ein erstes öffentliches Zeichnungsangebot für den Verkauf oder die Zeichnung von Dividendenpapieren,

die von der Gesellschaft ausgegeben werden und die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind. Ein erstes
Öffentliches Zeichnungsangebot dieser Art beinhaltet eine Bestimmung zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft

43134

L

U X E M B O U R G

in Übereinstimmung mit dem Vorschlag der Bank(en), als Mitglied(er) eines Emissionssyndikats, bezüglich des Betrags
dieser Kapitalerhöhung. Das Emissionssyndikat muss wenigstens eine der weltweit führenden Investitionsbanken, die über
eine Zeitdauer von zwei Jahren vor dem Beginn des ersten Öffentlichen Zeichnungsangebotes zu den zehn größten "Equity
Underwriters" (berechnet nach der weltweiten Kapitalausgabe) gezahlt haben, als Mitglied haben, unter Vorbehalt dass,
die untere Preisangabe wie vereinbart in einem price range agreement, der Gesellschaftswert von Grohe Group nicht
weniger  als  sechs  mal  den  angepassten  EBITDA  vom  vollständigen  Geschäftsjahr  der  Gesellschaft  vor  IPO  darstellt.
"Wertpapiermarkt" bedeutet ein regulierter Markt im Sinne der EU-Richtlinie über Markte für Finanzinstrumente (MiFID)
oder gleichwertige Markte außerhalb der EU.

Die Vetorechte der Cai GmbH, so wie in diesem Absatz beschrieben, sollen mit Eintritt des zuerst eintretenden der

folgenden  Ereignisse  enden  (i)  eine  Entscheidung  einer  außerordentlichen  Hauptversammlung  der  Gesellschafter  der
Gesellschaft zwecks Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Rahmen eines ersten Öffentlichen Zeichnungsangebotes, die
mit der besonderen Stimmehrheit zur Änderung der Satzung, wie sie im Handelsgesellschaften Gesetz des 10. August
1915 vorgesehen ist, getroffen worden ist, oder (ii) der Abschluss eines Verkaufs der Mehrheit der Geschäftsanteile der
Gesellschaft oder eine Änderung der Kontrolle der Gesellschaft, wobei die Geschäftsanteile des Käufers an einem Wert-
papiermarkt gehandelt werden und der Gegenwert eines solchen Verkaufs oder einer solchen Änderung der Kontrolle
zahlbar an Cai GmbH aus Geschäftsanteilen des Käufers, die zum Handel an einem Wertpapiermarkt zugelassen sind,
besteht, oder iii) Cai GmbH ist Eigentümer von weniger als fünf Millionen (5.000.000,-) Geschäftsanteilen der Gesellschaft,
oder (iv) das Datum an dem Herr Cai, Jianshe und Herr Cai, Jilin (die "Cai Familie") aufhören werden direkte oder indirekte
Eigentümer sämtlicher Geschäftsanteile und Stimmrechte der Cai GmbH zu sein. "Kontrolle" bedeutet das Eigentum an
mehr als fünfzig Prozent des ausgegebenen Stammkapitals/Stimmrechte oder die Möglichkeit, die Geschäftsführung und
die  Maßnahmen  (policies)  einer  Person,  direkt  oder  indirekt,  anzuweisen  oder  anweisen  zu  lassen,  sei  es  durch  das
Eigentum an Wertpapieren oder mittels einer Beteiligung oder anderer Eigentumsbeteiligungen und/oder Stimmrechte,
vertraglich oder anders. "Person" bedeutet, in weiter Auslegung, eine natürliche Person oder eine Treuhand, eine Ge-
sellschaft, eine Teilhaberschaft, eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung oder irgendeine andere juristische Person.

Im Falle der Beendigung der Vetorechte sollen alle Entscheidungen, die im zweiten Paragraph dieses Absatzes aufgeführt

werden, ohne Einschränkung in Obereinstimmung mit der vorliegenden Satzung getroffen werden.

18.2 Die Folgenden Punkte sollen der Zustimmung der Hauptversammlung unterliegen und keine der folgenden Ent-

scheidungen soll dem Geschäftsführungsrat unterliegen, wenn anwendbar, ohne die Zustimmung der Hauptversammlung
gemäß Artikel 17 erster (1.) Absatz der Mehrheitsregel:

- Verabschiedung des Wirtschaftsplans (Originalversion und Teilüberarbeitungen) der Gesellschaft;
- Unternehmensrestrukturierungen, einschließlich Verschmelzung mit den Mehrheitsgesellschaftern und Betriebsauf-

spaltungen;

- Ernennung und Abberufung von Geschäftsführern der Gesellschaft;
- Verabschiedung des Jahresabschlusses der Gesellschaft sowie zusammenhängende Ausschüttung von Gewinn- und

Verlustvorträgen;

- Jede Handlung der Gesellschaft welche den Gesellschaftswert der Gesellschaft wesentlich beeinflusst;
- Die Verabschiedung des vierteljährlichen Finanzberichts;
- Gewährung von Kapitalausgaben der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mitinbegriffen) welche fünf Mil-

lionen Euro (EUR 5.000.000,-) überschreiten;

-  Gewährung  von  Darlehen  (oder  anderer  Fremdfinanzierung)  der  Gesellschaft  und  Konzerngesellschaften  (Joyou

mitinbegriffen) welche sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-) überschreiten;

- Freigabe von Hedging-Formeln für Wechselkursrisiken der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mitinbe-

griffen) welche sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-) überschreiten;

- Gründung einer Gesellschaft mit einem Kapital von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-) oder mehr, als direkte

oder indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft;

- Die Annahme von neuen Schulden Dritter (welche nicht der Grohe Group SARL angehören) oder Garantieleistungen

für Dritte, die eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) einzeln oder fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) insgesamt pro Jahr
überschreiten;

- Wesentliche organisatorische Veränderung der Gesellschaft und Konzerngesellschaften (Joyou mitinbegriffen) welche

eine Änderung von Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft oder andere Führungskräfte der Konzernge-
sellschaften, die direkt an den CEO berichten herbeiführen;

- Wesentliche Änderungen der Statuten der Gesellschaft, Grohe Holding GmbH, Grohe Beteiligungs GmbH, Grohe

AG, Joyou Grohe Holding AG und Joyou AG (jede, ohne die Gesellschaft, „Wesentliches Tochterunternehmen“);

- Ernennung und Abberufung von Organen der Gesellschaft oder einer wesentlichen Tochtergesellschaft;
- Alle anderen Themen, die von der Hauptversammlung entschieden werden.
Für Joyou Grohe Holding AG und ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Joyou AG mitinbegriffen (zu-

sammen „Joyou“), sind die oben aufgezählten Freigabe- und Zustimmungsvoraussetzungen nur anwendbar, sofern kein
Deutsches Aktiengesetz diese Regelungen einschränkt, insbesondere bezüglich der Befugnisse des Geschäftsführungsrates
von Joyou Grohe Holding AG und Joyou AG.“

43135

L

U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschafter hat den Rücktritt folgender Geschäftsführer zu Kenntnis genommen:
- Malte Janzarik
- Charles Pieper
- John Lancaster Oliver
- Stephen Peel
- Kenneth Lohsen
- Colin Taylor
- Jean-Paul Gennari
- Pedro-Emanuel Gouveia Fernandes das Neves
und hat mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit die Ernennung der folgenden neuen Geschäftsführer der

Gesellschaft beschlossen:

- Herrn David Haines, geb. am 10. Mai 1960 in Pontypool, Grossbritanien mit beruflicher Anschrift in: Feldmühleplatz

15, 40545 Düsseldorf, Deutschland, als Vorsitzenden,

- Herrn Jilin Cai, geb. am 8. Oktober 1977 in Nan’an, Fujian Province, China, mit beruflicher Anschrift in: Joyou Industrial

Park, Luncang Town, Na'an City, Fujian Province, China,

- Herrn Takashi Okuda, geb. am 22. März 1963 in Shizuoka, Japan, mit beruflicher Anschrift in: 2-1-1, Ojima, Koto-ku,

J-136-8535 Tokyo, Japan,

- Herrn Rainer Mues, geb. am 22. Dezember 1972 in Olsberg, Deutschland mit beruflicher Anschrift in: Feldmühleplatz

15, 40545 Düsseldorf, Deutschland,

- Herrn Gerald Mulvin, geb. am 24. April 1966 in Dublin, Irland mit beruflicher Anschrift in: Feldmühleplatz 15, 40545

Düsseldorf, Deutschland,

- Herrn Detlef Schmitz, geb. am 16. Januar 1963 in Essen, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in: Feldmühleplatz 15,

40545 Düsseldorf, Deutschland.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund

dieser Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte gab, wurde die Versammlung um 17.20 Uhr geschlossen.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen

genannten Personen das vorliegende Dokument auf englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage der-
selben Personen und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der Englische
Vorrang haben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem  das  Dokument  den  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen,  Personenstand  und  Wohnort

bekannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben die vorliegende Urkunde mit dem unterzeichn-
enden Notar unterzeichnet.

Signé: N. Gauzès, A. Sorcinelli, F. Forster, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 27 janvier 2014. REM/2014/249. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021511/395.
(140025461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Blue Eagle Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 184.229.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of January,
Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

43136

L

U X E M B O U R G

PENTALPHA, société à responsabilité limitée, a private limited liability company under the laws of the Grand-Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 6A route de Treves, L-2633 Senningerberg (Grand Duchy of Luxembourg),
registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B171746,

here represented by Mrs Sylvie Lexa, company director, with professional address at 6A Route de Treves, L-2633

Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.

Art. 2. Purpose.
2.1  The  object  of  the  Company  is  the  holding  of  participations  directly  or  indirectly,  in  any  form  whatsoever,  in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

2.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may lend funds

including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It
may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BLUE EAGLE CAPITAL S.à. r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand-Duchy of Luxembourg within the municipality

of Niederanven and may be transferred within such municipality by means of a resolution of its manager(s).

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its partners.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred shares (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners. If several Managers have

been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the “Board of Managers”).

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-

holders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.

43137

L

U X E M B O U R G

The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they
may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of
the general meeting of shareholders.

In case there is more than one Manager, the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of share-

holders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.He (they) may be
dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the Board of Managers has the most extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with
the Company's purpose.

The Manager, or as the case may be, the Board of Managers, may delegate his powers for specific purposes to one or

several representatives.

The Company is validly bound towards third parties, in case of a sole manager, by the individual signature of the sole

manager, or in case of several managers, by the joint signature of any two managers of the Company.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has

appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards
third parties only by the sole signature of one Class A Manager, or by the joint signatures of two Class B Managers, as
well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such
signatory power, within the limits of such power.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental

to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The  board  of  managers  can  deliberate  or  act  validly  only  if  at  least  the  majority  of  the  managers  are  present  or

represented at a meeting of the board of managers and in case the sole shareholder or, as the case may be, the general
meeting of shareholders has decided to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers, the
board of managers can deliberate or act validly only if at least a Manager of Class A and a Manager of Class B are present
or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers
present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers or in case the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders has decided to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers by a Manager of
Class A and a Manager of Class B jointly. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

43138

L

U X E M B O U R G

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The financial year of the Company commences on the 1 

st

 January and ends of the 31 

st

 December.

Art. 21. Each year on the 31 

st

 of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by the société à responsabilité limitée PENTALPHA, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31

st

 , 2014.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100).

43139

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the Sole Partner

Then the sole partner, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has imme-

diately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be in L-2633 Senningerberg, 6A route de Treves.
2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Adrian Braimer-Jones, born on 16 

th

 September 1958 in Nairobi (Kenya), with professional address at 49 Gros-

venor St, London W1K 3HP (United Kingdom);

- Mr. Gregory Noyen, born on 22 

nd

 January 1980 in Liège (Belgium) with professional address at 6A route de Treves,

L-2633 Senningerberg; and;

- Mrs. Sylvie Lexa, born on 8 

th

 February 1954 in Mont-St-Martin (France) with professional address at 6A route de

Treves, L-2633 Senningerberg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PENTALPHA, société à responsabilité limitée de droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé

au  6A  route  de  Trêves,  L-2633  Senningerberg  (Grand-Duché  de  Luxembourg),  immatriculée  auprès  du  Registre  du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171746,

ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6A route de

Trêves, L-2633 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après «la Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bonds de caisse et
d'autres valeurs, ainsi que la propriété, l'administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également
détenir des parts dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt.

La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BLUE EAGLE CAPITAL S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg dans la commune de Niederanven et peut être

transféré à une autre adresse dans cette commune par décision du ou des gérants.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

43140

L

U X E M B O U R G

B - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Si plusieurs gérants sont

nommés, les gérants constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les gérants sont nommés par l'associé unique, ou le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée limitée ou illimitée de leur mandat. Les gérants sont nommés jusqu'à la
nomination de leurs successeurs: ils peuvent être réélus au terme de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'associé unique, ou le cas échéant par une assemblée générale des
associés.

Dans le cas d'une pluralité de gérants, l'associé unique ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider

de nommer des gérants de Classe A et des gérants de Classe B. Il (ils) peut (peuvent) être révoqués librement à tout
moment par l'associé unique ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas ou il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

La Société est engagée valablement vis-à-vis des tiers en cas de gérant unique par la signature du gérant unique ou en

cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants.

Dans le cas ou l'associé unique, ou le cas échéant l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérants

de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances, par
la seule signature d'un gérant de la Classe A ou par la signature conjointe de deux (2) gérants de la Classe B, ou par la
signature du ou des mandataire(s) à qui pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le cas échéant
par le conseil de gérance, dans les limites d'un tel pouvoir.

Même après le terme de leur mandat, le (les) gérant(s) ont le devoir de ne pas divulguer d'information(s) sur la société

qui pourrait nuire aux intérêts de la Société, à l'exception du cas ou une telle divulgation d'information est requise par la
loi.

Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

43141

L

U X E M B O U R G

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement qui si la majorité des gérants sont présents ou repré-

sentés à la réunion du conseil de gérance et dans le cas ou l'associé unique, ou le cas échéant l'assemblée générale des
associés a nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, le conseil de gérance ne
pourra délibérer ou agir valablement qui si au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B sont présents ou
représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants ou dans le cas ou l'associé unique, ou le cas échéant l'assemblée
générale des associés a nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, par un gérant
de Classe A et un gérant de Classe B conjointement. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

43142

L

U X E M B O U R G

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

La société à responsabilité limitée PENTALPHA, pré-mentionnée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cent euros (EUR 1.100).

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a

tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trêves.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Adrian Braimer-Jones, né le 16 septembre 1958 à Nairobi (Kenya), avec adresse professionnelle au 49

Grosvenor St, Londres W1K 3HP (Royaume-Uni);

- Monsieur Grégory Noyen, né le 22 janvier 1980 à Liège (Belgique) avec adresse professionnelle au 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg; et;

- Madame Sylvie Lexa, née le 8 février 1954 à Mont-St-Martin (France) avec adresse professionnelle au 6A route de

Trêves, L-2633 Senningerberg.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de ladite partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Sylvie Lexa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 janvier 2014. LAC / 2014 / 3864. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 février 2014.

Référence de publication: 2014019412/372.
(140024841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Blue Hawk Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 184.227.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of January,
Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

43143

L

U X E M B O U R G

AERIUM CAPITAL GROUP LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware (United States

of America), having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, County of Newcastle
(USA), registered with the Register of Companies of the State of Delaware under number 4422331,

here represented by Mrs. Sylvie Lexa, company director, with professional address at 6A Route de Trèves, L-2633

Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.

Art. 2. Purpose.
2.1  The  object  of  the  Company  is  the  holding  of  participations  directly  or  indirectly,  in  any  form  whatsoever,  in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships.

2.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may lend funds

including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It
may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BLUE HAWK CAPITAL S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the Grand-Duchy of Luxembourg within the municipality

of Niederanven and may be transferred within such municipality by means of a resolution of its manager(s).

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its partners.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred shares (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners. If several Managers have

been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the “Board of Managers”).

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-

holders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate.

43144

L

U X E M B O U R G

The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they
may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of
the general meeting of shareholders.

In case there is more than one Manager, the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of share-

holders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.

He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the Board of Managers has the most extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with
the Company’s purpose. The Manager, or as the case may be, the Board of Managers, may delegate his powers for specific
purposes to one or several representatives.

The Company is validly bound towards third parties, in case of a sole manager, by the individual signature of the sole

manager, or in case of several managers, by the joint signature of any two managers of the Company.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has

appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards
third parties only by the sole signature of one Class A Manager, or by the joint signatures of two Class B Managers, as
well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such
signatory power, within the limits of such power.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental

to the Company’s interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The  board  of  managers  can  deliberate  or  act  validly  only  if  at  least  the  majority  of  the  managers  are  present  or

represented at a meeting of the board of managers and in case the sole shareholder or, as the case may be, the general
meeting of shareholders has decided to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers, the
board of managers can deliberate or act validly only if at least a Manager of Class A and a Manager of Class B are present
or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers
present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers or in case the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders has decided to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers by a Manager of
Class A and a Manager of Class B jointly. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason

43145

L

U X E M B O U R G

of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The financial year of the Company commences on the 1 

st

 January and ends of the 31 

st

 December.

Art. 21. Each year on the 31 

st

 of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by AERIUM CAPITAL GROUP LLC, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31

st

 , 2014.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100).

<i>Resolutions of the Sole Partner

Then the sole partner, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has imme-

diately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be in L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.

43146

L

U X E M B O U R G

2. Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Adrian Braimer-Jones, born on 16 

th

 September 1958 in Nairobi (Kenya), with professional address at 49 Gros-

venor St, London W1K 3HP (United Kingdom);

- Mr. Grégory Noyen, born on 22 

nd

 January 1980 in Liège (Belgium) with professional address at 6A route de Trèves,

L-2633 Senningerberg; and;

- Mrs. Sylvie Lexa, born on 8 

th

 February 1954 in Mont-St-Martin (France) with professional address at 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AERIUM CAPITAL GROUP LLC, une limited liability company de droit de l’Etat de Delaware, dont le siège social est

situé à Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, County de Newcastle (USA), immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de l’Etat de Delaware (USA) sous le numéro 4422331;

ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée ci-après, «la Société», qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, titres d'emprunt, bonds de caisse et
d'autres valeurs, ainsi que la propriété, l'administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également
détenir des parts dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt.

La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BLUE HAWK CAPITAL S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg dans la commune de Niederanven et peut être

transféré à une autre adresse dans cette commune par décision du ou des gérants.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

43147

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Si plusieurs gérants sont

nommés, les gérants constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les gérants sont nommés par l’associé unique, ou le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée limitée ou illimitée de leur mandat. Les gérants sont nommés jusqu’à la
nomination de leurs successeurs: ils peuvent être réélus au terme de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par une résolution de l’associé unique, ou le cas échéant par une assemblée générale des
associés.

Dans le cas d’une pluralité de gérants, l’associé unique ou le cas échéant, l’assemblée générale des associés peut décider

de nommer des gérants de Classe A et des gérants de Classe B. Il (ils) peut (peuvent) être révoqués librement à tout
moment par l’associé unique ou le cas échéant, l’assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas ou il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

La Société est engagée valablement vis-à-vis des tiers en cas de gérant unique par la signature du gérant unique ou en

cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux gérants.

Dans le cas ou l’associé unique, ou le cas échéant l’assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérants

de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, la Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances, par
la seule signature d’un gérant de la Classe A ou par la signature conjointe de deux (2) gérants de la Classe B, ou par la
signature du ou des mandataire(s) à qui pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou le cas échéant
par le conseil de gérance, dans les limites d’un tel pouvoir.

Même après le terme de leur mandat, le (les) gérant(s) ont le devoir de ne pas divulguer d’information(s) sur la société

qui pourrait nuire aux intérêts de la Société, à l’exception du cas ou une telle divulgation d’information est requise par la
loi.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent

43148

L

U X E M B O U R G

s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement qui si la majorité des gérants sont présents ou repré-

sentés à la réunion du conseil de gérance et dans le cas ou l’associé unique, ou le cas échéant l’assemblée générale des
associés a nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, le conseil de gérance ne
pourra délibérer ou agir valablement qui si au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B sont présents ou
représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le viceprésident, ou par deux gérants ou dans le cas ou l’associé unique, ou le cas échéant l’assemblée générale
des associés a nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, par un gérant de Classe
A et un gérant de Classe B conjointement. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

43149

L

U X E M B O U R G

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

AERIUM CAPITAL GROUP LLC, pré-mentionnée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cent euros (EUR 1.100).

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a

tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Adrian Braimer-Jones, né le 16 septembre 1958 à Nairobi (Kenya), avec adresse professionnelle au 49

Grosvenor St, Londres W1K 3HP (Royaume-Uni);

- Monsieur Grégory Noyen, né le 22 janvier 1980 à Liège (Belgique) avec adresse professionnelle au 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg; et;

- Madame Sylvie Lexa, née le 8 février 1954 à Mont-St-Martin (France) avec adresse professionnelle au 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de ladite partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Sylvie Lexa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 janvier 2014. LAC / 2014 / 3863. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 février 2014.

Référence de publication: 2014019413/370.
(140024816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

Merlen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 163.723.

L'an deux mille treize, le trente et un décembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Joakim Karlsson, né le 2 novembre 1971 à Katrineholm, Suède, résidant à 20, Trasthagen, S-181 41 Lidingö,

Suède (ci-après l’«Associé Unique»),

ici représenté par Madame Monica Morsch, avec adresse professionnelle à 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-

Findel,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Stockholm, le 18 décembre 2013.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

43150

L

U X E M B O U R G

Le comparant est l’associé unique de Merlen S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 163.723, constituée suivant acte notarié en date du 8 septembre 2011, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 2793 du 16 novembre 2011. Les statuts de la Société n'ont
pas été modifiés depuis

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a

ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:

<i>Première résolution:

L’Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg vers

L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de modifier, dans les versions anglaise et fran-

çaise, le premier (1 

er

 ) alinéa de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

“The Company has its registered office in the Municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.”

Version française:

«Le siège social est établi dans la Municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution:

L’Associé Unique décide de destituer:
- Madame Ingrid Moinet, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, et

-  Madame  Noëlla  Antoine,  née  le  11  janvier  1969  à  Saint-Pierre,  Belgique  avec  adresse  professionnelle  au  5,  rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

comme gérants de la Société avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

<i>Quatrième résolution:

L’Associé Unique décide d’accepter:
- la démission de Madame Wilhelmina von Alwyn-Steennis, administrateur, née le 29 août 1967 à Rotterdam, Pays-

Bas, avec adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, en tant que gérant de la Société et
de nommer Madame Wilhelmina von Alwyn-Steennis, prénommée, en tant que gérant de classe A de la Société.

- la démission de Monsieur Klas Tikkanen, administrateur, né le 7 décembre 1970 à Storkyrkof, Suède, demeurant à

10, Bielkevägen, SE-182 63 Djursholm, Suède; en tant que gérant de la Société et de nommer Monsieur Klas Tikkanen,
prénommé, en tant que gérant de classe A de la Société.

avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures

<i>Cinquième résolution:

L’Associé Unique décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures, les personnes suivantes comme

nouveaux gérants de la Société pour une durée illimitée:

<i>Gérants de classe B:

a) Monsieur Andreas Demmel, né le 11 avril 1969 à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou

Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel,

b) Monsieur Ganash Lokanathen, né le 5 juillet 1978 in Pahang, Malaysia, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou

Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel.

<i>Sixième résolution:

L’Associé Unique décide de renommer dans les versions anglaise et française des statuts de la Société la section

Gérance/Management comme suit:

Version anglaise:

“Management, Powers and Representations”

Version française:

«Conseil de Gérance, Pouvoirs et Représentations»

43151

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution:

L’Associé Unique note que l’adresse de Madame Wilhelmina von Alwyn-Steennis, prénommée, est changée au L-1748

Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer avec effet au 31 décembre 2013 à 23.59 heures.

Dont acte, fait et passé à L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: M. Morsch, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 14 janvier 2014. REM/2014/127. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 février 2014.

Référence de publication: 2014022255/76.
(140026725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Okaidi Luxe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 154.136.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 15 novembre 2013

L'associé unique a pris acte de la démission des Messieurs Eric VANDENDRIESSCHE et Charles-Henri Jérôme GAS-

QUET de leurs mandats de gérants avec effet au 15 novembre 2013.

L'associé unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants:
- Monsieur Michel HAUTEKIET, né le 3 avril 1961, à Lille, gérant de sociétés, demeurant au 4 rue Risban, 59700 Marcq

en Baroeul, France, avec effet au 15 novembre 2013 et pour une durée indéterminée;

- Monsieur Patrick DAMBRINE, né le 30 octobre 1959, à Lille, gérant de sociétés, demeurant au 216 rue Jean Jaurès,

59170 CROIX (France), avec effet au 15 novembre 2013 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose alors comme suit:
- Monsieur Michel HAUTEKIET;
- Monsieur Patrick DAMBRINE.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014024193/20.
(140029188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

VECTIS Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.929.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2013

L’Assemblée a décidé de reconduire dans leurs fonctions:
- Monsieur Pierre Paul Boegen, administrateur
- Monsieur Gérard Flamion, administrateur
- Monsieur Jean-Philippe Wagnon, administrateur
- Monsieur Roger Greden, administrateur-délégué et président du conseil d’administration Leurs mandats prendront

fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.

L’Assemblée a également décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes AP &amp; Associés S.à r.l., ayant son

siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024320/19.
(140028720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

43152


Document Outline

Blue Eagle Capital S.à r.l.

Blue Hawk Capital S.à r.l.

Capital NL Topco S.à r.l.

Germa Holding S.A.

GP Canada Holding S.à r.l.

Grohe Group S.à r.l.

ILCAV Capital Investment S.A.

Ivaldi Multi-Strategy Fund GP

IVG Luxembourg S.à r.l.

La Croisette Property S.A.

La Croisette Property S.A.

Limba Luxco 1 S.à r.l.

Limba Luxco 2 S.à r.l.

LuxES S.A.

Lux Insulation Holdings S.à r.l.

Luxlait Développement S.A.

L.W.A. Financial Engineering SPF, S.A.

Mami SCI

Mandrinvest Finance S.A.

Margaux S.A.

Marley Tile S.A.

MEA SPF, S.A.

M.E. Consult S.à r.l.

Merlen S.à r.l.

MFA S.à r.l.

Michel Euro Finance S.A.

Mine Holding S.A.

Nade Luxco 1 S.à r.l.

Nade Luxco 2 S.à r.l.

Nade Luxco 3 S.à r.l.

Nigricolis Company S.A.

Nuti Luxco S.à r.l.

Okaidi Luxe S.à r.l.

Opéra Finance International S.A.

Opera Finance S.A.

Opera Finance S.A.

Orion III European 22 S.à r.l.

Orion III European 23 S.à r.l.

OT LUX G.m.b.H.

Paradis Night Sàrl

Pemberton Sàrl

PSPFINLUX

PSPFINLUX II

Roosevelt International S.à r.l.

Tesa Real Estate S.A.

Titan SPF S.A.

TP Façades S.à r.l.

VECTIS Group S.A.