logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 878

5 avril 2014

SOMMAIRE

Axpro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42138

BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l.  . . . . .

42098

Coripha S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42131

Cultiver l'Etre A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42143

DB Valoren S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42139

FRP 12 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42141

Genid S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42098

GPE VII FIS S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42099

Herres Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42142

Köhl Maschinenbau A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42144

Legal Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42143

Leumi Global Managers Fund  . . . . . . . . . . .

42144

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF  . . . . .

42099

Markanne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42098

Mavico Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42124

Mdor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42123

ML Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42129

Morgan Stanley Infrastructure Partners II-

B GP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42126

Morgan Stanley Infrastructure Partners II

Investors C GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42126

Multi Units Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42105

New Friends S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42101

Paradis Night Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42144

Silam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42101

Skyline Residences S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42134

Snow S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42099

Société de Financement et de Transac-

tions Conseil, SOFITRA CONSEIL S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42137

Société de Financement pour les Trans-

ports, SOFITRA S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42137

Sofichar Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42100

Sol Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42102

Sorbholding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42100

Sorti S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42100

SR Diffusion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42102

Stadtparkturm ProCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

42099

Steel Center S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42102

Stinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42103

Stock Port International S.A.  . . . . . . . . . . .

42103

Summum Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42104

T & Brothers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42104

TI Design S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42102

Timelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42104

Trahern Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42102

Tronox Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

42135

Tuscany Rig Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

42104

Verdaine SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42101

Vicanne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42103

World Software Services S.A.  . . . . . . . . . . .

42103

WPW GEO.LUX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42098

42097

L

U X E M B O U R G

WPW GEO.LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Z.I. Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 131.131.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Februar 2014.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2014021852/14.
(140025697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 88.587.123,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 152.280.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021995/10.
(140026930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

Genid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 171.184.

EXTRAIT

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, les avocats à la cour, Maître

Leclère &amp; Maître Walry, informent de la résiliation de la convention de domiciliation conclue avec Genid S.à r.l. (R.C.S.
Luxembourg: B 171184), une société de droit luxembourgeois, et ce, avec effet au 12 février 2014.

Par conséquent, le siège social de la Société, situé à L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, est dénoncé avec effet au

12 février 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014023383/16.
(140027882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Markanne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 114.882.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014023541/14.
(140027728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42098

L

U X E M B O U R G

GPE VII FIS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 180.819.

Il résulte de la constitution de la société en commandite par actions, «GPE VII FIS S.C.A.», établie et ayant son siège

social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem
(Luxembourg), en date du 8 octobre 2013, déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés le 15 octobre 2013,
référence: L130176408, publié au Mémorial C No 2883 en date du 15 novembre 2013, qu'en version anglaise et version
française, le nombre d'actions a été erronément indiqué. La société procède soixante-et-un mille trois cent (61.300)
actions et non trois cent six mille cinq cents (306.500) actions comme indiqué dans l'acte.

Il y a donc lieu de rectifier dans l'acte, le nombre d'actions.
Enregistré à Esch/AIzette Actes Civils, le 10 février 2014. Relation: EAC/2014/2078. Reçu douze euros 12,00 €
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 6 février 2014.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014023390/19.
(140027624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.733.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014023505/11.
(140027957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Stadtparkturm ProCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 182.664.

<i>Rectificatif et remplacement du dépôt N°L140019690 du 30/01/2014

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 13 février 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014023678/12.
(140027993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Snow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 157.840.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d’administration de la Société en date du 11 février 2014

- Le siège social de la société est transféré du 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg au 23, avenue de la Liberté

L-1931 Luxembourg avec effet au 31 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014023710/12.
(140027661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42099

L

U X E M B O U R G

Sorbholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.079.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 février 2014

Il est porté à la connaissance de tous que Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40,

avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, remplacera Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg en tant que représentant permanent de la société Lux Business
Management S.à r.l., administrateur de la société Sorbholding S.A..

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014023676/16.
(140028081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Sofichar Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 38.111.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 février 2014

Il est porté à la connaissance de tous que Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40,

avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, remplacera Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg en tant que représentant permanent de la société Lux Business
Management S.à r.l., administrateur de la société Sofichar Spf S.A..

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014023714/16.
(140028082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Sorti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.274.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 11 juillet 2013 que:
- le mandat de Monsieur Moyse Dargaa comme administrateur et président du conseil est renouvelé jusqu'à l'issue de

l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.

- les mandats de Monsieur Benoît Lejeune, Monsieur Arnaud Schreiber et Madame Bénédicte Reis comme adminis-

trateurs sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

- le mandat de la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. (RCS Luxembourg B 34.813), ayant son siège social

au L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, comme commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Statutaire de 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SORTI S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014023718/22.
(140028236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42100

L

U X E M B O U R G

Silam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 122.029.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 5 février 2014 que:
- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de MONTBRUN RÉVISION S.à r.l.:
* Gestman S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 37378 avec siège social au 23, rue Aldringen

- L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2018.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014023703/15.
(140028435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

New Friends S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 180.895.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 février 2014

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Norbert MEISCH de son poste d'administrateur unique de la

société.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Denis VAN DEN ABBEEL, né le 7 avril 1971 à Bastogne (B), demeurant

professionnellement 2, rue des Tilleuls à L-8832 ROMBACH-MARTELANGE au poste d'administrateur unique de la
société.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014023576/17.
(140028288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Verdaine SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.433.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14.02.2013

<i>Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil
d'Administration de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié profession-
nellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de Monsieur
Pierre LENTZ, Expert-comptable, né à Luxembourg le 22.04.1959, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2,
Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique)
le 14.02.1966, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi
que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65,469, pour une
nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VERDAINE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014023786/22.
(140027761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42101

L

U X E M B O U R G

Sol Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.382.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 Février 2014.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2014023715/14.
(140028387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

SR Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4984 Sanem, Z.I. Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 167.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014023720/9.
(140027926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Steel Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 51.342.

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration en date du 12 février 2014 que les fonctions d'adminis-

trateur délégué confiées à Monsieur Jean-Paul KLING ont été reconduites pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014023722/10.
(140027651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Trahern Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 134.952.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014023736/9.
(140028520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

TI Design S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 170.961.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014023750/12.
(140028548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42102

L

U X E M B O U R G

Stinvest, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 45.962.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 février 2014

Il est porté à la connaissance de tous que Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse professionnelle 40,

avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, remplacera Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg en tant que représentant permanent de la société Lux Business
Management S.à r.l., administrateur de la société Stinvest S.A..

Luxembourg, le 5 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014023723/16.
(140028080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Stock Port International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 69.662.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 5 février 2014

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé de révoquer avec effet immédiat M. Hans Pieterman de son mandat d’administrateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé de nommer avec effet immédiat en tant que nouvel administrateur:
- M. Alexander Villaverde Zweegers, demeurant à Hoeven 1, B-2275 Lille – Poederlee, Belgique.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2014.

Référence de publication: 2014023724/16.
(140028504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Vicanne S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 130.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 12 février 2014.

<i>Pour Vicanne S.à r.l.

Référence de publication: 2014023791/11.
(140027893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

World Software Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.089.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eckart Vogler
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014023806/11.
(140028113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42103

L

U X E M B O U R G

Summum Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 159.972.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 février 2014

- Monsieur Christian KNAUFF, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxem-

bourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management S.à.r.l. en remplacement de Monsieur Gerard
VAN HUNEN qui occupait jusqu'alors cette fonction.

Luxembourg, le 11 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014023728/15.
(140027654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

T &amp; Brothers S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 123.982.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 février 2014, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1905 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- Société anonyme T &amp; BROTHERS S.A., immatriculée au RCS sous le numéro B123982, avec siège social à L-1123

LUXEMBOURG, 9b Plateau Altmünster, dénoncé en date du 9 juin 2009;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge, et liquidateur Maître Claire CLESSE,

avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 février 2014 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Maître Claire CLESSE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014023729/19.
(140028440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Timelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 39, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 34.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014023751/10.
(140028135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Tuscany Rig Leasing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 154.366.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014023742/10.
(140028067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

42104

L

U X E M B O U R G

Multi Units Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.129.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of January,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

Is held:

an extraordinary general meeting of shareholders of "MULTI UNITS LUXEMBOURG", a société anonyme qualified as

a société d’investissement à capital variable having its registered office in L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare,
recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 115.129, incorporated pursuant to a
notarial deed dated 29 

th

 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 766 of

14 

th

 April 2006 (hereafter the “Company”).

The Articles of Incorporation were amended pursuant to a notarial deed dated 5 

th

 October 2009, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2049 of 20 

th

 October 2009.

The meeting is opened at 11.00 a.m. with Mr Nicolas BIGUMA, employee, residing professionally in Luxembourg, in

the chair,

who appointed as secretary Mr Benjamin POUJOL, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Karine NARDINI, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the general meeting was convened by registered letters send to the shareholders on 10 

th

 January 2014;

II. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

I.- Approval of the amendment of (i) all references in the articles of incorporation of the Company (the“Articles of

Incorporation”) to the Directive 85/611/EEC and to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective
investment (the “2002 Law”), in order to replace them by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to
the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”) and (ii) all references
to specific articles of the 2002 Law in order to replace them by the relevant articles of the 2010 Law;

II.- Approval of the amendments of the Articles of Incorporation to ensure compliance with the 2010 Law as follows:
1) Amendment of Article 14 “Suspension of the calculation of the Net Asset Value and of the issue, the redemption

and the conversion of Shares” in order to introduce new cases of temporary suspension of the calculation of the net
asset value of the one or more sub-fund and the issue, redemption and conversion of any class of shares;

2) Amendment of Article 26 “Powers of the Board of Directors” in order to fully comply with the 2010 Law and take

master feeder structures into consideration;

3) Amendment of Article 33 (formerly 34) “Dissolution of the Company” in order to fully comply with the 2010 Law

and take master feeder structures into consideration.

4) Creation of Article 35 “Mergers of Sub-Funds and / or Classes of Shares” (following the modification of Article 33

(formerly 34)), reflecting the new provisions of the 2010 Law on merger possibilities offered by the 2010 Law.

III.- Approval of other main amendments of the Articles of Incorporation as follows:
1) Amendment of Article 7 “Sub-Funds” in order to inter alia provide that any sub-fund of the Company which qualifies

as an “exchange-traded fund” should use the identifier “ETF” in its denomination;

2) Amendment of Article 8 “Classes of Shares” in order to provide that fractional shares may confer voting rights if

their sum equals to one share;

3) General rewording of Article 11 “Limitation to the ownership of the Shares” to inter alia give to the board of

directors the power to impose or relax the restrictions of ownership on any sub-fund or class of shares, clarify the
definition of U.S. Person and restrict the issue or transfer of shares of the Company to institutional investors;

4) Amendment of Article 12 “Net Asset Value” to modify the rules of valuation of the assets of the Company and to

allow the board of directors to establish a pool of assets for each sub-fund;

5) General rewording of Article 13 “Issue, redemption and conversion of Shares”;
6) Amendment of Article 14 “Suspension of the calculation of the Net Asset Value and of the issue, the redemption

and the conversion of Shares” in order to introduce new cases of temporary suspension of the calculation of the net
asset value of the one or more sub-funds and the issue, redemption and conversion of any class of shares;

7) Amendment of Article 16 “Annual general Shareholders’ meeting” to allow the board of directors of the Company

to hold the annual general meeting of shareholders at a date, time or place other than those set forth in the Articles of
Incorporation, to the extent permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and
regulations;

42105

L

U X E M B O U R G

8) Amendment of Article 18 “Functioning of Shareholders’ meetings” in order to inter alia allow shareholders to vote

by means of voting forms;

9) Amendment of Article 19 “Notice to the General Shareholders’ meetings” to include a reference to a “record date”

for the determination of the quorum and majority applicable to a general meeting of shareholders;

10) Amendment of Article 21 “Duration of the functions of the Directors, renewal of the Board of Directors” in order

to modify the election term of a director that shall not exceed one year;

11) Amendment of Article 23 “Meetings and deliberations of the Board of Directors” in order to reduce the delay to

convene a meeting of the board of directors to 24 hours, to allow the directors to cast their votes in writing or any
electronic means capable of evidencing their vote and to allow the directors to participate at any meeting by videocon-
ference or other means of telecommunication allowing their identification;

12) General rewording of Article 32 (formerly 33) “Distribution Policy”.
IV. Approval of the general rewording of the Articles of Incorporation for clarity purposes, amending inter alia articles:
1) Article 4 “Registered office”;
2) Article 9 “Form of the Shares”;
3) Article 15 “General provisions”;
4) Article 17 “General meetings of Shareholders of Sub-Funds or Classes of Shares”;
5) Article 27 “Conflict of Interest”;
6) Article 30 (formerly 31) “Auditor”;
7) Article 31 (formerly 32) “Accounting year”;
8) Article 33 (formerly 34) “Dissolution of the Company”;
9) Article 34 (formerly 35) “Terminations of Sub-Funds and/or classes of Shares”;
10) Article 39 (formerly 38) “Amendment of the Articles of Incorporation”.
V. Approval of the adjunction of Article 35 “Merger of Sub-Funds and / or Classes of Shares”, Article 36 “Division of

Sub-Funds” and Article 37 “Amalgamation of Sub-Funds” following the amendment of Article 34 (formerly 35) and Article
38 “Depositary” following the removal of Article 30;

VI. Approval of the removal of Article 30 “Management Company, Investment Managers, Custodian and other con-

tractual parties” and Article 37 “Expenses borne by the Company”;

VII. Approval of the general rewording of the Articles of Incorporation for consistency purposes, amending inter alia

articles: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33 (formerly 34), 34 (formerly 35) and 40 (formerly
39);

VIII. Approval of the general renumbering of the Articles of Incorporation following the removal and the adjunction

of articles from and to the Articles of Incorporation;

IX. Update of the registered office of the Company to reflect the change resolved by the board of directors on 15 July

2013.

X. Approval of the withdrawal of the French translation of the Articles of Incorporation as permitted by the 2010 Law.
III.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented share-
holders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

IV.- That it results from the attendance list that out of 56,814,166 shares, 332,847 shares are present or represented

at the present general meeting.

V. - That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 18 December 2013 where the

quorum conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.

The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present
or represented.

VI.- As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting resolves to amend (i) all references in the Articles of Incorporation to the Directive 85/611/EEC

and to the 2002 Law, in order to replace them by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the 2010
Law, and (ii) all references to specific articles of the 2002 Law in order to replace them by the relevant articles of the
2010 Law.

42106

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution:

The general meeting resolves to amend the Articles of Incorporation to ensure compliance with the 2010 Law as

follows:

1) Amendment of Article 14 which will henceforth be entitled “Suspension of the calculation of the Net Asset Value

and of the issue, the redemption and the conversion of Shares” in order to introduce new cases of temporary suspension
of the calculation of the net asset value of the one or more sub-fund and the issue, redemption and conversion of any
class of shares;

2) Amendment of Article 26 “Powers of the Board of Directors” in order to fully comply with the 2010 Law and take

master feeder structures into consideration;

3) Amendment of Article 34 “Dissolution of the Company” in order to fully comply with the 2010 Law and take master

feeder structures into consideration;

4) Creation of new Article 35 entitled “Mergers of Sub-Funds and / or Classes of Shares” reflecting the new provisions

of the 2010 Law on merger possibilities offered by the 2010 Law.

<i>Third resolution:

The general meeting resolves as well to amend the Articles of Incorporation as follows:
1) Amendment of Article 7 “Sub-Funds” in order to inter alia provide that any sub-fund of the Company which qualifies

as an “exchange-traded fund” should use the identifier “ETF” in its denomination;

2) Amendment of Article 8 which will henceforth be entitled “Classes of Shares” in order to provide that fractional

shares may confer voting rights if their sum equals to one share;

3) General rewording of Article 11 which will henceforth be entitled “Limitation to the ownership of the Shares” to

inter alia give to the board of directors the power to impose or relax the restrictions of ownership on any subfund or
class of shares, clarify the definition of U.S. Person and restrict the issue or transfer of shares of the Company to insti-
tutional investors;

4) Amendment of Article 12 which will henceforth be entitled “Net Asset Value” to modify the rules of valuation of

the assets of the Company and to allow the board of directors to establish a pool of assets for each subfund;

5) General rewording of Article 13 which will henceforth be entitled “Issue, redemption and conversion of Shares”;
6) Amendment of Article 14 which will henceforth be entitled “Suspension of the calculation of the Net Asset Value

and of the issue, the redemption and the conversion of Shares” in order to introduce new cases of temporary suspension
of the calculation of the net asset value of the one or more sub-funds and the issue, redemption and conversion of any
class of shares;

7) Amendment of Article 16 which will henceforth be entitled “Annual general Shareholders’ meeting” to allow the

board of directors of the Company to hold the annual general meeting of shareholders at a date, time or place other than
those set forth in the Articles of Incorporation, to the extent permitted by and in accordance with the conditions set
forth under Luxembourg laws and regulations;

8) Amendment of Article 18 which will henceforth be entitled “Functioning of Shareholders’ meetings” in order to

inter alia allow shareholders to vote by means of voting forms;

9) Amendment of Article 19 which will henceforth be entitled “Notice to the General Shareholders’ meetings” to

include a reference to a “record date” for the determination of the quorum and majority applicable to a general meeting
of shareholders;

10) Amendment of Article 21 “Duration of the functions of the Directors, renewal of the Board of Directors” in order

to modify the election term of a director that shall not exceed one year;

11) Amendment of Article 23 “Meetings and deliberations of the Board of Directors” in order to reduce the delay to

convene a meeting of the board of directors to 24 hours, to allow the directors to cast their votes in writing or any
electronic means capable of evidencing their vote and to allow the directors to participate at any meeting by videocon-
ference or other means of telecommunication allowing their identification;

12) General rewording of Article 33 “Distribution Policy”.

<i>Fourth resolution:

The general meeting approves the general rewording of the Articles of Incorporation for clarity purposes, amending

inter alia articles:

1) Article 4 “Registered office”;
2) Article 9 “Form of the Shares”;
3) Article 15 “General provisions”;
4) Article 17 “General meetings of Shareholders of Sub-Funds or Classes of Shares”;
5) Article 27 “Conflict of Interest”;
6) Article 31 “Auditor”;

42107

L

U X E M B O U R G

7) Article 32 “Accounting year”;
8) Article 34 “Dissolution of the Company”;
9) Article 35 “Terminations of Sub-Funds and/or classes of Shares”.

<i>Fifth resolution:

The general meeting approves the adjunction of new Article 35 “Merger of Sub-Funds and / or Classes of Shares”,

Article 36 “Division of Sub-Funds”, Article 37 “Amalgamation of Sub-Funds” and Article 38 “Depositary”.

<i>Sixth resolution:

The general meeting resolves to remove Article 30 “Management Company, Investment Managers, Custodian and

other contractual parties” and Article 37 “Expenses borne by the Company”.

<i>Seventh resolution:

The general meeting approves the general rewording of the Articles of Incorporation for clarity or consistency pur-

poses.

<i>Eighth resolution:

The general meeting approves the general renumbering of the Articles of Incorporation following the removal and the

adjunction of articles from and to the Articles of Incorporation.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Company will henceforth read as follows:

“1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office

Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares (the "Shares")

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, qualifying as a société d'investissement à capital variable
with multiple sub-funds under the name of "MULTI UNITS LUXEMBOURG" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a

resolution of the shareholders (the "Shareholders") adopted in the manner required for amendment of these articles of
incorporation (the "Articles of Incorporation").

Art. 3. Corporate object. The exclusive object of the Company is the collective investment of its assets in transferable

securities, money market instruments and other permissible assets such as referred to in the law of 17 December 2010
on undertakings for collective investment, as may be amended (the "Law"), with the purpose of offering various investment
opportunities, spreading investment risk and offering its Shareholders the benefit of the management of the Company’s
assets.

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and deve-

lopment of its object in the broadest sense in the frame of Part I of the Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy

of Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the registered
office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Furthermore, the
board of directors (hereafter collegially referred to as the "Board of Directors" or the "Directors" or individually referred
to as a "Director") may decide to transfer the registered office of the Company within the city of Luxembourg. Wholly
owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.

2. Share capital, Variations in share capital, Characteristics of the shares

Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall at any time be equal to the total net assets of the Company,

as defined in Article 12. The minimum share capital of the Company shall not be less than the amount prescribed by the
Law.

For consolidation purposes, the reference currency of the Company is the Euro.

Art. 6. Variations in share capital. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the

Company of new fully paid-up shares (each a "Share") or the repurchase by the Company of existing Shares from its
Shareholders.

42108

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Sub-Funds. The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid-up Shares at any time in

accordance with Article 13 hereof without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of
the Shares to be issued.

Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different sub-funds corresponding to separate portfolios

of assets (each a "Sub-Fund") (which may, as the Board of Directors shall determine, be denominated in different cur-
rencies) and the proceeds of the issue of the Shares of each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 3 hereof in
transferable securities, money market instruments or other permitted assets corresponding to such geographical areas,
industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities and other permitted assets,
as the Board of Directors shall from time to time determine.

Each Sub-Fund is deemed to be a compartment within the meaning of the Law (in particular article 181 of the Law).

The Company constitutes one single entity. However, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit
of the relevant Sub-Fund. In addition, each Sub-Fund shall only be responsible for the liabilities which are attributable to
such Sub-Fund.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Sub-Funds.

Any Sub-Fund which qualifies as an “exchange-traded fund” should use the identifier “UCITS-ETF” in its denomination.

Art. 8. Classes of Shares. The Board of Directors may, at any time, within each Sub-Fund, issue different classes of

Shares (each a "Class") which may differ in, inter alia, their charging structure, the minimum investment requirements,
the management fees or type of target investors, their listing on a stock exchange or not (in case of Classes of Shares of
the ETF type) or corresponding to a specific distribution policy, such as giving right to regular dividend payments ("Dis-
tribution Shares") or giving no right to distributions as earnings will be reinvested ("Capitalisation Shares"). Fractions of
Shares may be issued under the conditions as set out in the Company's sales documents but shall not be entitled to vote.
If the sum of the fractional Shares so held by the same Shareholder represents one or more entire Share(s), such Sha-
reholder has the correspondent voting right.

When the context so requires, references in these Articles of Incorporation to Sub-Fund(s) shall mean references to

Class(es) of Shares and vice-versa.

Art. 9. Form of the Shares. The Company may issue Shares of each Sub-Fund and of each Class of Shares in both

registered and bearer form.

Registered Shares shall be materialized by an inscription in the register of Shareholders and are issued in uncertificated

form with a confirmation statement, unless a share certificate is specifically requested at the time of subscription, and in
such case, the subscriber will bear the risk and any additional expense arising from the issue of such certificate. Holders
of certificated Shares must return their share certificates, duly renounced, to the Company before conversion or re-
demption instructions may be effected.

If bearer Shares are issued, share certificates shall be issued under supervision of the depositary of the Company (the

"Depositary") in such denominations as shall be determined by the Board of Directors.

In the absence of a specific request for Share certificates, each Shareholder will receive written confirmation of the

number of Shares held in each Sub-Fund and in each Class of Shares. Upon request, a Shareholder may receive without
any charge, a Share certificate in respect of the Shares held.

The Share certificates delivered by the Company are signed by two Directors (the two signatures may be either hand-

written, printed or appended with a signature stamp) of by one Director and another person authorized by the Board
of Directors for the purpose of authenticating certificates (in which case, the signature must be hand-written).

In case a holder of bearer Shares requests that rights attaching to such certificates be modified through their conversion

into certificates with different denominations, such Shareholder shall bear the cost of such conversion.

In case a holder of registered Shares requests that more than one share certificate be issued for his Shares, the cost

of such additional certificates may be charged to him.

A register of Shareholders (the “Shareholders Register”) shall be kept at the registered office of the Company. Such

Shareholders Register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of
Shares held by him, the Class of Share, the amounts paid for each such Share, the transfer of Shares and the dates of such
transfers. The Shareholders Register is conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of
a Share as the absolute and beneficial owner thereof.

Shares shall only be issued upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price by the Depositary

or by a person acting for its account. Subject to all applicable laws and regulations, payment of the purchase price will be
made in the currency in which the Shares are denominated as well as in certain other currencies as may be determined
from time to time by the Board of Directors. Following acceptance of the subscription and receipt of the relevant purchase
price, rights in the subscribed Shares shall be vested in the subscriber and, following his request, he shall forthwith receive
final Share certificates in bearer or registered form.

The transfer of bearer Shares shall be carried out by way of the delivery to the relevant holder of the corresponding

share certificate(s). The transfer of a registered Share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on

42109

L

U X E M B O U R G

the register of shareholders, such declaration of transfer, in a form acceptable to the Company, to be dated and signed
by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company
may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Any owner of registered Shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the Shareholder

Register. All notices and announcements of the Company given to owners of registered Shares shall be validly made at
such address. Any Shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the
Shareholder Register. In case no address has been indicated by an owner of registered Shares, the Company is entitled
to deem that the necessary address of the Shareholder is at the registered office of the Company. The Shareholder shall
be responsible for ensuring that his details, including his address, for the Shareholders Register are kept up to date and
shall bear any and all responsibility should any details be incorrect or invalid.

The Shares are issued, and Share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription

and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the Company's sales documents.

The Company will recognise only one holder in respect of each Share in the Company. In the event of joint ownership,

the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant Share or Shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

If a conversion or a payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, such fraction shall be

entered into the Shareholders Register. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine,
be entitled to a corresponding fraction of the dividend.

Art. 10. Loss or destruction of share certificates. If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that

his share certificate has been mislaid, damaged or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be
issued under such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification
of title or claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue
of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become
null and void.

Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company.
The mutilated or defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be cancelled immediately.
The Company, at its discretion, may charge the Shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate,

as well as all costs and reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration
thereof, or in connection with the annulment of the old Share certificate.

Art. 11. Limitation to the ownership of Shares. The Board of Directors shall have power to impose or relax such

restrictions on any Sub-Fund or Class of Shares (other than any restrictions on transfer of Shares) (but not necessarily
on all Classes of Shares within the same Sub-Fund) as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares
in the Company are acquired or held by or on behalf of (a) any person in breach of the law or requirements of any country
or governmental or regulatory authority (if the Directors shall have determined that any of them, the Company, any
manager of the Company’s assets, any of the Company’s investment managers or advisers or any other person as de-
termined by the Directors would suffer any disadvantage as a result of such breach) or (b) any person in circumstances
which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering
any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered, including a requi-
rement to register under any securities or investment or similar laws or requirements of any country or authority.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm

or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter.

For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
(a) decline to issue any Share where it appears to it that such registration would or might result in such Share being

directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Company;

(b) at any time require any person whose name is entered in the Shareholders Register to furnish it with any infor-

mation, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial
ownership of such Shareholder’s Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company; and

(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded pursuant to this Article from holding Shares

in the Company with any other person is a beneficial or registered owner of Shares. In such cases enumerated under (a)
through (c) above, the Company may compulsorily redeem from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder
in the following manner: 1) the Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the "Redemption Notice") upon
the holder of Shares subject to compulsory repurchase; the Redemption Notice shall specify the Shares to be repurchased
as aforesaid, the Redemption Price (as defined here below) to be paid for such Shares and the place at which this price
is payable. Any such notice may be served upon such Shareholder by registered mail, addressed to such Shareholder at
his last known address or at his address as indicated in the Shareholders Register. The said Shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate, if issued, representing Shares specified in the Re-
demption  Notice.  Immediately  after  the  close  of  business  on  the  date  specified  in  the  Redemption  Notice,  such
Shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in the Redemption Notice and the share certificate, if
issued, representing such Shares shall be cancelled in the books of the Company, 2) the price at which the Shares specified

42110

L

U X E M B O U R G

in any Redemption Notice shall be purchased (hereinafter referred to as the "Redemption Price") shall be an amount
based on the Net Asset Value per Share of the Class of the Sub-Fund to which the Shares belong, determined in accordance
with Article 12 hereof, as at the date of the Redemption Notice, 3) subject to all applicable laws and regulations, payment
of the Redemption Price will be made to the owner of such Shares in the currency in which the Shares are denominated
or in certain other currencies as may be determined from time to time by the Board of Directors, and will be deposited
by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such
owner upon surrender of the share certificate, if issued, representing the Shares specified in such Redemption Notice.
Upon deposit of such Redemption Price as aforesaid, no person interested in the Shares specified in such Redemption
Notice shall have any further interest in such Shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof,
except the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the Redemption Price so deposited (without
interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid, 4) the exercise by the
Company of the powers conferred by this Article 11 shall not be questioned or invalidated in any case on the ground
that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person at the date of any Redemption Notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded

pursuant to this Article from holding Shares in the Company at any meeting of Shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall include a national or resident of the United States of

America or any of its states, territories, possessions or areas subject to its jurisdiction (the "United States") and any
partnership, corporation or other entity organised or created under the laws of the United States or any political sub-
division thereof but shall not include “accredited investor” and a “qualified purchaser” as such terms are defined in the
United States Securities Act of 1933 (as amended) and in the United States Investment Company Act of 1940. The
Directors may clarify the term U.S. person in the Company's sales documents.

In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Class of Shares

or  of  a  Sub-Fund  to  institutional  investors  within  the  meaning  of  the  Law  ("Institutional  Investor(s)").  The  Board  of
Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a Class of Shares or
of a Sub-Fund reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that
the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Class of Shares or
of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the
relevant Shares into Shares of a Class of Shares or of a Sub-Fund which is not restricted to Institutional Investors (provided
that there exists such a Class of Shares or of a Sub-Fund with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant
Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect
to any transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the register of shareholders
in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a Class of Shares or of a Sub-Fund to
Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition
to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds
Shares in a Class of Shares or of a Sub-Fund restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the
Company, the Board of Directors, the other Shareholders of the relevant Class of Shares or of a Sub-Fund and the
Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where
the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue repre-
sentations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of
such status.

3. Net asset value, Issue and repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value

Art. 12. Net Asset Value. The Net Asset Value per Share of each Class of Shares in each Sub-Fund of the Company

shall be determined periodically by the Company, but in any case not less than twice a month or, subject to regulatory
approval, no less than once a month, as the Board of Directors may determine (every such day for determination of the
Net Asset Value being referred to herein as the "Valuation Day") on the basis of prices whose references are specified
in the Company's sales documents.

The Net Asset Value per Share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund and, for each Class of Shares

for all Sub-Funds, is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such Class
of Shares less the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such Class of Shares by the total number of Shares
of such Class outstanding on any Valuation Day.

If since the close of business, there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial

portion of the investments attributable to a particular Sub-Fund are dealt or quoted, the Company may, in order to
safeguard the interests of Shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

Upon the creation of a new Sub-Fund, the total net assets allocated to each Class of Shares of such Sub-Fund shall be

determined by multiplying the number of Shares of a Class issued in the Sub-Fund by the applicable purchase price per
Share.  The  amount  of  such total  net  assets  shall  be  subsequently adjusted  when  Shares of  such Class  are  issued or
repurchased according to the amount received or paid as the case may be.

The valuation of the Net Asset Value per Share of the different Classes of Shares shall be made in the following manner:

42111

L

U X E M B O U R G

a) The assets of the Company shall be deemed to include:
1. all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2. all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3. all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stocks, units or shares of undertakings for collective investment,

subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted
for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (i)
below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);

4. all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

5. all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

6. the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off;
7. all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
i. The value of any cash on hand or on deposit bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends, interests declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

ii. Securities listed on a recognised stock exchange or dealt on any other regulated market (hereinafter referred to as

a "Regulated Market") that operates regularly, is recognised and is open to the public, will be valued at their last available
closing prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their last available closing prices
on the main market for the relevant security;

iii. In the event that the last available closing price does not, in the opinion of the Directors, truly reflect the fair market

value of the relevant securities, the value of such securities will be determined by the Directors based on the reasonably
foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;

iv. Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market will be valued on the

basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the Directors;

v. The value of financial derivative instruments traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based

upon the last available settlement prices of these financial derivative instruments on exchanges and Regulated Markets
on which the particular financial derivative instruments are traded by the Company; provided that if financial derivative
instruments could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for
determining the value of such financial derivative instruments shall be such value as the Directors may deem fair and
reasonable;

vi. the financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other

organised market will be valued in a reliable and verifiable manner on a daily basis and verified by a competent professional
appointed by the Company;

vii. investments in open-ended UCI will be valued on the basis of the last available net asset value of the units or shares

of such UCI;

viii. all other transferable securities and other permitted assets will be valued at fair market value as determined in

good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors;

ix. liquid assets and money market instruments may be valued at market value plus any accrued interest or on an

amortised cost basis as determined by the Board of Directors. All other assets, where practice allows, may be valued in
the same manner. If the method of valuation on an amortised cost basis is used, the portfolio holdings will be reviewed
from time to time under the direction of the Board of Directors to determine whether a deviation exists between the
Net Asset Value calculated using the market quotation and that calculated on an amortised cost basis. If a deviation exists
which may result in a material dilution or other unfair result to investors or existing shareholders, appropriate corrective
action will be taken including, if necessary, the calculation of the Net Asset Value by using available market quotations;
and.

x. in the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board of Directors

may adjust the value of any investment or permit some other method of valuation to be used for the assets of the Company
if it considers that the circumstances justify that such adjustment or other method of valuation should be adopted to
reflect more fairly the value of such investments.

Any  assets  held  not  expressed  in  the  reference  currency  of  the  Company  will  be  converted  into  such  reference

currency at the rate of exchange prevailing in a recognised market on the day preceding the Valuation Day.

b) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;

42112

L

U X E M B O U R G

b) all accrued or payable administrative expenses (including global management fees, distribution fees, depositary fees,

administrative agent fees, registrar and transfer agent fees, nominee fees and other third party fees);

c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or

property;

d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the dealing day preceding the Valuation

Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the
Directors, in particular those that have been set aside for a possible depreciation of the investments of the Company;
and

e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares of the

Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its Directors (including all reasonable out of pocket
expenses), the management company of the Company, investment advisors or investment managers and sub-investment
managers, accountants, depositary bank and paying agent, administrative, corporate and domiciliary agent, registrar and
transfer agent and permanent representatives in places of registration, nominees and any other agent employed by the
Company, fees for legal and auditing services, cost of any proposed listings, maintaining such listings, promotion, printing,
reporting  and  publishing  expenses  (including  reasonable  marketing  and  advertising  expenses  and  costs  of  preparing,
translating and printing in different languages) of prospectuses of the Company, explanatory memoranda or registration
statements, annual reports, semi-annual reports and long form reports, taxes or governmental and supervisory authority
charges, insurance costs and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interests, bank
charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of
a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in
equal proportions over any such period.

The Directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:
a. the proceeds from the allotment and issue of each Class of Shares of such Sub-Fund shall be applied in the books

of the Company to the portfolio of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and
expenditure attributable thereto shall be applied to such pool subject to the provisions of this Article;

b. where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;

c.  where  the  Company  incurs  a  liability  which  relates  to  any  asset  of  a  particular  pool  or  to  any  action  taken  in

connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;

d. in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the Net Asset Values of each pool; provided that
all liabilities, attributable to a pool shall be binding on that pool; and

e. upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Class of Shares,

the Net Asset Value of such Class of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.

For the purpose of valuation under this Article:
a. Shares of the Company to be redeemed under Article 13 hereof shall be treated as existing and taken into account

until immediately after the time specified by the Directors on the Valuation Day on which such valuation is made, and,
from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

b. Shares of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received

shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and
the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;

c. all investments, cash balances and other assets of any Sub-Fund expressed in currencies other than the currency of

denomination in which the Net Asset Value per Share of the relevant Sub-Fund is calculated shall be valued after taking
into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value
of the relevant Sub-Fund;

d. effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Day, to the extent practicable; and

e. the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to

the performance under contract or otherwise by agents for management company services (if appointed), asset mana-
gement, custodial, domiciliary, registrar and transfer agency, audit, legal and other professional services and with the
expenses of financial reporting, notices and dividend payments to Shareholders and all other customary administration
services and fiscal charges, if any.

The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more Sub-

Fund(s) (hereafter referred to as "Participating Funds") on a pooled basis where it is applicable with regard to their
respective investment sectors to do so. Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by
transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds.
Thereafter the Directors may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. They may also transfer

42113

L

U X E M B O U R G

assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating
Fund concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to
the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

The  assets  of  the  Enlarged  Asset  Pool  to  which  each  Participating  Fund  shall  be  entitled,  shall  be  determined  by

reference to the allocations and withdrawals made on behalf of the other Participating Funds.

Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset

Pool will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective entitlements to the assets
in the Enlarged Asset Pool at the time or receipt.

Art. 13. Issue, redemption and conversion of Shares. The Board of Directors is authorised to issue further fully paid-

up Shares of each Class and of each Sub-Fund at any time at a price based on the Net Asset Value per Share for each
Class of Shares and for each Sub-Fund determined in accordance with Article 12 hereof, as of such Valuation Day as is
determined in accordance with such policy as the Board of Directors may from time to time determine. Such price may
be  increased  by  applicable  charges,  as  approved  from  time  to  time  by  the  Board  of  Directors  and  described  in  the
Company's sales document. Such price may be rounded upwards or downwards as the Board of Directors may resolve.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new Shares.

All new Share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely paid-up, and the Shares issued carry the same rights

as those Shares in existence on the date of the issuance. The subscription price shall be paid within a period as determined
by the Board of Directors and specified in the Company's sales documents not exceeding 5 business days after the relevant
Valuation Day.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the Directors may, at any time and from time to

time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of Shares of any
Class in any one or more Sub-Funds.

The subscription price (not including the sales commission or any other changes) may, upon approval of the Board of

Directors, and subject to all applicable laws and regulations, namely with respect to a special audit report confirming the
value of any assets contributed in kind (if legally required), be paid by contributing to the Company securities acceptable
to the Board of Directors consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company. The costs
for such subscription in kind, in particular the costs of the special audit report, will be borne by the Shareholder requesting
the subscription in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board of Directors considers
that the subscription in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.

Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that:
(i) in the case of a request for redemption of part of his Shares, the Company may, if compliance with such request

would result in a holding of Shares of any one Class or in any one Sub-Fund with an aggregate Net Asset Value of less
than such amount or number of Shares as the Board of Directors may determine from time to time and as described in
the sales documents, redeem all the remaining Shares held by such Shareholder; and

(ii) the Company may limit the total number of Shares of any Sub-Fund which may be redeemed (including conversions)

on a Valuation Day to a certain percentage as disclosed in the Company's sales documents of the total net assets of such
Sub-Fund on a Valuation Day.

In case of deferral of redemption the relevant Shares shall be redeemed at a price based on the Net Asset Value per

Share prevailing at the date on which the redemption is effected, less any redemption charge in respect thereof and/or
less any applicable dilution levy and/or less any contingent deferred charge and/or less any other charge as foreseen by
the sales documents of the Company. Redemption requests that have not been dealt with in case of such deferral will be
given priority as if the request had been made for the next following Valuation Day or dates until completion of full
treatment of the original request, subject always to the limit set out under (ii) above. The redemption proceeds shall
normally be paid within five days which are business days in Luxembourg following the applicable Valuation Day and shall
be based on the price for the relevant Class of Shares of the relevant Sub-Fund as determined in accordance with the
provisions of Article 12 hereof, less any redemption charge in respect thereof and/or less any applicable dilution levy and/
or less any contingent deferred charge and/or less any other charge as foreseen by the sales documents of the Company.
If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the Class of Shares of a
given Sub-Fund being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment
shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest.

With the consent or upon request of the Shareholder(s) concerned, the Board of Directors may (subject to the

principle of equal treatment of Shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the
redeeming Shareholders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable to the Shares
to be redeemed as described in the Company’s sales documents. Such redemption will, if required by law or regulation,
be subject to a special audit report by the approved statutory auditor of the Company confirming the number, the
denomination and the value of the assets which the Board of Directors will have determined to be contributed in coun-
terpart of the redeemed Shares. The costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report,
will be borne by the Shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the

42114

L

U X E M B O U R G

Company unless the Board of Directors considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made
to protect the interests of the Company. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined
on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares in the relevant Sub-
Fund.

Any such request must be filed or confirmed by such Shareholder in written form at the registered office of the

Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of
Shares. Proper evidence of transfer or assignment must be received by the Company or its agent appointed for that
purpose before the redemption proceeds may be paid.

Under exceptional circumstances, the Board of Directors reserves the right to conduct the necessary sales of trans-

ferable securities before setting the price at which Shareholders can apply to have their Shares redeemed or converted.
In this case, subscriptions, redemptions and conversion applications in process shall be dealt with on the basis of the Net
Asset Value thus calculated after the necessary sales, which shall have been effected without delay.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Any Shareholder is entitled to request for the conversion of whole or part of his Shares, provided that the Board of

Directors may, in the Company's sales documents: a) set terms and conditions as to the right for and frequency of
conversion of Shares between Sub-Funds or between Classes of Shares; and b) subject conversions to the payment of
such charges and commissions as it shall determine.

If as a result of any request for conversion, the aggregate Net Asset Value per Share of the Shares held by a Shareholder

in any Sub-Fund or Class of Shares would fall below such value as determined by the Board of Directors, then the Company
may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such Shareholder’s holding of
Shares in such Sub-Fund or Class of Shares.

Such a conversion shall be effected on the basis of the Net Asset Value of the relevant Shares of the different Sub-

Funds, determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof.

The Shares which have been converted into another Sub-Fund or Class of Shares will be cancelled.

Art. 14. Suspension of the calculation of the Net Asset Value and of the issue, the redemption and the conversion of

Shares. The Company may suspend the calculation of the Net Asset Value of one or more Sub-Funds and the issue,
redemption and conversion of any Classes of Shares in the following circumstances:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the

investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise
than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Directors as a result

of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be impracticable;

c) during any breakdown or restriction in the means of communication normally employed in determining the price

or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market
in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of
investments or payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the Directors, be effected at normal
rates of exchange;

e) during any period when in the opinion of the Directors of the Company there exist unusual circumstances where

it would be impracticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing with Shares of any Sub-Fund of the
Company or any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Shareholders of the
Company, a Sub-Fund or a Class of Shares incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages
or other detriment which the shareholders of the Company, a Sub-Fund or a Class of Shares might not otherwise have
suffered;

f) in the event of (i) the publication of the convening notice to a general meeting of at which a resolution to wind up

the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of (ii) the decision of the Board of Directors to wind up one or more
Sub-Funds, or (iii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the Shareholders, of the notice
of the general meeting of Shareholders at which the merger of the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of the
decision of the Board of Directors to merge one or more Sub-Funds;

g) when for any other reason beyond the control of the Board of Directors, the prices of any investments owned by

the Company attributable to such Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained;

h) where a UCI in which a Sub-Fund has invested a substantial portion of its assets temporarily suspends the calculation

of the net asset value of its shares/units or the repurchase, redemption or subscription of its shares/units, whether on
its own initiative or at the request of its competent authorities;

i) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or con-

version of shares/units, at the level of a master fund in which a Sub-Fund invests in its quality of feeder fund of such master
fund.

42115

L

U X E M B O U R G

The suspension of the calculation of the Net Asset Value of a Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the

Net Asset Value per Share, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Sub-Fund which is not suspended.

Any such suspension shall be promptly notified to Shareholders requesting redemption or conversion of their Shares

by the Company at the time of the filing of the written request for such redemption as specified in Article 13 hereof. The
Board of Directors may also make public such suspension in such a manner as it deems appropriate.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that

the Company receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscription, redemption and conversion applications shall be executed on the first Valuation Day following

the resumption of Net Asset Value calculation by the Company.

4. General shareholders’ meetings

Art. 15. General provisions. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent

the entire body of Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the Class
of Shares held by them.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items

to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company
by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.

Art. 16. Annual general Shareholders’ meeting. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on the first Friday of April at 10.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is a bank
holiday, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of

Shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date,
time and place are to be decided by the Board of Directors.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 17. General meetings of Shareholders of Sub-Funds or Classes of Shares. The Shareholders of any Sub-Fund or

any Class of Shares may hold or be convened to, at any time, general meetings to decide on any matters which relate
exclusively to such Sub-Fund or Class of Shares.

The general provisions set out in these Articles of Incorporation, as well as in the Luxembourg law dated 10 August

1915 on commercial companies as amended from time to time, shall apply to such meetings.

Two or more Classes of Shares or Sub-Funds may be treated as a single Class or Sub-Fund if such Sub-Funds or Classes

would be affected in the same way by the proposals requiring the approval of Shareholders relating to the separate Sub-
Funds or Classes.

Art. 18. Functioning of Shareholders’ meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and

conduct of the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each whole Share, regardless of the Class and of the Sub-Fund to which it belongs, is entitled to one vote, subject to

the limitations imposed by these articles. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable, telegram, telefax message, facsimile transmission or any other electronic means
capable of evidencing such proxy. Fractions of Shares are not entitled to a vote. If the sum of the fractional Shares so
held by the same Shareholder represents one or more entire Share(s), such shareholder has the correspondent voting
right.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly

convened will be passed by simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to Shares in
respect of which the Shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take

part in any meeting of Shareholders.

Where there is more than one Class of Shares or Sub-Fund and the resolution of the general meeting is such as to

change the respective rights thereof, such resolution must, in order to be valid, be approved separately by Shareholders
of such Class of Shares or Sub-Fund in accordance with the quorum and majority requirements provided for by this
Article.

If and to the extent permitted by the Board of Directors for a specific meeting of Shareholders, each Shareholder may

vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the
convening notice.

The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least:
- the name, address or registered office of the relevant Shareholder;

42116

L

U X E M B O U R G

- the total number of Shares held by the relevant Shareholder and, if applicable, the number of Shares of each Sub-

Fund or Class of Shares held by the relevant Shareholder;

- the place, date and time of the general meeting;
- the agenda of the general meeting;
- the proposal submitted for decision of the general meeting; as well as - for each proposal three boxes allowing the

Shareholder to vote in favour, against or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms, which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention shall be void. The

Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of Shareholders to which they
relate.

Art. 19. Notice to the general Shareholders' meetings. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.

To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of Shareholders

may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the
Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date") and that the
right of a Shareholder to participate at a general meeting of Shareholders and to exercise the voting right attached to his
Shares will be determined by reference to the Shares held by this Shareholder as at such Record Date.

5. Management of the company

Art. 20. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three

members who need not to be Shareholders of the Company.

Art. 21. Duration of the functions of the Directors, renewal of the Board of Directors. The Directors shall be elected

by the general meeting of Shareholders for a period ending at the next annual general meeting and until their successors
are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced or
an additional director appointed at any time by resolution adopted by the general meeting of Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of Shareholders.

Art. 22. Committee of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen.

It may also chose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the Board of Directors and of the Shareholders.

Art. 23. Meetings and deliberations of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the

chairman, or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of Directors, but in his absence the Share-

holders or the Board of Directors may appoint another Director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of Shareholders and in the case no Director is present, any other person may be appointed as chairman.

The Board of Directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, any

assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors. Officers need not be Directors
or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least 24 hours in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile transmission or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate
notice shall not be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.

Any Director may act at any meetings of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile transmission or any other electronic means capable of evidencing such appointment another Director as his
proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, facsimile transmission or any other electronic
means capable of evidencing such vote.

Any Director may also participate at any meeting of the Board of Directors by videoconference or any other means

of telecommunication permitting the identification of such Director. Such means must allow the Director(s) to participate
effectively at such meeting of the Board of Directors.

The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.

42117

L

U X E M B O U R G

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company

by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors are present or

represented at a meeting of Directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The

chairman shall have the casting vote.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and other means capable of evidencing such
consent.

The Board of Directors may delegate, under its responsibility and supervision, its powers to conduct the daily mana-

gement and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose,
to natural persons or corporate entities which need not be members of the Board of Directors.

Art. 24. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman, or in his

absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

such chairman or by the secretary or by two Directors.

Art. 25. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two

members of the Board of Directors or by the individual signature of any duly authorised officer of the Company or by
the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 26. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors determines the general orientation of the mana-

gement and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always
in application of the principle of risk diversification.

When any investment policies are determined and implemented, the Board of Directors shall ensure compliance with

the following provisions:

The Board of Directors may decide that investment of the Company be made (i) in transferable securities and money

market instruments admitted to or dealt in on a Regulated Market as defined by the Law, (ii) in transferable securities
and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated,
operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments
admitted to official listing on a stock exchange in Europe, Asia, Oceania (including Australia), the American continents
and Africa, or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated,
operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities, and money
market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in
any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured
within one year of issue, as well as (v) in any other securities such as units/shares in UCITS including shares or units of a
master fund to the extent permitted and at the conditions stipulated by the Law, and/or other UCIs as defined by the
Law, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance
with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

Any Sub-Fund which acts as a feeder fund of a master fund shall invest at least eighty five (85) percent of its assets in

shares/units of another UCITS or of a compartment of such UCITS, which shall neither itself be a feeder fund nor hold
units/shares of a feeder fund. The feeder Sub-Fund may not invest more than fifteen (15) percent of its assets in one or
more of the following:

a) ancillary liquid assets in accordance with Article 41 (1) a) and b) of the Law;
b) financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 41 (1) g)

and Article 42 (2) and (3) of the Law;

c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of the Company’s business.
The Board of Directors may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of each Sub-Fund of

the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member
State, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory
authority and disclosed in the sales documents of the Company (including but not limited to OECD member states,
Singapore and Brazil), or public international bodies of which one or more of Member States of the European Union are
members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold, on behalf of
the Sub-Fund concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account
for more than thirty per cent of such Sub-Fund's total net assets.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments,

including equivalent cash settled instruments, dealt in on a Regulated Market as referred to in the Law and / or over-the-
counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law, financial

42118

L

U X E M B O U R G

indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment
objectives as disclosed in its prospectus.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund to be made with the aim to replicate a certain

index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is
sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an appro-
priate manner.

Investments of the Company may be made either directly or indirectly through wholly owned subsidiaries. When

investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf, carry on
only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the
redemption of units at the request of Shareholders, Article 48 paragraphs (1) and (2) of the Law do not apply. Any
reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets
beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

Except in case of master-feeder structures, the Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-

Fund in undertakings for collective investment as defined in Article 41 (1) e) of the Law unless specifically foreseen in the
sales documents of the Company for a Sub-Fund.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Sub-Fund may, to the widest extent permitted

by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents,
invest in one or more Sub-Funds of the Company. The relevant legal provisions on the computation of the net asset value
will be applied accordingly. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations,
the voting rights, if any, attaching to the Shares held by a Sub-Fund in another Sub-Fund of the Company are suspended
for as long as they are held by the Sub-Fund concerned. In addition and for as long as these Shares are held by a Sub-
Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes
of verifying the minimum capital required by the Law.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems

appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with
the provisions set forth in the sales documents of the Company (i) create any Sub-Fund qualifying either as a feeder UCITS
or as a master UCITS, (ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS Sub-Fund or (iii) change the master UCITS
of any of its feeder UCITS Sub-Funds.

The Board of Directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Sub-

Funds on a pooled basis, as described in Article 12, where it is appropriate with regard to their respective investment
sectors to do so.

Art. 27. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of any such other company or firm. Any Director or officer of the
Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business, shall not, by reason of his/her/its connection and/or relationship with that other company
or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to any such contract or other
business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted

for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, that Director or officer shall make such a
conflict known to the Board of Directors, and any such transaction shall be reported to the next meeting of Shareholders.

The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board of Directors or by the single Director relates

to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or any other
company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion, provided that
this personal interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.

Art. 28. Indemnification of the Directors. The Company shall indemnify any Director or officer, and his heirs, executors

and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its
request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Art. 29. Allowance of the Board of Directors.  The  general  meeting  of  Shareholders  may  allow  the  Directors,  as

remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as Directors’ remuneration, such amount being carried as general
expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the Board of Directors among themselves.

42119

L

U X E M B O U R G

Furthermore, the members of the Board of Directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of

the Company insofar as they are reasonable.

6. Auditor

Art. 30. Auditor. The general meeting of Shareholders shall appoint an approved statutory auditor ("réviseur d’entre-

prises agréé") who shall carry out the duties prescribed by the Law and serve until its successor is elected.

7. Annual accounts

Art. 31. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1 

st

 in each year and shall end

on December 31 

st

 of the same year.

The accounts of the Company shall be expressed in Euro or to the extent permitted by laws and regulations such

other currency, as the Board of Directors may determine. Where there shall be different Sub-Funds as provided for in
Article 7 hereof, and if the accounts within such Sub-Funds are expressed in different currencies, such accounts shall be
converted into Euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company.

Art. 32. Distribution Policy. The Shareholders shall in a special meeting of each Class of Shares, upon proposal from

the Directors and within the limits provided by Luxembourg law, determine how the results of the Company shall be
disposed of and other distributions shall be effected and may from time to time declare, or authorise the Directors to
declare distributions.

For  any  Sub-Fund  or  Class  of  Shares,  the  Directors  may  decide  to  pay  interim  dividends  in  compliance  with  the

conditions set forth by law. The annual general meeting resolving on the approval of the annual accounts shall also ratify
interim dividends resolved by the Directors. Distribution shares confer in principle on their holders the right to receive
dividends  declared  on  the  portion  of  the  net  assets  of  the  Company  attributable  to  the  relevant  Class  of  Shares  in
accordance with the provisions below. Accumulation shares do not in principle confer on their holders the right to
dividends. The portion of the net assets of the Company attributable to accumulation shares of the relevant Class of
Shares in accordance with the provisions below shall automatically be reinvested within the relevant Class of Shares and
shall automatically increase the Net Asset Value of these Shares.

The Directors shall for the purpose of the calculation of the Net Asset Value of the Shares as provided in Article 12

operate within each Sub-Fund and Class of Shares a separate pool of assets corresponding to distribution and accumulation
shares in such manner that at all times the portion of the total assets of the relevant Sub-Fund and Class of Shares
attributable to the distribution shares and accumulation shares respectively shall be equal to the portion of the total of
distribution shares and accumulation shares respectively in the total number of Shares of the relevant Sub-Fund and Class
of Shares.

Dividends may further, in respect of any Class of Shares, include an allocation from an equalisation account which may

be maintained in respect of any such Class of Shares and which, in such event, will in respect of such Class of Shares, be
credited upon issue of Shares and debited upon redemption of Shares, in an amount calculated by reference to the accrued
income attributable to such Shares.

Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law, be paid out on the Shares of any Class

of Shares upon decision of the Board of Directors.

Dividends paid in cash will normally be paid in the currency in which the relevant Class of Shares is expressed or, in

exceptional circumstances, in such other currency as selected by the Board of Directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividends into the currency of their payment.

The Board of Directors may decide that dividends be automatically reinvested for any Sub-Fund or Class of Shares

unless a Shareholder entitled to receive cash distribution elects to receive payment of such dividends. However, no
dividends will be paid if their amount is below an amount to be decided by the Board of Directors from time to time.
Such dividends will automatically be reinvested.

No distribution shall be made if as a result thereof the capital of the Company becomes less than the minimum required

by Law.

Declared dividends not claimed within five years of the due date will lapse and revert to the relevant Sub-Fund or

Class. The Board of Directors has all powers and may take all measures necessary for the implement of this position. No
interest shall be paid on a dividend declared and held by the Company at the disposal of its beneficiary.

8. Dissolution and liquidation

Art. 33. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by the general

meeting of Shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 39 hereof and in the Law.

Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Law, the Board of Directors

has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of Shareholders. The general meeting
for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the Shares presented at the meeting.

42120

L

U X E M B O U R G

The question of the dissolution and of the liquidation of the Company shall also be referred to the general meeting of

Shareholders whenever the capital fall below one quarter of the minimum capital as provided by Law. In such event the
general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the Shareholders
holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets

of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.

The issue of new Shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders'

meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

The Company may also be liquidated if it acts as a feeder UCITS of a master UCITS and if such master UCITS is itself

either liquidated, merged into another UCITS or divided into two or more UCITS except under circumstances provided
by the Law.

In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The appointed liquidator(s) shall realize the assets of the Company,
subject to the supervision of the relevant supervisory authority. The net proceeds of liquidation corresponding to each
Class of Shares shall be distributed by the liquidators to the Shareholders of each Class of Shares of each Sub-Fund in
proportion of their holding of Shares in such Class of Shares of each Sub-Fund either in cash or, upon the prior consent
of the Shareholder, in kind. Any funds to which Shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which
are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons
entitled thereto to the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the Law. Amounts so deposited shall
be forfeited in accordance with Luxembourg laws.

Art. 34. Termination of Sub-Funds and / or Classes of Shares. The Directors may decide at any moment the termination

of any Sub-Fund or Class of Shares. In the case of termination of a Sub-Fund or Class of Shares, the Directors may offer
to the Shareholders of such Sub-Fund or Class of Shares the conversion of their Shares into Classes of Shares of another
Sub-Fund or into another Class of Shares within the same Sub-Fund, under terms fixed by the Directors.

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund or of any Class of Shares within a Sub-

Fund has decreased to an amount determined by the Directors from time to time to be the minimum level for such Sub-
Fund or such Class of Shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economic or political
situation relating to the Sub-Fund concerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-
Fund, the Directors may decide (i) to compulsorily redeem all the Shares of the relevant Sub-Fund or Class of Shares at
the Net Asset Value per Share, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and
calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect or (ii) to offer to the Shareholders of the relevant
Sub-Fund or Class of Shares the conversion of their Shares into Shares of another Sub-Fund or Class of Shares.

The Company shall serve a notice to the Shareholders of the relevant Sub-Fund or Class of Shares prior to the effective

date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations.

Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal treatment between, the Shareholders, the

Shareholders of the Sub-Fund or Class of Shares concerned may continue to request redemption or conversion of their
Shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and prior to
the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred on the Board of Directors by the preceding paragraph hereof, the general

meeting of Shareholders of any one or all Classes of Shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal of the Board of
Directors, redeem all the Shares of the relevant Classes and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their
Shares, taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses and calculated on the Valuation
Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of Share-
holders that shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption be deposited with

the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto. All redeemed Shares will be cancelled in the books
of the Company.

Art. 35. Merger of Sub-Funds and / or Classes of Shares. The Board of Directors may decide to proceed with a merger

(within the meaning of the Law) of the assets and of the liabilities of the Company or a Sub-Fund with those of (i) another
existing Sub-Fund within the Company or another existing sub-fund within another Luxembourg or foreign UCITS, or of
(ii) another Luxembourg or foreign UCITS. In such a case, the Board of Directors is competent to decide on or to approve
the effective date of the merger. Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law,
in particular concerning the terms of the merger to be established by the Board of Directors and the information to be
provided to the Shareholders.

The Board of Directors may also decide to absorb (i) any sub-fund within another Luxembourg or a foreign UCI,

irrespective of their form, or (ii) any Luxembourg or foreign UCI constituted under a non-corporate form. Without
prejudice to the more stringent and/or specific provisions contained in any applicable law or regulation, the decision of
the Board of Directors will be published (either in newspapers to be determined by the Board of Directors or by way

42121

L

U X E M B O U R G

of a notice sent to the relevant Shareholders at their addresses indicated in the Shareholders Register) one month before
the date on which the merger becomes effective in order to enable Shareholders to request during such period the
repurchase or redemption of their units or, where possible, the conversion thereof into Shares in another Sub-Fund with
similar investment, without any charge other than those retained by the Sub-Fund to meet disinvestment costs. At the
expiry of this period, the decision to absorb shall bind all the Shareholders who have not exercised such right. The
exchange ratio between the relevant Shares of the Company and those of the absorbed UCI or of the relevant sub-fund
thereof will be calculated on the effective date of the absorption on the basis of the relevant net asset value per Share
on such date.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraphs, the Shareholders of

the Company or the Shareholders of the relevant Sub-Fund(s), as the case may be, may also decide on any of the mergers
or absorptions described above as well as on the effective date thereof by resolution taken with no quorum requirement
and adopted at a simple majority of the votes validly cast. Where the Company is the absorbed entity which, thus, ceases
to exist as a result of the merger, the general meeting of Shareholders of the Company must decide on the effective date
of the merger. Such general meeting will decide by resolution taken with no quorum requirement and adopted by a simple
majority of the votes validly cast.

In addition to the above, the Company may also absorb another Luxembourg or foreign UCI incorporated under a

corporate form in compliance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended
from time to time.

Art. 36. Division of Sub-Funds. In the event that the Board of Directors believes it is required for the interests of the

Shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund
concerned has occurred which would justify it, the Board of Directors may decide to divide any Sub-Fund. In the case of
division of Sub-Funds, the existing Shareholders of the respective Sub-Funds have the right to require, within thirty days
of notification and enforcement of such event, the redemption by the Company of their Shares without redemption costs.

Any request for subscription, redemption and conversion shall be suspended as from the moment of the announcement

of the division of the relevant Sub-Fund.

Art. 37. Amalgamation of Classes. In the event that for any reason the value of the assets in any Class has decreased

to an amount determined by the Board of Directors (in the interests of Shareholders) to be the minimum level for such
Class to be operated in an economically efficient manner or for any reason determined by the Board of Directors and
disclosed in the sales documents of the Company, the Board of Directors may decide to allocate the assets of any Class
to those of another existing Class within the Company and to redesignate the Shares of the Class or Classes concerned
as Shares of another Class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding
to any fractional entitlement to Shareholders).The Company shall send a written notice to the Shareholders of the relevant
Class informing them of such amalgamation.

8. Final provisions

Art. 38. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with a bank (hereinafter referred to as the

“Depositary”) which shall satisfy the requirements of the Law. All assets of the Company are to be held by or to the
order of the Depositary who shall assume towards the Company and its Shareholders the responsibilities provided by
law.

In the event of the Depositary desiring to retire the Board of Directors shall use its best endeavors to find another

bank to be Depositary in place of the retiring Depositary and the Board of Directors shall appoint such bank as Depositary.
The Board of Directors may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless
and until a successor Depositary shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.

Art. 39. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to

time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the Luxembourg
law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time. For the avoidance of doubt, such
quorum and majority requirements shall be as follows: fifty percent of the Shares issued must be present or represented
at the general meeting and a super-majority of two thirds of the validly cast votes is required to adopt a resolution. In
the event that the quorum is not reached, the general meeting of Shareholders must be adjourned and re-convened.
There is no quorum requirement for the second meeting but the majority requirement remains unchanged.

Art. 40. General provisions. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies and
the Law.”

<i>Ninth resolution:

The general meeting approves the transfer of the registered office of the Company from L-2449 Luxembourg, 16,

boulevard Royal to L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare as decided by resolution of the board of directors of
the Company on 15 July 2013.

42122

L

U X E M B O U R G

<i>Tenth resolution:

The general meeting resolves to withdraw the French translation of the Articles of Incorporation as permitted by the

2010 Law.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, at the date named

at the beginning of this document.

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.
Signé: N. BIGUMA, B. POUJOL, K. NARDINI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2014. LAC / 2014 / 4775. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021645/1037.
(140025662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Mdor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 132.569.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft MDOR S.A., mit Sitz in L-9706 Clervaux, 2A, route d’Eselborn, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer B 132569, gegründet durch Urkunde des Notars Martine Scheaffer, mit Amtssitz zu
Luxemburg, vom 3. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2600 vom 14. November 2007.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Thierry Bichel, Gesellschaftsleiter, mit beruflicher Anschrift in L-5365 Muns-

bach, 2 rue Gabriel Lippmann,

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Jean-Pierre Dias, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Thierry Bichel, vorbenannt.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf

einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.

Etwaige Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem ins-

trumentierenden Notar “ne varietur“ unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Entscheidung den Sitz nach L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss zu verlegen und dementsprechend Abän-

derung von Artikel 1, Absatz 2.

2.- Abberufung von Herr Joseph Delree als Kommissar der Gesellschaft.
3.- Ernennung von FOP CONSEIL &amp; EXPERTISE S. A. als neuen Kommissar.
4.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9706 Clervaux, 2A, route d’Eselborn nach L-9990

Weiswampach, 19, Duarrefstrooss zu verlegen und dementsprechend Artikel 1, Absatz 2 der Satzung abzuändern wie
folgt:

Art. 1. (Absatz 2). „Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herr Joseph Delree als Kommissar der Gesellschaft abzuberufen.

42123

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft FOP CONSEIL &amp; EXPERTISE S. A., mit Sitz in L-9990 Weis-

wampach, 19, Duarrefstrooss, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 176877, für
eine Dauer von 6 Jahren, zu ernennen.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf EINTAUSEN EURO

(EUR 1.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Thierry Bichel, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 janvier 2014. LAC / 2014 / 4296. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. Februar 2014.

Référence de publication: 2014021635/60.
(140025637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Mavico Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 39.946.

L'an deux mille treize, le dix décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MAVICO HOLDING S.A.», ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 39946, constituée suivant acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 20 mars 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémo-
rial») numéro 387 de l'année 1992, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les NEUF MILLE (9.000) actions représentant l'intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article un, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

42124

L

U X E M B O U R G

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAVICO HOLDING S.A.».
2. Modification de l'article deux in fine des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences et autres droits dérivant de ces brevets ou

pouvant  les  compléter,  participer  à  la  constitution,  au  développement,  à  la  transformation  et  au  contrôle  de  toutes
sociétés.»

3.- Modification de l'article quatre des statuts afin d'insérer les dispositions légales sur l'administrateur unique;
4.- Modification de l'article cinq des statuts afin d'insérer les dispositions légales sur l'administrateur unique;
5.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du deuxième vendredi du mois de mai à 10 heures au

deuxième mardi du mois d'avril à 14.00 heures et modification de l'article huit.

6.- modification de l'article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que toutes ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  à  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article un des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAVICO HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article deux in fine des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences et autres droits dérivant de ces brevets ou

pouvant  les  compléter,  participer  à  la  constitution,  au  développement,  à  la  transformation  et  au  contrôle  de  toutes
sociétés.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au

42125

L

U X E M B O U R G

conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

<i>Cinquième Résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du deuxième vendredi du

mois de mai à dix heures au deuxième mardi du mois d'avril à quatorze heures.

L'assemblée décide dès lors de modifier l'article huit des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois d'avril à quatorze heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article onze des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: K. ROTI, R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58653. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014021632/115.
(140025539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP, Société à responsabilité limitée,

(anc. Morgan Stanley Infrastructure Partners II-B GP).

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 179.084.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of February,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE II GP L.P., incorporated under the laws of Cayman Islands, registered at

the offices of c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands under number MC-71647, acting through its general partner MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE II INC.,
incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company
(DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, United States, registered under number
5346814,

duly represented by Grégory Beltrame, avocat à la cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The appearing party is the sole shareholder of MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE PARTNERS II-B GP, a Lu-

xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 64, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) under number B179084, having a share capital of USD 20,000.- and incorporated pursuant
to a notarial deed of Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in
replacement of the undersigned notary dated 19 July 2013, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations) of 17 September 2013, number 2279 (the "Company").

42126

L

U X E M B O U R G

The appearing party requested the notary to state the following:
I. That the agenda of the meeting is as follows:
1) Change of denomination of the Company from “Morgan Stanley Infrastructure Partners II-B GP” into “Morgan

Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP“ and subsequent amendment of article 1 of the Company’s articles of
association which shall henceforth read as follows:

“The name of the company is Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and
these articles of association (the Articles).”

2) Change of the corporate object of the Company and subsequent amendment of article 3.1 of the Company’s articles

of association which shall henceforth read as follows:

“The purpose of the Company is to act as managing general partner (associé gérant commandité) of Morgan Stanley

Infrastructure Partners II Investors C, a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale) (the
Partnership). The Company shall have the power, to the fullest extent permitted by the 1915 Law, to manage and conduct
the activities of the Partnership in accordance with the limited partnership agreement governing the Partnership.”

3) Miscellaneous.
II. That the represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing party will also remain annexed to

the present deed.

Then the sole shareholder takes the following resolutions and requested the undersigned notary to record as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company resolves to change the denomination of the Company from “Morgan Stanley

Infrastructure Partners II-B GP” into “Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP“ and to subsequently
modify article 1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“The name of the company is Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and
these articles of association (the Articles).”

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to change the corporate object of the Company in order to reflect

the change of denomination of Morgan Stanley Infrastructure Partners II-B which has been denominated into Morgan
Stanley Infrastructure Partners II Investors C and to subsequently modify article 3.1 of the articles of association of the
Company, which shall henceforth read as follows: “The purpose of the Company is to act as managing general partner
(associé gérant commandité) of Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C, a Luxembourg special limited
partnership (société en commandite spéciale) (the Partnership). The Company shall have the power, to the fullest extent
permitted by the 1915 Law, to manage and conduct the activities of the Partnership in accordance with the limited
partnership agreement governing the Partnership.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the Extraordinary General Meeting, have been estimated at about one thousand euro
(EUR 1,000.-).

There being no further business, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states that on the request of the proxyholder of the

represented shareholder, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between
the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day specified at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, the proxyholder of the represented shareholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le trois février,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

42127

L

U X E M B O U R G

MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE II GP LP, un limited partnership constitué conformément aux lois des îles

Caïmans, ayant son siège social dans les locaux de c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, îles Caïmans, sous le numéro MC-71647, représentée par son general partner, MORGAN
STANLEY INFRASTRUCTURE II INC., une société constituée conformément aux lois de l’État du Delaware, ayant son
siège social à c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington
DE 19801, États-Unis d’Amérique, enregistrée sous le numéro 5346814,

dûment représenté par Maître Grégory Beltrame, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé. Ladite partie comparante agit en sa qualité d’associé unique de MORGAN STANLEY
INFRASTRUCTURE PARTNERS II-B GP, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 64, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179.084, et dont le capital social s’élève à USD 20.000,-, constituée
conformément à un acte notarié de Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, agissant en remplacement du notaire soussigné, daté du 19 juillet 2013 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2279 du 17 septembre 2013 (la «Société»).

La partie comparante demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la Société de "Morgan Stanley Infrastructure Partners II-B GP" en "Morgan

Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP" et modification en conséquence de l'article 1 des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:

«Le nom de la société est Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), ainsi que les présents statuts (les Statuts).»

2) Modification de l'objet social de la Société et modification en conséquence de l'article 3.1 des statuts de la Société,

lequel sera désormais rédigé comme suit:

«L’objectif de la Société est d’agir en tant qu’associé gérant commandité de la société Morgan Stanley Infrastructure

Partners II Investors C, une société en commandite spéciale luxembourgeoise (la SCSp). La Société aura le pouvoir, dans
toute la mesure de ce qui est permis par la Loi de 1915, de gérer et de diriger les activités de la Société conformément
à la convention gouvernant la SCSp.»

3) Divers.
II. Que l’associé unique représenté, le mandataire de l’associé représenté et le nombre de ses parts sociales sont

indiqués sur une liste de présence; que cette liste de présence, signée par le mandataire de l’associé représenté et par le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

III. La procuration de l’associé représenté, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante, restera également

annexée au présent acte. L’associé unique adopte ensuite les résolutions suivantes et demande au notaire soussigné d’acter
ce qui suit:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société décide de changer la dénomination de la Société de "Morgan Stanley Infrastructure

Partners II-B GP" en "Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP" de modifier en conséquence l’article 1
des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Le nom de la société est Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), ainsi que les présents statuts (les Statuts).»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique de la Société décide de changer l'objet social de la Société afin de refléter le changement de déno-

mination  de  Morgan  Stanley  Infrastructure  Partners  II-B,  qui  portera  désormais  la  dénomination  «Morgan  Stanley
Infrastructure Partners II Investors C», et de modifier en conséquence l’article 3.1 des statuts de la Société, lequel aura
désormais la teneur suivante:

«L’objectif de la Société est d’agir en tant qu’associé gérant commandité de la société Morgan Stanley Infrastructure

Partners II Investors C, une société en commandite spéciale luxembourgeoise (la SCSp). La Société aura le pouvoir, dans
toute la mesure de ce qui est permis par la Loi de 1915, de gérer et de diriger les activités de la Société conformément
à la convention gouvernant la SCSp.»

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge dans le cadre de la présente assemblée générale extraordinaire, s’élève à environ mille Euros.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

42128

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande du mandataire et de l’associé représenté,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état

civil et demeure, le mandataire de l’associé représenté a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. BELTRAME, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 5 février 2014. Relation: LAC/2014/5625. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014021624/147.
(140025997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

ML Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 184.253.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le vingt janvier.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Marc LAMBOT, employé de banque, né à Messancy (Belgique), le 2 mai 1967, demeurant à L-8011 Strassen,

289b, route d'Arlon.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont il a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ML Consult S.à

r.l.».

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par décision du ou des associés pris

aux conditions requises pour la modification des statuts.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services administratifs, commerciaux et de gestion adressés aux pro-

fessionnels et aux particuliers.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières

qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social ou susceptible d'en favoriser le
développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), divisé en cent vingt quatre (124) parts

sociales de cent euros (100,-EUR) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par l'associé unique, Monsieur Marc LAMBOT,

préqualifié, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 €) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant moyennant certificat bancaire.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. L'associé unique est libre de céder ses parts.
En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

42129

L

U X E M B O U R G

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés autres que le conjoint survivant

et les descendants, que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale des autres associés représentant au moins
les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée

générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Les décisions de l'associé unique

prises dans ce domaine sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès verbal

ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui

lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-

mément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 980,-EUR.

<i>Décisions de l'Associé Unique

Les statuts de la société ainsi été arrêtés, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, se réunissant en

lieu et place de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-2449 Luxembourg, 26a, Boulevard Royal.

42130

L

U X E M B O U R G

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Marc LAMBOT, préqualifié.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Hesperange en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Lambot, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 janvier 2014. Relation: LAC/2014/3318. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014021639/104.
(140025403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Coripha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 184.257.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le seizième jour du mois de janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon, 65, rue de Freylange (Belgique),
ici représenté par Mademoiselle Morgane HIM, employée privée, demeurant professionnellement à L-2430 Luxem-

bourg, 18-20, rue Michel Rodange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 23 octobre 2013,
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital

Art. 1 

er

 .  La société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg

(et en particulier, la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi de 1915”) et par la loi du 25 août
2006) et par les présents statuts (les “Statuts”).

La société (ci-après la “Société”) adopte la dénomination de: “CORIPHA S.A.”

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution

de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses
actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

Le conseil d'administration de la Société (le “Conseil d'Administration”) est autorisé à changer l'adresse de la Société

à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert conservera la
nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'administration.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour principal objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La Société a aussi pour objet la détention, l'exploitation, la mise en valeur, la vente ou la location d'immeubles, de

terrains et autres, situés au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'à toutes les opérations financières, mobilières et im-
mobilières y rattachées directement ou indirectement.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de

placement, les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

42131

L

U X E M B O U R G

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, d'avances, de garanties ou autrement.

La Société pourra également prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnais-

sances de dettes.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement
ou indirectement, en tout ou partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.002,- (trente et un mille deux Euros), représenté par 6 (six) actions de EUR

5.167,- (cinq mille cent soixante-sept Euros) chacune.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à la libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ou des ac-

tionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un adminis-
trateur (l'“Administrateur Unique”) jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi
de 1915.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un Président. Le premier Président peut être nommé par

la première assemblée générale des Actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Adminis-
trateur élu à cette fin parmi les membres présents.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Admi-

nistrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 8. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par le conseil

d'administration agissant par son Président ou un administrateur - délégué.

Art. 11. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 12. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

42132

L

U X E M B O U R G

Art. 13. La Société se trouve engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur

Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs. Dans le cas où un
administrateur délégué serait nommé, la Société se trouverait engagée par la signature conjointe de deux administrateurs
dont obligatoirement la signature de l'administrateur délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 14. La société anonyme peut avoir un actionnaire unique lors de la constitution ainsi que par la réunion de toutes

ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la Société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale est également autorisée à octroyer des tantièmes à ses administrateurs.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle de ou des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 1 

er

 jeudi du mois d'avril, à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ou des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit
de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 19. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine 31 décembre 2014.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les six (6) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, Monsieur

Pierre-Paul BOEGEN, pré-qualifié et représenté comme dit ci-avant, et intégralement libérées par le souscripteur prédit
moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.002,- (trente et un mille deux Euros) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.

<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

42133

L

U X E M B O U R G

2) Comme autorisé par la Loi de 1915 et les Statuts, Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, administrateur de sociétés, né

à Arlon (Belgique), le 20 octobre 1948, demeurant à B-6700 Arlon, 65, rue de Freylange (Belgique), est appelé à la fonction
d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3) La société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “EP INTERNATIONAL

S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 130232, est nommée commissaire de la Société, est appelée
à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle

de l'année 2019.

5) Le siège social de la Société sera établi à L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. HIM, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 janvier 2014. LAC/2014/2974. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014021415/166.
(140025413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Skyline Residences S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 183.645.

RECTIFICATION

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), déclare

par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par son ministère, en date du 17 décembre 2013, enregistré à
Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2013, relation: LAC/2013/58626, déposé au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014, référence L140013408, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, pour compte de la société à responsabilité limitée "Skyline Residences S.à r.l.", établie et ayant
son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 183645,

il y a lieu de procéder, suite à mauvaise manipulation informatique, de rectifier et ceci avec effet à la date de la prédite

constitution, (i.e.: 17 décembre 2013), la première résolution prise par l'associé unique consécutivement à la constitution
et portant sur la nomination du conseil de gérance.

IL Y A LIEU DE LIRE:

Version anglaise:

<i>First resolution

The following persons are appointed as managers for an undetermined period:
Mr. Arnold uit de BOS, businessman, born on 25 March 1969 in Landsmeer (Netherlands), residing professionally in

Bohdana Khmelnytskogo Street 19-21a, 4 

th

 floor office 22, 01030 Kiev, Ukraine.

Mr. Fabrice GEIMER, employee, born on 23 January 1978 in Arlon (Belgium), residing professionally at 5, avenue Gaston

Diderich, L - 1420 Luxembourg.

Mr. Roberto CHIAPPALONE, employee, born on 15 May 1978 in Metz (France), residing professionally at 5, avenue

Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg.

The Company is validly bound by the joint signature of all of the managers.

Version française:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Arnold uit de BOS, homme d'affaires, né le 25 mars 1969 à Landsmeer (Pays-Bas), demeurant profession-

nellement à Bohdana Khmelnytskogo Street 19-21a, 4 

th

 floor office 22, 01030 Kiev, Ukraine.

Monsieur Fabrice GEIMER, employé, né le 23 janvier 1978 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 5,

avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

42134

L

U X E M B O U R G

Monsieur Roberto CHIAPPALONE, employé, né le 15 mai 1978 à Metz (France), demeurant professionnellement au

5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de tous les gérants.
AU LIEU DE:

Version anglaise:

<i>First resolution

The following persons are appointed as managers for an undetermined period:
Mr. Arnold uit de BOS, businessman, born on 25 March 1969 in Landsmeer (Netherlands), residing professionally in

Bohdana Khmelnytskogo Street 19-21a, 4 

th

 floor office 22, 01030 Kiev, Ukraine.

Mr. Sinan SAR, employee, born on 5 June 1980 in Luxembourg, residing professionally at 5, avenue Gaston Diderich,

L - 1420 Luxembourg.

Mrs. Valérie FISSON, employee, born on 11 November 1975 in Aye (Belgium), residing professionally at 5, avenue

Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg.

The Company is validly bound by the joint signature of all of the managers.

Version française/

<i>Première résolution

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Arnold uit de BOS, homme d'affaires, né le 25 mars 1969 à Landsmeer (Pays-Bas), demeurant profession-

nellement à Bohdana Khmelnytskogo Street 19-21a, 4 

th

 floor office 22, 01030 Kiev, Ukraine.

Monsieur Sinan SAR, employé, né à Luxembourg, le 5 juin 1980, demeurant professionnellement au 5, avenue Gaston

Diderich L-1420 Luxembourg.

Madame Valérie FISSON, employée, né à Aye (Belgium), le 11 novembre 1975, demeurant professionnellement au 5,

avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de tous les gérants.
Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 février 2014. Relation: LAC/2014/5380. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Carole FRISING.

Luxembourg, le 29 janvier 2013.

Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014021764/66.
(140025576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Tronox Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 122.339.670,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 63.591.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of November, before Maître Francis KESSELER, notary

residing in Esch-sur-Alzette,

there appeared:

Tronox (Switzerland) Holding GmbH, having its registered offices at Seefeldstrasse 45, CH-8008 Zürich, Switzerland,

registered with the Trade Registry of Zürich under no. CH-020.4.026.378-5 (the “Sole Shareholder”), duly represented
herein by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon
Bernard, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been initialed and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record that:
(i) it holds all of the 4,077,989 registered shares of a nominal value of thirty Euro (EUR 30.-) each in the issued and

paid up share capital of Tronox Luxembourg S.à r.l., a private company with limited liability according to the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg (société à responsabilité limitée), having its registered offices at 21, Allée Scheffer, L- 2520
Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg and its effective place of management and central place of administration

42135

L

U X E M B O U R G

at One Brodie Hall Drive, Bentley, Western Australia 6102, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Registry under no. B 63.591, incorporated pursuant to a notarial deed of March 2, 1998, published in the Official Gazette
of Luxembourg on June 11, 1998 no. 419, whose articles of association were last amended by notarial deed of February
1, 2011, published in the Official Gazette of Luxembourg on June 6, 2011, no. 1212 (the “Company”),

(ii)  the  Company's  share  capital  is  set  at  one  hundred  twenty-two  million  three  hundred  thirtynine  thousand  six

hundred seventy Euro (EUR 122,339,670,-), divided into four million seventy-seven thousand nine hundred eighty-nine
(4,077,989) registered shares of a nominal value of thirty Euro (EUR 30.-) each, fully paid-up;

(iii) the Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect from the date

of this notarial deed;

(iv) the Sole Shareholder hereby assumes the role of liquidator of the Company;
(v) the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has

ceased, that the known liabilities of the Company have been settled in full or fully provided for as per the interim balance
sheet of the Company as per September 30, 2013, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby
expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those
hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

(vi) as a consequence, the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
(vii) the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and is perfectly familiar

with the financial situation of the Company;

(viii) the Sole Shareholder grants full discharge to the members of the board of managers of the Company for the

exercise of their mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting; and

(ix) the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the

present meeting at the registered offices of the Company.

Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Follows the French translation of the preceding text.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour du mois de novembre, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Tronox (Switzerland) Holding GmbH, un société à responsabilité limitée Suisse, ayant son siège au Seefeldstrasse 45,

CH-8008  Zürich,  la  Suisses,  immatriculée  auprès  le  Registre  de  Commerce  (Handelsregister)  de  Zürich  sous  le  no.
CH-020.4.026.378-5 (l «Associé Unique»), ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée
privée, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, en vertu d'un pouvoir donné
sous seing privé.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
(i) la comparante détient toutes les 4,077,989 parts sociales dans le capital social de Tronox Luxembourg S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeoise ayant son siège social au 21, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg
et sa place de gestion effective et administration centrale au One Brodie Hall Drive, Bentley, Western Australia 6102,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous no. B. 63.591, constituée en vertu d'un acte notarié du 2
mars 1998, publié au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C du 11 juin, 1998 no. 419, dont les statuts ont été
modifiés la dernière fois par acte du 1 

er

 février 2011, publié au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, du 6

juin, 2011, no. 1212 (la «Société»);

(ii) Le capital social de la Société est actuellement fixé à cent vingt-deux millions trois cents trente-neuf mille six cents

soixante-dix euro (EUR 122,339,670,-) représenté par 4,077,989 parts sociales ordinaires avec une valeur nominale de
trente euro (EUR 30,-) chacune, intégralement libérées;

(iii) par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
(iv) par la présente, l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
(v) l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné selon le bilan intérimaire de la Société en date du 30 septembre 2013, qu'il
est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore
exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

42136

L

U X E M B O U R G

(vi) partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
(vii) l'Associé Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
(viii) l'Associé Unique donne décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société pour leur

mandat à compter de la date de leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et

(ix) les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date

de la présente assemblée au siège de la Société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16046. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014021814/95.
(140025440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Société de Financement et de Transactions Conseil, SOFITRA CONSEIL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société de Financement pour les Transports, SOFITRA S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 37.965.

L'an deux mille quatorze, le quatorze janvier.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANS-

PORTS, SOFITRA S.A.", établie et ayant son siège à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte du
notaire André SCHWACHTGEN de Luxembourg, en date du 20 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Numéro 82 du 11 mars 1992, modifiée pour la dernière fois suivant acte sous seing privé du 31
décembre 2001 publié au dit Mémorial C, Numéro 702 du 7 mai 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 37.965,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Jérôme DOMANGE, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 23, rue

Beaumont,

L'assemblée choisit comme scrutateur Jérôme DOMANGE, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg,

23, rue Beaumont,

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société;
2. Modification afférente de l’article 1 

er

 des statuts de la Société;

3. Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

42137

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de «SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES

TRANSPORTS,  SOFITRA  S.A.»  en  «SOCIETE  DE  FINANCEMENT  ET  DE  TRANSACTIONS  CONSEIL,  SOFITRA
CONSEIL S.A.».

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée choisit de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société

pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

“  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions  ci-après  créées  une  société  anonyme  luxembourgeoise,  dénommée:  SOCIETE  DE  FINANCEMENT  ET  DE
TRANSACTIONS CONSEIL, SOFITRA CONSEIL S.A."

<i>Troisième résolution

L’article 4 des statuts de la Société est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger:
- le conseil et la représentation en matière fiscale, respectivement l’ingénierie financière, fiscale et immobilière;
- l’étude et l’analyse des conditions de production, prestations de services et commercialisation des sociétés en vue

de leur amélioration;

- la définition et le management des conditions d’exercice de sociétés et établissements tiers sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immo-
bilières,  pouvant  se  rattacher  directement  ou  indirectement  à  l’objet  social  ci-dessus  ou  à  tous  objets  similaires  ou
connexes, de nature à favoriser son extension et son développement."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: BECKER, DOMANGE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 janvier 2014. Relation: LAC / 2014 / 2385. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur <i>ff . (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021793/68.
(140025720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

Axpro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.748.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales du 7 février 2014
Que Madame Joscely PEREIRA DUTRA, employée, née à Imperatriz (Brésil) le 23 mai 1975, demeurant à F-54190

Villerupt, 2, rue des Merles, cède et transporte cent (100) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société à Monsieur
Nuno Filipe GAMEIRO DOS SANTOS, né le 20-02-1974 à Ourém, et demeurant à F-54190 Villerupt, 2, rue des Merles

Que cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €
Qu'à la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:

1. Monsieur Nuno Filipe GAMEIRO DOS SANTOS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Fait à Luxembourg, le 07 février 2014.

Monsieur Nuno Filipe GAMEIRO DOS SANTOS /

Madame Joscely PEREIRA DUTRA /

Monsieur Carlos Alberto DA COSTA.

<i>Cession de parts sociales

L'an deux mille quatorze, le sept février

Ont comparu:

42138

L

U X E M B O U R G

1. Madame Joscely PEREIRA DUTRA, employée, née à Imperatriz (Brésil) le 23 mai 1975, demeurant à F-54190 Ville-

rupt, 2, rue des Merles

Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée AXPRO S.à r.l., avec siège

social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section
B numéro 147.748, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 août 2 009, publié
au Mémorial C numéro 1777 du 15 septembre 2 009, dont le capital social est de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€
125,-) chacune est réparti comme suit:

1. Madame Joscely PEREIRA DUTRA prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

2. La société a responsabilité prédite AXPRO Sàrl, représentée par ses gérants:
a. Madame Joscely PEREIRA DUTRA, prénommée, gérante administrative;
b. Monsieur Carlos Alberto DA COSTA, gérant technique, né à Casteloes (Portugal) le 17 août 1965, demeurant à

L-1327 Luxembourg, 2, rue Charles VI

3. Monsieur Nuno Filipe GAMEIRO DOS SANTOS, né le 20-02-1974 à Ourém, et demeurant à F-54190 Villerupt, 2,

me des Merles

Les comparants ont conclu les cessions des parts suivantes:
1. Madame Joscely PEREIRA DUTRA, prénommée, cède et transporte cent (100) parts sociales à Monsieur Nuno Filipe

GAMEIRO DOS SANTOS, prénommé, ce acceptant

2. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €
La société à responsabilité limitée AXPRO Sàrl, avec siège à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, représentée

comme il vient d'être dit, déclare accepter les cessions ci-avant mentionnées, conformément à l'article 190 de la loi des
sociétés commerciales et n'avoir entre les mains aucun empêchement qui puisse arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues au 3 août 2012, le capital de la société se trouve désormais réparti comme

suit:

1. Monsieur Nuno Filipe GAMEIRO DOS SANTOS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 février 2014

Ensuite l'associé unique se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions sui-

vantes:

1) La démission de Madame Joscely PEREIRA DUTRA prénommée, en tant que gérante de la société est acceptée.
2) Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminé:
Monsieur Nuno Filipe GAMEIRO DOS SANTOS, prénommé

Fait à Luxembourg, le 07 février 2014.

Monsieur Nimo-Filipe GAMEIRO DOS SANTOS /

Madame Joscely PEREIRA DUTRA /

Monsieur Carlos Alberto DA COSTA.

Référence de publication: 2014021874/58.
(140026087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

DB Valoren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.774.875.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.379.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zweiundzwanzigsten Januar,

erschien

vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit mit Amtssitz in Luxemburg,
Deutsche Bank A.G., eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Taunusanlage 12, D-60325

Frankfurt am Main, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nummer HRB 30 000
(die „Gesellschafterin“),

vertreten durch Herrn Manfred MÜLLER, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, erteilt in Frankfurt, am 9. Januar 2014.
Die Gesellschafterin, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar aufgefordert, Folgendes festzuhalten.
Die  Gesellschafterin  ist  die  Alleingesellschafterin  der  unter  dem  Namen  DB  Valoren  S.à  r.l.  und  unter  Nummer

B-111.379 in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

42139

L

U X E M B O U R G

gegründet durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 13. Oktober 2005, die im Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 4. Februar 2006 veröffentlicht worden ist, mit Gesellschaftssitz in 6, avenue
Pasteur, L-2310 Luxemburg, und einem Stammkapital von Euro eine Milliarde achthundertvierundachtzig Millionen vie-
rhundertvierundachtzig  Tausend  (EUR  1.884.484.000,-)  (die  „Gesellschaft“).  Die  Satzung  der  Gesellschaft  ist  zuletzt
abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des amtierenden Notars vom 18. Dezember 2013, die noch nicht im
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden ist.

Die Gesellschafterin erklärt, ausführlich über die Beschlüsse, welche auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen

sind, informiert zu sein:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe eines Betrages von Euro zwei Milliarden achthundertneunzig

Millionen dreihunderteinundneunzig Tausend (EUR 2.890.391.000,-), um das bestehende Kapital von Euro eine Milliarde
achthundertvierundachtzig Millionen vierhundertvierundachtzig Tausend (EUR 1.884.484.000,-), eingeteilt in sechs Mil-
lionen dreihundertsechsundsechzig Tausend fünfhundert (6.366.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert in Höhe
von jeweils Euro zweihundertsechsundneunzig (EUR 296,-) auf Euro vier Milliarden siebenhundertvierundsiebzig Millionen
achthundertfünfundsiebzig Tausend (EUR 4.774.875.000,-) zu erhöhen, und zwar mittels Erhöhung des Nennwertes eines
jeden Gesellschaftsanteils um Euro vierhundertvierundfünfzig (EUR 454,-) auf Euro siebenhundertfünfzig (EUR 750,-).

2. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft, entsprechend dem gemäß Tagesordnungspunkt

1) gefassten Beschlusses.

3. Vollmachterteilung an das Geschäftsführungsgremium zwecks Umsetzung des unter Tagesordnungspunkt 1) gefass-

ten Beschlusses.

4.  Genehmigung  der  Kapitalerhöhung  der  DB  Equity  S.à  r.l.  in  Höhe  eines  Betrages  von  Euro  zwei  Milliarden

achthundertachtunddreißig Millionen (EUR 2.838.000.000,-) mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaft-
santeils.

5. Verschiedenes.
Die Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe eines Betrages von Euro

zwei Milliarden achthundertneunzig Millionen dreihunderteinundneunzig Tausend (EUR 2.890.391.000,-), um das beste-
hende  Kapital  von  Euro  eine  Milliarde  achthundertvierundachtzig  Millionen  vierhundertvierundachtzig  Tausend  (EUR
1.884.484.000,-), eingeteilt in sechs Millionen dreihundertsechsundsechzig Tausend fünfhundert (6.366.500) Gesellschaft-
santeile mit einem Nennwert in Höhe von jeweils Euro zweihundertsechsundneunzig (EUR 296,-) auf Euro vier Milliarden
siebenhundertvierundsiebzig Millionen achthundertfünfundsiebzig Tausend (EUR 4.774.875.000,-) zu erhöhen, und zwar
mittels Erhöhung des Nennwertes eines jeden Gesellschaftsanteils um Euro vierhundertvierundfünfzig (EUR 454,-) auf
Euro siebenhundertfünfzig (EUR 750,-).

Die Gesellschafterin erklärt durch ihren ordnungsgemäß bestellten Bevollmächtigten den für die Erhöhung des Nenn-

wertes  der  Gesellschaftsanteile  erforderlichen  Gesamtbetrag  in  Höhe  von  Euro  zwei  Milliarden  achthundertneunzig
Millionen dreihunderteinundneunzig Tausend (Euro 2.890.391.000,-) durch Bareinlage einzuzahlen.

Der Nachweis dieser Einzahlung durch die Gesellschafterin zugunsten der Gesellschaft ist dem amtierenden Notar

erbracht worden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt infolge des obigen ersten Beschlusses, Artikel 5, Absatz 1, der Gesellschaftssatzung wie

folgt abzuändern:

« Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vier Milliarden siebenhundertvierundsiebzig Millio-

nen achthundertfünfundsiebzig Tausend Euro (EUR 4.774.875.000,-) und ist in sechs Millionen dreihundertsechsundsech-
zig Tausend fünfhundert (6.366.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils siebenhundertfünfzig Euro (EUR
750,-) eingeteilt, die sämtlich vollständig eingezahlt sind.»

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt, dem Geschäftsführungsgremium der Gesellschaft Vollmacht zur Umsetzung der vo-

rangehenden Beschlüsse zu erteilen. Das Geschäftsführungsgremium ist dazu ermächtigt, alle mit dieser Kapitalerhöhung
verbundenen notwendigen oder sachdienlichen Maßnahmen zu treffen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterin beschließt in Übereinstimmung mit Artikel 12, Absatz 2 (d) der Satzung der Gesellschaft, der am

Tag der vorliegenden Urkunde durchzuführenden Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft der Gesellschaft, DB Equity
S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, eingetragen in das Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter Nummer B-111.380, in Höhe eines Betrages von Euro zwei Milliarden achthundertachtund-

42140

L

U X E M B O U R G

dreiâig  Millionen  (EUR  2.838.000.000,-)  mittels  Erhöhung  des  Nennwertes  eines  jeden  Gesellschaftsanteils  um  Euro
vierhundertdreißig (EUR 430,-), sowie allen durch das Geschäftsführungsgremium im Zusammenhang mit dieser Kapita-
lerhöhung vorzunehmenden notwendigen und sachdienlichen Maßnahmen, zuzustimmen.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf sechstausend vierhundert Euro (EUR 6.400) geschätzt.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach  Verlesung  der  Urkunde  durch  den  Notar  gegenüber  den  ihm  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen  und

Wohnort bekannten Vertretern der erschienenen Gesellschafterin, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar un-
terzeichnet.

Gezeichnet: M. Müller, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 janvier 2014. Relation: LAC/2014/3374. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations erteilt.

Luxemburg, den 12. Februar 2014.

Référence de publication: 2014022640/89.
(140027280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

FRP 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 178.981.

1. Springre S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and registered

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B-148.329, the corporate capital of which is fixed at
EUR 12,500;

2. CURZON 50 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and registered

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of Commerce and Companies under number B-173.695, the
corporate capital of which is fixed at EUR 14,664;

3. Sagace S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and registered under

the laws of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B-157 832;

4. GREENWOOD rC Limited, a private limited liability company, incorporated under the laws of Gibraltar, having its

registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar registered with the Gibraltar Companies' Register under number
107820;

Pursuant to a sale and purchase agreement dated 10 February 2014, the issued shares of FRP 12 S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and registered under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg register of Commerce and Companies under number B-178.981 (the "Company"), have been transfered as
follows:

1. CURZON 50 S.à r.l. transferred twenty-eight thousand (28,000) Class B shares to Springre S.à r.l.
2. Sagace S.à r.l. transferred thirty-six thousand (36,000) Class A shares to Springre S.à r.l.
3. GREENWOOD rC Limited transferred eight thousand (8,000) Class C shares to Springre S.à r.l.
Consequently, the new shareholding is composed as follows:
1. Springre S.à r.l. holds seventy-two thousand (72,000) shares split as follows: thirty-six thousand (36,000) Class A

shares, twenty-eight thousand (28,000) Class B shares and eight thousand (8,000) Class C shares.

2. CURZON 50 S.à r.l. holds eight thousand (8,000) Class B shares of the Company.

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

1. Springre S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B numéro 148.329;

42141

L

U X E M B O U R G

2. CURZON 50 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B numéro 173.695, dont le capital social est fixé à EUR 14,664;

3. Sagace S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous le droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro, B-157 832;

4. GREENWOOD rC Limited, une société à responsabilité limitée, constituée et régie sous le droit de Gibraltar, ayant

son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Gibraltar
sous le numéro 107820;

Conformément à un contrat de cession de parts sociales conclu en date du 10 février 2014, les parts sociales émises

de la Société, ont été transférées comme suit:

1. CURZON 50 S.à r.l. a transféré vingt-huit mille (28.000) parts sociales de Classe B à Springre S.à r.l.
2. Sagace S.à r.l. a transféré trente-six mille (36.000) parts sociales de Classe A à Springre S.à r.l.
3. GREENWOOD rC Limited a transféré huit mille (8.000) parts sociales de Classe C à Springre S.à r.l.
Par conséquent, le nouvel actionnariat est composé comme suit:
1. Springre S.à r.l. détient soixante-douze mille (72.000) parts sociales de la Société divisé comme suit: trente-six mille

(36.000) parts sociales de Classe A, vingt-huit mille (28.000) parts sociales de Classe B et huit mille (8.000) parts sociales
de Classe C.

2. CURZON 50 S.à r.l. détient huit mille (8.000) parts sociales de Classe B de la Société.
Référence de publication: 2014022731/57.
(140027477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Herres Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 142.435.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den dreißigsten Tag im Monat Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1° Herr Heinz HERRES, Steuerberater, Wirtschaftsmediator, geboren in Trier am 22. April 1962, wohnhaft in D-54317

Osburg, Zum Kirschbäumchen 13;

2° Herr Andreas FALK, Finanzwirt, geboren in Trier am 11. Januar 1985, wohnhaft in D- 54293 Trier, Schillerstr. 9;
Der vorgenannte Erschienene unter 1° erklärt, dass er der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung Herres Consult S.à r.l. ist, die ihren Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig hat, eingetragen im Han-
delsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 142.435, gegründet durch Urkunde des unterzeichnenden
Notars am 6.Oktober 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2678 vom 3. November 2008.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichnenden Notar, folgende Anteilsübertragung zu beurkunden:
Herr Heinz HERRES, vorgenannt unter 1°, überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens seine sieben (7) Anteile, die

er in der Gesellschaft Herres Consult S.à r.l. besitzt, an den unter 2° vorgenannten Herrn Andreas FALK, welcher hier
anwesend ist und dies annimmt, zum dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, ausserhalb der Buchführung des
unterzeichnenden Notars.

Herr Heinz HERRES, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft Herres Consult

S.à r.l., nimmt die vorgenannte Anteilsübertragung im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches, an.

Im Anschluss an vorangehende Anteilsübertragung erklärt der Gesellschafter, dass alle einhundertfünfundzwanzig (125)

Anteile der Gesellschaft wie folgt gehalten werden:

1° Herr Heinz HERRES, vorbenannt, einhundertachtzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2° Herr Andreas FALK, vorbenannt, sieben Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

TOTAL: EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Im Anschluss an vorangehende Anteilsübertragungen haben die vorgenannten Gesellschafter der Gesellschaft sich zu

einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgenden Beschluss gefasst:

<i>Erster Beschluss

Infolge der vorangehenden Anteilsübertragungen erklären die Gesellschafter, Artikel 6 der Satzungen abzuändern wie

folgt:

„ Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in

einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR) eingeteilt.“

42142

L

U X E M B O U R G

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Umänderung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf etwa eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Heinz Herres, Andreas Falk, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 février 2014. LAC / 2014/ 5498. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 8. Februar 2014.

Référence de publication: 2014022752/51.
(140027247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

Cultiver l'Etre A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2446 Howald, 16, Ceinture des Rosiers.

R.C.S. Luxembourg F 1.847.

Art. 3. L'association a pour objet ... tels que définis dans les présents statuts.
A ajouter:
L'association n'appartient à aucun mouvement politique et n'adhère à aucune tendance religieuse. Tous les sujets traités

lors des évènements organisés par l'association n'engagent que la responsabilité des intervenants.

Art. 9. L'association est gérée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de cinq au plus, nommés

parmi les associés par l'assemblée générale: Le conseil d'administration ..... sont rééligibles.

A changer:
L'association est gérée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de sept au plus, élus parmi les

adhérents à l'assemblée générale. Le conseil d'administration se renouvelle tous les ans; ses membres sont rééligibles.

Art. 12. Les membres du conseil d'administration désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
A remplacer:
Les membres du conseil d'administration désignent entre eux un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) tré-

sorier(e) et deux secrétaires ou plus. Chaque membre peut cumuler deux fonctions.

Art. 17. L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles des membres. La cotisation est fixée à cinq

cents francs (frs 500,-) par membre par exercice.

A remplacer:
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles des membres. La cotisation est fixée à quinze EURO

(15,- EURO) minimum par membre par exercice.

Paola CASTELLANI / Marie LEONARD
<i>La Présidente / La Trésorière

Référence de publication: 2014024365/27.
(140028539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

Legal Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 95.415.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement n°197/14 rendu en date du 6 février 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg VI 

ème

Chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport le liquidateur et le
Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de la procédure de liquidation
n°L-8067/12 de la société à responsabilité limitée LEGAL CAPITAL S.àr.l., dont le siège social à L-1233 Luxembourg, 13,

42143

L

U X E M B O U R G

rue Jean Bertholet, a été dénoncé en date du 16 février 2007, au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 95415.

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Maître Julien BOECKLER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014024133/18.
(140029216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Köhl Maschinenbau A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 21, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 139.482.

Die neue Adresse von:
Frau Köhl Edith
Amtsausführung: Verwaltungsratsmitglied + Vorsitzender
ist
15, Um Kecker, L-5489 Ehnen

Wecker, den 03.02.2014.

KÖHL MASCHINENBAU AG
Edith Köhl

Référence de publication: 2014024112/15.
(140029059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Leumi Global Managers Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.896.

Suite à la résolution en date du 24 juin 2013, les associés de la société ont décidé d’élire Madame Orit Crystal, ayant

son adresse professionnelle 35 Yehuda Halevy Street, 65136, Tel Aviv, Israël, comme administrateur de la société pour
une durée déterminée, avec effet au 24 juin 2013 jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2014.

Monsieur Eli Sellman a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 24 juin 2013.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2014024136/14.
(140029170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Paradis Night Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 61, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 75.936.

Suite à diverses cessions de parts sociales intervenues en date du 03 février 2014, les parts sociales de la société

PARADIS NIGHT sont actuellement réparties comme suit:

- Mme Marina-Daniela RADUCANU, demeurant à L-2230 Luxembourg, 61 Rue du Fort Neipperg: 112 parts sociales
- Monsieur Eugène DELEU, demeurant à F-57190 Terville 4 Avenue des Sapins: 12 parts sociales

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014024216/14.
(140028589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

42144


Document Outline

Axpro S.à r.l.

BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l.

Coripha S.A.

Cultiver l'Etre A.s.b.l.

DB Valoren S.à r.l.

FRP 12 S.à r.l.

Genid S.à r.l.

GPE VII FIS S.C.A.

Herres Consult S.à r.l.

Köhl Maschinenbau A.G.

Legal Capital S.à r.l.

Leumi Global Managers Fund

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF

Markanne S.A.

Mavico Holding S.A.

Mdor S.A.

ML Consult S.à r.l.

Morgan Stanley Infrastructure Partners II-B GP

Morgan Stanley Infrastructure Partners II Investors C GP

Multi Units Luxembourg

New Friends S.A.

Paradis Night Sàrl

Silam S.A.

Skyline Residences S.à r.l.

Snow S.à r.l.

Société de Financement et de Transactions Conseil, SOFITRA CONSEIL S.A.

Société de Financement pour les Transports, SOFITRA S.A.

Sofichar Spf S.A.

Sol Holding S.à r.l.

Sorbholding S.A.

Sorti S.A.

SR Diffusion S.à r.l.

Stadtparkturm ProCo S.à r.l.

Steel Center S.A.

Stinvest

Stock Port International S.A.

Summum Spf S.A.

T &amp; Brothers S.A.

TI Design S.A.

Timelux S.à r.l.

Trahern Capital S.à r.l.

Tronox Luxembourg S.à r.l.

Tuscany Rig Leasing S.A.

Verdaine SA

Vicanne S.à r.l.

World Software Services S.A.

WPW GEO.LUX S.à r.l.