This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 604
7 mars 2014
SOMMAIRE
Acertis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28990
Actor Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28989
ADN Consultants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28990
Agence Générale d'Assurances Schon
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
A H Luxco 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28989
A.I.E. Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28984
Air Filters Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28990
Airtrust Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28990
Airtrust Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28988
Ak Bars Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
28985
Alinea Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28989
Alliages SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28991
A.L.P. Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28989
Altrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28991
Amalthee Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
28968
Amalthee Participations S.à r.l. . . . . . . . . .
28968
Amber Shipping International S.A. . . . . . .
28991
Aria Structured Investments S.à r.l. . . . . .
28991
Automotive Parts International Sàrl . . . . .
28989
Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
28990
Baltic Professional Investment S.A. . . . . . .
28979
Bluebill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28978
Bluebill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28979
BMF Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
28978
Chaves Café S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
Cherry S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
Cirio Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
28992
Clio Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28957
Grey Hills Management . . . . . . . . . . . . . . . . .
28946
Grey Hills Management . . . . . . . . . . . . . . . . .
28957
GSO Coastline Credit (Luxembourg) Part-
ners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28972
integratedPlace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28984
Kailash Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
28971
Katoen Natie Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
28972
Quality and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
Scorpio International AG . . . . . . . . . . . . . . .
28964
Twist Beauty S.à r.l. & Partners S.C.A. . . .
28985
28945
L
U X E M B O U R G
Grey Hills Management, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 183.284.
STATUTES
<i>Deed of Incorporation of Grey Hills Management, a cooperative company organised as a public limited liability companyi>
THE PRESENT DEED OF INCORPORATION (the "Deed") is passed on 5 December 2013.
Vorndran Beteiligungs-GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung, incorporated and existing under the laws of
Germany, with registered office at Am Moritzberg 4, 97228 Rottendorf, Germany ("VB") and
Mannheims Beteiligungs GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung, incorporated and existing under the laws of
Germany, with registered office at Tölzer Straße 12, 82031 Grünwald, Germany ("MB")
wish to incorporate a cooperative company organised as a public limited liability company (société coopérative orga-
nisée comme une société anonyme) which they hereby declares organised with the following articles of association:
A. Name - Form
Art. 1. Name. There exists a cooperative company organised as a public limited liability company (société coopérative
organisée comme une société anonyme) under the name Grey Hills Management (hereinafter the "Company"), which
shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as
by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity and act as director or manager in entities in which it holds a participation or in which
companies belonging to the same group of companies as the Company directly or indirectly hold a participation.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of directors.
B. Share Capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at a minimum of one thousand euro (EUR 1,000), represented by one hundred
thousand (100,000) shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
5.2 Any shares issued and to be issued shall be paid up in cash by the shareholder(s).
5.3 At the Company's incorporation, thirty-three thousand eight hundred seventy (33,870) shares have been subscribed
by MB and sixty-six thousand one hundred thirty (66,130) shares have been subscribed by VB for a price of five cents
(EUR 0.05) per share.
28946
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Shares.
6.1 The Company may have one or several shareholders. The Company's share capital is divided into shares, each of
them having the same nominal value. The shares of the Company are in registered form.
6.2 Shares may neither be transferred nor pledged or assigned except between shareholders. They may, however, be
redeemed by the Company in accordance with Article 9. Redemption proceeds may be pledged.
6.3 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law.
7.2 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
Art. 8. Admission and issuance of shares.
8.1 The board of directors of the Company is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid
up shares at any time.
8.2 Subscription requests for shares shall be addressed to the board of directors of the Company which may accept
or reject them in its absolute discretion.
8.3 The numbers and the price of shares to be issued in the event of a subscription will be determined by the board
of directors of the Company considering the value of the shares to be issued.
8.4 Each new share subscribed may be subject to an issuance fee or a premium, determined at the sole discretion of
the board of directors of the Company.
Art. 9. Resignation, exclusion, death and redemption of shares.
9.1 Shareholders cease to be shareholder of the Company through resignation, exclusion or death. In any such case,
the Company will redeem their shares. Redeemed shares will be automatically cancelled and the share capital will be
reduced accordingly within the limit of the share capital set forth in Article 5 above.
9.2 A shareholder may resign from the Company at any time in accordance with the Law by addressing a notice in
writing to the board of directors. The board of directors shall accept any resignation received, subject to (i) the Company
having sufficient and immediately available funds to pay the redemption price for the shares redeemed to the shareholders,
(ii) the resignation not causing the insolvency of the Company, and (in) the resignation not entailing a redemption of the
shares of the last or only shareholder of the Company or a reduction of the share capital below the minimum set in article
5 hereof.
9.3 Moreover, any shareholder may be excluded for any severe misconduct to be assessed by the board of directors
of the Company. The exclusion is decided by the board of directors. The board will draw up minutes relating to any such
decision and an excluded shareholder shall receive a copy of such minutes.
9.4 The redemption price per share shall be equal to the nominal value of the shares redeemed and shall be paid within
a period determined by the board of directors of the Company, which shall not exceed fourteen (14) days since the
receipt of the resignation request/decision of redemption, provided that the share certificates, if any, have been received
by the Company.
Art. 10. Liability of the shareholders. The shareholders shall only be liable for payment to the Company of the nominal
value and, as the case be, of the issuance premium of each subscribed share. In particular, shareholders shall not be liable
for the debts, liabilities and/or obligations of the Company or of any other shareholder.
C. General meetings of shareholders
Art. 11. Powers of the general meeting of shareholders.
11.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.
11.2 If the Company has only one (1) shareholder, any reference made herein to the "general meeting of shareholders"
shall be construed as a reference to the "sole shareholder", depending on the context and as applicable and powers
conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 12. Convening of general meetings of shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or,
as the case may be, by the internal auditor(s).
28947
L
U X E M B O U R G
12.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one (1) or
several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general
meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.
12.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this
formality has been complied with needs to be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices
may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8)
days before the date scheduled for the meeting.
12.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 13. Conduct of general meetings of shareholders.
13.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 31 May at 12:00
o'clock (noon). If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening
notices.
13.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. If all the share-
holders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may
unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the
board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board of the meeting"
shall in such case be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be to the "single person
who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially
ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in
relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.
13.3 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
13.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
13.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on
a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present
for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place
of the meeting.
13.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each
proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed
resolution by ticking the appropriate box.
13.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into
account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.
13.8 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 14. Quorum and vote.
14.1 Each share entitled to one (1) vote in general meetings of shareholders.
14.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 15. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association
may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless
of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions
28948
L
U X E M B O U R G
and nil votes shall not be taken into account. The shareholders may change the nationality of the Company only by
unanimous consent.
Art. 16. Minutes of general meetings of shareholders.
16.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
16.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any
two of its members.
D. Management
Art. 17. Composition and powers of the board of directors.
17.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where
the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the
shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the
next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent
applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to
the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".
17.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 18. Daily management.
18.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one (1) or more directors, officers or other
agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the
board of directors.
18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 19. Appointment, removal and term of office of directors.
19.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor
is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.
19.3 Each director is appointed by a simple majority the shares present or represented in a general meeting. Any
director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple
majority the shares present or represented.
Art. 20. Convening and conduct of meetings of the board of directors.
20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors
shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. No prior notice
shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a board meeting and
waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board
of directors.
20.2 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not
need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.
20.3 The board of directors may decide upon further internal rules of conduct and convening.
Art. 21. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
21.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore, Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by the chairman.
21.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director, Copies or
excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.
Art. 22. Dealing with third parties.
22.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director,
or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two of the directors or by (ii) the joint signatures
or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within
the limits of such delegation.
28949
L
U X E M B O U R G
22.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 23. Auditor(s).
23.1 The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several internal auditors (commissaire(s)). The
general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may
not exceed six (6) years.
23.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
23.3 The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
23.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one (1) or more independent auditor(s) (réviseur
(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and com-
panies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor
(s) is suppressed.
23.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 24. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 25. Annual accounts and allocation of profits.
25.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
25.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
25.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve
may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
25.4 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
25.5 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 26. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
26.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
26.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 27. Liquidation.
27.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
27.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 28. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.
28950
L
U X E M B O U R G
3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened
to approve the Company's annual accounts for the financial year ending on 31 December 2019:
- Mr. Wilhelm Mannheims, born in Würselen, Germany, on June 23, 1960, residing at Tiergartenstr. 78, 47800 Krefeld,
Germany;
- Mr. Peter van Opstal, born in Zwijndrecht, the Netherlands, on 12 February 1969, with professional address at 40,
Avenue Monterey L-2163 Luxembourg; and
- Ms. Lucinda Clifton-Bryant, born in Aachen on 18 October 1977, Germany, with professional address at 40, Avenue
Monterey L-2163 Luxembourg.
3. Co-Ventures S.A., a société anonyme having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register Under number B 48838, is appointed as internal auditor
of the Company until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the
financial year ending on 31 December 2019.
4. The respective subscription price set by article 5.3 shall be paid by VB and MB to the Company in cash within one
month of the date of the present deed of incorporation.
Executed in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated at the beginning of this deed of incorpo-
ration.
Es folgt die deutsche Übersetzung des Gründungsaktes:
Die vorliegende Gründungsurkunde (die „Urkunde") wurde am 5. Dezember 2013 unterzeichnet.
Vorndran Beteiligungs-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach deutschem
Recht, mit Sitz Am Moritzberg 4, 97228 Rottendorf, Deutschland („VB"), und
Mannheims Beteiligungs-GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach deutschem
Recht, mit Sitz in Tölzer Straße 12, 82031 Grünwald, Deutschland („MB"),
wünschen hiermit eine Genossenschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société coopérative organisée comme
une société anonyme) zu gründen, welche mit folgender Satzung organisiert wird:
A. Name - Rechtsform
Art. 1. Name. Es besteht eine Genossenschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société coopérative organisée
comme une société anonyme) mit dem Namen Grey Hills Management (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und
dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher
Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Aktionär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und
Verpflichtungen jeder luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaft handeln und als Verwaltungsratsmitglied oder
Geschäftsführer für Gesellschaften, in welchen sie eine Beteiligung hält oder in welchen Gesellschaften, die der gleichen
Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft angehören, direkt oder indirekt eine Beteiligung halten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
28951
L
U X E M B O U R G
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst
werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung er-
forderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
B. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt mindestens eintausend Euro (EUR 1 000) bestehend aus einhunderttausend (100
000) Aktien mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) pro Aktie.
5.2 Alle ausgegebenen und auszugebenden Aktien sind von dem/den Aktionär/en durch Bareinlag(en) einzuzahlen.
5.3 Am Tag der Gründung der Gesellschaft wurden dreiunddreißigtausendachthundertsiebzig (33 870) Aktien durch
MB und sechsundsechzigtausendeinhundertdreißig (66 130) Aktien durch VB zum Preis von fünf Cent (EUR 0,05) pro
Aktie gezeichnet.
Art. 6. Aktien.
6.1 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien
mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.2 Die Aktien dürfen weder übertragen noch verpfändet oder abgetreten werden, außer zwischen Aktionären. Die
Aktien dürfen jedoch im Einklang mit Artikel 9 zurückgekauft werden. Rücknahmeerlöse können verpfändet werden.
6.3 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von jedem Aktionär eingesehen werden kann.
Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen (1) Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
Art. 8. Zulassung und Ausgabe von Aktien.
8.1 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist jederzeit und ohne Beschränkung dazu berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl
von voll eingezahlten Aktien auszugeben.
8.2 Alle Zeichnungsanträge für Aktien sind an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten, der sie nach eigenem
Ermessen annehmen oder ablehnen kann.
8.3 Die Anzahl und der Preis der auszugebenden Aktien im Falle einer neuen Zeichnung wird von dem Verwaltungsrat
der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Wertes der auszugebenden Aktien bestimmt.
8.4 Jede neue gezeichnete Aktie kann einer Ausgabegebühr oder einem Agios unterliegen, die nach eigenem Ermessen
des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestimmt werden sollten.
Art. 9. Rücktritt, Ausschluss, Tod und Rückkauf von Aktien.
9.1 Aktionäre scheiden im Falle von Rücktritt, Ausschluss oder Tod als Aktionäre der Gesellschaft aus. In diesen Fällen
kauft die Gesellschaft deren Aktien zurück. Zurückgekaufte Aktien werden automatisch annulliert und das Kapital dem-
entsprechend reduziert im Rahmen des in Artikel 5 vorgesehenen Gesellschaftskapitals.
9.2 Ein Aktionär der Gesellschaft kann jederzeit im Einklang mit dem Gesetz von 1915 als Aktionär zurücktreten,
indem er eine schriftliche Mitteilung an den Verwaltungsrat schickt. Der Verwaltungsrat hat jeden empfangenen Rücktritt
anzunehmen, unter der Voraussetzung, dass (i) die Gesellschaft über ausreichende und sofort verfügbare Mittel verfügt,
um den Rückkaufpreis der von den Aktionären zurückgekauften Aktien zu zahlen, (ii) der Rücktritt nicht zur Insolvenz
der Gesellschaft führt und (iii) der Rücktritt nicht zum Rückkauf der Aktien des letzten oder des einzigen Aktionärs der
Gesellschaft oder zur Unterschreitung des in Artikel 5 festgelegten Mindestkapitals führt.
9.3 Darüber hinaus kann jeder Aktionär von der Gesellschaft ausgeschlossen werden auf Grund einer vom Verwal-
tungsrat festgestellten schweren Pflichtverletzung. Der Ausschluss wird vom Verwaltungsrat entschieden. Der Verwal-
tungsrat wird eine Niederschrift über einen derartigen Ausschlussbeschluss erstellen und der ausgeschlossene Aktionär
wird davon eine Kopie erhalten.
28952
L
U X E M B O U R G
9.4 Der Rückkaufspreis pro Aktie soll dem Nominalwert der zurückgekauften Aktien entsprechen und muss innerhalb
einer von dem Verwaltungsrat zu bestimmenden Frist bezahlt werden, die nicht mehr als vierzehn (14) Tage ab dem
Empfang des Rücktrittsantrags/des Rückkaufbeschlusses betragen darf, unter dem Vorbehalt, dass die Aktienzertifikate,
soweit vorhanden, von der Gesellschaft vorher empfangen worden sind.
Art. 10. Haftung von Aktionären. Die Aktionäre haften nur für die Einzahlung des Nominalwertes und gegebenenfalls
des Agios für jede gezeichnete Aktie an die Gesellschaft. Aktionäre sollen insbesondere nicht für Schulden, Verbindlich-
keiten und/oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines anderen Aktionärs haften.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 11. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig
einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Haupt-
versammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen
Befugnisse.
11.2 Hat die Gesellschaft nur einen (1) Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre" in der
vorliegenden Satzung, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Bezug auf den „alleinigen Aktionär" zu verstehen,
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.
Art. 12. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
12.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch
den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.
12.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Pro-
zent (10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern
einberufen werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab
Zugang des Ersuchens abgehalten werden.
12.3 Die Einberufungsbekanntmachung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den
Ort und die Tagesordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufungsbekanntmachung im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von
mindestens acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einbe-
rufungsbekanntmachungen per Post sind acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber
von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt
es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die Einberufungsbekanntmachung ausschließlich durch Einschreiben
erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden
sind.
12.4 Falls alle Aktionäre in einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und auf Ladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung
abgehalten werden.
Art. 13. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
13.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen
in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort am 31. Mai um 12:00 Uhr (mittags) abgehalten. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere
Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort zu der darin
angegebenen Zeit abgehalten werden.
13.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,
einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen. Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre entscheiden, dass eine ordnungsgemäße Abstim-
mung derart gewährleisten werden kann, so können sie einstimmig beschließen, lediglich (i) einen Vorsitzenden und einen
Schriftführer oder (ii) eine Person zu ernennen, die die Rolle des Rates der Versammlung übernimmt, und in einem solchen
Fall ist die Ernennung eines Stimmzählers nicht erforderlich. Soweit anwendbar und je nach Zusammenhang ist jeder Bezug
auf den „Rat der Versammlung" in dieser Satzung als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer" oder gegebenenfalls
als Verweis auf die „Einzelperson, die die Rolle des Rates übernommen hat", zu verstehen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem im Einklang mit den
Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.
13.3 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird eine Anwesenheitsliste geführt.
13.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch
ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.
13.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
28953
L
U X E M B O U R G
und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und des
Stimmrechts, insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.
13.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimm-
karte abgeben, welches per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft
öder an die in der Einberufungsbekanntmachung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche
Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und
die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen ent-
halten, die es dem Aktionären ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder
sich zu enthalten, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.
13.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen
den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.
13.8 Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären eingehalten werden müssen,
um an einer Hauptversammlung teilzunehmen.
Art. 14. Quorum und Stimmrecht.
14.1 Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
14.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in
einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 15. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der
Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3)
der abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.
Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser.
Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquo-
rum beschlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen
gültigen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
16.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches von den Mitgliedern des Rats
der Versammlung sowie von jedem Aktionär, der dies ersucht, unterzeichnet wird.
16.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht
werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der
die Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei be-
liebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 17. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusam-
mensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in einer Hauptver-
sammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die Gesellschaft bis
zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die auf die Fest-
stellung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff
„einziges Verwaltungsratsmitglied" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Ver-
waltungsrat" als Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied" auszulegen.
17.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Tägliche Geschäftsführung.
18.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung
der Gesellschaft einem (1) oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen,
mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse
werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.
18.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
28954
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
19.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
19.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten, und jedes Verwaltungs-
ratsmitglied übt sein Amt aus, bis sein/ihr Nachfolger gewählt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiedergewählt
werden.
19.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der in einer Hauptversammlung anwesenden oder
vertretenen Aktien gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der
in einer Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien abberufen werden.
Art. 20. Einladung zu und Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
20.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-
mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt. Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese
alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
20.2 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen
Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokoll-
führung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.
20.3 Der Verwaltungsrat kann weitere interne Verfahrensregeln bestimmen.
Art. 21. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
21.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner
Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden unterzeichnet.
21.2 Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom ein-
zigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfah-
ren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.
Art. 22. Geschäfte mit Dritten.
22.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwal-
tungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift
jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, verpflichtet.
22.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder
Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 23. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
23.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire
(s)). Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf.
23.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen wer-
den.
23.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
23.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen,
in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s))
ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.
23.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 25. Jahresabschluss und Gewinne.
25.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
28955
L
U X E M B O U R G
25.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
25.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der
gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rück-
lage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
25.4 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.
25.5 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen
Aktien.
Art. 26. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
26.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen Abschlagsdividenden auszahlen.
26.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden,
G. Liquidation
Art. 27. Liquidation.
27.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen
(1) oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts
anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte
und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
27.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 28. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2015 abgehalten werden.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Beschlüsse der Aktionärei>
Der Gründer, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbe-
kanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt, bis zur Hauptversammlung
der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr verab-
schiedet:
- Herr Wilhelm Mannheims, geboren am 23. Juni 1960 in Würselen, Deutschland, wohnhaft in Tiergartenstraße 78,
47800 Krefeld, Deutschland;
- Herr Peter van Opstal, geboren am 12. Februar 1969 in Zwijndrecht, Niederlande, geschäftsansässig in 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg; und
- Frau Lucinda Clifton-Bryant, geboren am 18. Oktober 1977 in Aachen, Deutschland, geschäftsansässig in 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg.
3. Co-Ventures S.A, eine luxemburgische société anonyme mit Sitz in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, ein-
getragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.838, wird bis zur Hauptversammlung der Aktionäre,
die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr verabschiedet, als Rech-
nungsprüfer der Gesellschaft ernannt.
4. Der in Artikel 5.3 jeweils festgelegte Bezugspreis ist durch VB und MB innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten
der vorliegenden Gründungsurkunde in bar an die Gesellschaft zu zahlen.
Unterschrieben in. Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem zu Beginn dieser Gründungsurkunde aufgeführten
Datum.
Mannheims Beteiligungs GmbH
28956
L
U X E M B O U R G
Wilhelm Mannheims
<i>Geschäftsführer
i>Vorndran Beteiligungs GmbH
Helmut Vorndran
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2014006057/606.
(140005923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Grey Hills Management, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 183.284.
Klarstellung der Beschlüsse der Aktionäre, die unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft am 5. Dezember 2013
gefasst wurden, und Bestätigung, dass die Amtszeit der Direktoren und des Rechnungsprüfers mit der jährlichen Haupt-
versammlung der Aktionäre endet, welche den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 genehmigt, welche Hauptver-
sammlung im Jahre 2019 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 10. Januar 2014.
Grey Hills Management
Unterschrift
Référence de publication: 2014006058/15.
(140005923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Clio Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 183.572.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of December
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
EF TRUST S.A., a public limited liability company,, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 153.491, having its registered
office at 6A, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, ("EF Trust"),
here represented by Mr Geoffroy t'Serstevens, company director with professional address in L - 2633 Senningerberg,
6A, route de Trèves, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-
corporation of a société anonyme which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as
follows:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of CLIO HOLDING S.A., (the
Company).
The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,
the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.
The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder will not cause the dissolution
of the Company.
Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the board of
directors of the Company or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are
imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
28957
L
U X E M B O U R G
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. Purpose.
4.1.The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio, including the holding of heritage and family financial assets.
4.2. The company is strictly forbidden to carry out any commercial activity.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of three
hundred and ten (310) ordinary shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each. Each ordinary share is
entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Administration - Supervision
Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.
Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director.
The general meeting of shareholders may decide to appoint class A and class B directors, the rights and obligations of
which are set out below.
When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-
sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office not exceeding six years. The director(s) shall be re-
eligible. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 7. The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause
to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.
All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting
fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.
Art. 8. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be chaired by
another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the consti-
tutive general meeting.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,
cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/her
colleagues.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of
communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.
The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-
sented at a meeting of the Board.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the
case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
director's meetings.
The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the
Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
28958
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Corporate Signature. Towards third parties, the Company is validly bound by (i) the signature of the sole
director, (ii) the joint signature of any two directors of the Company, (ii) the signature of the managing director(s) within
the context of the daily management or, (iii) by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been
delegated by the board of directors.
Art. 10. Delegation of Powers. The Board may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily
management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided
for by article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee
or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other
agents who may act individually or jointly.
The Board shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to
these delegations of authority including the authority to sub-delegate.
The Board may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
Supervision
Art. 11. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Accounting year - General meetings
Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
January and shall terminate on the 31
st
December
of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on the 31 December 2014.
Art. 13. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting
pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.
The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of
the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Each share is entitled to one vote.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
Art. 14. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the
legal requirements.
Art. 16. The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such
other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
second Wednesday of the month of June at 11.00 am, and for the first time in 2014. If such a day is not a business day
for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act 1915 as amended.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing, EF TRUST, pre-named, declares to sub-
scribe all the three hundred and ten (310) shares.
All the shares of a par value of one hundred euros (EUR 100-) each have been fully paid up by payment in cash and
the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000-) is now available to the corporation, evidence thereof was given
to the undersigned notary.
28959
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 as amended of the law of
August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended have been observed.
<i>Estimation - Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting duly
convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the sole shareholder has passed the following resolutions:
1) The registered office of the corporation is fixed at: L-2633 Senningerberg. 6A route de Trèves.
2) The number of directors is fixed at one (1) and has been appointed as Director of the Company:
- Mr Grégory Noyen, born on 22
nd
January 1980 in Liège (B) and residing professionally at 6A route de Trèves, L-2633
Senningerberg;
3) Has been appointed statutory auditor:
ISIS GROUP SERVICES Ltd, having its registered office at Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, registered with the Registrar of Companies of Tortola under number 1520049.
4) The Directors' and auditor's terms of office will expire after the annual general meeting of shareholder(s) of the
year 2018, unless they previously resign or are revoked.
<i>Powersi>
The appearing person does hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm of the undersigned notary,
acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.
WHEREOF, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
EF TRUST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le no B153.491, dont le siège social est situé à 6A, route de Trèves, L-2633 Luxembourg ("EF Trust"),
ici représentée par Mr Geoffroy t'Serstevens, administrateur de société, demeurant professionnellement à L - 2633
Senningerberg, 6A, route de Trèves, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de CLIO HOLDING S.A., ci-après, la Société.
La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires.
Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seu-
lement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.
La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la
banqueroute de l'associé unique.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la
commune du siège social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.
28960
L
U X E M B O U R G
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet.
4.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations, incluant la détention d'un patrimoine familial.
4.2. La Société ne pourra en aucun cas exercer une activité de nature commerciale, quelle qu'elle soit.
Art. 5. Capital Social.
5.1 Capital social émis
5.1.1. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix
actions (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. Chaque Action Ordinaire
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique
seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant
au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée
générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place.
L'assemblée générale des actionnaires peut décider de nommer des administrateurs de classe A et des administrateurs
de classe B, dont les droits et obligations sont décrits ci-après.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat ne pouvant excéder six ans. Ils seront rééli-
gibles. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l'assemblée générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus
pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents
statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.
Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la
présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,
soit par téléfax, cable, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
28961
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une
réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas
prépondérante.
Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil
d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.
Art. 9. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par (i) la signature de l'administrateur
unique, (ii) la signature conjointe de deux administrateurs, (iii) la signature individuelle de l'un des administrateurs délégués
à la gestion quotidienne dans le cadre de la gestion quotidienne de la Société ou (iv) la (les) signature(s) de toute(s) autre
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 10. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la
gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément
à l'article 60 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou à un ou plusieurs
comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres
mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement.
Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachés à
ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son
choix.
Surveillance
Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,
jusqu'au 31 décembre 2014.
Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées
générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes
en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
28962
L
U X E M B O U R G
Art. 16. L'assemblée générale se tiendra de plein droit le second mercredi du mois de juin à 11h et pour la première
fois en deux mille quatorze au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les
convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante EF TRUST, précitée, déclare souscrire le capital
comme suit:
Trois cent dix actions
TOTAL: Trois cent dix actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi
sur les sociétés commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.800.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'actionnaire unique, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite
constitué en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris
les résolutions suivantes:
1. Le siège social est fixé au L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Le nombre d'administrateurs est fixé à un (1) et est appelé aux fonctions d'administrateur:
Mr Grégory Noyen, né le 22 janvier 1980 à Liège (B) et résidant professionnellement à 6A route de Trèves, L-2633
Senningerberg;
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- ISIS GROUP SERVICES Ltd, dont le siège social est situé à Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola,
Iles Vierges Britanniques, et enregistrée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1520049.
4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de
2018.
<i>Pouvoirsi>
Le comparant donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant
individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. T'SERSTEVENS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2014. Relation: LAC/2014/283. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 janvier 2014.
Référence de publication: 2014010711/351.
(140012472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
28963
L
U X E M B O U R G
Scorpio International AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 183.270.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend dreizehn, am dreizehnten Dezember.
Vor uns Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz zu Rambruch, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Die Aktiengesellschaft D.A.L. Holding S.A. SPF, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
17.995, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitburg, vertreten durch einen Geschäftsführenden Vorsitzenden, na-
mentlich Herrn Gernot Kos, Expert-comptable, geboren am 23. Januar 1970 in Eisenstadt (A), beruflich ansässig in L-1273
Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
Welche Erschienene, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden
Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es existiert eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Scorpio International AG“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Gesellschaftssitz innerhalb
der Gemeinde verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Filialen und
Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet wer-
den.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
oder des einzigen Verwalters, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg
verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs an
jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist allgemein der Handel („Commerce“), insbesondere der Erwerb, das Halten, Ver-
walten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art im eigenen Namen und für eigene Rechnung
sowie alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an
irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Vermarktung von Lizenzen und Patenten sowie die Verwaltung, Vermittlung
und Handel von Immobilien, Einrichtungen sowie alle damit verbundene Dienstleistungen.
Die Gesellschaft kann ihren gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschaftern Genussrechte gewähren.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten und Lizenzen zusammensetzt, sich beteiligen an der
Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese
Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente aus-
werten.
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an
alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien
gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 120.000 € (hundert zwanzig tausend Euro) eingeteilt in 120 (ein-
hundertzwanzig) Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000 € (eintausend Euro).
28964
L
U X E M B O U R G
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der
Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Der Verwaltungsrat ist im Besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein
Vorzugsrecht einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-
vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche
die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel
automatisch anzupassen.
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Option-
sanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher
Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von Wandelobliga-
tionen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.
Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle
anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.
Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Wenn und solange ein Aktionär alle Aktien besitzt, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter
verwaltet wurde, der kein Aktionär sein muss, welcher von dem alleinigen Aktionär für eine Dauer ernannt wird, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und der von dem alleinigen Aktionär jederzeit abberufen werden kann.
Wenn und solange zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat
verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalver-
sammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten
verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige
Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und/oder einen Präsidenten. Im Falle
der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder
Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit
ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsan-
gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig,
was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalver-
sammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat kann Dritten oder seinen Mitgliedern, welche nicht Aktionäre
zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des einzigen Verwalters oder durch
die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen
28965
L
U X E M B O U R G
der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft
durch die Einzelunterschrift eines Verwalters des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von dem alleinigen Aktionär oder von der
Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Ver-
gütung festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung fest-
gelegt. Sie kann sechs Jahre nicht überschreiten jedoch danach erneuert werden.
Generalversammlung
Art. 14. Wenn und solange ein Aktionär alle Aktien besitzt, hat dieser alle Befugnisse der Generalversammlung und
fasst seine Beschlüsse schriftlich.
Im Falle einer Vielzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitest gehenden
Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-
chreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag im Monat Juni um 11.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.
Art. 16. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche
Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Inhaber pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört,
hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Der einzige Verwalter oder Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat
Vorschussdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-
tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmung
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2013.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2014 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
28966
L
U X E M B O U R G
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Die 120 (einhundertzwanzig) Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000 € (eintausend Euro) wurden durch den
alleinigen Aktionär:
D.A.L. Holding S.A. SPF, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 17.995, mit Sitz in L-1273
Luxemburg, 19, rue de Bitburg, vertreten durch Herrn Gernot Kos, Expert-comptable, geboren am 23. Januar 1970 in
Eisenstadt (A), beruflich wohnhaft in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, gezeichnet.
Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von 120.000 € (hundert zwanzig tausend Euro) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.
<i>Handelsermächtigung - Reglementierte Berufei>
Der Notar informiert die erschienene Parteien darüber dass vor jedweder Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit,
beziehungsweise eines reglementierten Berufes, die Gesellschaft zunächst im Besitz einer Handelsermächtigung bezie-
hungsweise einer Genehmigung betreffend die Ausübung eines reglementierten Berufes seitens der zuständigen Behörden
sein muss sowie alle anderen Auflagen und Verpflichtungen erfüllen muss. Die Komparenten bestätigen ausdrücklich
diesen Hinweis erhalten zu haben.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
zweitausend EUR.
<i>Beschlüsse des alleinigen Aktionärsi>
Der vorgenannte alleinige Aktionär, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat
sofort folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des Geschäftsjahres 2018 befindet,
werden ernannt:
1. Herr Jan-Peter Grewing, Kaufmann, geboren am 28. November 1978, wohnhaft in Alter Dyk 12, D-48703 Stadtlohn;
2. Herr Franz-Josef Grewing, Kaufmann, geboren am 14. März 1948 in Schermbeck, jetzt Dorsten (Deutschland),
wohnhaft in Immingfeldweg 12, D-48703 Stadtlohn;
3. Frau Resi Gesina Steinbach-Grewing, Kauffrau, geboren am 15. August 1952 in Stadtlohn (Deutschland), wohnhaft
in Immingfeldweg 12, D-48703 Stadtlohn;
4. Herr Erhard Helmut Steinbach, Kaufmann, geboren am 10. Mai 1957 in Stadtlohn (Deutschland), wohnhaft in Düster
Stegge 89, D-48703 Stadtlohn.
<i>Zweiter Beschlussi>
Herr Jan-Peter Grewing, wird Vorstandsvorsitzender und Präsident des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung,
die über die Bilanz des Geschäftsjahres 2018 befindet, ernannt.
<i>Dritter Beschlussi>
Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des Geschäftsjahres 2018 befindet, wird ernannt:
„G.T. Fiduciaires S.A.“, Société Anonyme, R.C.S. Luxembourg B 121.820, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bit-
bourg.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, vertreten wie besagt, welcher Vertreter dem
Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat die Erschienene mit dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Kos, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 17 décembre 2013. Relation: RED/2013/2228. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
28967
L
U X E M B O U R G
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintra-
gung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, den 20. Dezember 2013.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2014006299/216.
(140006143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Amalthee Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Amalthee Participations S.A.).
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 133.722.
L'an deux mille treize, le quatre novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AMALTHEE PARTICIPATIONS", (ci-après
la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, constituée en date du
8 novembre 2007 suivant acte reçu par Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C
numéro 2938 du 18 décembre 2007,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133.722.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Géraldine NUCERA, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à Luxembourg qui se désigne également comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à res-
ponsabilité limitée (S.à r.l.) conformément à l'article 3 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée.
2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société avec décharge pleine et entière pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
3. Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société sans en modifier
les caractéristiques essentielles.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
B) Que les actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une
liste de présence; laquelle liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire des actionnaires
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les
besoins de l'enregistrement.
D) Que l'intégralité du capital social étant représentée et que les actionnaires, représentés, déclarent avoir été dûment
notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de
convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transformer la forme légale de la Société en une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.)
conformément à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Par cette transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée,
la société à responsabilité limitée étant la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec
la même personnalité juridique, et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que le passif de cette société.
L'assemblée convertit les actions de la société anonyme en parts sociales, de sorte que le capital sera représenté
dorénavant par quatre millions deux cent quinze mille cinq cent six (4.215.506) parts sociales d'une valeur nominale d'un
euro (1,- EUR) chacune.
28968
L
U X E M B O U R G
Les quatre millions deux cent quinze mille cinq cent six (4.215.506) actions sont annulées et échangées contre quatre
millions deux cent quinze mille cinq cent six (4.215.506,-) parts sociales, entièrement détenues par la société à respon-
sabilité limitée «TTF INVEST S.à r.l.» ayant son siège social au 128, boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg,
immatriculée près du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 161.596.
Ainsi l'article 5 des statuts de la Société est modifié comme suit:
« Art. 5. Le capital de la Société est de quatre millions deux cent quinze mille cinq cent six euros (4.215.506,- EUR),
représenté par quatre millions deux cent quinze mille cinq cent six (4.215.506) parts sociales d'une valeur nominale d'un
euro (1,- EUR) chacune.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de révoquer, suite au changement de la forme juridique, les administrateurs actuels, savoir
Messieurs Alain NOULLET et Stéphane BIVER, tous deux demeurant professionnellement au 128 Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg, ainsi que Monsieur Javier OTERO et Madame Ariane SLINGER, tous deux demeurant au 1 Place de
Saint-Gervais L-1211 Genève (Suisse) et de révoquer également le commissaire «DATA GRAPHIC S.A.» demeurant 128
Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg (RCS Luxembourg B 42.166) et leurs confère pleine et entière décharge
pour l'accomplissement de leurs mandats à la date de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter les résolutions prises ci-avant et pour les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société, l'assemblée
générale décide de procéder à une refonte totale des statuts, et de leur donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "AMALTHEE PARTICIPATIONS",
(la "Société"), régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg). Il
pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à quatre millions deux cent quinze mille cinq cent six euros (4.215.506,-
EUR), représenté par quatre millions deux cent quinze mille cinq cent six (4.215.506,-) parts sociales d'une valeur nominale
d'un euro (1,- EUR) chacune.
La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul ayant-droit pour chacune
d'elles.
S'il y a plusieurs ayant-droits d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à
ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en
cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément des associés
représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément des associés
représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
28969
L
U X E M B O U R G
Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la Société.
Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts
seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 9. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
En cas de décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 12. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 14. L'exercice social commence le premier novembre de chaque année et se termine le trente et un octobre de
l'année suivante.
Art. 15. Chaque année, au 31 octobre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital
social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit,
le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
28970
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée nomme, pour une durée illimitée comme gérant:
a. Madame Ariane SLINGER, administrateur de sociétés, né à Menton (France), le 26 juillet 1963, demeurant profes-
sionnellement à CH-1211 Genève, Place de Saint Gervais, 1 (Suisse), en tant que gérant A;
b. Monsieur Javier OTERO, administrateur de sociétés, né à Lausanne (Suisse), le 26 octobre 1973, demeurant pro-
fessionnellement à CH-1211 Genève, Place de Saint Gervais, 1 (Suisse), en tant que gérant A;
c. Monsieur Alain NOULLET, employé privé, né à Berchem-Sainte-Agathe (Belgique), le 2 novembre 1960, demeurant
professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, en tant que gérant B;
d. Monsieur Stéphane BIVER, employé privé, né à Watermaël Boitsfort (Belgique), le 3 août 1968, demeurant profes-
sionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, en tant que gérant B.
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire
et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille deux cent soixante-
quatorze euros (1.274,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, celles-ci ont toutes signées avec le notaire le présent acte
Signé: G. NUCERA, V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 05/11/2013. Relation: LAC/2013/50154. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05/11/2013.
Référence de publication: 2014005826/188.
(140005944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Kailash Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 140.729.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social le 09 juillet 2013.i>
Les Administrateurs et Commissaires sortant sont réélus jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura en 2019.
<i>Administrateuri>
- Mr Pierre Goffinet, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg;
- Mr Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel B-6700 Arlon;
- Mr Herbert Grossmann, demeurant au 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg
<i>Commissairei>
- Stratego International Sàrl, avec son siège social au 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
Référence de publication: 2014013933/15.
(140015985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
28971
L
U X E M B O U R G
Katoen Natie Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 110.988.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2014i>
Est nommé comme nouvel administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2013:
Monsieur Monsieur Stefan HUTS, demeurant à 8, Vosstraat, B - 9170 Sint-Gillis-Waas, Belgique.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013935/13.
(140015904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 183.276.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of December.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette.
THERE APPEARED:
GSO Coastline Credit Partners LP, a limited partnership organized under the laws of the state of Delaware (USA),
having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801 (USA), registered with the Secretary of State, Division of Corporations of Delaware under
authentication number 0627821 and corporate file number 5375602, acting through its general partner, GSO Coastline
Credit Associates LLC, a limited liability company organized under the laws of the state of Delaware (USA),
here represented by:
Maître Sophie ARVIEUX, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10
th
August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the
"Articles").
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the acquisition, sale and/or holding of participations, in Lu-
xembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations.
The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares
and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more ge-
nerally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the
creation, development, management and control of any company, enterprise or interest. It may further invest in the
acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin what-
soever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt in registered form only and subject to the transfer restrictions of article
1690 of the Luxembourg Code Civil and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any
borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any entity identified by the
investment manager of the group to which the Company belongs. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having
obtained the requisite authorization.
28972
L
U X E M B O U R G
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may invest in, acquire, sell and/or hold directly or indirectly real estate or movable property in Luxem-
bourg and/or abroad.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations, which directly or indirectly favour or
relate to its object.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name "GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l.".
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at EUR 20,000.- (twenty thousand Euro), represented by
20,000 (twenty thousand) shares of EUR 1.- (one Euro) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by a pro-vote of the shareholders representing 3/4 of the
corporate capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the corporate capital by cancellation
of all the redeemed shares.
Art. 7. Modification of the capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any
time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 13 of
these Articles.
Art. 8. Payments. Each share entitles to a fraction of the corporate assets of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 9. Multiple beneficiaries. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Art. 11. Management of the Company. The Company is managed by one or more managers. If several managers have
been appointed, they will constitute a board of managers composed of manager(s) of category A and manager(s) of
category B. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers formed by a manager
(managers) of category A and a manager (managers) of category B.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of two members of the board of managers, obligatorily one manager of category A and one manager of
category B.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
28973
L
U X E M B O U R G
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings, whereby signatures may be executed on separate counterparts each of which is an original but all of
which together will constitute one and the same instrument.
Art. 12. Managers liability. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 13. Shareholders’ meeting, shareholders’ resolutions, amendment to the Articles. The sole shareholder assumes
all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the corporate capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s corporate capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 14. Financial year. The Company’s year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December, with the
exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
st
December 2013.
Art. 15. Annual accounts. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are
established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. Distribution of profits, legal reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s).
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 17. Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency
or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders
or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 18. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The 20,000 (twenty thousand) shares have been subscribed by GSO Coastline Credit Partners LP, prenamed.
GSO Coastline Credit Partners LP, prenamed, represented as stated here above, declares to have fully paid the shares
by contribution in cash, so that the amount of EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Dohyun (Doris) LEE-SILVESTRI, born in Seoul (South Korea) on 26 September 1977, with professional address at
345 Park Avenue, New York, NY 10154, category A manager;
- Marisa BEENEY, born in Missouri (United States of America) on 30 December 1970, with professional address at
345 Park Avenue, 30 Floor NY 10154 New-York, United States of America, category A manager;
- Livio GAMBARDELLA, born in Terlizzi (Italy) on 2 December 1975, with professional address at 16 avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, category B manager;
- Jean-Claude KOCH, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 25 April 1952, with private address at
6 rue Nicolas Petit, L-2326 Luxembourg, category B manager; and
28974
L
U X E M B O U R G
- Tony WHITEMAN, born in Hamilton (New Zealand) on 24 May 1969, with professional address at 14, rue Jean
Mercatoris L-7237 Helmsange, Luxembourg, category B manager.
2) The address of the Company is fixed in L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euros (1,200.- Euro).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dix-septième jour de décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU:
GSO Coastline Credit Partners LP, une société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), établie et
ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, Delaware 19801 (Etats-Unis d’Amérique), immatriculée auprès du Secretary of State, Division of Corporations du
Delaware sous le numéro d’identification 0627821 et sous le numéro de dossier 5375602, dûment représentée par son
general partner, GSO Coastline Credit Associates LLC, une société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Améri-
que),
ici représentée par:
Maître Sophie ARVIEUX, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d’une procuration délivrée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la "Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts").
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet l’acquisition, la vente et/ou la détention de participations, tant au Luxem-
bourg qu'à l’étranger, dans d’autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces
participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière
tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs
ou tous instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la gestion et au contrôle de toute société, entreprise ou intérêt. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder, par
voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créan-
ces, enregistrées uniquement et sujettes aux restrictions de transfert de l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois. La
Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre entité identifiée par le gestionnaire d’investissement du groupe dont la Société fait partie.
Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir,
céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
28975
L
U X E M B O U R G
La Société peut d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société peut investir dans, acquérir, vendre et/ou détenir directement ou indirectement des biens immobiliers au
Luxembourg ou à l’étranger.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions
relatives à l’immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la
réalisation de son objet social.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Nom. La Société aura la dénomination: "GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l.".
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à EUR 20.000,- (vingt mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille)
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote favorable des associés représentant trois
quarts (3/4) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Modification du capital. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment
par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article
13 des présents Statuts.
Art. 8. Paiements. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Bénéficiaires multiples. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.
Art. 10. Cession de parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont
librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 et 190 de la Loi.
Art. 11. Gestion de la société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérants
ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article 11 aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance composé d’un (des) gérant(s)
de catégorie A et d’un (des) gérant(s) de catégorie B.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance, dont obligatoirement un gérant de catégorie A et un gérant de
catégorie B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
28976
L
U X E M B O U R G
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, les signatures pouvant être apposées sur différents exemplaires, chaque
exemplaire étant un original mais tous les exemplaires ensemble constituant le même document.
Art. 12. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 13. Assemblées générales, décision des associés, modifications des statuts. L’associé unique exerce tous pouvoirs
conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la
première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant,
ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des
actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 16. Distribution de bénéfices, réserve légale. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après
déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 17. Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité
ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 20.000 (vingt mille) parts sociales ont été souscrites par GSO Coastline Credit Partners LP, prénommée.
GSO Coastline Credit Partners LP, prénommée, représentée ainsi qu'il a été dit, a déclaré que toutes les parts sociales
ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 20.000,- (vingt mille euros) est
à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Résolution de l’associé uniquei>
1) La Société sera administrée par les gérants suivants:
- Dohyun (Doris) LEE-SILVESTRI, née à Séoul (Corée du Sud) le 26 septembre 1977, demeurant professionnellement
au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, gérante de catégorie A;
- Marisa BEENEY, née à Missouri (Etats-Unis d’Amérique) le 30 décembre 1970, demeurant professionnellement au
345 Park Avenue, étage 30 NY 10154 New-York, Etats-Unis d'Amérique, gérante de catégorie A;
- Livio GAMBARDELLA, né à Terlizzi (Italie) le 2 décembre 1975, demeurant professionnellement au 16 avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, gérant de catégorie B;
28977
L
U X E M B O U R G
- Jean-Claude KOCH, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 25 avril 1952, demeurant au 6, rue Nicolas
Petit, L-2326 Luxembourg, gérant de catégorie B; et
- Tony WHITEMAN, né à Hamilton (Nouvelle-Zélande) le 24 mai 1969, résidant professionnellement au 14, rue Jean
Mercatoris L-7237 Helmsange, Luxembourg, gérant de catégorie B.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de
la Loi et déclare expressément qu'elles ont été remplies.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées
approximativement à mille deux cents euros (1.200.- euros).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête
de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant ainsi qu'il a été dit, il a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: ARVIEUX, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18/12/2013. Relation: EAC/2013/16686. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): HALSDORF.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 08/01/2014.
Référence de publication: 2014006071/334.
(140006335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
BMF Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 174.191.
<i>Extrait sincère et conforme des décisions de l'Actionnaire unique adoptées le 31 décembre 2013i>
Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société sera transféré le 1
er
janvier 2014 au 37A avenue J-F
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Référence de publication: 2014013578/11.
(140015634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Bluebill, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 178.235.
Suite au contrat de transfert de parts sociales daté du 30 décembre 2013, le nouvel associé de la société est:
Armando Montelongo Jr, né le 25 octobre 1970 au Texas (Etats Unis d'Amérique) résidant au 4144 Jung Road, 78247
San Antonio, Texas, Etats Unis d'Amérique.
L'actionnariat de la société est représenté comme suit:
Actionnaire
Parts
Sociales
Armando Montelongo Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 23 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013575/17.
(140016373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
28978
L
U X E M B O U R G
Bluebill, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 178.235.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 30 décembre 2013 les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de TITAN en tant que gérant unique de la société avec effet immédiat.
- Nomination de Monsieur Armando Montelongo Jr né le 25 octobre 1970 au Texas (Etats Unis d'Amérique) résidant
au 4144 Jung Road, 78247 San Antonio, Texas, Etats Unis d'Amérique au poste de gérant unique de la société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 23 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013576/16.
(140016373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Baltic Professional Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 151.529.
In the year two thousand and thirteen.
On the thirty-first day of December.
Before us the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) Baltic Professional
Investment S.A. (the "Company"), with registered office in L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, R.C.S. Lu-
xembourg number B 151.529, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 5
th
of February 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 706 of the 2
nd
of April 2010, and whose
articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 1
st
of December 2011 published
in the Mémorial C number 107 on the 13
th
of January 2012.
The meeting is presided by Mr Arnaud DELALLE, private employee, residing in Howald, 45 rue des Scillas.
The chairman appoints as secretary Mrs Laure SINESI, private employee, residing in Howald, 45 rue des Scillas.
The meeting elects as scrutineer Mr Michaël DUVAL, private employee, residing in Howald, 45 rue des Scillas.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an
attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; the said
attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting,
shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting
can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads
as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the Company's share capital by a total amount of three million eight hundred and ten thousand four
hundred euros (EUR 3,810,400.-), so as to bring it up from its current amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-)
to three million eight hundred and forty-one thousand four hundred euros (EUR 3,841,400.-), by the creation and issue
of thirty-eight thousand one hundred and four (38,104) new shares each having a nominal value of one hundred euros
(EUR 100.-) and having the same rights and obligations as the existing shares, by means of a contribution in kind of shares
to the company known as Baltic Professional Investment S.A., made up of one hundred per cent (100%) of its holdings in
various companies: Baker Tilly Poland spółka z ograniczona odpowiedzialnościś, InterGest Poland spółka z ograniczonś
odpowiedzialnościś, Contract Administration spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, StaffPoland spółka z ograniczonś
odpowiedzialnościś and TGC Tax Advisers spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, valued in the total amount of three
million eight hundred and ten thousand four hundred euros (EUR 3,810,400.-).
28979
L
U X E M B O U R G
2. Subscription for, paying up and payment by TG Consultants Limited for thirty-eight thousand one hundred and four
(38,104) new shares each having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) and having the same rights and
obligations as the existing shares, by means of a contribution in kind consisting of:
- the entirety of its holding in the Polish company Baker Tilly Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having
its registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city
of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 0000067027, being 100 shares of 500
Polish zlotys each, valued at EUR 1,062,300.-- (one million sixty-two thousand three hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company StaffPoland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having its re-
gistered office at ul. Biała 4, 00-895 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city of Warsaw, XII
Commercial Division of the State Court Register under number 0000021752, being 592 shares of 500 Polish zlotys each,
valued at EUR 29,100.- (twenty-nine thousand one hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company Contract Administration spółka z ograniczona odpowiedzialnościś
having its registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for
the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 0000028831, being 7,244 shares
of 100 Polish zlotys each, valued at EUR 2,457,900.- (two million four hundred fifty-seven thousand nine hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company InterGest Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having its
registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city of
Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 0000004531, being 500 shares of 100 Polish
zlotys each, valued at EUR 145,600.- (one hundred forty-five thousand six hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company TGC Tax Advisers spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having
its registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city
of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 00000139218, being 74 shares of 500
Polish zlotys each, valued at EUR 115,500.- (one hundred and fifteen thousand five hundred euros).
3. The powers to be conferred on the Board of Directors to deal with all the detailed arrangements for the capital
increase, in particular the registration of the accounting documents relating thereto.
4. Correlative amendment of the first paragraph of Article 5 of the Company's articles of association, to read henceforth
as follows:
In English:
" Art. 5. (first paragraph). The Company's share capital is fixed at three million eight hundred and forty-one thousand
four hundred euros (EUR 3,841,400.-) represented by thirty-eight thousand four hundred and fourteen (38,414) fully paid
up shares each having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-)."
In French:
Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à EUR 3,841,400,- (trois millions huit cent quarante-et-un mille quatre-
cents EUROS) représenté par 38,414 (trente-huit mille quatre-cent-quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR 100,-
(cents EUROS) chacune.
5. Any other modifications to the articles of association that may be necessary or expedient.
6. Any other business.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the Company's share capital by three million eight hundred and ten thousand four
hundred. euros (EUR 3,810,400.-), so as to bring it up from its current amount of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-)
to three million eight hundred and forty-one thousand four hundred euros (EUR 3,841,400.-), by the creation and issue
of thirty-eight thousand one hundred and four (38,104) new shares each having a nominal value of one hundred euros
(EUR 100.-) and having the same rights and obligations as the existing shares, by means of a contribution in kind of shares
to the company known as Baltic Professional Investment S.A., made up of one hundred per cent (100%) of its holdings in
various companies: Baker Tilly Poland spółka z ograniczona odpowiedzialnościś, InterGest Poland spółka z ograniczonś
odpowiedzialnościś, Contract Administration spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, StaffPoland spółka z ograniczonś
odpowiedzialnościś and TGC Tax Advisers spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, valued in the total amount of three
million eight hundred and ten thousand four hundred euros (EUR 3,810,400.-).
<i>Subscription and paymenti>
The thirty-eight thousand one hundred and four (38,104) new shares, with a nominal value of one hundred euros (EUR
100.-) each have been subscribed by the sole Shareholder and paid up by a contribution in kind consisting of:
- the entirety of its holding in the Polish company Baker Tilly Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having
its registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city
of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 0000067027, being 100 shares of 500
Polish zlotys each, valued at EUR 1,062,300.- (one million sixty-two thousand three hundred euros).
28980
L
U X E M B O U R G
- the entirety of its holding in the Polish company StaffPoland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having its re-
gistered office at ul. Biała 4, 00- 895 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city of Warsaw, XII
Commercial Division of the State Court Register under number 0000021752, being 592 shares of 500 Polish zlotys each,
valued at EUR 29,100.- (twenty-nine thousand one hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company Contract Administration spółka z ograniczona odpowiedzialnościś
having its registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for
the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 0000028831, being 7,244 shares
of 100 Polish zlotys each, valued at EUR 2,457,900.- (two million four hundred fifty-seven thousand nine hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company InterGest Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having its
registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city of
Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 0000004531, being 500 shares of 100 Polish
zlotys each, valued at EUR 145,600.- (one hundred forty-five thousand six hundred euros).
- the entirety of its holding in the Polish company TGC Tax Advisers spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś having
its registered office at ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Poland, registered in the in the District Court for the city
of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register under number 00000139218, being 74 shares of 500
Polish zlotys each, valued at EUR 115,500.- (one hundred and fifteen thousand five hundred euros).
Evidence of the value of the Contributions in Kind have been proved to the undersigned notary by a valuation report
of an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) "INTERAUDIT S.à r.l." with registered office in Howald, under
the signature of Mr Edward KOSTA, réviseur d'entreprises, issued on 23
rd
of December 2013, whose conclusion is as
follows:
"Based on verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution
which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued in consideration of the Share
premium.".
<i>Second resolutioni>
The General Meeting confers all Powers to the Board of Directors to deal with all the detailed arrangements for the
capital increase, in particular the registration of the accounting documents relating thereto.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the General Meeting decides to amend article Five (5) of the articles of
incorporation to read as follows:
« Art. 5. The Company's share capital is fixed at three million eight hundred and forty-one thousand four hundred
euros (EUR 3,841,400.-) represented by thirty-eight thousand four hundred and fourteen (38,414) fully paid up shares
each having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-)."
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 3,300.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Howald, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize.
Le trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Baltic Professional Investment S.A. (la
«Société»), avec siège social à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg numéro B 151.529,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
28981
L
U X E M B O U R G
Sociétés et Associations, numéro 706 du 2 avril 2010, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 1
er
décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 107 du 13 janvier 2012.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Arnaud DELALLE, employé, demeurant à Howald, 45 rue des
Scillas.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laure SINESI, employé, demeurant à Howald, 45 rue des Scillas.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michaël DUVAL, employé, demeurant à Howald, 45 rue des Scillas.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, et les membres
du bureau, qui demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de trois millions huit cent dix mille quatre cents
euros (3.810.400,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions
huit-cent-quarante-et-un mille quatre cents euros (3.841.400,- EUR), par la création et l'émission de trente-huit mille cent
quatre (38.104) nouvelles actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant des mêmes
droits et obligations que les actions existantes, par un apport en nature de Baltic Professional Investment S.A., de cent
pour cent (100%) des différentes participations qu'elle détient dans différents sociétés : Baker Tilly Poland spółka z ogra-
niczona odpowiedzialnościś, InterGest Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, Contract Administration spółka z
ograniczonś odpowiedzialnościś, StaffPoland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś and TGC Tax Advisers spółka z
ograniczonś odpowiedzialnościś, évalué à trois millions huit cent dix mille quatre cents euros (3.810.400,- EUR)
2. Souscription, libération et paiement par TG Consultants Limited des trente-huit-mille cent-quatre (38.104) nouvelles
actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant des mêmes droits et obligations que les
actions existantes, par apport en nature constitué de:
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise Baker Tilly Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś
ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District Court for the city of
Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000067027, constituée par cent (100)
actions de cinq cents (500) zlotys polonais chacune, évaluée à 1.062.300,- EUR (un million soixante-deux mille trois cents
euros)
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise StaffPoland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś odpo-
wiedzialnościś ayant son siège social à ul. Biała 4, 00-895 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District Court for the city
of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000021752, constituée par cinq cent
quatre-vingt-douze (592) actions de cinq cents (500) zlotys polonais chacune, évaluée à vingt-neuf mille cent euros
(29.100,- EUR).
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise Contract Administration spółka z ograniczona odpowied-
zialnościś odpowiedzialnościś ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du
“District Court for the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000028831,
constituée par sept mille deux cent quarante-quatre (7.244) actions de cent (100) zlotys polonais chacune, évaluée à deux
millions quatre cent cinquante-sept mille neuf cents euros (2.457.900,- EUR).
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise InterGest Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś
odpowiedzialnościś ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District
Court for the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000004531,
constituée par cinq cents (500) actions de cent (100) zlotys polonais chacune, évaluée à cent quarante-cinq mille six cents
euros (145.600,- EUR).
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise TGC Tax Advisers spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś
odpowiedzialnościś ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District
Court for the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 00000139218,
constituée par soixante-quatorze (74) actions de cinq cents (500) zlotys polonais chacune, évaluée à cent quinze mille
cinq cents euros (115.500,- EUR).
3. Pouvoirs à conférer au Conseil d'administration afin de procéder à toutes les écritures, transcriptions, radiations
et formalités pour réaliser ledit apport, et en particulier de procéder à toutes les écritures relatives à ce dernier.
4. Modification corrélative du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, lequel aura la teneur suivante:
28982
L
U X E M B O U R G
En Anglais:
" Art. 5. (first paragraph). The Company's share capital is fixed at three million eight hundred and forty-one thousand
four hundred euros (EUR 3,841,400.-) represented by thirty-eight thousand four hundred and fourteen (38,414) fully paid
up shares each having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-)."
En Français:
Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à EUR 3,841,400,- (trois millions huit-cent-quarante-et-un mille quatre-
cents EUROS) représenté par 38,414 (trente-huit mille quatre-cent-quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR 100,-
(cent EUROS) chacune.
5. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles
6. Divers.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois millions huit cent dix mille quatre
cents euros (3.810.400,-EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois
millions huit-cent-quarante-et-un mille quatre cents euros (3.841.400,- EUR), par la création et l'émission de trente-huit
mille cent quatre (38.104) nouvelles actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant des
mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en nature de Baltic Professional Investment S.A., de
cent pour cent (100%) des différentes participations qu'elle détient dans différents sociétés: Baker Tilly Poland spółka z
ograniczona odpowiedzialnościś, InterGest Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, Contract Administration
spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, StaffPoland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś and TGC Tax Advisers
spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś, évalué à trois millions huit cent dix mille quatre cents euros (3.810.400,- EUR).
<i>Souscription et libérationi>
Les trente-huit mille cent quatre (38.104) nouvelles actions ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune ont été souscrites par l'Associé unique, lequel déclare les libérer intégralement par apport en nature de:
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise Baker Tilly Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś
ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District Court for the city of
Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000067027, constituée par cent (100)
actions de cinq cents (500) zlotys polonais chacune, évaluée à 1.062.300,- EUR (un million soixante-deux mille trois cents
euros)
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise StaffPoland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś odpo-
wiedzialnościś ayant son siège social à ul. Biała 4, 00-895 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District Court for the city
of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000021752, constituée par cinq cent
quatre-vingtdouze (592) actions de cinq cents (500) zlotys polonais chacune, évaluée à vingt-neuf mille cent euros (29.100,-
EUR).
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise Contract Administration spółka z ograniczona odpowied-
zialnościś odpowiedzialnościś ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du
“District Court for the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000028831,
constituée par sept mille deux cent quarante-quatre (7.244) actions de cent (100) zlotys polonais chacune, évaluée à deux
millions quatre cent cinquante-sept mille neuf cents euros (2.457.900,- EUR).
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise InterGest Poland spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś
odpowiedzialnościś ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District
Court for the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 0000004531,
constituée par cinq cents (500) actions de cent (100) zlotys polonais chacune, évaluée à cent quarante-cinq mille six cents
euros (145.600,- EUR).
- l'intégralité de sa participation dans la société polonaise TGC Tax Advisers spółka z ograniczonś odpowiedzialnościś
odpowiedzialnościś ayant son siège social à ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw, Pologne inscrite auprès du “District
Court for the city of Warsaw, XII Commercial Division of the State Court Register” sous le numéro 00000139218,
constituée par soixante-quatorze (74) actions de cinq cents (500) zlotys polonais chacune, évaluée à cent quinze mille
cinq cents euros (115.500,- EUR).
La valeur de cet apport en nature a été prouvée au notaire instrumentant au moyen d'un rapport d'évaluation d'un
réviseur d'entreprises agréé, effectuée par le cabinet de révision «INTERAUDIT S.à r.l.», avec siège social à Howald, sous
la signature de Mr Edward KOSTA, réviseur d'entreprises, émis en date du 23 décembre 2013, dont la conclusion est la
suivante:
"Based on verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contribution
which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued in consideration of the Share
premium.".
28983
L
U X E M B O U R G
Copie de ce rapport après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexé aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale mandate le Conseil d'administration de procéder à toutes les écritures, transcriptions, radiations
et formalités pour réaliser ledit apport, et en particulier de procéder à toutes les écritures relatives à ce dernier.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à EUR 3'841'400,- (trois millions huit-cent-quarante-et-un mille
quatre-cents EUROS) représenté par 38'414 (trente-huit mille quatre-cent-quatorze) actions d'une valeur nominale de
EUR 100,- (cents EUROS) chacune."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 3.300,- EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Arnaud DELALLE, Laure SINESI, Michaël DUVAL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2014. Relation GRE/2014/142. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 21 janvier 2014.
Référence de publication: 2014010615/289.
(140012382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
A.I.E. Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 154.435.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013436/10.
(140016462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
integratedPlace, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2129 Howald, 20, rue Marie-Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 113.855.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013431/10.
(140016477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
28984
L
U X E M B O U R G
Ak Bars Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 60.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 127.473.
- Mme. Anja Wunsch, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nom-
mé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mme Heike Kubica, avec effet au 23
janvier 2014.
- Le nouveau mandat de Mme. Anja Wunsch prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014013445/15.
(140015666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Twist Beauty S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 161.913.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as proxyholder of Twist Beauty S.à r.l. & Partners S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite
par actions) having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161913 (the Company), incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 22, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2168, of September 15, 2011, and whose articles of incorporation have been last amended pursuant
to a deed of the undersignd notary dated November 26, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 68, of January 11, 2013.
by virtue of two (2) powers of attorney granted by resolutions taken by Twist Beauty S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg law, with registered office at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 152445, being the general partner of the Company (the General Partner), represented by its managers (the Managers)
on December 31, 2013 and on January 9, 2014.
A copy of said resolutions, signed ne varietur by the proxyholder of the Company and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state the following decla-
rations:
I. That the share capital of the Company was as from December 31, 2013 fixed at two hundred sixteen thousand two
hundred eighty-eight Euro (EUR 216.288,00) represented by (202.217,00) class A ordinary shares (hereinafter, the Class
A Ordinary Shares), one management share (hereinafter the Management Share), twelve thousand three hundred twenty
(12.320) class B0 ordinary shares (hereinafter, the Class B0 Ordinary Shares) and one thousand seven hundred fifty (1.750)
class B1 shares (hereinafter the Class B1 Shares) all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
II. According to article 5 of the Company's articles of association, the authorized share capital, excluding the share
capital which has been subscribed, is set at twenty-nine million twenty-six thousand six hundred thirty Euro (EUR
29.026.630,00) represented by twenty-nine million (29.000.000) Class A Shares, sixteen thousand six hundred thirty
(16.630) Class B0 Ordinary Shares or Class B1 Ordinary Shares and ten thousand (10.000) Class B2 Ordinary Shares,
with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
III. Paragraphs 2 and 3 of article 5 of the Company's articles of association state the modalities of the right of the
General Partner to increase the share capital of the Company within the frame of the authorized capital.
IV. That by resolutions taken on December 31, 2013, and on January 9, 2014 in the frame of the authorized capital,
the Managers of the General Partner resolved to effect part of the authorized capital and to increase the subscribed share
capital to the extent of one thousand seven hundred forty Euro (EUR 1.740,00) in order to raise it from its amount of
two hundred sixteen thousand two hundred eighty-eight Euro (EUR 216.288,00) to two hundred eighteen thousand
twenty-eight Euro (EUR 218.028,00), by the creation and issuance of one thousand seven hundred forty (1.740) class B2
28985
L
U X E M B O U R G
ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, and resolved to accept the subscriptions and payments
for these new Class B2 Shares from the subscribers and for the amounts as shown below:
- Guillaume de Demandolx, with address at 2 rue Marietta Martin, 75016 Paris, France, has subscribed for four hundred
fifty (450) Class B2 Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and paid them in cash at their nominal value,
together with a share premium in the amount of twenty-five thousand eight hundred forty-four Euro and forty cents (EUR
25.844,40) by a contribution in cash in the aggregate amount of twenty-six thousand two hundred ninety-four Euro and
forty cents (EUR 26.294,40);
- Jean-Jacques Alexis, with address at 17, rue du Gue, 89100 Saligny, France, has subscribed for two hundred (200)
Class B2 Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and paid them in cash at their nominal value, together
with a share remium in the amount of eleven thousand four hundred eighty-six Euro and forty cents (EUR 11.486,40) by
a contribution in cash in the aggregate amount of eleven thousand six hundred eighty-six Euro and forty cents (EUR
11.686,40);
- Richard Poyol, with address at 22, rue Escudier, 92100 Boulogne Billancourt, France has subscribed for three hundred
fifty (350) Class B2 Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and paid them in cash at their nominal value,
together with a share premium in the amount of twenty thousand one hundred one Euro and twenty cents (EUR
20.101,20) by a contribution in cash in the aggregate amount of twenty thousand four hundred fifty-one Euro and twenty
cents (EUR 20.451,20);
- Thierry Sarfati, with address at APP22 2ETG, 6 rue Jean Mermoz, 92500 Rueil Malmaison, France, has subscribed for
two hundred twenty (220) Class B2 Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and paid them in cash at their
nominal value, together with a share premium in the amount of twelve thousand six hundred thirty-five Euro and four
cents (EUR 12.635,04) by a contribution in cash in the aggregate amount of twelve thousand eight hundred fifty-five Euro
and four cents (EUR 12.855,04);
- Jose Thome Xavier de Brito Neto, with address at Rua Pedro Leardini, 419, Casa 09, 13271-651, Valinhos, Sào Paulo,
Brazil, has subscribed for two hundred twenty (220) Class B2 Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and
paid them in cash at their nominal value, together with a share premium in the amount of twelve thousand six hundred
thirty-five Euro and four cents (EUR 12.635,04) by a contribution in cash in the aggregate amount of twelve thousand
eight hundred fifty-five Euro and four cents (EUR 12.855,04);
- Xavier Leclerc de Hauteclocque, with address at 25 rue du General Delestraint, Paris 75016, France, has subscribed
for three hundred (300) Class B2 Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) and paid them in cash at their
nominal value, together with a share premium in the amount of seventeen thousand two hundred twenty-nine Euro and
sixty cents (EUR 17.229,60) by a contribution in cash in the aggregate amount of seventeen thousand five hundred twenty-
nine Euro and sixty cents (EUR 17.529,60).
The payment of the subscribed share capital together with the total share premium, amounting to one hundred one
thousand six hundred seventy-one Euro and sixty-eight cents (EUR 101.671,68) has been made in cash, which payment
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
V. Further to these increases of the share capital, paragraphs 1 and 2 of article 5 of the Company's articles of association
are amended as follows:
" Art. 5. Paragraphs 1 and 2. The subscribed share capital of the Company is set at two hundred eighteen thousand
twenty-eight Euro (EUR 218.028,00) represented by two hundred two thousand two hundred seventeen (202.217) Class
A Shares, one (1) Management Share, twelve thousand three hundred twenty (12.320) Class B0 Shares, one thousand
seven hundred fifty (1.750) class B1 shares and one thousand seven hundred forty (1.740) class B2 shares, all with a
nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
The authorized capital, excluding the subscribed share capital, is set at twenty-nine million twenty-six thousand six
hundred thirty Euro (EUR 29.026.630,00) represented by twenty-nine million (29.000.000) Class A Shares, sixteen thou-
sand six hundred thirty (16.630) Class B0 Ordinary Shares or Class B1 Ordinary Shares and eight thousand two hundred
sixty (8.260) Class B2 Ordinary Shares to be issued at the sole discretion of the General Partner, with a nominal value
of one Euro (EUR 1,00) each, to be vested with the same rights and obligations as the existing shares, save as for the
specific provisions of the Articles or as defined in any securityholders' agreement that may be entered into or amended
from time to time between, amongst others, all of the shareholders of the Company."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the above resolutions are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.
28986
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille quatorze, le dix janvier.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Twist Beauty S.à r.l. & Partners S.C.A. (ci-après, la Société), une société
en commandite par actions établie au Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
161913, constituée par acte du notaire soussigné en date du 22 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2168, daté du 15 septembre 2011 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte
du notaire instrumentaire en date du 26 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 68, daté du 11 janvier 2013,
en vertu de deux (2) procurations conférées par résolutions prises par Twist Beauty S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152445, en tant qu'associé commandité de
la Société (l'Associé Commandité) représenté par ses gérants (les Gérants), en date du 31 décembre 2013 et en date du
9 janvier 2014.
Les copies desdites résolutions, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la Société et le notaire
instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
La Société, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:
I. Que le capital social à la date du 31 décembre 2013, était fixé à deux cent seize mille deux cent quatre-vingt-huit
Euros (EUR 216.288,00), représenté par deux cent deux mille deux cent dix-sept (202.217) actions ordinaires de catégorie
A (ci- après les Actions de Catégorie A), une (1) action de commandité (ci-après l'Action de Commandité), douze mille
trois cent vingt (12.320) actions ordinaires de catégorie B0 (ci-après les Actions de Catégorie B0) et de mille sept cent
cinquante (1.750) actions ordinaires de catégorie B1 (ci-après les Actions de Catégorie B2), d'une valeur nominale d'un
Euro (EUR 1,00) chacune.
II. Qu'aux termes de l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé, excluant le capital social souscrit, est fixé
à vingt-neuf million vingt-six mille six cent trente Euros (EUR 29.026.630,00) représenté par vingt-neuf million (29.000.000)
Actions de Catégorie A, seize mille six cent trente (16.630) Actions de Catégorie B0 ou Actions de Catégorie B1 et dix
mille (10.000) Actions de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
III. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 des statuts de la Société fixent les modalités d'exercice du droit d'augmenter
le capital social par l'Associé Commandité dans le cadre du capital autorisé.
IV. Au terme des résolutions prises en date du 31 décembre 2013 et du 9 janvier 2014, dans le cadre du capital autorisé,
les Gérants de l'Associé Commandité ont décidé de réaliser une partie du capital autorisé et d'augmenter le capital social
souscrit d'un montant de mille sept cent quarante Euros (EUR 1.740,00), afin de le porter du montant de deux cent seize
mille deux cent quatre-vingt-huit Euros (EUR 216.288,00) à deux cent dix-huit mille vingt-huit Euros (EUR 218.028,00),
par l'émission de mille sept cent quarante (1.740) actions ordinaires de catégorie B2, d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune, et d'accepter les souscriptions et la libération de ces nouvelles Actions de Catégorie B2, par les
souscripteurs et pour les montants suivants:
- Guillaume de Demandolx, ayant son adresse au 2 rue Marietta Martin, 75016 Paris, France, a souscrit quatre cent
cinquante (450) Actions de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) et les a payées en numéraire
à valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de vingt-cinq mille huit cent quarante-quatre Euros
et quarante cents (EUR 25.844,40), par paiement en numéraire d'un montant total de vingt-six mille deux cent quatre-
vingt-quatorze Euros et quarante cents (EUR 26.294,40);
- Jean-Jacques Alexis, ayant son adresse au 17, rue du Gue, 89100 Saligny, France, a souscrit deux cents (200) Actions
de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) et les a payées en numéraire à valeur nominale, ensemble
avec une prime d'émission d'un montant de onze mille quatre cent quatre-vingt-six Euros et quarante cents (EUR
11.486,40), par paiement en numéraire d'un montant total de onze mille six cent quatre-vingt-six Euros et quarante cents
(EUR 11.686,40);
- Richard Poyol, ayant son adresse au 22, rue Escudier, 92100 Boulogne Billancourt, France, a souscrit trois cent
cinquante (350) Actions de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) et les a payées en numéraire
à valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de vingt mille cent un Euros et vingt cents (EUR
20.101,20), par paiement en numéraire d'un montant total de vingt mille quatre cent cinquante-et-un Euros et vingt cents
(EUR 20.451,20);
28987
L
U X E M B O U R G
- Thierry Sarfati, ayant son adresse au APP22 2ETG, 6 rue Jean Mermoz, 92500 Rueil Malmaison, France, a souscrit
deux cent vingt (220) Actions de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) et les a payées en
numéraire à valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de douze mille six cent trente-cinq Euros
et quatre cents (EUR 12.635,04), par paiement en numéraire d'un montant total de douze mille huit cent cinquante-cinq
Euros et quatre cents (EUR 12.855,04);
- Jose Thome Xavier de Brito Neto, ayant son adresse au Rua Pedro Lardini, 419, Casa 09, 13271-651, Valinhos, Sâo
Paulo, Brazil, a souscrit deux cent vingt (220) Actions de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
et les a payées en numéraire à valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de douze mille six
cent trente-cinq Euros et quatre cents (EUR 12.635,04), par paiement en numéraire d'un montant total de douze mille
huit cent cinquante-cinq Euros et quatre cents (EUR 12.855,04);
- Xavier Leclerc de Hauteclocque, ayant son adresse au Longchene, 25 rue du Général Delestraint, Paris 75016, France,
a souscrit trois cents (300) Actions de Catégorie B2, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) et les a payées en
numéraire à valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission d'un montant de dix-sept mille deux cent vingt-neuf
Euros et soixante cents (EUR 17.229,60), par paiement en numéraire d'un montant total de dix-sept mille cinq cent vingt-
neuf Euros et soixante cents (EUR 17.529,60);
Le paiement du capital souscrit ensemble avec le montant total de la prime d'émission, d'un montant total de cent un
mille six cent soixante-et-onze Euros et soixante-huit cents (EUR 101.671,68), a été effectué en numéraire.
V. Suite à cette augmentation de capital, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 des statuts de la Société sont modifiés
pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Paragraphes 1 et 2. Le capital social est fixé à deux cent dix-huit mille vingt-huit Euros (EUR 218.028,00)
représenté par deux cent deux mille deux cent dix¬sept (202.217) Actions de Catégorie A, une (1) Action de Comman-
dité, douze mille trois cent vingt (12.320) Actions de Catégorie B0, mille sept cent cinquante (1.750) actions ordinaires
de catégorie B1 et mille sept cent quarante (1.740) actions ordinaires de catégorie B2, d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune.
Le capital autorisé, excluant le capital social souscrit, est fixé à vingt-neuf million vingt-six mille six cent trente Euros
(EUR 29.026.630,00) représenté par vingt-neuf million (29.000.000) Actions de Catégorie A, seize mille six cent trente
(16.630) Actions de Catégorie B0 ou Actions de Catégorie B1 et huit mille deux cent soixante (8.260) Actions de Caté-
gorie B2, à la discrétion de l'associé commandité, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, devant être
investies des mêmes droits et obligations, à l'exception des dispositions spécifiques des Statuts ou tel que défini dans tout
pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu ou modifié entre, entre autre, tous les actionnaires de la Société.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 janvier 2014. Relation: EAC/2014/994. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014013370/204.
(140014733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2014.
Airtrust Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 78.145.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28988
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 17 janvier 2014.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2014013482/12.
(140015574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Actor Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 134.109.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013442/10.
(140016326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
A.L.P. Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 113.682.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013437/10.
(140016300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Alinea Verde, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 170.858.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013448/10.
(140016463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
A H Luxco 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 32.344.312,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 106.230.
Les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2014.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014013435/11.
(140016155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Automotive Parts International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 177.464.
Par décision de Gérance tenu le 16 janvier 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- De transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 19-21, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
vers 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28989
L
U X E M B O U R G
AUTOMOTIVE PARTS INTERNATIONAL S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2014013463/13.
(140015891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Acertis, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 141.230.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ACERTISi>
Référence de publication: 2014013472/10.
(140016308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
ADN Consultants, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 161.862.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013473/10.
(140016468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.225.
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2012 (rectificatif des comptes déposés le 6 décembre 2013 sous la
référence L130207675) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013465/11.
(140016563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Air Filters Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 54.494.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014013480/11.
(140015704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Airtrust Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 78.145.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28990
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 17 janvier 2014.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2014013481/12.
(140015573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Alliages SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4881 Lamadelaine, 116, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 135.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013486/10.
(140016524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Altrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 61.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013494/10.
(140015714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Amber Shipping International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5523 Remich, 2, Montée de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 69.043.
Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 24 janvier 2014.
<i>Pour AMBER SHIPPING INTERNATIONAL SA
i>Fiduciaire Roger Linster Sàrl
Référence de publication: 2014013495/12.
(140015907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Aria Structured Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.148.
<i>Procès-verbal de l'associé unique de la société en date du 2 janvier 2014.i>
Finexis SA (ci-après «l'associé»), domicilié au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg agissant en tant qu'associé
unique d'Aria Structured Investments S.àR.L (ci-après «la société»), prend la décision suivante:
<i>Décisioni>
Suite à l'approbation de la commission de surveillance du secteur financier pour le changement des gérants de la société,
l'associé décide de nommer au Conseil de Gérance, pour un mandat d'une durée indéterminée, les personnes suivantes:
- Monsieur Rodrigo de Freitas-Branco, né le 23 juillet 1963 à Lisbonne, Portugal, résidant au 59, rue du Verger, L-2665
Luxembourg, gérant de classe B.
- Monsieur Philippe Bruneton, né le 18 juillet 1963 à Paris, France, résidant 5, rue Abraham Lincoln, L-8333 Olm,
Luxembourg, gérant de classe B.
- Finexis S.A., représentée par Christian Denizon, gérant de classe A.
En remplacement des administrateurs démissionnaires, Declan o'Hannrachain et Gerry Salucci.
28991
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 janvier 2014.
Certifié sincère et conforme
Finexis S.A.
Référence de publication: 2014013459/22.
(140016092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Agence Générale d'Assurances Schon S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9657 Harlange, 5, rue Bettlange.
R.C.S. Luxembourg B 150.507.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013477/10.
(140016663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Cherry S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 137.333.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014013651/10.
(140015331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Chaves Café S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 101, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 154.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014013649/10.
(140015516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Cirio Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 75.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Référence de publication: 2014013655/10.
(140016032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Quality and Design, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 103, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 166.752.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014014180/9.
(140015831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
28992
Acertis
Actor Invest S.A.
ADN Consultants
Agence Générale d'Assurances Schon S.à.r.l.
A H Luxco 1 S.àr.l.
A.I.E. Lux
Air Filters Europe S.A.
Airtrust Holding S.A.
Airtrust Holding S.A.
Ak Bars Luxembourg S.A.
Alinea Verde
Alliages SA
A.L.P. Investment S.A.
Altrans S.A.
Amalthee Participations S.A.
Amalthee Participations S.à r.l.
Amber Shipping International S.A.
Aria Structured Investments S.à r.l.
Automotive Parts International Sàrl
Avenue Asia (Luxembourg) S.à r.l.
Baltic Professional Investment S.A.
Bluebill
Bluebill
BMF Investissements S.A.
Chaves Café S.à r.l.
Cherry S.A.
Cirio Finance Luxembourg S.A.
Clio Holding S.A.
Grey Hills Management
Grey Hills Management
GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l.
integratedPlace
Kailash Management S.A.
Katoen Natie Group S.A.
Quality and Design
Scorpio International AG
Twist Beauty S.à r.l. & Partners S.C.A.