This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 556
3 mars 2014
SOMMAIRE
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26678
Arcavest Project Topalu Co. KG . . . . . . . .
26688
Arcavest Project Topalu S.à r.l. . . . . . . . . .
26688
Auguri S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26685
Blue Dolphin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26684
Boduhura Resort S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26672
Brando International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
26688
Broome S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26682
BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated
company of JSC BTA Bank . . . . . . . . . . . . .
26680
Casadores Investments . . . . . . . . . . . . . . . . .
26680
Cesto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26642
Choix de Vie S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26687
Cornet Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
26654
d'Amico International Shipping S.A. . . . . .
26643
d'Amico International Shipping S.A. . . . . .
26646
Daytona Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26678
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26675
Elite World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26650
EMCap S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26650
Eurizon Strategia Flessibile . . . . . . . . . . . . .
26672
Fair Play Capital Advisory (Lux) S.à r.l. . .
26659
Faune Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26651
Grant Thornton Weber & Bontemps . . . .
26666
Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . .
26650
Hope Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26652
Hyadinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26651
Patri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26643
Patrilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26642
Patrinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26642
Pioneer P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26671
Prologis Fund Management S.à r.l. . . . . . . .
26652
Prologis Management II S.à. r.l. . . . . . . . . .
26652
Sohmisa Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
26654
'SOMALUX' Société de Matériel Luxem-
bourgeoise S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26652
The CMI Managed Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
26675
UBS (Lux) Institutional Sicav . . . . . . . . . . . .
26648
UBS (Lux) Key Selection SICAV . . . . . . . . .
26648
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 . . . . . . .
26645
UBS (Lux) Sicav 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26649
Universe, The CMI Global Network Fund
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26675
W Industries Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . .
26642
26641
L
U X E M B O U R G
W Industries Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 83.294.
L'Assemblée générale ordinaire du 13 février 2014 n'ayant pu délibérer valablement sur l'article 100 de la loi du 10
août 1915, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le <i>7 avril 2014i> à 14.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014027540/14.
Patrilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 30.409.
Ordre du jour de
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires de la Société qui se tiendra le <i>25 mars 2014i> à 13.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du commissaire pour l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2013 et approbation des
comptes annuels;
2. Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
Référence de publication: 2014028236/581/16.
Patrinvest, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 69.080.
Ordre du jour de
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires de la Société qui se tiendra le <i>25 mars 2014i> à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2013 et
approbation des comptes annuels;
2. Affectation du résultat;
3. Rémunération du Gérant;
4. Décharge au Gérant pour l'exercice de son mandat;
5. Opérations en relation avec l'article 57 LSC;
6. Divers.
Référence de publication: 2014028237/581/17.
Cesto S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.586.
Ordre du jour de
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires de la Société qui se tiendra le <i>25 mars 2014i> à 12.30 heures.
26642
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du commissaire pour l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2013 et approbation des
comptes annuels;
2. Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
Référence de publication: 2014028238/581/16.
Patri, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 67.161.
Ordre du jour de
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires de la Société qui se tiendra le <i>25 mars 2014i> à 11.30 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice comptable clôturant le 31 décembre 2013 et
approbation des comptes annuels;
2. Affectation du résultat;
3. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats;
4. Rémunération des Administrateurs;
5. Opérations en relation avec l'article 57 LSC;
6. Divers.
Référence de publication: 2014028239/581/17.
d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.790.
<i>Convening notice of the annual general meeting of shareholders to the holders of shares with Common Code 029069751 and ISINi>
<i>Code LU0290697514i>
The ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company (hereinafter, the "Meeting") will be held at the registered address of the Company,
25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>2 April 2014i> , at 11.00 a.m., to discuss and
resolve on the following:
<i>Agenda:i>
I. Consideration of the reports of the Company's Board of Directors and of the Company's auditor ("réviseur
d'entreprises agréé") on the annual accounts of the Company as at 31 December 2013;
II. Consideration and approval of the consolidated annual accounts of the Company as at 31 December 2013 and of
the Company's statutory annual accounts as at 31 December 2013;
III. Approval of the allocation of results for the 2013 year and payment of dividends;
IV. Discharge of the members of the Board of Directors for the year ended on 31 December 2013;
V. Approval of Directors fees;
VI. Consideration and evaluation of Section I of the Report of the Board of Directors on 2013 Remunerations and
of the 2014/2016 General Remuneration Policy;
VII. Appointment of the members of the Board of Directors for a term ending at the Company's annual general meeting
of shareholders to be held in 2017;
VIII. Appointment of external independent auditor for a period ending at the Company's annual general meeting of
shareholders to be held in 2017.
<i>Quorum and Majority Requirementsi>
The Meeting shall validly deliberate regardless of the percentage of the Company's corporate capital being represented.
Resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the
Meeting.
26643
L
U X E M B O U R G
<i>Declaration of Intention to Participate in the Meetingi>
Shareholders must notify the Company on the day of the Record Date (as defined hereafter) of their intention to
participate in the Meeting by sending a certificate (the "Certificate") indicating, inter alia, (i) the name and/or corporate
name and the domicile of the shareholder and/or registered address, (ii) a confirmation of participation in the Meeting
and (iii) a confirmation of the number of shares held by the shareholder after closing of the markets on the Record Date
(the "Shareholder's Details"). For shareholders holding their shares through an Intermediary (as defined hereafter), the
Certificate being prepared by the Intermediary with which the shares are held shall be sent to BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg branch ("BNP Paribas") in its capacity as the duly mandated agent of the Company with copy to
the Company exclusively through Euroclear and Clearstream. In that respect, Intermediaries are further requested to
compulsory instruct Euroclear and Clearstream to further confirm to BNP Paribas all Shareholder's Details.
<i>Voting Rights and Record Datei>
The rights of a shareholder to attend and speak at the Meeting and to vote in respect of his shares shall be determined
with respect to the shares held by the shareholder on 19 March 2014 at 24:00 hours Luxembourg time (the "Record
Date"). Only those who are shareholders on that Record Date shall have the right to participate and vote at the Meeting.
Shareholders present or represented are requested to bring a copy of the Certificate to the Meeting in order to
present it to the board of the Meeting.
<i>Representation by Proxy or Voting by Ballot Paperi>
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
Shareholders need not be present at the Meeting in person. In accordance with the Company's Articles of Association,
a shareholder at the Record Date may act at the Meeting by appointing another person who need not be a shareholder
himself, subject to the production of the original of the executed proxy to the Meeting in order to present it to the board
of the Meeting. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions at the Meeting as those to which
the shareholder thus represented would be entitled. Each shareholder shall only be represented by one proxy holder at
the Meeting except that:
(i) if a shareholder has shares of the Company held in more than one securities account, he may appoint one proxy
holder per securities account at the Meeting;
(ii) a shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each of these
natural or legal persons or third parties appointed by them.
A person acting as a proxy holder may hold a proxy from more than one shareholder without limitation as to the
number of shareholders so represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, it may cast
votes for a certain shareholder differently from votes cast for another shareholder.
Alternatively, in accordance with the Company's Articles of Association, a shareholder may cast his vote by a ballot
paper ("formulaire") expressed in the English language.
Any ballot paper which does not bear the mentions or indications required by the Company's Articles of Association
is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes. In case a proposed resolution is amended by the
Meeting, the votes expressed on such proposed resolution pursuant to the ballot papers received shall be void.
Shareholders must instruct the commercial bank, broker, dealer, custodian, trust company, accountholder, professional
securities depositary, financial institution or other qualified intermediary through which they hold their shares (hereinafter,
the "Intermediary") who handles the management of the Company's shares by using the proxy form or the ballot paper
form.
Intermediaries shall ensure that the signed and dated proxy forms with vote instructions and the ballot papers be
delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post with acknowledgment of receipt, by special courier
service using an internationally recognised courier company, by email or by fax to BNP Paribas with copy to the Company
no later than 5:00 p.m. Luxembourg time on 28 March 2014. Beneficial owners of shares held through an Intermediary
are urged to confirm the deadline for receipt of their proxy forms with vote instructions and ballot papers by such
Intermediary to ensure their onward delivery to BNP Paribas by the relevant deadline.
Shareholders acknowledge that by sending their proxy forms with their voting instructions or their ballot paper form
they will be deemed to consent to having the relevant Intermediary, including but not limited to Euroclear and Clears-
tream, provide all details concerning their identity to BNP Paribas and to the Company.
Relevant proxy forms and/or ballot papers forms ("formulaires") may be obtained, free of charge, at the registered
office of the Company, on the Company's website www.damicointernationalshipping.com (hereinafter, the "Website")
or at BNP Paribas.
<i>Documentation for the Meetingi>
In full compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting
documentation, the convening notice, the total number of shares and voting rights, the draft resolutions and the proxy
and ballot papers forms are deposited and available to the public at the Company's registered office and on the Website.
26644
L
U X E M B O U R G
The above mentioned set of documents is also filed with Borsa Italiana S.p.A. and CONSOB through the SDIR-NIS
mechanism.
Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted to the
Meeting and draft resolutions proposed to be adopted by the Meeting by electronic means at the address of the Company
indicated below or by postal services at the registered office of the Company.
<i>Right to Put Items on the Agenda and to Table Draft Resolutionsi>
In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders holding individually or collectively at least five
per cent (5%) of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the Meeting; and (b)
have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the Meeting. Those rights
shall be exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or electronic
means at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a justification or a draft
resolution to be adopted in the Meeting and shall include the electronic or mailing address at which the Company can
acknowledge receipt of these requests. The requests from the shareholders shall be received by the Company at the
latest on 11 March 2014.
<i>Right to Ask Questionsi>
In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders shall have the right to ask questions at the
Meeting related to items on the agenda of the Meeting. The Company shall answer the questions put to it by shareholders.
The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the measures to be taken by the
Company to ensure the identification of shareholders, the good order of general meetings and their preparation as well
as the protection of confidentiality and business interests of the Company.
The contact details of the Company are as follows:
Company
d'Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: + 352 26 26 24 54, Email: ir@damicointernationalshipping.com
Attention: Mr. Marco FIORI, CEO / Mrs. Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager
The details of the centralising bank mandated by the Company are as follows:
BNP Paribas Securities Services Branch Luxembourg
Corporate Trust Services
33 rue de Gasperich - Howald - Hesperange,
L-2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel: + 352 2696 2518/2407 Fax: + 352 2696 9757
Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Attention: Lux ost domiciliées, Sabrina DEVERSENNE / Rudolf VOIGTLANDER
Luxembourg, 27 February 2014.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2014032621/267/123.
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.049.
Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>20. März 2014i> um 10:30 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2013
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
26645
L
U X E M B O U R G
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formu-
lare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014032624/755/33.
d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.790.
<i>Convening notice of the extraordinary general meeting of shareholders to the holders of shares with Common Code 029069751i>
<i>and ISIN Code LU0290697514i>
The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company (hereinafter, the "Meeting") will be held at the registered address of the Company,
25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>2 April 2014i> , at 11.40 a.m., to discuss and
resolve on the following:
<i>Agenda:i>
1. To amend Article 19 of the Articles of Association of the Company as per the wording proposed in the Board of
Directors report tabled to the meeting.
<i>Quorum and Majority Requirementsi>
The Meeting shall validly deliberate provided a quorum of half of the shares issued and outstanding is reached. If the
quorum is not reached at the first meeting a second meeting may be convened at which no quorum requirement shall
apply. Resolutions shall be adopted by a majority of 2/3 of the votes cast by the shareholders present or represented at
the Meeting.
<i>Declaration of Intention to Participate in the Meetingi>
Shareholders must notify the Company on the day of the Record Date (as defined hereafter) of their intention to
participate in the Meeting by sending a certificate (the "Certificate") indicating, inter alia, (i) the name and/or corporate
name and the domicile of the shareholder and/or registered address, (ii) a confirmation of participation in the Meeting
and (iii) a confirmation of the number of shares held by the shareholder after closing of the markets on the Record Date
(the "Shareholder's Details"). For shareholders holding their shares through an Intermediary (as defined hereafter), the
Certificate being prepared by the Intermediary with which the shares are held shall be sent to BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg branch ("BNP Paribas") in its capacity as the duly mandated agent of the Company with copy to
the Company exclusively through Euroclear and Clearstream. In that respect, Intermediaries are further requested to
compulsory instruct Euroclear and Clearstream to further confirm to BNP Paribas all Shareholder's Details.
<i>Voting Rights and Record Datei>
The rights of a shareholder to attend and speak at the Meeting and to vote in respect of his shares shall be determined
with respect to the shares held by the shareholder on 19 March 2014 at 24:00 hours Luxembourg time (the "Record
Date"). Only those who are shareholders on that Record Date shall have the right to participate and vote at the Meeting.
Shareholders present or represented are requested to bring a copy of the Certificate to the Meeting in order to
present it to the board of the Meeting.
<i>Representation by Proxy or Voting by Ballot Paperi>
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
Shareholders need not be present at the Meeting in person. In accordance with the Company's Articles of Association,
a shareholder at the Record Date may act at the Meeting by appointing another person who need not be a shareholder
26646
L
U X E M B O U R G
himself, subject to the production of the original of the executed proxy to the Meeting in order to present it to the board
of the Meeting. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions at the Meeting as those to which
the shareholder thus represented would be entitled. Each shareholder shall only be represented by one proxy holder at
the Meeting except that:
(i) if a shareholder has shares of the Company held in more than one securities account, he may appoint one proxy
holder per securities account at the Meeting;
(ii) a shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each of these
natural or legal persons or third parties appointed by them.
A person acting as a proxy holder may hold a proxy from more than one shareholder without limitation as to the
number of shareholders so represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, it may cast
votes for a certain shareholder differently from votes cast for another shareholder.
Alternatively, in accordance with the Company's Articles of Association, a shareholder may cast his vote by a ballot
paper ("formulaire") expressed in the English language.
Any ballot paper which does not bear the mentions or indications required by the Company's Articles of Association
is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes. In case a proposed resolution is amended by the
Meeting, the votes expressed on such proposed resolution pursuant to the ballot papers received shall be void.
Shareholders must instruct the commercial bank, broker, dealer, custodian, trust company, accountholder, professional
securities depositary, financial institution or other qualified intermediary through which they hold their shares (hereinafter,
the "Intermediary") who handles the management of the Company's shares by using the proxy form or the ballot paper
form.
Intermediaries shall ensure that the signed and dated proxy forms with vote instructions and the ballot papers be
delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post with acknowledgment of receipt, by special courier
service using an internationally recognised courier company, by email or by fax to BNP Paribas with copy to the Company
no later than 5:00 p.m. Luxembourg time on 28 March 2014. Beneficial owners of shares held through an Intermediary
are urged to confirm the deadline for receipt of their proxy forms with vote instructions and ballot papers by such
Intermediary to ensure their onward delivery to BNP Paribas by the relevant deadline.
Shareholders acknowledge that by sending their proxy forms with their voting instructions or their ballot paper form
they will be deemed to consent to having the relevant Intermediary, including but not limited to Euroclear and Clears-
tream, provide all details concerning their identity to BNP Paribas and to the Company.
Relevant proxy forms and/or ballot papers forms ("formulaires") may be obtained, free of charge, at the registered
office of the Company, on the Company's website www.damicointernationalshipping.com (hereinafter, the "Website")
or at BNP Paribas.
<i>Documentation for the Meetingi>
In full compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting
documentation, the convening notice, the total number of shares and voting rights, the draft resolutions and the proxy
and ballot papers forms are deposited and available to the public at the Company's registered office and on the Website.
The above mentioned set of documents is also filed with Borsa Italiana S.p.A. and CONSOB through the SDIR-NIS
mechanism.
Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted to the
Meeting and draft resolutions proposed to be adopted by the Meeting by electronic means at the address of the Company
indicated below or by postal services at the registered office of the Company.
<i>Right to Put Items on the Agenda and to Table Draft Resolutionsi>
In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders holding individually or collectively at least five
per cent (5%) of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the Meeting; and (b)
have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the Meeting. Those rights
shall be exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or electronic
means at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a justification or a draft
resolution to be adopted in the Meeting and shall include the electronic or mailing address at which the Company can
acknowledge receipt of these requests. The requests from the shareholders shall be received by the Company at the
latest on 11 March 2014.
<i>Right to Ask Questionsi>
In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders shall have the right to ask questions at the
Meeting related to items on the agenda of the Meeting. The Company shall answer the questions put to it by shareholders.
The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the measures to be taken by the
Company to ensure the identification of shareholders, the good order of general meetings and their preparation as well
as the protection of confidentiality and business interests of the Company.
The contact details of the Company are as follows:
26647
L
U X E M B O U R G
Company
d'Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: + 352 26 26 24 54, Email: ir@damicointernationalshipping.com
Attention: Mr. Marco FIORI, CEO / Mrs. Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager
The details of the centralising bank mandated by the Company are as follows:
BNP Paribas Securities Services Branch Luxembourg
Corporate Trust Services
33 rue de Gasperich - Howald - Hesperange,
L-2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel: + 352 2696 2518/2407 Fax: + 352 2696 9757
Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Attention: Lux ost domiciliées, Sabrina DEVERSENNE / Rudolf VOIGTLANDER
Luxembourg, 27 February 2014.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2014032622/267/113.
UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.580.
Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>20. März 2014i> um 10:00 Uhr an deren Geschäftssitz mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2013
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formu-
lare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014032623/755/34.
UBS (Lux) Institutional Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.477.
Die Aktionäre der UBS (Lux) Institutional SICAV sind zur
26648
L
U X E M B O U R G
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>20. März 2014i> um 10:00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formu-
lare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014032625/755/33.
UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.357.
Die Aktionäre der UBS (Lux) SICAV 1 sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>20. März 2014i> um 10:15 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2013
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A,
26649
L
U X E M B O U R G
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formu-
lare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014032626/755/33.
EMCap S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 165.088.
Les actionnaires sont conviés à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires devant se tenir le <i>19 mars 2014i> à 9h30 au siège social de la société avec l'agenda suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la date de l'assemblée nonobstant la date prévue dans les statuts;
2. Présentation du rapport du gérant et du rapport des membres du conseil de surveillance;
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 Décembre 2012;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge pleine et entière à donner au gérant et aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice de leur
mandat jusqu'au 31 Décembre 2012;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014033250/18.
Elite World, Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 73.844.
The shareholders are hereby convened to the
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
which will be held extraordinarily on Monday, the <i>12th of March 2014i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Resignation of the company Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, in abridged form:
CLERC, as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) with effect to February 11, 2014 and discharge.
2. Appointment of the company PricewaterhouseCoopers, cooperative company, having its registered office at L-1471
Luxembourg, 400, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg B65477, as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises
agréé) with effect to February 11, 2014 until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2018.
3. Change of the composition of the board of directors.
4. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2014026401/729/19.
Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 77.949.
Notice is hereby given to the shareholders of Henderson Gartmore Fund that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Henderson Gartmore Fund will be held at its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg at 11
a.m. (Luxembourg time) on <i>13 March 2014i> for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Review and approval of the Audited Annual Report and Accounts for the year ended 30 September 2013.
2. Allocation of net results.
3. Discharge of liabilities to the Directors for the exercise of their mandate.
26650
L
U X E M B O U R G
4. Re-election of Les Aitkenhead, Iain Clark, Jean-Claude Wolter, Stewart Cazier, Tony Sugrue, Jeremy Vickerstaff
and Steven de Vries to the Board of Directors.
5. Approval of the remuneration of the Independent Directors (Les Aitkenhead (as Chairman of the Board), Jean-
Claude Wolter and Iain Clark (as Directors).
6. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as the Statutory Auditor of the Company.
7. Any other business.
30 January 2014.
<i>The Board of Directorsi> .
Notes:
All shareholders are entitled to attend or be represented at the above Meeting. A shareholder is entitled to appoint
one or more proxies to attend and vote in his place. A proxy holder is not required to be a shareholder. To be valid,
Forms of Proxy must be lodged at Victor Buck Services S.A. - Client Services (Ref.______________), IVY Building, Parc
d'Activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, not less than 48 hours before the time appointed for the
Meeting.
The Audited Annual Report and Accounts of the Company may be obtained from the registered office of Henderson
Gartmore Fund at the offices of the representatives and distributors and electronically at www.henderson.com.
Référence de publication: 2014023826/29.
Faune Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 62.514.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra jeudi, le <i>14 mars 2014i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Eric TAZZIERI, pour l'exercice de son mandat d'administrateur.
6. Ratification de la cooptation de M. Julien NAZEYROLLAS comme administrateur décidée par les administrateurs
restants en date du 10 février 2014 et nomination de M. Julien NAZEYROLLAS comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.
7. Reconduction de M. Sébastien ANDRE dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2019.
8. Reconduction de Mme Katia CAMBON dans ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'adminis-
tration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.
9. Reconduction de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. dans son mandat de commissaire jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014026403/729/25.
Hyadinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 164.253.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>11 mars 2014i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
26651
L
U X E M B O U R G
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au
plus tard en séance, le jour de l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014026409/755/18.
Hope Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 141.624.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>12 mars 2014i> à 15.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31/12/2013
3. Affectation des résultats au 31/12/2013
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période de 6 ans
6. Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014026412/19.
Somalux S.A. SPF, 'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme -
Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 4.523.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>11 mars 2014i> à 10:00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Paiement de prestations volontaires
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014027538/795/18.
Prologis Management II S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.417.
Prologis Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.622.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of February.
Before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Maître Diederik Wintershoven, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting in his capacity as a special attorney-in-fact of:
26652
L
U X E M B O U R G
- the board of managers of Prologis Management II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of
Luxembourg, with a share capital of one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-), having its registered
office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 131.417 and incorporated following a notarial deed, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2150 of 1 October 2007, which articles of association
have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, of 19 December 2013, in the course of
being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Manco II");
and
- the board of managers of PROLOGIS FUND MANAGEMENT S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by
the laws of Luxembourg, with a share capital of one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-), having its
registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 124.622 and incorporated following a notarial deed,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 729 of 27 April 2007, which articles of asso-
ciation have been amended for the last time following a notarial deed, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1903 of 19 August 2011 ("Manco I").
The said appearing person, acting in such capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
- that in accordance with the joint merger proposal in notarial form recorded in a deed of the undersigned notary on
27 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 112 of 14 January 2014
(the "Joint Merger Proposal"), Manco II, as absorbing company (the "Absorbing Company"), and Manco I, as absorbed
company (the "Absorbed Company"), contemplated to merge;
- that no shareholder required, during the period of one (1) month following the publication of the Joint Merger
Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, an extraordinary general meeting of the Absorbing
Company, to be convened in order to resolve on the approval of the merger;
- that the conditions fixed by article 279 (1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have
been fulfilled;
- that the Absorbing Company hereby acknowledges that the merger became effective on 14 February 2014;
- that the merger entailed the universal transfer, between the merging companies, of all assets and liabilities of the
Absorbed Company to the Absorbing Company on the date of this deed;
- that following the merger, the Absorbed Company ceased to exist;
- that following the absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed
Company have been cancelled and the books and documents of the Absorbed Company are kept during the legal period
(five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;
- that on the day of publication of this deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the merger will
become effective towards third parties.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version and that at the request of the appearing person and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept février.
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Diederik Wintershoven, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial:
- du conseil de gérance de Prologis Management II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit
luxembourgeois, avec un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), ayant son siège social au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.417 et constituée par acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2150 du 1
er
octobre 2007. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant un acte
du notaire soussigné en date du 19 décembre 2013, en cours de publication auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations («Manco II»); et
- du conseil de gérance de PROLOGIS FUND MANAGEMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par
le droit luxembourgeois, avec un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), ayant son siège social au
26653
L
U X E M B O U R G
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 124.622 et constituée par acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 729 du 27 avril 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte
notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1903 du 19 août 2011 («Manco I»);
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et consta-
tations suivantes:
- qu'aux termes d'un projet commun de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date
du 27 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 112 du 14 janvier 2014 (le
«Projet Commun de Fusion»), Manco II, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et Manco I, en tant
que société absorbée (la «Société Absorbée»), ont projeté de fusionner;
- qu'aucun associé de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du Projet
Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale ex-
traordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion;
- que les conditions fixées par l'article 279 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée,
ont été remplies;
- que la Société Absorbante constate que la fusion est devenue définitive le 14 février 2014;
- que la fusion a entraîné la transmission universelle, entre les sociétés fusionnantes, de l'ensemble du patrimoine actif
et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante à la date du présent acte;
- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée
sont annulées et les livres et documents de la Société Absorbée sont conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au
siège de la Société Absorbante: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- qu'au jour de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la fusion deviendra
définitive à l'égard des tiers.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la comparante et en cas
de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire soussigné par son nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Wintershoven, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 20 février 2014. REM/2014/453. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 26 février 2014.
Référence de publication: 2014031891/107.
(140035705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2014.
Sohmisa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.798.
Cornet Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.669.
DRAFT OF TERMS OF MERGER BY ACQUISITION
By virtue of resolutions adopted on 24 February 2014, the board of managers of both Merging Companies (as this
term is defined below) unanimously approved (i) the merger by acquisition (the "Merger") as defined by article 259 of the
law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law"), whereby the Acquired
Company (as this term is defined below) will transfer all of its assets and liabilities (universalité de patrimoine) to the
Acquiring Company (as this term is defined below) following the Acquired Company's dissolution without liquidation and
(ii) the following common draft of terms and conditions of the Merger (the "Merger Terms"). The Merger shall occur in
26654
L
U X E M B O U R G
compliance with articles 261 and following of the Law. As provided for by article 263 of the Law, the Merger is subject
to the approval of the shareholders of each of the Merging Companies (as this term is defined below).
1. Description of the companies involved in the merger by acquisition.
1.1 ACQUIRING COMPANY
SOHMISA INVESTMENTS S.A R.L. is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having a share
capital of EUR 12,500.-, with registered office at 28, Boulevard Royal, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.798, incorporated
under the laws of Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster
dated 20 July 2010, published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés and Associations on
29 September 2010, number 2028, page 97321 (the "Acquiring Company").
1.2 ACQUIRED COMPANY
CORNET INVESTMENTS S.A R.L. is a private limited liability company [société à responsabilité limitée), having a share
capital of EUR 12,500.-, with registered office at 28, Boulevard Royal, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.669, incorporated
under the laws of Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster
dated 14 April 2010, published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés and Associations
on 4 June 2010, number 1172, page 56251. (the "Acquired Company" together with the Acquiring Company the "Merging
Companies").
2. Terms of the merger.
2.1. EXCHANGE RATIO OF THE SHARES
2.1.1. The following events (the "Events") should occur between the date of the present Merger Terms and the approval
of the Merger Terms by the shareholders of both Merging Companies:
- transfer of all the shares and loans in the Acquiring Company from its sole shareholder Leiptziger Zwei Ltd. to
Leiptziger Eins Ltd., which will become as a consequence the sole shareholder of the Acquiring Company and the Acquired
Company before the Effective Date (as defined below); and
- capital increase in both Merging Companies, consisting in the issuance of one share of EUR 100, the remaining amount
being allocated to the share premium.
2.1.2. The Events have been already taken into account for the calculation of the above mentioned exchange ratio.
2.1.3. The assets and liabilities of the Acquired Company shall be transferred to the Acquiring Company at their net
book value.
2.1.4. According to the interim financial statements dated 31 January 2014 of the Acquired Company(the "Interim F/
S"), the negative net asset amounts to EUR 239,726.50. The board of managers of each of the Merging Companies will
draw up the interim financial statements as of 28 February 2014 taking into account the Events and those financial sta-
tements shall be approved by the shareholders resolutions approving the Merger and Merger Terms for each of the
Merging Companies.
2.1.5. As of the date of the Merger Terms, the board of managers of each of the Merging Companies proposed an
exchange ratio of one share of the Acquired Company for one share of the Acquiring Company.
2.1.6. As a result thereof, the share capital of the Acquiring Company shall be increased by EUR 12,600 (the "New
Shares") under the Merger.
2.2. TERMS OF DELIVERY OF THE NEW SHARES, DATE ON WHICH THE SHARES CARRY THE RIGHT TO
PARTICIPATE TO THE PROFITS
2.2.1. The New Shares will be issued under registered form within the framework of a share capital increase in the
Acquiring Company and will be registered under the name of the shareholders of the Acquired Company in the share-
holders' register of the Acquiring Company.
2.2.2. The New Shares will be entitled to participate in the profit distributions of the Acquiring Company to be decided
after the Effective Date (as defined hereafter) without distinction of the year during which the distributed profits have
been made.
2.3. EFFECTIVE DATES OF THE MERGER
2.3.1. The Merger and the Merger Terms shall be approved for each Merging Company by the shareholders at the
earliest one month following the publication of these Merger Terms in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, made in accordance with article 262 of the Law.
2.3.2. Between the Merging Companies, the Merger shall take effect on the date on which the shareholders have for
each of the Merging Company concurrently approved the Merger and the Merger Terms (the "Effective Date").
2.3.3. Towards third parties, the Merger shall come into effect on the date of publication in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of the shareholders' resolutions of each of the Merging Companies approving the Merger
and the Merger Terms.
26655
L
U X E M B O U R G
2.3.4. From an accounting and tax point of view the operations of the Acquired Company shall be treated as being
carried out on behalf of the Acquiring Company as from the Effective Date.
2.4. EFFECT OF THE MERGER
2.4.1. According to article 274 of the Law, on the Effective Date the Merger shall automatically result in the transfer
of all of the assets and liabilities of the Acquired Company to the Acquiring Company and the Acquired Company will
automatically be substituted by the Acquiring Company in all the rights and obligations of the Acquired Company of any
nature whatsoever.
2.4.2. The Acquired Company shall cease to exist ipso jure as at the Effective Date and its shares shall be cancelled.
All the records and documents of the Acquired Company will be kept at the registered office of the Acquiring Company.
2.4.3. The Acquiring Company shall carry out all the formalities to give effect to the Merger and the transfer of all the
assets and liabilities of the Acquired Company.
2.5. TRANSFERRED ASSETS AND LIABILITIES
2.5.1. The main transferred assets of the Acquired Company are (i) 12,4% participation in the share capital of HGHI
Leiptziger Platz GmbH, with its business seat in Berlin, registered with the commercial register of the local court of
Charlottenburg under HRB 107054 B, which net book value is EUR 1,709,702.53 as indicated in the Interim F/S ("LP 12"),
(ii) receivables against LP 12, which net book value is EUR 27,672,913.36 and (iii) cash at bank. The main transferred
liabilities of the Acquired Company are receivables granted to the Company by its sole shareholder Leipziger Eins Ltd,
which net book value is EUR 29,382,615.89 as indicated in the Interim F/S.
2.5.2. The rights and obligations transferred to the Acquiring Company are transferred to the Acquiring Company
together with all the security interests whether personal or real attached thereto. The Acquiring Company shall auto-
matically be subrogated in all the personal and real rights and in all the obligations of the Acquired Company without
novation. As from the Effective Date, the Acquiring Company shall perform all the agreements attached to the assets and
liabilities transferred to it by virtue of this Merger. In general, the Acquiring Company shall be entitled to all the rights
and shall be subject to all the obligations which are attached to the assets and liabilities transferred to it by virtue of the
Merger.
2.5.3. All the taxes, duties, costs and fees, in relation to an asset or a liability, shall be borne by the Acquiring Company.
2.6. SPECIAL RIGHTS, SPECIAL ADVANTAGES
2.6.1. The Merging Companies have only issued one class of shares and all the shareholders are entitled to the same
rights. None of the Merging Companies has issued securities other than shares.
2.6.2. No special advantage is granted to any expert, members of the board of managers and to auditors of the Merging
Companies.
2.7. REPORTS REFERRED TO IN ARTICLES 265 AND 266 OF THE LAW
The board of managers of the Acquiring Company and of the Acquired Company by resolutions taken on 24 February
2014 decided to propose to the shareholders of the Merging Companies to renounce to (i) the report of the board of
managers of the Merging Companies provided for by article 265 of the Law and (ii) the examination of the Merger Terms
by independent experts and the related written reports provided for by article 266 of the Law.
2.8. PROTECTION OF CREDITORS
2.8.1. As a result of the Merger, the Acquiring Company will take over the entire liabilities of the Acquired Company
at the Effective Date.
2.8.2. As a consequence and in accordance with article 268 of the Law, the creditors of the Merging Companies whose
claims predate the date of publication of the deeds recording the merger provided for by article 273 of the Law, may
notwithstanding any agreement to the contrary apply within two months of that publication, to the judge presiding the
chamber of Tribunal d'arrondissement, dealing with commercial matters in the district in which registered office of the
debtor is located and sitting as in urgency matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any matured or unmatured
debts, where they can credibly demonstrate that due to the merger the satisfaction of their claims is at stake and that no
adequate safeguards have been obtained from the company. The president shall reject the application if the creditor is
already in possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary, having regard to the financial situation
of the company after the merger. The debtor company may cause the application to be turned down by paying the creditor,
even if it is a term debt.
2.9. DOCUMENTS AT DISPOSAL OF THE SHAREHOLDERS
The documents referred to in article 267 paragraphs a) and b) of the Law will be put at the disposal of the shareholders
at the registered office of each of the Merging Companies at least one month before the date on which the shareholders
will be called to decide for each of the Merging Companies on the Merger and the Merger Terms.
2.10. MISCELLANEOUS
2.10.1. For the avoidance of doubt, the shareholders shall have the right to make any amendment to these Merger
Terms and enact these amendments in the written resolutions deciding on the Merger and the Merger Terms to be taken
for each of the Merging Companies.
2.10.2. The Merger shall have ispo jure the consequences detailed in article 274 of the Law as from the Effective Date.
26656
L
U X E M B O U R G
2.10.3. The Acquiring Company shall proceed to all the formalities necessary, incidental or useful to effect the Merger
and its consequences towards all third parties with the relevant Luxembourg authorities in accordance with the applicable
special laws.
2.10.4. The present Merger Terms are worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies
between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction en langue française
PROJET DE FUSION PAR ACQUISITION
En vertu des résolutions adoptées le 24 février 2014, le conseil de gérance des deux Sociétés Fusionnantes (tel que
ce terme est défini ci-dessous) a, à l'unanimité, approuvé (i) la fusion par acquisition (la «Fusion») tel que défini à l'article
259 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée à tout moment (la «Loi»), par laquelle la
Société Absorbée (tel que ce terme est défini ci-dessous) transférera l'universalité de son patrimoine à la Société Ab-
sorbante (tel que ce terme est défini ci-dessous) suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée et (ii) ledit
projet commun des termes et conditions de la Fusion (le «Projet de Fusion»). La Fusion aura lieu conformément aux
articles 261 et suivants de la Loi. Tel que prévu par l'article 263 de la Loi, la Fusion est soumise à l'approbation des associés
de chaque Société Fusionnante (tel que ce terme est défini ci-dessous).
1. Description des sociétés concernées par la fusion par acquisition.
1.1 SOCIETE ABSORBANTE
SOHMISA INVESTMENTS S.A R.L. est une société à responsabilité limitée, au capital de 12.500 EUR, ayant son siège
social au 28, Boulevard Royal, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B. 154.798, constituée sous le droit luxembourgeois en
vertu d'un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster le 20 juillet 2010, publié au Journal Officiel
luxembourgeois, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 septembre 2010, numéro 2028, page 97321 (la
«Société Absorbante»).
1.2 SOCIETE ABSORBEE
CORNET INVESTMENTS S.A R.L. est une société à responsabilité limitée, au capital de 12.500 EUR, ayant son siège
social au 28, Boulevard Royal, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B. 152.669, constituée sous le droit luxembourgeois en
vertu d'un acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster le 14 avril 2010, publié au Journal Officiel
luxembourgeois, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 juin 2010, numéro 1172, page 56251 (la «Société
Absorbée», ensemble avec la Société Absorbante; les «Sociétés Fusionnantes»).
2. Termes de la fusion.
2.1 RATIO D'ECHANGE POUR LES PARTS SOCIALES
2.1.1 Les évènements suivant (les «Evènements») devraient intervenir entre la date du présent Projet de Fusion et
l'approbation dudit Projet de Fusion par les associés des deux Sociétés Fusionnantes:
- transfert de toutes les parts sociales et de tous les prêts dans la Société Absorbante de son seul associé Leiptziger
Zwei Ltd. à Leiptziger Eins Ltd., lequel deviendra en conséquence le seul associé de la Société Absorbante et de la Société
Absorbée avant la Date d'Effet (tel que ce terme est défini ci-dessous); et
- augmentation de capital dans les deux Sociétés Fusionnantes, consistant en l'émission d'un part sociale de 100 EUR,
le montant restant étant alloué à la prime d'émission.
2.1.2 Les Evènements ont déjà été pris en compte pour le calcul du rapport d'échange mentionné ci-dessous.
2.1.3 Les éléments du patrimoine de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante à leur valeur nette
comptable.
2.1.4 Conformément aux comptes intérimaires de la Société Absorbée arrêtés au 31 janvier 2014 (les «Comptes
Intérimaires»), l'actif net négatif s'élève à 239.726,50 EUR. Le conseil de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes
préparera des comptes intérimaires arrêtés au 28 février 2014 prenant en compte les Evènements et ces états financiers
seront approuvés par les résolutions des associés approuvant la Fusion et le Projet de Fusion pour chacune des Sociétés
Fusionnantes.
2.1.5 A la date du Projet de Fusion, le conseil de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes proposera un ratio
d'échange d'une part sociale de la Société Absorbée pour une part sociale de la Société Absorbante.
2.1.6 En conséquence, le capital social de la Société Absorbante sera augmenté de 12.600 EUR (les «Nouvelles Parts
Sociales») lors de la Fusion.
2.2 MODALITES DE REMISE DES NOUVELLES PARTS SOCIALES, DATE A LAQUELLE LES PARTS DONNERONT
DROIT DE PARTICIPER AUX BENEFICES
2.2.1 Les Nouvelles Parts Sociales seront émises sous forme nominative dans le cadre de l'augmentation de capital de
la Société Absorbante et seront enregistrées sous le nom des associés de la Société Absorbée dans le registre des associés
de la Société Absorbante.
26657
L
U X E M B O U R G
2.2.2 Les Nouvelles Parts Sociales donneront droit de participer aux dividendes décidés par la Société Absorbante
après la Date d'Effet (tel que défini ci - après) sans distinction de l'année pendant laquelle les bénéfices distribués auront
été réalisés.
2.3 DATES D'EFFET DE LA FUSION
2.3.1 La Fusion et le Projet de Fusion seront approuvés pour chaque Société Fusionnante par les associés au plus tôt
un mois après la publication de ce Projet de Fusion dans le Journal Officiel luxembourgeois, Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, conformément à l'article 262 de la Loi.
2.3.2 Entre les Sociétés Fusionnantes, la Fusion prendra effet à la date à laquelle les associés ont, pour chaque Société
Absorbante, simultanément approuvé la Fusion et le Projet de Fusion (la «Date d'Effet»)
2.3.3 Envers les tiers, la Fusion aura effet à la date de la publication des résolutions des associés de chaque Société
Fusionnante approuvant la Fusion et le Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2.3.4 D'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme ayant été
effectuées pour le compte de la Société Absorbante depuis la Date d'Effet.
2.4 EFFET DE LA FUSION
2.4.1 Conformément à l'article 274 de la Loi, la Fusion entraînera automatiquement à la Date d'Effet le transfert de
l'universalité du patrimoine de la Société Absorbée à la Société Absorbante et la Société Absorbée sera automatiquement
substituée par la Société Absorbante dans tous les droits et obligations de la Société Absorbée de quelque nature qu'ils
soient.
2.4.2 La Société Absorbée cessera d'exister ipso jure à la Date d'Effet et ses parts sociales seront annulées. Tous les
registres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante.
2.4.3 La Société Absorbante accomplira toutes les formalités afin de donner effet à la Fusion et au transfert des actifs
et passifs de la Société Absorbée.
2.5 ELEMENTS DU PATRIMOINE, ACTIF ET PASSIF, TRANSFERES
2.5.1 Les principaux actifs transférés de la Société Absorbée sont (i) une participation de 12.4% dans le capital de HGHI
Leiptziger Platz GmbH, ayant son siège à Berlin, inscrite auprès du registre de commerce de la Court Local de Charlot-
tenburg sous le numéro HRB 107054 B, dont la valeur nette comptable est de EUR 1.709.702,53 comme mentionné dans
les Comptes Intérimaires («LP 12»), (ii) des créances envers LP 12 dont la valeur nette comptable est de EUR
27,672,913.36 comme mentionné dans les Comptes Intérimaires et (iii) du cash en banque. Les principaux passifs trans-
férés de la Société Absorbée sont des créances consenties à la Société par son associé unique Leipziger Eins Ltd, dont la
valeur nette comptable est de EUR 29.382.615,89 comme mentionné dans les Comptes Intérimaires.
2.5.2 Les droits et obligations transférés à la Société Absorbante sont transférés à la Société Absorbante ensemble
avec toute sûreté qu'elle soit personnelle ou réelle y relative. La Société Absorbante sera automatiquement subrogée
dans tous les droits personnels ou réels et dans toutes les obligations de la Société Absorbée sans novation. Depuis la
Date d'Effet, la Société Absorbante accédera à tous les contrats attachés aux actifs et passifs lui transférés en vertu de la
Fusion. En général, la Société Absorbante sera le titulaire de tous les droits et sera tenue de toutes les obligations, attachés
aux actifs et passifs lui transférés en vertu de la Fusion.
2.5.3 Tous les taxes, droits, coûts et honoraires en relation avec un actif ou un passif seront supportés par la Société
Absorbante.
2.6 DROITS SPECIAUX, AVANTAGES SPECIAUX
2.6.1 Les Sociétés Fusionnantes ont émis une seule classe de parts sociales et tous les associés ont les mêmes droits.
Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis des titres autres que les parts sociales.
2.6.2 Aucun avantage spécifique n'a été accordé à un expert, aux membres du conseil de gérance et aux auditeurs des
Sociétés Fusionnantes.
2.7 RAPPORTS MENTIONNES SOUS LES ARTICLES 265 ET 266 DE LA LOI
Le conseil de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont décidé, par résolutions datées du 24
février 2014, de proposer aux associés des Sociétés Fusionnantes de renoncer au (i) rapport du conseil de gérance des
Sociétés Fusionnantes visé à l'article 265 de la Loi et (ii) à l'examen du Projet de Fusion par des experts indépendants
ainsi que le rapport y relatif tels que prévus par l'article 266 de la Loi.
2.8 PROTECTION DES CREANCIERS
2.8.1 Il résulte de la Fusion que la Société Absorbante reprendra l'ensemble du passif de la Société Absorbée avec effet
à la Date d'Effet.
2.8.2 En conséquence et conformément à l'article 268 de la Loi, les créanciers des Sociétés Fusionnantes dont les
créances sont antérieures à la date de publication des actes constatant la fusion prévue à l'article 273 de la Loi, peuvent,
nonobstant toute convention contraire, dans les 2 mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre
du Tribunal d'Arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège, siégeant en matière commerciale
et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent
démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur
a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates
26658
L
U X E M B O U R G
ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société
débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
2.9 DOCUMENTS A LA DISPOSITION DES ASSOCIES
Les documents listés à l'article 267 paragraphes a) et b) de la Loi seront mis à disposition des associés au siège social
de chaque Société Fusionnante au moins un mois avant la date à laquelle les associés de chaque Société Fusionnante seront
convoqués pour se prononcer sur la Fusion et sur le Projet de Fusion.
2.10 Divers
2.10.1 A toutes fins utiles, il est indiqué que les associés ont le droit de demander toute modification au présent Projet
de Fusion et de faire constater ces modifications dans les résolutions écrites se prononçant sur la Fusion et le Projet de
Fusion à prendre par chacune des Sociétés Fusionnantes.
2.10.2 La Fusion produira ipso jure les effets mentionnés à l'article 274 de la Loi à compter de la Date d'Effet.
2.10.3 La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires, accessoires ou utiles pour rendre effective
la Fusion ainsi que ses conséquences vis-à-vis de tous tiers auprès des autorités luxembourgeoises compétentes en con-
formité avec les lois spéciales applicables.
2.10.4 Le présent Projet de Fusion est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en français et en cas de différences entre
la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
Luxembourg, le 24 février 2014.
SOHMISA INVESTMENTS S.A R.L.
Mr. Rachid OUAICH / E. Benjamin HARTMEIER
<i>Chairman and manager / Manager
i>CORNET INVESTMENTS S.A R.L.
Mr. Rachid OUAICH / Mr. Benjamin HARTMEIER
<i>Chairman and manager / Manageri>
Référence de publication: 2014031369/270.
(140034757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
Fair Play Capital Advisory (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 183.687.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of January.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Mr. Anthony COSTARD, Lawyer, born on 22 June 1978 in Rennes (France) residing professionally at 84, rue du
Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris (France),
- Mr. Pierre MATHEY, Lawyer, born on 23 April 1977 in Marseille (France) residing professionally at 84, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (France),
- Mr. Laurent PICHONNIER, Managing Partner of Global Finance Consult (Luxembourg), born on January 4
th
1972
in Bordeaux (France), residing professionally at 53, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
All here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of one
proxy given under private seal in Paris (France) on 23 December 2013.
Such proxy, after having been initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société á responsabilité limitée) known by the name of
“FAIR PLAY CAPITAL ADVISORY (LUX) S.À R.L.” (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is to carry out investment advisory activities for the benefit
to FAIR PLAY CAPITAL SIF SICAV S.A., a Luxembourg investment fund regulated by the law of 13
th
July 2007 related
to the specialised investment fund and this in conformity with the article 1-1 (2) i) of the Luxembourg law of the 5
th
April 1993 related to the financial sector as amended.
26659
L
U X E M B O U R G
The Company can also act as an introducer/arranger bringing two or more parties together with a view to the con-
clusion of a transaction between the parties.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the Board of Managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.-
EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares without par value.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the shareholder
meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of Shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the Shareholders who represent at least three quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorisation is required for a transfer of shares among the Shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the Shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving Shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the 1915 Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the Shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the Shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of one of the Shareholders or of the sole shareholder will not terminate the Company
to an end.
Art. 12. Management. The Company is managed by a sole Manager or by a Board of Managers composed of two or
several Managers, who need not be Shareholders.
In dealing with third parties, the sole Manager or the Board of Managers has extensive powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The
Managers are appointed by the general meeting of Shareholders. They may be dismissed freely at any time by the general
meeting of Shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole Manager.
If managed by a Board of Managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two
Managers. However, the Company will be validly bound by the sole signature of each Manager for the acts relating to its
daily management.
However, the Board of Managers cannot, without a prior consent of the Shareholders representing at least seventy
per cent (75%) of the Shareholders and resulting from an ordinary decision, enter into engagements which bound the
Company, make bank transfer or enter into agreements for amounts exceeding five thousand euros (EUR 5000).
The Board of Managers may choose from among its members a Chairman. It may also choose a secretary, who need
not be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.
The Board of Managers shall meet upon call by the Chairman or two Managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The Chairman shall preside all meetings of the Board of Managers, but in his absence, the Board of Managers
may appoint another Manager as Chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the Managers at least five days in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by
26660
L
U X E M B O U R G
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Managers.
When the board is composed at least of three Managers, any Manager may act at any meeting of the Board of Managers
by appointing in writing or by facsimile another Manager as his proxy. A Manager may not represent more than one of
his colleagues.
Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented
at a meeting of the Board of Managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the Managers present or
represented at such meeting. In the event that, at any meeting of the Board of Managers, the number of votes for and
against a resolution is equal, the Chairman shall have a casting vote.
The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
or by facsimile, or any other similar means of communication to be confirmed in writing. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by two Managers. Copies or extracts of such
minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by two Managers or by any person
duly appointed to that effect by the Board of Managers.
The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 13. Liability of the Managers. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholder(s). An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting, on the last working day of June at 2.00 p.m. and for the first time in the year 2013.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the Shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the Shareholders.
In case of a plurality of Shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the Shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the 1915 Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of Managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
26661
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled
and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the 1915 Act.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December 2014.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established and twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by:
- Mr. Anthony COSTARD, prequalified, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,625
- Mr. Pierre MATHEY, prequalified, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,625
- Mr. Laurent PICHONNIER, prequalified, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,250
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
All these shares have been fully paid-up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.-
EUR) is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary who confirms.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the Shareholders representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1.- The number of Managers is set at three (3). The meeting appoints as Managers of the Company for an unlimited
period of time:
- Mr. Jean-Luc BUISINE, Head of Recruitment, born on 5 October 1961 at Caudebec-en-Caux (France), residing at
61, Le Cros d'Entassi, 83310 Grimaud (France);
- Mr. Charles ETONDE, Legal Advisor, born on 27 February 1976 in Douala (Cameroon) residing professionally at
53, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
- Mr. Carlo SCONOSCIUTO, Legal Advisor born on 4 May 1977 in Terracina (Italy) residing professionally at 53, Rue
d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
2.- The registered office is established at 53, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with Us,
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le huit janvier.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- Mr. Anthony COSTARD, Avocat, né le 22 juin 1978 à Rennes (France), résident professionnellement au 84, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (France),
- Mr. Pierre MATHEY, Avocat, né le 23 Avril 1977 à Marseille France), résident professionnellement au 84, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (France),
- Mr. Laurent PICHONNIER, Managing Partner de Global Finance Consult (Luxembourg), né le 4 janvier 1972 à
Bordeaux (France) résidant professionnellement au 53, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
Tous ici dûment représentées par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 décembre 2013 à Paris (France).
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer.
26662
L
U X E M B O U R G
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «FAIR PLAY CAPITAL
ADVISORY (LUX) S.À R.L.» (la Société).
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet l'activité de conseiller en investissement au bénéfice de «FAIR PLAY
CAPITAL SIF SICAV S.A.», un fonds d'investissement luxembourgeois soumis aux dispositions de la loi du 13 février 2007
relative aux fonds d'investissement spécialisés; et ce conformément à l'article 1-1 (2) i) de la loi luxembourgeoise du 5
avril 1993 relative au secteur financier telle qu'elle a été modifiée.
La Société pourra aussi agir comme apporteur d'affaire/arrangeur en mettant en relation deux ou plusieurs parties
permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces parties, sans intervenir dans la réception et la transmission
d'ordres.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du Conseil de Gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,-EUR)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sans valeur nominale.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
des associés sinon de l'associé unique, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un gérant unique ou par un Conseil de Gérance composé de deux ou
plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont
nommés par l'assemblée générale des associés. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'assemblée générale
des associés.
La Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique.
Si la gestion est confiée à un Conseil de Gérance, la Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature
conjointe de deux gérants. Cependant, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant,
pour les actes relatifs à sa gestion journalière.
Le Conseil de Gérance ne peut cependant pas, sans l'autorisation préalable résultant d'une décision ordinaire des
associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des parts sociales, contracter des engagements, faire
des virements bancaires ou signer des contrats pour des sommes supérieures à cinq mille euros (5000 EUR).
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui
n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
26663
L
U X E M B O U R G
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en son absence le Conseil de Gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Lorsque le Conseil de Gérance est composé d'au moins trois membres, tout gérant pourra se faire représenter à toute
réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant
ne peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil de Gérance, il y a égalité de voix pour et contre
une décision, la voix du président sera prépondérante.
Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par lettre ou par télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à
confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par deux gérants. Les copies ou
extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par deux gérants ou par toute personne
dûment mandatée à cet effet par le Conseil de Gérance.
Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se
tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convo-
cation à l'assemblée, le dernier jour ouvrable de Juin à quatorze heures, et pour la première fois en 2013.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. Chaque associé peut participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il
possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant
qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le
Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de
pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
26664
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi sur les sociétés commerciales.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi de 1915.
<i>Disposition Transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts ont été déterminés et les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Mr. Anthony COSTARD, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.625
- Mr. Pierre MATHEY, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.625
- Mr. Laurent PICHONNIER, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le confirme.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille euros (1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentés comme ci-avant, représentant la totalité
du capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:
1.- Les membres du Conseil de Gérance sont au nombre de trois (3). Sont nommés gérants pour une durée indéter-
minée:
- M. Jean-Luc BUISINE, Responsable Recrutement, né le 5 octobre 1961 à Caudebec-en-Caux (France), résidant au
61, Le Cros d'Entassi, 83310 Grimaud (France),
- M. Charles ETONDE, Juriste, né le 27 février 1976 à Douala (Cameroun), résidant professionnellement au 53, Rue
d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
- M. Carlo SCONOSCIUTO, Juriste, né le 4 mai 1977 à Terracina (Italie), résidant professionnellement au 53, Rue
d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
2.- Le siège social de la société est établi au 53, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 09.01.2014. Relation: LAC/2014/1110. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.01.2014.
Référence de publication: 2014012277/345.
(140014331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.
26665
L
U X E M B O U R G
Grant Thornton Weber & Bontemps, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 183.690.
STATUTS
L'an deux mille treize, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, résident à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en tant que
mandataire de:
1. M. Ronald WEBER, expert comptable et réviseur d'entreprises agréé, né à Maastricht (Pays-Bas) le 2 août 1953,
domicilié professionnellement au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg,
2. M. Alain TIRCHER, expert comptable, né à Watermael-Boitsfort (Belgique) le 13 mars 1959, domicilié profession-
nellement au 1, rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg,
3. M. Romain BONTEMPS, expert comptable et réviseur d'entreprises agréé, né à Dudelange le 27 décembre 1960,
domicilié professionnellement au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg,
4. M. Jean-Michel HAMELLE, expert comptable, né à Reims (France) le 13 septembre 1962, domicilié professionnel-
lement au 1, rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg,
5. M. Ralph BOURGNON, expert comptable, né à Bâle (Suisse) le 23 juin 1975, domicilié professionnellement au 6,
place de Nancy L-2212 Luxembourg, et
6. «Grant Thornton Participations», une société anonyme, ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Lu-
xembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et par conséquent non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
en vertu de six (6) procurations données sous seing privé en date du 31 décembre 2013.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire des comparants et le notaire ins-
trumentant resteront annexée aux présentes.
Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après
les Statuts) d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et qu'ils ont arrêtés comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Grant Thornton Weber & Bontemps». La
Société pourra également exercer son activité sous le nom commercial «Grant Thornton Tax & Accounting».
Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision de l'administrateur-unique ou du conseil
d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.
4.1. La société a pour objet l'exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou indirectement
de la profession d'expert-comptable, l'expertise comptable, le conseil ou l'assistance dans les domaines de la fiscalité, de
la création, gestion, cession ou restructuration ou finance d'entreprises.
4.2. La société également pour objet d'exercer, à titre indépendant, tout mandat de contrôle ou de surveillance sta-
tutaire, contractuel ou légal, à l'exclusion des missions confiées par la loi aux réviseurs d'entreprises agréés ou à d'autres
professions.
4.3. La Société peut encore exercer toutes activités accessoires à l'objet principal. Elle pourra notamment prendre
des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires et accomplir toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières utiles à son activité.
4.4. La Société n'exercera pas d'activités commerciales et elle n'exercera aucune activité incompatible, de part la
réglementation ou la déontologie applicables, avec ses activités définies sous 4.1..
26666
L
U X E M B O U R G
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000.- EUR) représenté par cinquante mille et vingt-cinq (50.025)
actions de classe A et quarante-neuf mille neuf cent soixante quinze (49.975) actions de classe B, toutes les actions ayant
une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.
Les actions des classes A et B jouissent des mêmes droits sauf que les actions de classe B sont sans droit de vote et
donnent droit à un dividende privilégié et récupérable équivalent au décuple de leur valeur nominale majorée d'un intérêt
capitalisé annuel au taux de 6% et à un boni de liquidation privilégié équivalent au dividende privilégié calculé des cinq
exercices ayant précédé la mise en liquidation de la Société. Les conditions entourant l'acquisition et la détention d'actions
B sont régies dans un contrat de souscription spécifique.
L'assemblée générale statuant avec un quorum et une majorité de cent pourcents (100%) peut décider la conversion
d'actions A en actions B et vice-versa à raison d'une action A pour chaque action B.
Les actions de la Société sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre spécial tenu au siège de la société. Ce
registre contient la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre et des numéros de ses actions,
l'indication des versements effectués, ainsi que les transferts avec leur date. Des certificats constatant ces inscriptions
seront délivrés aux actionnaires.
Sur décision unanime de tous les actionnaires les actions de la Société peuvent aussi être nominatives ou au porteur,
au gré de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Art. 6.
6.1. Sauf accord des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 18 des statuts,
chaque actionnaire s'interdit de gager les actions détenues par lui ou de les faire grever d'une charge quelconque sus-
ceptible d'avoir pour effet d'en transférer le bénéfice économique ou tout ou partie des droits de propriété à autrui.
6.2. L'actionnaire titulaire d'actions de classe A qui souhaite céder tout ou partie de ses actions doit les offrir préala-
blement aux titulaires des actions de classe B aux conditions et modalités définies dans une convention sous seing privé
(le «Pacte d'Actionnaires».
6.3. Lorsque des actionnaires détenant ensemble directement ou indirectement au moins soixante pourcents (60%)
du capital décident de céder leur participation à un tiers, les autres actionnaires auront le droit de subordonner cette
cession à l'acquisition par le tiers de leur propre participation dans le capital; les conditions et modalités en seront définies
dans le Pacte d'Actionnaires6.4. Lorsque des actionnaires détenant ensemble directement ou indirectement au moins
soixante pourcents (60%) du capital décident de céder leur participation à un tiers, ils auront le droit de requérir des
autres actionnaires qu'ils cèdent également leur participation à ce tiers aux conditions et modalités définies dans le Pacte
d'Actionnaires.
6.5. Les actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 18 des statuts pourront
décider le rachat des actions détenues par un ou plusieurs actionnaires aux conditions et modalités définies dans le Pacte
d'Actionnaires.
6.6. Tout candidat acquéreur d'actions de la Société devra préalablement avoir été agréé par les actionnaires statuant
aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 18 des statuts et devra préalablement avoir adhéré au Pacte
d'Actionnaires. Il en ira de même de tout héritier ou ayant droit d'un actionnaire. La Société s'interdit l'inscription au
registre des actionnaires de détenteurs d'actions non-agréés ou n'ayant pas adhéré au Pacte d'Actionnaires.
6.7. Chaque actionnaire peut obtenir sans frais et sur demande adressée à la Société, un exemplaire de la dernière
version du Pacte d'Actionnaires. Ce contrat sous seing privé définit également le prix de cession applicable dans différents
cas de figure et d'autres modalités et conditions entourant la détention d'actions.
Titre III. Administration
Art. 7. La Société est administrée en cas d'un actionnaire unique par un administrateur unique ou par un conseil
d'administration ou en cas de pluralité d'actionnaires par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années par l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur unique ou les membres du Conseil peuvent être élus, réélus et révoqués avec ou sans motif à tout
moment par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 18 des statuts.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoi-
rement, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
26667
L
U X E M B O U R G
Art. 8.
8.1. En cas d'existence d'un conseil d'administration, le conseil d'administration pourra élire parmi ses membres un
président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
8.2. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné par lettre recommandée et courriel à l'adresse courriel
professionnelle à tous les administrateurs au moins quatorze jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. En cas de
convocation à une réunion qui a été reportée faute de quorum ce délai est ramené à deux jours. Les convocations doivent
inclure l'ordre du jour et la documentation de support nécessaire à préparer une prise de décision. Il pourra être passé
outre à cette convocation ou à certains aspects formels relatifs à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
8.3. Pour les décisions qui ne requièrent pas l'approbation formelle de l'assemblée générale le conseil d'administration
pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si la majorité de ses membres sont présents ou repré-
sentés par procurations. Les résolutions ne sont adoptées que si les votes favorables atteignent au moins une majorité
simple.
8.4. Pour les décisions qui requièrent l'approbation formelle de l'assemblée générale le conseil d'administration pourra
seulement valablement délibérer et prendre des décisions si tous ses membres sont présents ou représentés par pro-
curations. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou messagerie électronique un autre administrateur comme son man-
dataire. Sur accord de l'assemblée générale un administrateur pourra se faire représenter par un tiers en cas de motifs
graves et légitimes. Un administrateur ou un tiers ne pourra représenter qu'un seul administrateur. Toute décision prise
par le conseil d'administration sera adopté à la majorité des quatre cinquièmes. Le président du conseil d'administration
éventuellement nommé n'aura pas de voix prépondérante.
8.5. Si le quorum requis sous 8.4. n'est pas atteint lors d'une première réunion, celle-ci est reportée d'au minimum
sept jours et d'au maximum quatorze jours avec un ordre du jour identique. Lors de cette réunion le quorum requis sera
de trois quarts et les résolutions seront adoptées à la majorité des quatre cinquièmes (4/5). Si le quorum requis n'est pas
atteint lors de la deuxième réunion, celle-ci est reportée d'au minimum trois jours et d'au maximum sept jours avec un
ordre du jour identique. Lors de cette réunion le quorum requis sera de 51% et les résolutions seront adoptées à la
majorité des quatre cinquièmes (4/5).
8.6. Les votes nuls et abstentions ne seront pas pris en compte pour la détermination des conditions de majorité au
sein du conseil d'administration.
8.7. Les procès-verbaux des réunions seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion. Le cas échéant
l'avis de convocation et les procurations paraphés par les signataires seront annexés au procès-verbal. Les copies ou
extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux adminis-
trateurs. Lorsque la Société est gérée par un administrateur unique, ce dernier signera.
8.8. Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer par le biais d'une conférence téléphonique ou par tout autre
moyen de télécommunication permettant à différentes personnes de participer à la même réunion et de communiquer
entre eux. Une telle participation est à considérer comme étant égale à une présence physique. Une telle décision peut
être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu signé par tous les membres
ayant participé à la réunion.
8.9. Le Conseil d'administration peut prendre différentes décisions par des résolutions circulaires, si l'approbation est
faite par écrit, câble, télégramme, télex, télécopieur, messagerie électronique ou tout autre moyen de communication
agréé. Une telle décision peut être documentée sur un seul document ou sur plusieurs documents ayant le même contenu
signé par tous les membres ayant participé à la réunion.
Art. 9. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-
dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. L'administrateur unique ou le cas échéant le conseil d'administration préparera une situation intérimaires des comp-
tes de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
26668
L
U X E M B O U R G
Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou en
cas d'existence d'un conseil d'administration par la signature conjointe de tous les administrateurs, ou par la signature
conjointe des administrateurs-délégués ou la signature individuelle de l'administrateur délégué unique, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.
Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. Les opérations suivantes sont
soumises à l'approbation formelle de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par
l'article 18 des statuts:
1. Toute décision de nature à affecter matériellement le mode de fonctionnement, la performance et les résultats de
la Société ou l'engageant sur le long terme qui implique des dépenses, des risques ou des manques à gagner dépassant un
montant de cent mille euros (€100.000) ou tout autre montant fixé par l'assemblée générale en considérant la durée
totale pendant laquelle la décision génère des conséquences;
2. Création, liquidation, restructuration de filiales, acquisition ou cession d'un fonds de commerce;
3. Nomination d'un administrateur délégué et définition du périmètre de ses attributions;
4. Adhésion à un réseau international ou local de cabinets professionnels;
5. Embauche de cadres dont l'enveloppe globale annuelle dépasse la limite de 80% du montant annuel du salaire fixe
mensuel d'un administrateur salarié de la Société;
6. Modifications du système informatique ou de procédures impactant matériellement des outils et procédures définies
dans le règlement interne applicable au réseau international et/ou au groupe dont la Société fait partie;
7. Lancement de toute activité ou acceptation de mandats substantiels rentrant dans le périmètre du métier principal
d'une autre filiale du groupe dont la Société fait partie;
8. Définition d'un plan de développement stratégique;
9. Toute autre décision impactant matériellement plusieurs métiers exercés au sein du groupe dont la Société fait
partie ou le métier d'une autre filiale du groupe dont la Société fait partie;
10. Toute modification des statuts d'une filiale du groupe dont la Société fait partie ou d'une entité dans laquelle la
Société ou ce groupe détient une participation;
11. Les décisions relatives aux questions 1 à 10 ci-devant à prendre au niveau d'une filiale de la Société.
Sous réserve de l'approbation formelle de l'assemblée générale qui sera le cas échéant requise, le conseil d'adminis-
tration peut
- définir l'étendue du champ de la gestion journalière de la Société et peut la déléguer à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
- aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs
directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé
de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.
- également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 13. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le deuxième lundi du mois de Juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action avec droit de vote donne droit à une voix. Les conditions de quorum et de majorité applicables sont
définies à l'article 18 des statuts et s'appliquent par rapport au nombre d'actions, le cas échéant uniquement celles avec
droit de vote.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.
26669
L
U X E M B O U R G
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 18.
18.1. L'assemblée générale pourra seulement valablement délibérer et prendre des décisions si tous les actionnaires
sont présents ou représentés par procurations. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée en dé-
signant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou messagerie électronique un autre actionnaire comme
son mandataire. Sur accord de l'assemblée générale un actionnaire pourra se faire représenter par un tiers en cas de
motifs graves et légitimes. Un actionnaire ou un tiers ne pourra représenter qu'un seul actionnaire. Toute décision prise
par l'assemblée sera adoptée à la majorité des quatre cinquièmes.
18.2. Si le quorum requis n'est pas atteint lors d'une première assemblée, celle-ci est reportée d'au minimum sept
jours et d'au maximum quatorze jours avec un ordre du jour identique. Lors de cette assemblée le quorum requis sera
de trois quarts et les résolutions seront adoptées à la majorité des quatre cinquièmes (4/5). Si le quorum requis n'est pas
atteint lors de la deuxième assemblée, celle-ci est reportée d'au minimum trois jours et d'au maximum sept jours avec
un ordre du jour identique. Lors de cette assemblée le quorum requis sera de 51% et les résolutions seront adoptées à
la majorité des quatre cinquièmes (4/5).
18.3. Il sera admis que les actionnaires personnes morales tiennent simultanément avec l'assemblée et au sein de celle-
ci un conseil d'administration mais uniquement pour déterminer les votes de l'actionnaire qu'ils représentent par rapport
aux résolutions à adopter par l'assemblée.
18.4. Les conditions de quorum s'appliquent par rapport à l'ensemble des actions A et B. Les abstentions seront prises
en compte pour la détermination des conditions de majorité au sein de l'assemblée.
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 Décembre 2014.
2. La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015.
3. Le Pacte d'Actionnaires conclu sous seing privé auquel il est fait référence dans les présents statuts est complété
par une convention de fusion. Tant que cette dernière convention restera en vigueur il faudra considérer l'effet combiné
des deux documents.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent mille (100.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société ont toutes été souscrites inté-
gralement comme suit:
Actionnaire
Actions A
Actions B
M. Ronald WEBER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.005 actions
/
M. Alain TIRCHER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.005 actions
/
M. Romain BONTEMPS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.005 actions
/
M. Jean-Michel HAMELLE, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.005 actions
/
M. Ralph BOURGNON, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.005 actions
/
«Grant Thornton Participations», prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 actions 49.975 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.025 actions 49.975 actions
Les cent mille (100.000) actions ont toutes été libérées à raison de vingt-cinq pourcents (25%), de sorte que le montant
de vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate.
26670
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés
de 1915, et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux
dispositions de l'article 27 de la Loi sur les Sociétés de 1915.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent vingt
euros (1.320,- EUR).
<i>Résolutions des actionnaires:i>
Les actionnaires, représentés comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à six (6) et de commissaire à un (1).
2. Sont nommés Administrateurs de la Société:
- M. Ronald WEBER, prénommé, né à Maastricht (Pays-Bas) le 2 août 1953, domicilié professionnellement au 6, place
de Nancy, L-2212 Luxembourg, et
- M. Charles EMOND, prénommé, né à Arlon (Belgique) le 28 mars 1955, domicilié professionnellement au 1, rue
Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, et
- M. Alain TIRCHER, prénommé, né à Watermael-Boitsfort (Belgique) le 13 mars 1959, domicilié professionnellement
au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, et
- M. Romain BONTEMPS, prénommé, né à Dudelange le 27 décembre 1960, domicilié professionnellement au 6, place
de Nancy, L-2212 Luxembourg, et
- M. Jean-Michel HAMELLE, prénommé, né à Reims (France) le 13 septembre 1962, domicilié professionnellement au
1, rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg, et
- M. Ralph BOURGNON, prénommé, né à Bâle (Suisse) le 23 juin 1975, domicilié professionnellement au 6, place de
Nancy, L-2212 Luxembourg.
3. Est nommée commissaire de la Société:
«Compliance & Control» une société anonyme ayant son siège social au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg (RCS
Luxembourg B 172.482).
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année
2019.
5. Le siège social de la Société est fixé au 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la mandataire des comparants, connue du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,
celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 06/01/2014. Relation: LAC/2014/642. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.01.2014.
Référence de publication: 2014012310/316.
(140014364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Pioneer P.F., Fonds Commun de Placement.
The amended management regulations with respect to the fund PIONEER P.F. have been filed with the Luxembourg
Trade and Companies Register.
Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement PIONEER P.F. a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pionneer Asset Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2014022335/12.
(140026484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.
26671
L
U X E M B O U R G
Eurizon Strategia Flessibile, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion (modifié/coordonné) au 24-01-2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal & Financei>
Référence de publication: 2014027187/11.
(140032949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2014.
Boduhura Resort S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 91.707.
CLOTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and thirteen.
On the thirty first day of July.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "BODUHURA RESORT S.A., in
voluntary liquidation", with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg section B number 91707 (the "Company"), incorporated by deed of Maître André-Jean-Joseph
SCHWACHTGEN, then notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on February 17, 2003, published
in the Mémorial C number 285 of March 18, 2003, and which has been put into liquidation by deed of the undersigned
notary, on July 31, 2013, in process of registration with the Memorial C.
The corporate capital amounts to one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) divided into three million one hundred
and eighty seven thousand (3,187,000) shares without nominal value.
The meeting is presided by Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster.
The chairman appoints as secretary Ms Françoise HÜBSCH, employee, residing professionally in Junglinster.
The meeting elects as scrutineer Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an
attendance list, which after having been checked and signed by the shareholders who are present, the proxy holders of
the represented shareholders and the undersigned notary, shall be kept at the latter's office.
The proxies of the represented shareholders, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting
is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the audit report.
2. Acknowledgement of the allocation to the Company's shareholders of the shares of the Company's Spanish subsi-
diary, the company UNION HOTELERA BARCELO, carried out by the liquidator, the private limited company I.L.L.
Services S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B153141, with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte.
3. Discharge to the liquidator, the private limited company I.L.L. Services S.à r.l., pre-named, for the performance of
its mandate.
4. Closing of the liquidation.
5. Fixing of the place where the company's documents and vouchers are to be kept.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve the audit report and the liquidation accounts.
26672
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The meeting acknowledges that the liquidator, the private limited company, I.L.L. Services S.à r.l., pre-named, has
allocated to the Company's shareholders the shares of the Company's Spanish subsidiary, the company UNION HO-
TELERA BARCELO, as follows:
Mr. Gabriel BARCELÓ OLIVER - 1,593,500 shares (shares from 18,793,501 to 20,387,000);
Mrs. María TOUS JAUME - 580,755 shares (shares from 17,200,001 to 17,780,755);
Mrs. María-Lourdes BARCELÓ TOUS - 202,549 shares (shares from 18,388,403 to 18,590,951);
Mrs. María-Inmaculada BARCELÓ TOUS - 202,549 shares (shares from 18,590,952 to 18,793,500);
Mr. Simón BARCELÓ TOUS - 202,549 shares (shares from 17,983,305 to 18,185,853);
Mrs. Antonia BARCELÓ TOUS - 202,549 shares (shares from 17,780,756 to 17,983,304);
Mr. Guillermo BARCELÓ TOUS - 202,549 shares (shares from 18,185,854 to 18,388,402).
The liquidation report mentioning the above allocation, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties
and the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to give, without reserve nor restriction, full and entire discharge to the private limited company
I.L.L Services S.á r.l., pre-named, for the performance of its mandate as liquidator of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to close the liquidation and acknowledges the definitive cessation of the Company.
Fifth resolution The meeting decides to keep the company's documents and vouchers during the five years following
the closing of the liquidation at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 1,000.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the
attorney the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney, in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BODUHURA RESORT S.A., en liquidation volontaire"
ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
91707 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 février 2003, publié au Mémorial C numéro 285
du 18 mars 2003, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du... 2013, en cours de
publication au Mémorial C.
Le capital social s'élève à cent mille Euros (EUR 100.000,-) représenté par trois millions cent quatre-vingt-sept mille
(3.187.000) actions sans désignation de valeur nominale.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le président désigne comme secrétaire Madame Françoise HÜBSCH, employée demeurant professionnellement à
Junglinster.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
26673
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par les actionnaires présents les mandataires de ceux
représentés, et par le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire
instrumentant, demeureront annexées au présent acte lequel elles seront enregistrées.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Constatation de la répartition aux actionnaires de la Société des actions de la filiale espagnole de la Société, la société
UNION HOTELERA BARCELO, procédée par le liquidateur, la société à responsabilité limitée I.L.L. Services S.à r.l.,
R.C.S. Luxembourg B153141, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Décharge à donner au liquidateur, la société à responsabilité limitée I.L.L. Services S.à r.l., pré-nommée, pour l'exé-
cution de son mandat.
4. Clôture de la liquidation.
5. Destination à donner aux archives.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver le rapport du commissaire-vérificateur et d'approuver les comptes de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que le liquidateur, la société à responsabilité limitée I.L.L. Services S.à r.l., pré-nommée, a procédé
à la répartition aux actionnaires de la Société des actions de la filiale espagnole de la Société, la société UNION HOTELERA
BARCELO, de la manière suivante:
M. Gabriel BARCELÓ OLIVER - 1.593.500 actions (actions de 18.793.501 à 20.387.000);
Mme María TOUS JAUME - 580.755 actions (actions de 17.200.001 à 17.780.755);
Mme María-Lourdes BARCELÓ TOUS - 202.549 actions (actions de 18.388.403 à 18.590.951);
Mme María-Inmaculada BARCELÓ TOUS - 202.549 actions (actions de 18.590.952 à 18.793.500);
M. Simón BARCELÓ TOUS - 202.549 actions (actions de 17.983.305 à 18.185.853);
Mme Antonia BARCELÓ TOUS - 202.549 actions (actions de 17.780.756 à 17.983.304);
M. Guillermo BARCELÓ TOUS - 202.549 actions (actions de 18.185.854 à 18.388.402).
Le rapport du liquidateur mentionnant la répartition ci-dessus, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants
et le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte lequel il sera enregistré.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à la société à responsabilité limitée I.L.L Services S.à r.l., pré-
nommée, pour sa gestion comme liquidateur de la Société, sans réserve ni restriction.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation et constate que la Société a cessé définitivement d'exister.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans
à partir de la clôture de la liquidation à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 1.000,- EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-
dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
26674
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bob PLEIN, Françoise HÜBSCH, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 août 2013. Relation GRE/2013/3260. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014030927/150.
(140034578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 9.462.
Une modification des personnes qui ont droit de signature pour la société a été déposée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25.02.2014.
Gerd Kiefer / Katja Wilbert.
Référence de publication: 2014031001/11.
(140034748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
The CMI Managed Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 86.898.
Universe, The CMI Global Network Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 33.463.
In the year two thousand and fourteen on the eighteenth day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
There appeared:
1. THE CMI MANAGED FUND, a public limited company by shares ("société anonyme") qualifying as a "société
d'investissement à capital variable", having its registered office at 36, Rangwee, L-2412 Luxembourg (hereafter the "Com-
pany" or the “Existing Company”) represented by Me Laetitia Servais, Avocat à la Cour, professionally residing in
Luxembourg, on the basis of a proxy dated 18 February 2014 which shall remain attached to the original of this deed in
order to be registered with this deed;
2. UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, a public limited company by shares ("société anonyme") qua-
lifying as a "société d'investissement à capital variable" having its registered office at 36, Rangwee, L-2412 Luxembourg,
(hereafter the "Continuing Company") represented by Me Laetitia Servais, prenamed, on the basis of a proxy dated 18
February 2014 which shall remain attached to the original of this deed in order to be registered with this deed;
who declared the following:
1) The Company is a "société d'investissement à capital variable" incorporated as a public limited company by shares
("société anonyme") in Luxembourg on 18 April 2002 for an unlimited period in the form of an umbrella structure with
multiple compartments with different portfolios of assets (each, an "Existing Fund", collectively, the "Existing Funds"). The
Company is subject to part II of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective in-
vestment, as amended (the "Law").
2) The Continuing Company is a "société d'investissement à capital variable" incorporated as a public limited company
by shares (“société anonyme") in Luxembourg on 12 April 1990 for an unlimited period in the form of an umbrella
structure with multiple compartments with different portfolios of assets (each, a "Continuing Fund", collectively, the
"Continuing Funds"). The Continuing Company is subject to part I of the Law.
The Existing Funds in which shares are in issue on the Effective Date (as defined hereinafter) will be merged with the
corresponding Continuing Funds as detailed in the table hereinafter.
Existing Funds
Continuing Funds
The CMI Managed Fund - Sterling
Cautious Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Sterling Cautious Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Sterling
Balanced Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Sterling Balanced Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Sterling
Adventurous Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Sterling Adventurous Managed Sub-Fund, class 2
26675
L
U X E M B O U R G
The CMI Managed Fund - Dollar
Cautious Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Dollar Cautious Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Dollar
Balanced Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Dollar Balanced Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Dollar
Adventurous Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Dollar Adventurous Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Euro
Cautious Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Euro Cautious Managed SubFund, class 2
The CMI Managed Fund - Euro
Balanced Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Euro Balanced Managed SubFund, class 2
The CMI Managed Fund - Euro
Adventurous Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network
Fund - Euro Adventurous Managed Sub-Fund, class 2
The board of directors of the Company and the board of directors of the Continuing Company have approved the
common merger proposal for the following reasons:
By 23
rd
July 2014, investment funds such as the Existing Company (which does not qualify as a UCITS) must have to
comply with the requirements of the Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8
th
June
2011 on Alternative Investment Fund Managers (the "AIFM Directive"). Although the requirements of the AIFM Directive
are specifics to alternative investment funds, a number of the requirements are similar to the ones required by the laws
and regulations applicable to UCITS.
In addition, pursuant to the provisions of the Law, a sub-fund of a UCITS is now allowed to invest its assets in other
sub-funds of the same UCITS ("crossed sub-fund investment"). This means that it is now possible for the Existing Funds,
whose current investment policy is to invest in sub-funds of the Continuing Company, to be merged into the Continuing
Company without having to change the overall investment philosophy of the Existing Funds but taking into account the
investment restrictions applicable to UCITS.
After careful analysis of the cost versus benefit for the Existing Company to be compliant with the AIFM Directive,
the board of directors of the Existing Company believes the interests of investors will be better served if the Existing
Company is merged with the Continuing Company.
In addition, by merging the Existing Company into the Continuing Company, shareholders of the Existing Company
and of the Continuing Company will benefit from the advantages associated with superior scale due to the increased size
of assets under management further to the merger. The merger should therefore provide economics of scale, with the
expectations that this should ensure reduced costs in the future.
By becoming shareholders of the Continuing Company, the existing shareholders of the Existing Company will benefit
from the UCITS status (including the simplified registration / distribution possibilities in other Member States of the EU).
Contrary to the Existing Funds, the Continuing Funds fall within the scope of the European Savings Directive.
All expenses, costs and charges of the merger will be borne by the Company.
NOW THEREFORE IT IS AGREED, subject to (i) the provisions of paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall
be approved by the directors of the Company and/or of the Continuing Company pursuant to regulatory requirements,
that:
1) On 27 June 2014, after the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company required by the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "1915 Law") approving the merger (or if required by one
or more shareholders of the Continuing Company holding at least 5% of the shares outstanding of the Continuing Com-
pany, after the extraordinary general meeting of the shareholders of the Continuing Company approving the merger), or
on such other date as the extraordinary general meeting of the Company shall decide upon the chairman's proposal (this
date being not later than six months after the date of the extraordinary general meeting) as the effective date of the
merger (the "Effective Date"), the Company shall automatically contribute all the assets and liabilities of the Existing Funds
to the corresponding Continuing Funds within the Continuing Company, pursuant to section XIV of the 1915 Law.
2) The Continuing Company will issue to the benefit of the shareholders of the Company shares in the following class
and sub-fund of the Continuing Company:
Merger of The CMI Managed Fund
into Universe, the CMI Global Network Fund
The CMI Managed Fund - Sterling
Cautious Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Sterling Cautious Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Sterling
Balanced Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Sterling Balanced Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Sterling
Adventurous Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Sterling Adventurous Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Dollar
Cautious Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Dollar Cautious Managed Sub-Fund, class 2
26676
L
U X E M B O U R G
The CMI Managed Fund - Dollar
Balanced Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Dollar Balanced Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Dollar
Adventurous Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Dollar Adventurous Managed Sub-Fund, class 2
The CMI Managed Fund - Euro
Cautious Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Euro Cautious Managed SubFund, class 2
The CMI Managed Fund - Euro
Balanced Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Euro Balanced Managed SubFund, class 2
The CMI Managed Fund - Euro
Adventurous Managed Sub-Fund, Class B
Universe, the CMI Global Network Fund -
Euro Adventurous Managed Sub-Fund, class 2
Holders of shares in the Existing Funds will receive one share of class 2 shares of the relevant corresponding Continuing
Funds for each share they hold in the Existing Funds on the Effective Date. The base currency of the share class in which
shareholders will be invested as a result of the merger will be identical to the base currency of the share class in which
they are currently invested.
3) All new shares in the relevant Continuing Funds will be issued in registered form.
The registrar and transfer agent of the Continuing Company will allocate the new shares to the former shareholders
of the Company, on the basis of data contained in the register of shareholders of the latter on the Effective Date.
As from the Effective Date, shares in the relevant Continuing Funds issued to shareholders of the Existing Funds will
carry the right to participate in the profits of the relevant Continuing Funds.
4) As a result of the merger, the Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
5) As from the Effective Date, all assets and liabilities of the Company shall be deemed transferred to the Continuing
Company on the accounts of the respective Continuing Funds as aforesaid.
For accounting purposes, all operations of the Company shall be considered as operations of the Continuing Company
as from the Effective Date.
6) None of the shareholders of the Continuing Company have any special rights and no preferred shares have been
issued in the share capital of the Continuing Company.
7) Neither the board of directors of the Company and the Continuing Company, nor the auditors of the Company
and the Continuing Company, nor any third person involved with the proposed merger shall obtain any benefit in con-
nection with the merger.
Unless shareholders of the Continuing Company holding at least five per cent (5%) of the shares outstanding in the
Continuing Company so require on or prior to the day following the date of the extraordinary general meeting of
shareholders of the Company approving the merger on the basis of article 264 of the 1915 Law, the merger will be
implemented without a resolution of a general meeting of shareholders of the Continuing Company.
This common merger proposal, the special reports on the merger issued by PricewaterhouseCoopers for the Company
and for the Continuing Company, the reports of the boards of directors of the Company and the Continuing Company,
the financial reports containing the audited annual accounts and annual reports of the last three years of the Company
and the Continuing Company and the prospectus of the Continuing Company are available for inspection to the share-
holders of the Company and Continuing Company and copies thereof may be obtained free of charge on request by such
shareholders at the registered offices of the Company and Continuing Company.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Common Merger Plan and of all acts, docu-
ments and formalities incumbent on the Merging Parties pursuant to the Law.
The undersigned notary, who understands English, states herewith that on request of the above appearing persons
and in accordance with article 95(1) of the Law, this deed is worded in English.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.
Signé: L. SERVAIS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 février 2014. Relation: LAC/2014/7864. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2014.
Référence de publication: 2014031437/150.
(140034131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.
26677
L
U X E M B O U R G
ACQ, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 177.376.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen Herrn Gaston Alfred Mainz, beruflich ansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, mit Wirkung zum 24. Februar 2014 und bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, welche
im Jahr 2014 stattfindet, als neues Verwaltungsratsmitglied im Wege der Kooptierung zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014031542/11.
(140035418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2014.
Daytona Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 151.796.
In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of February.
Before us Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch, acting in replacement of Maître Gérard LECUIT, notary
residing in Luxembourg, to whom the present deed will remain.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of DAYTONA FUND (the Shareholders), a Lu-
xembourg société d'investissement à capital variable (investment company with variable capital) incorporated as a société
anonyme (public limited liability company ) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés et Associations under number B 151.796 (the Company). The Company was incorporated on 9 March
2010 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
number 586 dated March 19, 2010. The Articles have not been amended since then.
The Meeting is opened at 11.00 a.m. by Mrs. Valérie Glane, employee, professionally residing in Luxembourg (the
Chairman). The Chairman appoints Mr. Laurent Cromlin, employee, professionally residing in Luxembourg, as secretary
of the Meeting (the Secretary). The meeting elected Mr. Pierre Buisseret, professionally residing in Luxembourg, as
scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and Scrutineer are collectively hereafter referred
to as the Members of the Bureau or the Bureau.
The Bureau thus having constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. The agenda of the Meeting is as follows:
1. To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
2. To resolve on the appointment of KPMG, represented by Mr. Zia Hossen.
3. To determine the powers to be given to the liquidator of the Company and its remuneration.
4. To resolve on the appointment of Deloitte S.A. as auditor to the liquidation.
5. To grant discharge to the Directors and Auditors for the activities performed from 1
st
January, 2013 until the date
of liquidation.
6. Miscellaneous.
II. That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda and published:
13 January and 31 January 2014 in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 104 and 280 and in the
"Luxemburger Wort" and "Tageblatt".
and by registered letter dated 9 January 2014 to the shareholders.
The relevant excerpts are at the disposal of the meeting.
III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of (9.703,-) (nine thousand seven hundred three
shares) actually outstanding, (1.798,-) (one thousand seven hundred ninety eight shares) are duly represented at the
present general meeting. As a first meeting with the same agenda dated December, 27
th
, 2013 before Maître Gérard
Lecuit, had not been validly constituted and had accordingly not been authorized to deliberate failing the required quorum,
the present meeting can validly decide on all the items of the agenda whatever the proportion of the represented capital
may be.
26678
L
U X E M B O U R G
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to dissolve and liquidate the Company with effect as on this day.
Vote for: 849 shares
Vote against: /
Abstention: 949/
Therefore the Meeting ratifies and approves this resolution with a majority of all the shareholders present or repre-
sented and authorized to vote.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint, as liquidator of the Company, KPMG Luxembourg, Société à responsabilité limitée,
a company with registered office at Luxembourg, 9, allée Scheffer, duly registered with the Luxembourg Trade Register
under section B number 149.133. represented by Mr Zia Hossen,.
Vote for: 849 shares
Vote against: /
Abstention: 949/
Therefore the Meeting ratifies and approves this resolution with a majority of all the shareholders present or repre-
sented and authorized to vote.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to confer to the liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the law of 10
th
August
1915 governing commercial companies, as amended, (the «Law»).
The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The liquidator may, under his sole
responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni
de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the
books of the Company.
The liquidator shall be shall be remunerated according to standard usage.
Vote for: 849 shares
Vote against: /
Abstention: 949/
Therefore the Meeting ratifies and approves this resolution with a majority of all the shareholders present or repre-
sented and authorized to vote.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to appoint, as auditor to the liquidation of the Company, Deloitte S.A., with registered office at
L-2220 Luxembourg, 560, Rue de Neudorf, RCS Luxembourg B-67.895.
Vote for: 849 shares
Vote against: /
Abstention: 949/
Therefore the Meeting ratifies and approves this resolution with a majority of all the shareholders present or repre-
sented and authorized to vote.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to grant discharge to the Directors and the Auditors for the period from 1
st
January, 2013 until
the date of liquidation.
Vote for: 849 shares
Vote against: /
Abstention: 949/
Therefore the Meeting ratifies and approves this resolution with a majority of all the shareholders present or repre-
sented and authorized to vote.
There being no further business, the Meeting is closed at 11.30 a.m.
26679
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at one thousand Euro (EUR 1,000,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of
the law of Law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons, appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Signé: V. GLANE, L. CROMLIN, P. BRUISSERET, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2014. Relation: LAC/2014/7715. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2014.
Référence de publication: 2014031651/113.
(140035721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2014.
Casadores Investments, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.335.
<i>Extrait résolution des administrateurs en date du 09/01/2014i>
<i>Première résolutioni>
Par la présente résolution circulaire, l'associé-gérant commandité, Casadores Management, de la société, décide de
transférer son siège social ainsi que celui de la société Casadores Investments S.C.A., SICAV-FIS du 2, Boulevard Konrad
Adenauer L-1115 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
Finexis S.A.
Référence de publication: 2014010673/15.
(140012049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.100.
DISSOLUTION
In the year two thousand thirteen, on the twenty-seventh day of December.
Before the undersigned Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
JSC BTA Bank, a company incorporated under the laws of the Republic of Kazakhstan, with registered office at 97,
Zholdasbekov str., Samal 2 Microdistrict, 050051, Almaty, the Republic of Kazakhstan (the "Sole Shareholder"),
represented Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting in the name and on behalf of,
by virtue of a proxy given on 20 December 2013.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company "BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank" (the "Company"), having its
registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by the deed of Me Paul Bettingen, notary
residing in Niederanven on 22 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 1335, dated 6 December 2005.The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended
for the last time pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 25 May 2010, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1464, dated 30 July 2010.
26680
L
U X E M B O U R G
- that the capital of the Company is fixed at forty-three thousand two hundred dollars of the United States of America
(USD 43,200.-) divided into twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Shares and four thousand (4,000)
Securities. Each issued Share has a nominal value of one point fifty dollars of the United States of America (USD 1.50)
and is fully paid up;
- that Sole Shareholder, prenamed, has become owner of all the shares and declares that it has full knowledge of the
articles of incorporation and the financial standing of the Company;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 2 December 2013 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 2 December 2013 being only one information for
all purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the members of the Board of Directors of the Company are hereby granted discharge applicable to the information
and data contained in the Company's financial statements up to the date of liquidation of the Company, provided that
these financial statements of the Company do not contain any omissions or false statements of material facts;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued shares and the shareholders register;
- the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at L-1855 Luxembourg, 46A,
avenue J.F. Kennedy.
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to
the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to
be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved
and liquidated has demanded the creation of security.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand nine hundred euros (EUR 1,900.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
JSC BTA Bank, une société constituée selon les lois de la République du Kazakhstan, ayant son siège social au 97,
Zholdasbekov str., Samal 2 Microdistrict, 050051, Almaty, Kazakhstan (l "Actionnaire Unique")
ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration sous seing privé datée du 20 décembre 2013.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank, ayant son siège social à L-1855.
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, (la «Société») a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire
de résidence à Niederanven en date du 22 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1335 du 6 décembre 2005. Les statuts de la société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 mai 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1564 du 30 juillet 2010;
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à quarante-trois mille deux cents dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique (USD 43.200,-) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions de Catégorie A et quatre mille (4.000) Titres.
26681
L
U X E M B O U R G
Chaque Action émise a une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante cents (USD 1,50.-),
chacune entièrement libérée;
- que l'Actionnaire Unique, précité, étant devenu seul propriétaire de toutes les actions et qu'il déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution
anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 2 décembre 2013,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 2 décembre 2013 étant seulement un
des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge est accordée aux administrateurs de la Société sur les informations et données contenues dans les états
financiers jusqu'à la date de liquidation de la Société sous réserve que ces états financiers de la Société ne contiennent
pas d'omission ou de fausses déclarations sur des faits significatifs;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1855 Luxembourg,
46A, avenue J.F. Kennedy.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'ac-
tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille neuf cents euros (EUR 1.900.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses noms, prénom
usuels, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: NEZAR, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60452. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 janvier 2014.
Référence de publication: 2014010663/118.
(140012964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
Broome S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 95.234.
DISSOLUTION
L'an deux mille treize.
Le trente et un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société de droit italien FIDUCIARIA POLDI ALLAI S.r.l., ayant son siège social à Parma I-43121(Italie), Str. Calroll
23 (Nr Inscrizione Rag. Imprese Di Parma e Cod- Fisc 92057670340)
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3,
route de Luxembourg,
26682
L
U X E M B O U R G
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
I.- Que la société anonyme BROOME S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider,
R.C.S. Luxembourg numéro B95.234, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé,
en date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 956 du 17 septembre 2003.
II.- Que le capital social de la société anonyme BROOME S.A. pré-désignée, s'élève actuellement à EUR 35.000,- (trente-
cinq mille Euros) représenté par 350 (trois cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros)
chacune.
III.- Que le comparant est l'actionnaire unique de la prédite société BROOME S.A.
IV.- Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la société BROOME S.A. qui a interrompu ses activités.
V.- Que le comparant se désigne comme liquidateur de la société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
VI.- Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la société dissoute.
VII.- Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la
société indiqué au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la société BROOME S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement
close.
IX.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et administrateur délégué de la société dissoute
pour l'exécution de leurs mandats ainsi qu'au commissaire.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société
dissoute.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme 1.400,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise, à la requête de cette même personne et en
cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and thirteen.
On the thirty first day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
The company under the laws of Italy FIDUCIARIA POLDI ALLAI S.r.l., having its registered office at Parma I-43121
(Italy), Str. Calroll 23 (Nr Inscrizione Rag. Imprese Di Parma e Cod- Fisc 92057670340)
here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party declared and requested the notary to act:
I.- That the public limited company (société anonyme) BROOME S.A.,, with registered office at L-2522 Luxembourg,
6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg number B95.234, has been incorporated by deed of Maître Jean SECKLER,
notary prenamed, on the 29
th
June 2003, published in the Mémorial C number 956 of the 17
th
September 2003.
II.- That the capital of the company BROOME S.A., pre-named, presently amounts to EUR 35,000 (thirty five thousand
Euro), represented by 350 (three hundred and fifty) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per
share each.
III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named company BROOME S.A..
26683
L
U X E M B O U R G
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company BROOME S.A.,, which has discon-
tinued all activities.
V.- That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any
existing debt of the Company pursuant to point VI.
VIII.- That the liquidation of the company BROOME S.A., is completed and that the company is to be construed as
definitely terminated.
IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent directors and "Commissaire" of the dissolved company
for the performance of their assignment.
X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at the former registered office of the
company.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the present deed, is approximately EUR 1,400.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2014. Relation GRE/2014/176. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 21 janvier 2014.
Référence de publication: 2014010662/98.
(140012716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
Blue Dolphin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 140.823.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausenddreizehn, den achtzehnten Tag im Monat Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.
Sind erschienen:
1) Frau Miriam NEUMANN geborene HAU, Hausfrau, geboren am 16. Mai 1961 in Rüdesheim (Deutschland), wohnhaft
in D-81827 München, Am Eulenhorst 64 (Deutschland);
2) Herr Dr. Klaus-Günter NEUMANN, Kieferorthopäde, geboren am 10. September 1953 in Offenbach (Deutschland),
wohnhaft in D-81827 München, Am Eulenhorst 64 (Deutschland);
beide hier vertreten durch Herrn Emile SIMON, Geschäftsführer der Gesellschaft GES Maritime S.A., mit beruflicher
Anschrift in L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont, aufgrund zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche, nachdem sie
„ne varietur“ durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr registriert zu werden.
Die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
1) Dass die Gesellschaft BLUE DOLPHIN S.A. mit Sitz in L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont, eingetragen im
Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 140.823, gegründet wurde gemäss Urkunde,
aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Juni 2008, veröffentlicht im Memorial C am 30. August 2008
unter der Nummer 2107.
2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von FÜNFZIG TAUSEND
(50.000,-) EURO hat, eingeteilt in FÜNFZIG (50) AKTIEN einer und derselben Art zu je TAUSEND (1.000,-) EURO.
26684
L
U X E M B O U R G
3) Dass Frau Miriam NEUMANN und Herr Dr. Klaus-Günter NEUMANN, beide vorbenannt und vertreten wie vo-
rerwähnt, die einzigen Eigentümer aller Gesellschaftsaktien geworden sind.
4) Dass Frau Miriam NEUMANN und Herr Dr. Klaus-Günter NEUMANN, als einzige Aktionäre ausdrücklich erklären,
die Gesellschaft auflösen zu wollen, diese in Liquidation zu setzen und sich beide als Liquidatoren zu bestimmen.
5) Dass die Komparenten sofort die zweite und dritte ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft ein-
berufen, gemäss Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort
hintereinander abhalten wird.
Dass, in ihrer Eigenschaften als Liquidatoren, sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft
BLUE DOLPHIN S.A. besitzen, und die Passiva übernommen haben.
Dass der Liquidationsbericht, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Die Komparenten ernennen zum Prüfungskommissar Herrn Jean-Marc HEITZ, geboren am 28. September 1958 in
Luxemburg, wohnhaft in L-5670 Altwies, 2, Rue Jean-Pierre Koppes, mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.
Nach Kenntnisnahme durch die Komparenten des Berichtes des Prüfungskommissars, stimmen sie den Schlussfolge-
rungen des Berichtes zu, und erteilen Jean-Marc HEITZ, vorbenannt, Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
Der Bericht des Prüfungskommissars, verbleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
6) Dass die Komparenten den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres
Amtes, erteilen;
7) Dass die Komparenten in einer dritten ausserordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft
beschliessen, welche damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen
der Gesellschaft durch die Unterzeichnenden;
Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage vollendet.
Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-1219 Lu-
xembourg, 17, Rue Beaumont aufbewahrt bleiben werden.
Dass die Komparenten die Aktien der Gesellschaft auflösen dürfen.
Für alle erforderlichen Schritte, wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft BLUE DOLPHIN S.A., vorgenannt, fest-
gestellt.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten
Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Emile Simon, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2013. LAC/2013/58356. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 11. Januar 2014.
Référence de publication: 2014010647/64.
(140012264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
Auguri S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.857.
L'an deux mille treize, le vingt-quatre décembre,
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société anonyme, société de gestion du
patrimoine familial «AUGURI S.A., SPF», ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, Route d'Esch, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.857, constituée suivant acte notarié en date
du 25 mai 1994 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 389 du 11 octobre 1994 et
dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 31 décembre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1013 du 16 mai 2011 (la «Société»).
26685
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Martine Zellinger, employée privée, L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie Kaiser, employée privée, L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cheryl Geschwind, employée privée, L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente Assemblée a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de EUR 426.000,- (quatre cent vingt-six mille euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 84.000,- (quatre-vingt-quatre mille euros) à EUR 510.000,- (cinq cent dix mille euros) par incorporation,
à concurrence de EUR 426.000,- (quatre cent vingt-six mille euros), de résultats reportés au 31.12.2012 et par la création
et par l'émission de 17.040 (dix-sept mille quarante) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros);
2. Souscription et libération des actions ainsi créées;
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à EUR 510.000,- (cinq cent dix mille euros) qui sera représenté par 20.400 (vingt
mille quatre cents) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune»
4. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent vingt-six mille
euros (EUR 426.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 84.000,-) représenté
par trois mille trois cent soixante (3.360) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), à cinq cent dix
mille euros (EUR 510.000,-) par la création et l'émission de dix-sept mille quarante (17.040) actions nouvelles d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).
<i>Souscription et libération:i>
Toutes les dix-sept mille quarante (17.040) actions nouvelles sont souscrites par l'actionnaire unique LOUV S.à r.l., ici
représentée par Madame Cheryl Geschwind, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2013,
et intégralement libérée par incorporation de réserves à due concurrence.
L'existence des fonds ayant servi à l'augmentation de capital ci-dessus a été démontrée au notaire soussigné par un
bilan au 16 décembre 2013.
Ledit bilan restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Une attestation délivrée par deux administrateurs de la Société, certifiant que les réserves sont toujours disponibles
à la date du présent acte, y restera annexée pour être enregistrée en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 5 des
statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à cinq cent dix mille euros (EUR 510.000,-) qui sera représenté par vingt mille quatre
cents (20.400) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
26686
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. ZELLINGER, M. KAISER, C. GESCHWIND et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2013. LAC/2013 /60027. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 15 janvier 2014.
Référence de publication: 2014010606/76.
(140011998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
Choix de Vie S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8545 Niederpallen, 1, Ditzebierg.
R.C.S. Luxembourg B 113.559.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille treize,
Le vingt-trois décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Madame Myriam LELLING, gérante de société, demeurant à L-8545 Niederpallen, 1, Ditzebierg (ci-après la «compa-
rante» ou l'«associée unique»),
Ladite comparante, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «Choix de Vie S.à r.l.»,
établie et ayant son siège social à L-8545 Niederpallen, 1, Ditzebierg, inscrite au Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg sous le numéro B. 113559, constituée suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire alors de
résidence à Rambrouch, en date du 13 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations,
du 9 mai 2006, numéro 907 (ci-après la «société»); les statuts de la société n'ont été pas été modifiés depuis lors.
- Que l'ordre du jour de la présente assemblée, dont elle a été préalablement informée, est le suivant (ci-après l'«ordre
du jour»):
1. Dissolution et liquidation de la société;
2. Désignation d'un liquidateur;
3. Décharge à donner au gérant de la société;
4. Clôture de la liquidation;
5. Détermination du lieu de conservation des livres et documents de la société;
6. Divers.
- Qu'elle a renoncé à tout droit de convocation préalable;
- Qu'elle a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique, approuve le bilan de la société au 3 décembre 2013 et prononce la dissolution de la société avec
effet immédiat, ainsi que l'entrée de la société en liquidation.
Une copie dudit bilan, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant restera
annexée aux présentes en tant qu'annexe (ci-après l'«annexe»).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique se désigne elle-même liquidateur de la société (ci-après le «liquidateur») et aura pleins pouvoirs de
signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en oeuvre les stipulations du présent acte.
La comparante, en sa qualité de liquidateur et d'associée unique de la société, déclare que:
(i) la société n'exerce plus aucune activité;
(ii) tous droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la société, tels que décrits dans
l'annexe, sont cédés, transférés et transmis à l'associée unique;
(iii) tous droits, titres, intérêts et obligations se rapportant au passif existant de la société, sont assumés par l'associée
unique, respectivement transférés et transmis à l'associée unique et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation
est dûment provisionné et qu'elle s'engage irrévocablement à assumer et à payer tout passif éventuel de la société dissoute,
actuel ou futur, connu, inconnu et non payé.
26687
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique décide de clore la liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date qu'en tête des présentes, à la gérante
de la société, à savoir Madame Myriam LELLING, préqualifiée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associée unique décide également que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une
durée de 5 (cinq) années au siège social de la société.
A cet égard, l'associée unique donne instruction à Madame Myriam LELLING, préqualifiée, avec pouvoir de subdélé-
gation et lui donne pleins pouvoirs, pour prendre toute action ou signer tout document afin que les livres et documents
de la société soient conservés à ladite adresse.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,
cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. LELLING, E. SCHLESSER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60245. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME.
Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Référence de publication: 2014010680/67.
(140011951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.
Brando International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 132.492.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014012155/9.
(140013766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Arcavest Project Topalu Co. KG, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.114.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>LA GÉRANCEi>
Référence de publication: 2014012108/10.
(140014223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Arcavest Project Topalu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 139.073.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>La gérancei>
Référence de publication: 2014012109/10.
(140014216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
26688
ACQ
Arcavest Project Topalu Co. KG
Arcavest Project Topalu S.à r.l.
Auguri S.A., SPF
Blue Dolphin S.A.
Boduhura Resort S.A.
Brando International S.A.
Broome S.A.
BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank
Casadores Investments
Cesto S.A.
Choix de Vie S. à r.l.
Cornet Investments S.à r.l.
d'Amico International Shipping S.A.
d'Amico International Shipping S.A.
Daytona Fund
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Elite World
EMCap S.C.A.
Eurizon Strategia Flessibile
Fair Play Capital Advisory (Lux) S.à r.l.
Faune Holding S.A.
Grant Thornton Weber & Bontemps
Henderson Gartmore fund
Hope Invest S.A.
Hyadinvest S.A.
Patri
Patrilux S.A.
Patrinvest
Pioneer P.F.
Prologis Fund Management S.à r.l.
Prologis Management II S.à. r.l.
Sohmisa Investments S.à r.l.
'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF
The CMI Managed Fund
UBS (Lux) Institutional Sicav
UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2
UBS (Lux) Sicav 1
Universe, The CMI Global Network Fund
W Industries Finances S.A.