This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 428
17 février 2014
SOMMAIRE
Actavis Holding 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
20525
De Butz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20534
Eozen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20538
Fin Eleven S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20530
FLH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20530
Formax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20536
Icopal Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20531
ID4Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20530
Immeurope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20535
Interlux Platre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20539
International Cleaning Company S.A. . . . .
20530
LBBW Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20498
Luxbela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20539
Magenta Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
20531
Management Assistances & Advisors . . . . .
20539
Marowinia S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20533
Mieti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20532
Montefiore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20532
MyTravel Licensing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
20532
NDT European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
20533
Newbell & Kesson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
20533
Nima Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20533
Noma Star Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20541
NPG Wealth Management S.à r.l. . . . . . . .
20531
Ocean Dream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20541
Optical Center Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
20534
Orium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20540
OR TP SA - Demolition . . . . . . . . . . . . . . . . .
20539
Parkway International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
20525
Picard Bondco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20542
Pil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20525
Pioneer Alternative Investment Funds
(Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20540
Platheg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20544
Polyusus Lux III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20535
Private Estate Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20540
Procter & Gamble International Funding
SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20542
ProLogis European Finance XI S.àr.l. . . . .
20544
ProLogis Poland XXIII S.à r.l. . . . . . . . . . . .
20544
ProLogis UK CCXXX S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
20544
Promotions Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
20543
Raum & Wohnen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20543
Rémy Cointreau Luxembourg S.A. . . . . . .
20543
Robust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20524
Rose Velte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20543
Rubik Ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20544
SALT AND PEPPER by Jaco S.A. . . . . . . . .
20543
SBC International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
20528
Sol Designer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20543
UKP Consult S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20534
UKP Consult S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20534
Vicem Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20540
Watson Pharma 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
20525
20497
L
U X E M B O U R G
LBBW Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 15.585.
„Landesbank Baden-Württemberg“, Anstalt des öffentlichen Rechts.
Sitze: Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz.
Geschäftsanschrift: D-70173 Stuttgart, Am Hauptbahnhof 2.
Amtsgericht Stuttgart, Nummer HRA 12704.
Amtsgericht Mannheim (für Karlsruhe), Nummer HRA 104440.
Amtsgericht Mannheim, Nummer HRA 4356.
Amtsgericht Mainz, Nummer HRA 40687.
GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreizehten Februar.
Vor der unterzeichneten Notarin Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1. LBBW Luxemburg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 1C, rue Gabriel
Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“), eingetragen beim Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg unter der Nummer B 15.585 („LBBW Luxemburg“), als übertragender Rechtsträger,
hier vertreten durch ihre beiden Mitglieder des Managing Boards, namentlich Herr Dr. Stefan Grabowsky und Herr
Roby Haas, geschäftsansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg;
2. Landesbank Baden-Württemberg, eine Anstalt des öffentlichen Rechts unter deutschem Recht, mit Sitzen in Stutt-
gart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz und Geschäftsanschrift Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, eingetragen in den
Handelsregistern des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 12704, des Amtsgerichts Mannheims (für Karls-
ruhe) unter der Nummer HRA 104440, des Amtsgerichts Mannheim unter der Nummer HRA 4356 und des Amtsgerichts
Mainz unter der Nummer HRA 40687 („LBBW“), als übernehmender Rechtsträger,
hier vertreten durch Frau Rina Breininger, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in 31-33, rue Ste Zithe, L-2015 Luxemburg,
kraft einer am 11. Februar 2014 durch den Vorstand der LBBW erteilten Vollmacht als Bevollmächtigter des Vorstands
der LBBW.
Die vorgenannten Vollmachten, nachdem sie ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Parteien und die
unterzeichnete Notarin unterschrieben wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Die vorgenannten Erschienenen fordern daraufhin die amtierende Notarin auf, festzuhalten und notariell zu beurkun-
den, dass die LBBW Luxemburg und die LBBW hiermit den nachfolgenden gemeinsamen Verschmelzungsplan („Gemein-
samer Verschmelzungsplan“) aufstellen, festsetzen und vereinbaren:
<i>Präambeli>
(A) Das Managing Board der LBBW Luxemburg S.A., 1C, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg („Luxemburg“), eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 15.585 („LBBW Lu-
xemburg“), als übertragender Rechtsträger, sowie der Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof
2, 70173 Stuttgart, eingetragen in den Handelsregistern des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 12704, des
Amtsgerichts Mannheims (für Karlsruhe) unter der Nummer HRA 104440, des Amtsgerichts Mannheim unter der Num-
mer HRA 4356 und des Amtsgerichts Mainz unter der Nummer HRA 40687 („LBBW“), als übernehmender Rechtsträger
stellen hiermit den folgenden Gemeinsamen Verschmelzungsplan („Gemeinsamer Verschmelzungsplan“) für die grenzü-
berschreitende Verschmelzung der LBBW Luxemburg auf die LBBW („Verschmelzung“ oder „Grenzüberschreitende
Verschmelzung“) auf.
(B) Die LBBW Luxemburg ist eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme) mit satzungsmäßigem
Sitz in Munsbach, Luxemburg, und Geschäftsadresse in 1C, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg. Das
Stammkapital der LBBW Luxemburg beträgt gegenwärtig EUR 615.000.000 (in Worten: sechshundertfünfzehn Millionen
Euro) und ist eingeteilt in 1.178.652 (in Worten: eine Million einhundertachtundsiebzigtausend sechshundertzweiund-
fünfzig) Aktien ohne Nennwert, alle vollständig eingezahlt. Die Aktien der LBBW Luxemburg sind Namensaktien und
können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden und über die Aktien wird im Einklang mit Art. 39 des Luxemburger
abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften („LHG“) ein Aktienregister am Sitz der Gesell-
schaft geführt. Sämtliche Aktien der LBBW Luxemburg werden von der LBBW gehalten. Die LBBW Luxemburg hält keine
direkten oder indirekten Anteile an der LBBW.
(C) Die LBBW ist eine durch das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg („LBWG“) errichtete Anstalt des
öffentlichen Rechts mit satzungsmäßigen Sitzen in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz, Deutschland, und Geschäft-
sadresse Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Deutschland. Das Stammkapital der LBBW beträgt gegenwärtig EUR
3.483.912.867,65. Am Stammkapital sind als Träger der LBBW („Träger“) der Sparkassenverband Baden-Württemberg
20498
L
U X E M B O U R G
mit EUR 1.412.173.351,77, das Land Baden-Württemberg mit EUR 870.573.351,77, die Landeshauptstadt Stuttgart mit
EUR 659.566.164,11, die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH mit EUR 471.700.000,00 sowie die Landes-
kreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - mit EUR 69.900.000,00 beteiligt.
(D) Durch Art. 4 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze vom 19. Dezember
2013 (GBl. S. 491, 492) wurde der LBBW im LBWG die Möglichkeit eröffnet, sich an Umwandlungen zu beteiligen. Gemäß
§ 1 Abs. 5 Satz 2 LBWG kann die LBBW als übernehmender Rechtsträger an grenzüberschreitenden Verschmelzungen
beteiligt sein. Nach § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG sind auf Umwandlungen nach dem LBWG für die LBBW die für
Aktiengesellschaften maßgeblichen Regelungen des deutschen Umwandlungsgesetzes („UmwG“) entsprechend anzuwen-
den, soweit das LBWG oder die Satzung der LBBW nicht etwas anderes bestimmen. Die Verschmelzungsfähigkeit der
LBBW Luxemburg und das Verfahren in Luxemburg regeln Art. 278 ff. LHG.
(E) Die LBBW Luxemburg hat gemäß Art. 6 ff. der Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und
Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung), umgesetzt in Luxemburg durch Art. 2 ff. des abgeänderten
Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (das „Bankengesetz“) ihre Tätigkeit als Luxemburger Bank wahrge-
nommen und obliegt somit der Aufsicht der Luxemburger Aufsichtsbehörde des Finanzsektors, der Commission de
Surveillance du Secteur Financier („CSSF“). Die LBBW Luxemburg hat der CSSF ihre Absicht angezeigt, sich im Wege
der in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan vereinbarten grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme
auf die LBBW zu verschmelzen. Die LBBW hat in Deutschland gemäß § 24 Abs. 2 des Kreditwesengesetzes („KWG“)
der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ihre Absicht angezeigt, sich
im Wege der in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan vereinbarten Grenzüberschreitenden Verschmelzung mit
einem anderen Institut zu vereinigen, und die erforderliche Dokumentation eingereicht. Weder die CSSF noch die BaFin
haben Einwände gegen die Verschmelzung erhoben.
(F) Die LBBW Luxemburg wird bei Inkrafttreten der rechtlichen Wirksamkeit der Verschmelzung über 43 Arbeit-
nehmer in Luxemburg verfügen. Bei der LBBW Luxemburg besteht ein Personalrat (délégation du personnel). Am 2.
Dezember 2013 wurden die Arbeitnehmer der LBBW Luxemburg im Rahmen einer Personalversammlung von der Ge-
schäftsleitung über die Verschmelzung informiert. Der Personalrat der LBBW Luxemburg wird gemäß Art. 265 (1) LHG,
sowie Art. L.127-6 (1) des Arbeitsgesetzbuches über die beabsichtigte Verschmelzung und die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die Arbeitsverhältnisse und die Arbeitnehmervertretungen regelmäßig, zuletzt am 19. November 2013,
informiert. Die LBBW Luxemburg hat die LBBW darüber hinaus über die übergehenden Rechte und Pflichten informiert,
dies gemäß Art. L.127-3 (2) des Arbeitsgesetzbuches. Eine Kopie dieser Information wurde an das Gewerbeaufsichtsamt
übermittelt.
(G) Die LBBW Luxemburg verfügt über ein Supervisory Board mit 3 (drei) Mitgliedern und ein Managing Board mit 2
(zwei) Mitgliedern. Keines der Mitglieder dieser Gremien ist ein Arbeitnehmer- oder Gewerkschaftsvertreter.
(H) Die LBBW verfügt per 31. Dezember 2013 über 9.124 Arbeitnehmer, davon sind 217 im Ausland beschäftigt. Bei
der LBBW bestehen ein Gesamtpersonalrat sowie sechs örtliche Personalräte für die Regionen Baden-Württemberg
Nord, Stuttgart, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Baden-Württemberg Süd/Süd-Ost und Südwest. Gesamtpersonalrat und die
sechs örtlichen Personalräte werden nach den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß und rechtzeitig
über die Verschmelzung informiert.
(I) Die LBBW verfügt über einen Aufsichtsrat mit 21 (einundzwanzig) Mitgliedern und einen Vorstand mit 6 (sechs)
Mitgliedern. Sieben Mitglieder des Aufsichtsrats sind Arbeitnehmervertreter. Keines der Mitglieder des Vorstandes ist
ein Arbeitnehmer- oder Gewerkschaftsvertreter.
(J) Die LBBW Luxemburg verfügt über den in einem Beiblatt zu dieser Urkunde bezeichneten Grundbesitz. Das Beiblatt
wird nicht zusammen mit diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan veröffentlicht.
(K) Die Parteien beabsichtigen, die LBBW Luxemburg als übertragende Gesellschaft auf die LBBW als übernehmenden
Rechtsträger nach den Vorschriften von Art. 278 LHG und § 1 Abs. 5 und 6 LBWG in Verbindung mit §§ 122a ff. UmwG
grenzüberschreitend zu verschmelzen, wobei als Folge der vorstehenden Verschmelzung die LBBW Luxemburg unter
Ausschluss der Liquidation aufgelöst wird und sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf die LBBW als alleinige
Aktionärin der LBBW Luxemburg übertragen bzw. von dieser übernommen werden.
Dies vorausgeschickt stellen das Managing Board der LBBW Luxemburg und der Vorstand der LBBW gemäß Art. 278
ff. LHG und gemäß § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in Verbindung mit § 122c UmwG folgenden gemeinsamen Versch-
melzungsplan auf:
1. Verschmelzung, Vermögensübertragung, Gegenleistung.
1.1 Verschmelzung
Die LBBW Luxemburg wird als übertragende Gesellschaft im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß
Art. 278 ff. LHG und § 1 Abs. 5 und 6 LBWG in Verbindung mit §§ 122a ff. UmwG auf die LBBW als übernehmenden
Rechtsträger verschmolzen.
1.2 Vermögensübertragung
Durch die Verschmelzung wird das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der LBBW Luxemburg zum Zeitpunkt ihrer
Auflösung ohne Abwicklung auf die LBBW übertragen („Verschmelzung durch Aufnahme“).
1.3 Gegenleistung
20499
L
U X E M B O U R G
Die LBBW ist alleinige Aktionärin der LBBW Luxemburg. Deshalb wird gemäß § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in
Verbindung mit §§ 122a Abs. 2, 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG sowie Art. 278 LHG das Stammkapital der LBBW zur
Durchführung der Verschmelzung nicht erhöht, und es werden im Rahmen der Verschmelzung keine neuen Anteile am
Stammkapital der LBBW ausgegeben. Daher erübrigen sich im Gemeinsamen Verschmelzungsplan nach den anwendbaren
deutschen und luxemburgischen Vorschriften nähere Angaben zum Umtauschverhältnis, Angaben hinsichtlich der Über-
tragung von neuen Anteilen am Stammkapital der LBBW als dem übernehmenden Rechtsträger sowie die Angabe des
Zeitpunkts, von dem an neu ausgegebene Anteile am Stammkapital das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren. Gemäß
Art. 278 LHG entfallen die Angaben nach Art. 261 (2) b), c) und d) LHG.
2. Voraussichtliche Auswirkungen auf die Beschäftigung.
2.1 Rechte und Pflichten aus Arbeitsverhältnissen
Mit Wirksamwerden der Verschmelzung gehen sämtliche bestehenden Rechte und Pflichten aus Arbeitsverhältnissen
mit der LBBW Luxemburg automatisch im Wege der Universalsukzession auf die LBBW über. Sämtliche einzel- und
tarifvertraglichen Regelungen gelten auch im Verhältnis zur LBBW fort. Bei der LBBW Luxemburg besteht ein Tarifvertrag,
an den die LBBW nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung gebunden sein wird, dies bis zu dessen Kündigung,
Auslaufen oder Erneuerung.
2.2 Mitbestimmung bei der LBBW Luxemburg
Der Personalrat der LBBW Luxemburg wird im Anschluss an die Grenzüberschreitende Verschmelzung als Personalrat
der luxemburgischen Zweigniederlassung, welche den Geschäftsbetrieb der LBBW Luxemburg weiter führt, bestehen
bleiben. Da bei der LBBW Luxemburg keine unternehmerische Mitbestimmung existiert, hat die Verschmelzung keine
Konsequenz auf etwaige Mitbestimmungsrechte.
2.3 Mitbestimmung bei der LBBW
Die Grenzüberschreitende Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die aktuelle Zusammensetzung des Gesamt-
personalrats und der örtlichen Personalräte der LBBW. Die Grenzüberschreitende Verschmelzung hat auch keine
Auswirkungen in Bezug auf die unternehmerische Mitbestimmung und auf die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrats der
LBBW mit Vertretern der Beschäftigten der LBBW.
2.4 Personalmaßnahmen und sonstige negative Veränderungen
Personalmaßnahmen oder andere negative Veränderungen für die Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Versch-
melzung sind nicht geplant. Es ist davon auszugehen, dass die Verschmelzung selbst keine weiteren negativen Auswir-
kungen auf die Beschäftigungsbedingungen haben wird.
3. Verschmelzungsstichtag, steuerlicher Übertragungsstichtag.
3.1 Verschmelzungsstichtag
Zu Zwecken der Rechnungslegung erfolgt die Verschmelzung mit Wirkung zum 1. Januar 2014, 0.00 Uhr (MEZ/CET).
Ab diesem Zeitpunkt gelten alle Handlungen und Geschäfte der LBBW Luxemburg als für Rechnung der LBBW vorge-
nommen („Verschmelzungsstichtag“).
3.2 Steuerlicher Übertragungsstichtag
Für deutsche und luxemburgische steuerliche Zwecke erfolgt die Verschmelzung mit Wirkung zum Ablauf des 31.
Dezember 2013 („steuerlicher Übertragungsstichtag“).
4. Rechte, Maßnahmen und besondere Vorteile, Verschmelzungsprüfung, -bericht, Zustimmung, Einsichtrechte der
Aktionäre.
4.1 Es werden keine Rechte im Sinne des Art. 261 (2) f) LHG und des § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in Verbindung
mit § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG an Gesellschafter oder Träger mit Sonderrechten oder an Inhaber von anderen Wert-
papieren als Gesellschaftsanteile gewährt. Es wurden auch keine anderen Maßnahmen im Sinne der genannten Vorschriften
für diese Personen vorgeschlagen.
4.2 Es werden keine besonderen Vorteile im Sinne des Art. 261 (2) g) LHG und des § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG
in Verbindung mit § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG an Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane
der LBBW Luxemburg oder der LBBW gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorge-
sehen oder vorgeschlagen. Sachverständige Prüfer des Gemeinsamen Verschmelzungsplans werden nicht bestellt, weil
die LBBW alleinige Aktionärin der LBBW Luxemburg ist. In diesem Fall ist eine Verschmelzungsprüfung gemäß Art. 266
LHG in Verbindung mit Art. 278 LHG und § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in Verbindung mit §§ 122f Satz 1, 9 Abs. 3, 8
Abs. 3 Satz 1 UmwG nicht erforderlich.
4.3 Der Bericht der geschäftsführenden Organe der miteinander zu verschmelzenden Gesellschaften gemäß Art. 265
(1) LHG, bzw. § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in Verbindung mit § 122e UmwG wird den Aktionären der LBBW Luxemburg
und den Trägern der LBBW sowie den Personalvertretern der LBBW Luxemburg und der LBBW mindestens einen Monat
vor der Durchführung der Hauptversammlung der LBBW, welche über die Verschmelzung beschließen soll, zugänglich
gemacht. Die in Art. 265 (2) LHG bzw. § 1 Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in Verbindung mit §§ 122a, 64 Abs. 1 UmwG
genannten Informationen zu wesentlichen Änderungen von Aktiva und Passiva, welche zwischen dem Datum der Aufs-
tellung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans und dem Datum der Hauptversammlung der LBBW, welche hierüber
20500
L
U X E M B O U R G
befinden soll, eingetreten sind, werden den Aktionären der LBBW Luxemburg und den Trägern der LBBW vorgelegt
werden, sofern es nach den genannten Bestimmungen erforderlich sein sollte.
4.4 Der Gemeinsame Verschmelzungsplan erfordert nicht die Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre der
LBBW Luxemburg, da die LBBW alleinige Aktionärin der LBBW Luxemburg ist, vgl. Art. 279 (2) LHG.
4.5 Jeder Aktionär der LBBW Luxemburg sowie jeder Träger der LBBW hat gemäß Art. 267 LHG bzw. gemäß § 1
Abs. 6 Sätze 1 und 2 LBWG in Verbindung mit §§ 122a, 63 UmwG das Recht, mindestens einen Monat vor dem Tag der
Hauptversammlung der LBBW, die über den Gemeinsamen Verschmelzungsplan zu beschließen hat, am Sitz des jeweiligen
Rechtsträgers den Gemeinsamen Verschmelzungsplan, sowie die Jahresabschlüsse (und für die LBBW Luxemburg auch
die jährlichen Geschäftsberichte) der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger der letzten drei Geschäftsjahre
einzusehen.
5. Satzung der LBBW. Die Satzung der LBBW, als übernehmender Rechtsträger, wird im Zusammenhang mit der
Durchführung der Verschmelzung nicht geändert. Die aktuelle Satzung der LBBW ist diesem Gemeinsamen Verschmel-
zungsplan als Anlage 1 beigefügt. Anlage 1 bildet einen festen und untrennbaren Teil dieses Gemeinsamen Verschmel-
zungsplans.
6. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer.
6.1 Kein Erfordernis zur Durchführung eines Arbeitnehmerbeteiligungsverfahrens
Die Durchführung eines Verfahrens zur Beteiligung der Arbeitnehmer ist nicht erforderlich. Bei der Verschmelzung
der LBBW Luxemburg auf die LBBW handelt es sich um eine grenzüberschreitende Verschmelzung, die sich außerhalb
des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2005/56/EG vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesell-
schaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten vollzieht. Damit kommen keine Vorschriften zur Anwendung, die in Luxem-
burg oder Deutschland in Umsetzung von Art. 16 der Verschmelzungsrichtlinie (Mitbestimmung der Arbeitnehmer)
ergangen sind. Folglich ist weder das deutsche Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzübers-
chreitenden Verschmelzung („MgVG“) noch die luxemburgische Regelung der Art. 426-13 und ff. des Arbeitsgesetzbuches
und Art. 263 (6) und (7) LHG auf diese Verschmelzung anwendbar.
6.2 Übertragung der Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverträgen, -beziehungen
Die Rechte und Pflichten der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, die aus den Arbeitsverträgen oder Ar-
beitsbeziehungen resultieren und die zu dem Zeitpunkt bestehen, an dem die grenzüberschreitende Verschmelzung
rechtlich wirksam wird, werden gemäß den Bestimmungen des Art. 274 (4) LHG in Verbindung mit Art. 273ter (1) LHG,
sowie Art. L.127-3 (1) des Arbeitsgesetzbuches zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der grenzüberschreitenden Versch-
melzung an die LBBW als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
7. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens.
7.1 Keine gesonderte Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens
Eine gesonderte Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der LBBW Luxemburg wurde nicht durchgeführt, da die
LBBW alleinige Gesellschafterin der LBBW Luxemburg ist und mit Wirksamwerden der Verschmelzung das Aktiv- und
Passivvermögen der LBBW Luxemburg handelsrechtlich zu aus der Schlussbilanz der LBBW Luxemburg (Jahresabschluss
der LBBW Luxemburg für das Geschäftsjahr 2013) abgeleiteten Buchwerten auf die LBBW übertragen wird.
7.2 Handelsrechtliche Buchwertfortführung
Das Aktiv- und Passivvermögen der LBBW Luxemburg wird in der handelsrechtlichen Bilanz der LBBW zu den aus
der Schlussbilanz der LBBW Luxemburg abgeleiteten Buchwerten fortgeführt.
8. Bilanzstichtage zur Festlegung der Verschmelzungsbedingungen. Die Bilanzen der Jahresabschlüsse der LBBW Lu-
xemburg und der LBBW zum 31. Dezember 2013 werden als Bilanzen zur Festlegung der abschließenden grenzübers-
chreitenden Verschmelzung verwendet.
9. Kosten. Die durch den Abschluss dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplanes und seine Ausführung entstehenden
Kosten werden von der LBBW getragen. Im Übrigen trägt jeder der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger seine
Kosten selbst, insbesondere solche, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieses Gemeinsamen Verschmelzungs-
planes entstanden sind. Die Kostenregelung gilt auch, falls die Verschmelzung nicht wirksam werden sollte.
10. Gremienvorbehalt, Wirksamkeit der Verschmelzung, Rücktrittsrecht.
10.1 Dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan wird wirksam, wenn ihm die Hauptversammlung und die Rechtsauf-
sichtsbehörde der LBBW gemäß § 1 Abs. 6 Satz 3 LBWG zugestimmt hat, wobei der Beschluss der Hauptversammlung
der LBBW gemäß § 1 Abs. 6 Satz 4 LBWG einer Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen bedarf. Der
Luxemburger Notar wird sowohl die Bestätigung gemäß Art. 271 (2) LHG, als auch zu einem späteren Zeitpunkt (nach
Durchführung der Hauptversammlung der LBBW, welche über die Verschmelzung beschlossen hat) aus Gründen der
Rechtsicherheit eine Bestätigung gemäß Art. 273 (1) LHG erstellen.
10.2 Die rechtliche Wirksamkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung gegenüber Dritten tritt mit der Eintragung
der grenzüberschreitenden Verschmelzung in den Handelsregistern der LBBW ein, wobei der Vorstand der LBBW vor-
sorglich davon ausgeht, dass die grenzüberschreitende Verschmelzung erst mit der letzten Eintragung bei den vier
deutschen Handelsregistern der LBBW wirksam wird. Nach Durchführung der grenzüberschreitenden Verschmelzung
20501
L
U X E M B O U R G
hört die LBBW Luxemburg auf zu bestehen, wobei die Löschung der LBBW Luxemburg aus dem Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister, im Einklang mit den Bestimmungen von Art. 273ter LHG, jedoch erst nach dem Erhalt der
Benachrichtigung des Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregisters durch die deutschen Handelsregister der LBBW
als aufnehmender Rechtsträger erfolgt.
10.3 Die LBBW kann von diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan zurücktreten, wenn die Verschmelzung nicht bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2014 wirksam geworden ist.
11. Sonstiges.
11.1 Die Gläubiger der von der Verschmelzung betroffenen Rechtsträger können sich gemäß Art. 262 (2) c) LHG am
Gesellschaftssitz der von der Verschmelzung betroffenen Rechtsträger über die Vorkehrungen in Bezug auf ihre Gläubi-
gerrechte vollständig und kostenlos informieren.
11.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans, einschließlich dieser Klausel, bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung zwingend vorgesehen ist.
11.3 Bei Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans
oder bei sonstigen Zweifelsfällen gilt der deutsche Wortlaut dieses gemeinsamen Verschmelzungsplans, welcher allein
verlesen wurde.
11.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans nichtig, unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so bleiben davon die übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der nichtigen, unwirk-
samen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine Bestimmung, die demjenigen am nächsten kommt, was von den
Parteien mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich gewollt war. Gleiches gilt im
Falle von Regelungslücken.
11.5 Soweit erforderlich, wird die LBBW die Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister der für die LBBW
zuständigen Register beantragen und die entsprechende Benachrichtigung des Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
registers veranlassen.
11.6 Von dieser Urkunde erhalten die LBBW Luxemburg und die LBBW jeweils vier (4) Ausfertigungen und jeweils
vier (4) beglaubigte Abschriften. Die Handelsregister in Stuttgart, Mannheim (für Karlsruhe), Mannheim (für Mannheim)
und Mainz sowie das Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) erhalten
je eine (1) beglaubigte Abschrift.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche auf Grund dieser Urkunde entstehen, wer-
den auf EUR 8.500,- geschätzt.
<i>Bestätigungi>
Die amtierende Notarin bestätigt hiermit die Existenz und die Gesetzesmäßigkeit dieses Gemeinsamen Verschmel-
zungsplans.
Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Erschienenen
vorliegende Urkunde in Deutsch gehalten ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung, und dass im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, alleinig die deutsche Fassung rechtsgültig ist.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Munsbach, am Datum wie eingangs erwähnt, wobei darauf hingewiesen wird,
dass ausschließlich die deutsche Fassung der Urkunde maßgeblich ist und die nachfolgende englische Übersetzung nur der
Information dient.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Es folgt die englische Übersetzung der Urkunde:
In the Year Two Thousand and Fourteen, on the thirteenth day of February.
Before the undersigned Notary Cosita Delvaux, with offices in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
Appeared today:
1. LBBW Luxemburg S.A., a public company limited by shares (Société Anonyme) under the laws of Luxemburg, with
registered office in 1C, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxemburg (“Luxemburg”), registered
in the Commercial and Company Register Luxemburg under number B 15.585 (“LBBW Luxemburg”), as transferring
entity;
for the purposes hereof represented by its two members of the Managing Board, namely Mr. Stefan Grabowsky and
Mr. Roby Haas, with business address at 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxemburg;
2. Landesbank Baden-Württemberg, a public-law institution under German law, with registered offices in Stuttgart,
Karlsruhe, Mannheim and Mainz and business address at Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, registered in the Com-
mercial Register of the Local Court Stuttgart under number HRA 12704, in the Commercial Register of the Local Court
Mannheim (for Karlsruhe) under number HRA 104440, in the Commercial Register of the Local Court Mannheim under
20502
L
U X E M B O U R G
number HRA 4356 and in the Commercial Register of the Local Court Mainz under number HRA 40687 (“LBBW”), as
absorbing entity;
for the purposes hereof represented by Ms. Rina Breininger, attorney at law, with business address at 31-33, rue Ste
Zithe, L-2015 Luxemburg, by virtue of a power of attorney issued on 11 February 2014 by the Managing Board of LBBW,
as representative of the Managing Board of LBBW.
After having been signed ne varietur by the representative of each of the appeared parties and the undersigned Notary,
the above powers of attorney shall remain permanently attached to this deed for the purpose of registration.
The above individuals appeared then requested the officiating Notary to set out and record in her capacity as Notary
in this deed that LBBW Luxemburg and LBBW hereby draw up, determine and agree the following joint merger plan
(“Joint Merger Plan”):
<i>Preamblei>
(A) The Managing Board of LBBW Luxemburg S.A., 1C, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxemburg (“Luxemburg”), registered in the Commercial and Company Register Luxemburg under number B 15.585
(“LBBW Luxemburg”), as transferring entity, and the Managing Board of Landesbank Baden-Württemberg, Am Haupt-
bahnhof 2, 70173 Stuttgart, registered in the Commercial Register of the Local Court Stuttgart under number HRA 12704,
in the Commercial Register of the Local Court Mannheim (for Karlsruhe) under number HRA 104440, in the Commercial
Register of the Local Court Mannheim under number HRA 4356 and in the Commercial Register of the Local Court
Mainz under number HRA 40687 (“LBBW”), as absorbing entity, hereby draw up the following joint merger plan (“Joint
Merger Plan”) for the cross-border merger of LBBW Luxemburg into LBBW (“Merger” or “Cross-border Merger”).
(B) LBBW Luxemburg is a public company limited by shares under the laws of Luxemburg (Société Anonyme) with its
registered office, according to its articles of association, in Munsbach, Luxemburg, and business address at in 1C, rue
Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg. The share capital of LBBW Luxemburg currently amounts to EUR
615,000,000 (in words: six hundred fifteen million euros) and is divided into 1,178,652 (in words: one million one hundred
seventy eight thousand and six hundred fifty two) no par value shares, all fully paid-in. The shares of LBBW Luxemburg
are registered shares and may not be converted into bearer shares and a share register is maintained for the shares of
LBBW Luxemburg at the registered office of LBBW Luxemburg in accordance with Art. 39 of the Luxemburg Law of 10
August 1915 on Commercial Companies as amended (“LCC”). All shares of LBBW Luxemburg are held by LBBW. LBBW
Luxemburg does not hold any shares in LBBW, whether directly or indirectly.
(C) LBBW is a public-law institution established under the Landesbank Baden-Württemberg Act (“LBWA”) with reg-
istered offices, according to its ordinance, in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim and Mainz, Germany, and with business
address at Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, Germany. The share capital of LBBW currently amounts to EUR
3,483,912,867.65. The share capital is held by the owners of LBBW (“Owners”) as follows: by Sparkassenverband Baden-
Württemberg in an amount of EUR 1,412,173,351.77, by the land Baden-Württemberg in an amount of EUR
870,573,351.77, by the capital of the land Baden-Württemberg, Stuttgart, in an amount of EUR 659,566,164.11, by Land-
esbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH in an amount of EUR 471,700,000.00 and by Landeskreditbank Baden-
Württemberg - Förderbank - in an amount of EUR 69,900,000.00.
(D) Based on Art. 4 of the Law Amending the Fiscal Equalization Act and other laws dated 19 December 2013 (Law
Gazette p. 491, 492), LBBW has been given the option in the LBWA to participate in transformations. As provided for
in § 1 para. 5 sentence 2 LBWA, LBBW may participate as absorbing entity in cross-border mergers. Pursuant to § 1 para.
6 sentences 1 and 2 LBWA, in the event of a transformation under the LBWA, the relevant provisions for stock corpo-
rations contained in the German Transformation Act (“TA”) shall be applied analogously to LBBW, unless the LBWA or
the ordinance of LBBW provide otherwise. The capacity of LBBW Luxemburg to merge and the merger procedure in
Luxemburg are regulated in Art. 278 et seq. LCC.
(E) Pursuant to article 6 et seq. of Directive 2006/48/EC of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the
business of credit institutions (recast), implemented in Luxemburg in Art. 2 et seq. of the Law on the Financial Sector of
5 April 1993 as amended (the “Luxemburg Banking Act”), LBBW Luxemburg has pursued its business as a Luxemburg
bank and is therefore subject to the supervision of the Luxemburg Supervisory Authority for the Financial Sector, the
Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). LBBW Luxemburg has notified CSSF of its intention to merge
into LBBW through absorption by way of the Cross-border Merger as agreed in this Joint Merger Plan. As provided for
in § 24 para. 2 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz) (“German Banking Act”), LBBW has notified the German
Federal Bank (Deutsche Bundesbank) and the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdiens-
tleistungsaufsicht) (“BaFin”) of its intention to merge with another institution by way of the Cross-border Merger as
agreed in this Joint Merger Plan and submitted the required documentation to BaFin. Neither CSSF nor BaFin has raised
any objections to the Merger.
(F) LBBW Luxemburg will have 43 employees in Luxemburg when the Merger becomes legally effective. LBBW Lux-
emburg has a staff council (délégation du personnel). The employees of LBBW Luxemburg were informed about the
Merger by the management during a staff meeting on 2 December 2013. The staff council of LBBW Luxemburg is regularly
informed about the contemplated Merger and its effects on the employment relationships and employee representations
in accordance with Art. 265 (1) LCC and Art. L.127-6 (1) of the Labor Code, most recently on 19 November 2013.
20503
L
U X E M B O U R G
LBBW Luxemburg has additionally informed LBBW of the rights and duties that will transfer to it, as provided for in Art.
L.127-3 (2) of the Labor Code. A copy of such information was forwarded to the Trade Supervisory Authority.
(G) LBBW Luxemburg has a Supervisory Board with 3 (three) members and a Managing Board with 2 (two) members.
None of these board members is an employee representative or a trade union representative.
(H) As at 31 December 2013 LBBW has 9,124 employees, 217 of which are working abroad. LBBW has a central staff
council and six local staff councils for the regions Baden-Württemberg North, Stuttgart, Rhineland Palatinate, Saxony,
Baden-Württemberg South/South-East and Southwest. The central staff council and the six local staff councils will be
properly and timely informed about the Merger in accordance with the applicable laws and regulations.
(I) LBBW has a Supervisory Board with 21 (twenty-one) members and a Managing Board with 6 (six) members. Seven
members of the Supervisory Board are employee representatives. None of the members of the Managing Board is an
employee representative or a trade union representative.
(J) LBBW Luxemburg owns the real estate described in a supplementary sheet attached hereto. This supplementary
sheet will not be published together with this Joint Merger Plan.
(K) The parties intend to merge LBBW Luxemburg as transferring company into LBBW as absorbing entity in accord-
ance with the provisions set forth in Art. 278 LCC and in § 1 paras. 5 and 6 LBWA in conjunction with §§ 122a et seq.
TA in a cross-border merger as a result of which LBBW Luxemburg will be dissolved without liquidation and all assets
and liabilities of LBBW Luxemburg will be transferred to, and absorbed by, LBBW as sole shareholder of LBBW Luxem-
burg.
On these premises, the Managing Board of LBBW Luxemburg and the Managing Board of LBBW hereby draw up the
following Joint Merger Plan in accordance with Art. 278 et seq. LCC and § 1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in conjunction
with § 122c TA:
1. Merger, Transfer of Assets, Consideration.
1.1 Merger
LBBW Luxemburg, as transferring company, shall be merged into LBBW as absorbing entity by way of a cross-border
merger pursuant to Art. 278 et seq. LCC and § 1 paras. 5 and 6 LBWA in conjunction with §§ 122a et seq. TA.
1.2 Transfer of Assets
As a result of the Merger, all assets and liabilities of LBBW Luxemburg will be transferred to LBBW at the time of
LBBW Luxemburg's dissolution without liquidation (“merger by absorption”).
1.3 Consideration
LBBW is the sole shareholder of LBBW Luxemburg. Therefore, the share capital of LBBW will not be increased for
the purpose of the Merger pursuant to § 1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in conjunction with § 122a para. 2, § 68 para.
1 sentence 1 No. 1 TA and Art. 278 LCC and no new shares in LBBW will be issued in the context of the Merger.
Therefore, based on applicable German and Luxemburg laws, it is not necessary to include in this Joint Merger Plan details
as to exchange ratio, information as to the transfer of new shares in LBBW as absorbing entity and the date as of which
newly issued shares will participate in dividends. According to Art.278 LCC, the information to be provided under Art.
261 (2) b), c) and d) LCC can be dispensed with.
2. Anticipated Effects on Employment.
2.1 Rights and Duties under the Employment Relationships
Upon legal effectiveness of the Merger all existing rights and duties arising from the employment relationships with
LBBW Luxemburg will automatically pass over to LBBW by way of a universal succession. All provisions applying in
individual employment contracts and collective bargaining agreements will continue to apply vis-à-vis LBBW. LBBW Lux-
emburg has a collective bargaining agreement to which LBBW will be bound after the Merger has become legally effective
until the collective bargaining agreement is terminated or renewed or expires.
2.2 Co-Determination at LBBW Luxemburg
Following the Cross-border Merger, the staff council of LBBW Luxemburg will continue to exist as staff council of the
Luxemburg branch office which will continue the business operations of LBBW Luxemburg. As no entrepreneurial co-
determination exists at LBBW Luxemburg, the Merger will have no effects on any co-determination rights.
2.3 Co-Determination at LBBW
The Cross-border Merger has no impact on the current composition of the central staff council and the local staff
councils of LBBW. Further, the Cross-border Merger has no effect regarding the entrepreneurial co-determination and
the current composition of the Supervisory Board of LBBW with representatives of LBBW employees.
2.4 Personnel Actions and Other Negative Changes
Personnel measures or other negative changes for the employees are not planned in the context of the Merger. It can
be expected that the Merger as such will have no further negative effects on the employment terms and conditions.
3. Effective Merger Date; Tax Transfer Date.
3.1 Effective Merger Date
20504
L
U X E M B O U R G
For accounting purposes the Merger shall occur with effect as of 1 January 2014, 12 a.m. (midnight) (CET). As of such
date all acts and business transactions of LBBW Luxemburg shall be deemed to be performed and entered into for the
account of LBBW (“Effective Merger Date”).
3.2 Tax Transfer Date
For German and Luxemburg tax purposes the Merger shall occur with effect as of the end of 31 December 2013 (“Tax
Transfer Date”).
4. Rights, Measures and Special Advantages; Merger Audit, Merger Report, Approval, Shareholders' Rights of Inspec-
tion.
4.1 No rights within the meaning of Art. 261 (2) f) LCC and § 1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in conjunction with
§ 122c para. 2 No. 7 TA are granted to shareholders or Owners with special rights or holders of securities other than
company shares. Nor were any other measures within the meaning of these provisions proposed to be granted to such
persons.
4.2 No special advantages within the meaning of Art. 261 (2) g) LCC and § 1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in
conjunction with § 122c para. 2 No. 8 TA are granted to members of the administrative, managing, supervisory or control
bodies of LBBW Luxemburg or LBBW. Nor are any special measures provided or proposed for such persons. No expert
auditors will be appointed for the Joint Merger Plan because LBBW is the sole shareholder of LBBW Luxemburg. In such
a case it is not necessary to conduct a merger audit pursuant to Art. 266 LCC in conjunction with Art. 278 LCC and §
1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in conjunction with § 122, § 123 sentence 1, § 9 para. 3, § 8 para. 3 sentence 1 TA.
4.3 The report of the managing bodies of the companies to be merged pursuant to Art. 265 (1) LCC and § 1 para. 6
sentences 1 and 2 LBWA in conjunction with § 122e TA will be provided to the shareholders of LBBW Luxemburg and
the Owners of LBBW as well as the staff representatives of LBBW Luxemburg and LBBW at least one month before the
general meeting of LBBW resolving on the Merger is held. Any of the information referred to in Art. 265 (2) LCC and §
1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in conjunction with § 122a, § 64 para. 1 TA that needs to be provided in the event of
material changes of the assets and liabilities occurring between the date of drawing up the Joint Merger Plan and the date
of the general meeting of LBBW resolving on the Joint Merger Plan will be submitted to the shareholders of LBBW
Luxemburg and the Owners of LBBW if and when required in accordance with said provisions.
4.4 The Joint Merger Plan is not subject to the approval of the general meeting of the shareholders of LBBW Luxemburg,
because LBBW is the sole shareholder of LBBW Luxemburg, cf. Art. 279 (2) LCC.
4.5 Each shareholder of LBBW Luxemburg has the right pursuant to Art. 267 LCC and each Owner of LBBW has the
right pursuant to § 1 para. 6 sentences 1 and 2 LBWA in conjunction with § 122a, § 63 TA to inspect the Joint Merger
Plan and the annual financial statements (and, in the case of LBBW Luxemburg, also the annual reports) of the entities
participating in the Merger drawn up in the last three fiscal years at the registered office of LBBW Luxemburg and LBBW,
respectively, at least one month before the date of the general meeting of LBBW resolving on the Joint Merger Plan is
held.
5. Ordinance of LBBW. The Ordinance of LBBW, as absorbing entity, will not be changed in connection with the
Merger. The current Ordinance of LBBW is attached hereto as Annex 1. Annex 1 forms an integral and inseparable part
of this Joint Merger Plan.
6. Procedure for the Involvement of Employees.
6.1 No Necessity to Conduct a Procedure for the Involvement of Employees
It is not necessary to conduct a procedure for the involvement of employees. The contemplated merger of LBBW
Luxemburg into LBBW is a cross-border merger and as such outside the scope of application of Directive 2005/56/EC
of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies. Thus, no provisions will apply which were
adopted in Luxemburg or Germany in order to implement Art. 16 of the Merger Directive (Employee Participation).
Consequently, neither the German Act on Co-Determination of Employees in Cross-Border Mergers (deutsches Gesetz
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (“MgVG”)) nor the Luxem-
burg provision of Art. 426-13 et seq. Labor Code and Art. 263 (6) and (7) LCC will be applicable to the Merger.
6.2 Transfer of Rights and Duties under the Employment Contracts and Relationships
The rights and duties of the entities participating in the Merger arising from the employment contracts or employment
relationships and existing on the date on which the cross-border merger becomes legally effective shall be transferred
to LBBW as absorbing entity at such date in accordance with the provisions in Art. 274 (4) LCC in conjunction with Art.
273ter (1) LCC and Art. L.127-3 (1) Labor Code.
7. Valuation of the Assets and Liabilities.
7.1 No separate Valuation of the Assets and Liabilities
A separate valuation of the assets and liabilities of LBBW Luxemburg was not made because LBBW is the sole share-
holder of LBBW Luxemburg and the assets and liabilities of LBBW Luxemburg will be transferred to LBBW under
commercial law at the book values of LBBW Luxemburg derived from the closing balance sheet of LBBW Luxemburg
(annual financial statements of LBBW Luxemburg for fiscal year 2013) at the time the Merger becomes legally effective.
20505
L
U X E M B O U R G
7.2 Rollover of Book Values under Commercial Law
The assets and liabilities of LBBW Luxemburg will be rolled over on the commercial law balance sheet of LBBW at
the book values derived from the closing balance sheet of LBBW Luxemburg.
8. Balance Sheet Dates for the Purpose of Determining the Terms and Conditions of the Merger. The balance sheets
contained in the annual financial statements of LBBW Luxemburg and LBBW for the fiscal year ended on December 31,
2013 will be employed as the balance sheets relevant for the purpose of determining the final cross-border merger.
9. Costs. The costs incurred as a result of executing and implementing this Joint Merger Plan shall be borne by LBBW.
Other than that, each entity participating in the Merger shall bear its own costs, including, but not limited to those related
to the preparation of this Joint Merger Plan. This agreement on costs shall also apply if the Merger should not become
effective.
10. Approval, Effectiveness of the Merger, Right of Withdrawal.
10.1 This Joint Merger Plan will become effective when it has been approved by the general meeting of LBBW and the
legal supervisory authority of LBBW as provided for in § 1 para. 6 sentence 3 LBWA, with the resolution of the general
meeting of LBBW requiring a majority of 75 percent of the votes cast, as provided for in § 1 para. 6 sentence 4 LBWA.
The Luxemburg Notary shall issue both a certificate pursuant to Art. 271 (2) LCC and at a later date (following the general
meeting of LBBW approving the Merger) a certificate pursuant to Art. 273 (1) LCC establishing legal certainty.
10.2 The cross-border merger will become effective vis-à-vis third parties upon its registration in the commercial
registers of LBBW, with the Managing Board of LBBW assuming, as a matter of precaution, that the cross-border merger
will become effective only after registration in the last of the four Commercial Registers of LBBW. Following implemen-
tation of the cross-border merger, LBBW Luxemburg will cease to exist, but will be deleted from the Luxemburg
Commercial and Company Register, in compliance with Art. 273ter LCC, only after receipt of the notifications by the
Luxemburg Commercial and Company Register from the German Commercial Register of LBBW as absorbing entity.
10.3 LBBW may withdraw from this Joint Merger Plan if the Merger has not become effective at the end of December
31, 2014.
11. Miscellaneous.
11.1 The creditors of the entities participating in the Merger may fully and at no cost inform themselves about the
arrangements made with respect to their rights as creditors in accordance with Art. 262 (2) c) LCC at the registered
office of the entities participating in the Merger.
11.2 Any amendments of and supplements to this Joint Merger Plan, including this clause, must be in writing in order
to be valid, unless a notarial recording is mandatory.
11.3 In the event of any discrepancies between the German and the English version of this Joint Merger Plan or in any
other cases of doubt the German version of this Joint Merger Plan shall apply, which was solely read out to the parties
appearing.
11.4 If individual provisions of this Joint Merger Plan should be or become void, invalid or unenforceable, the remaining
provisions hereof shall not be affected thereby. Any void, invalid or unenforceable provision shall be replaced by such a
provision which comes as close as possible to what the parties intended under commercial aspects when agreeing on the
void, invalid or unenforceable provision. The same shall apply in the event of any gaps herein.
11.5 If and to the extent required, LBBW shall file for registration of the Merger in the Commercial Registers competent
for LBBW and cause the notification of such registrations to be sent to the Luxemburg Commercial and Company Register.
11.6 LBBW Luxemburg and LBBW will each receive four (4) executed versions and four (4) certified copies hereof.
The Commercial Registers in Stuttgart, Mannheim (for Karlsruhe), Mannheim (for Mannheim) and Mainz and the Lux-
emburg Commercial and Company Register (Registre de Commerce et des Sociétés) will each receive one (1) certified
copy hereof.
<i>Costsi>
The costs, expenses, charges and fees of all kinds resulting from this deed are estimated to be EUR 8,500.-.
<i>Confirmationi>
The officiating Notary hereby confirms the existence and lawfulness of this Joint Merger Plan.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in German, followed by an English version and that in case of any discrepancies between the
German and the English text, only the German version will be legally binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Munsbach, on the day named at the beginning of this document; it being
pointed out that solely the German version of the deed shall be authoritative and that the following English translation is
only intended for information purposes.
The document having been read to the persons appearing, each known to the undersigned notary by name, surname,
civil status and residence, they signed the present deed together with the notary.
20506
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: S. GRABOWSKY, R. HAAS, R. BREININGER, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 13 février 2014. Relation: RED/2014/346. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. ELS.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 13. Februar 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Folgt die Kopie der Anlage:
Anlage 1 - Satzung der LBBW:
SATZUNG
der
Landesbank Baden-Württemberg
- Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz -
<i>Präambeli>
Die Landesbank Baden-Württemberg (Landesbank) ist durch Vereinigung der Südwestdeutschen Landesbank Giro-
zentrale, der Landesgirokasse - öffentliche Bank und Landessparkasse und der Landeskreditbank Baden-Württemberg
gebildet worden. Gesetzliche Grundlage der Landesbank ist das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg vom
11. November 1998 (GBl. S.589), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. August 2010.
§ 1. Rechtsform, Sitze. Die Landesbank Baden-Württemberg ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit
Sitzen in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Mainz. Sitz des Vorstandsvorsitzenden ist Stuttgart. Die Landesbank kann
ohne regionale Begrenzung Niederlassungen, Zweigstellen, Börsenbüros und Repräsentanzen errichten und unterhalten.
§ 2. Träger und Haftung.
(1) Träger der Landesbank Baden-Württemberg sind der Sparkassenverband Baden-Württemberg (SVBW), das Land
Baden-Württemberg (Land), die Landeshauptstadt Stuttgart (Stadt), die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH
(Landesbeteiligungen BW) und die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - (L-Bank).
(2) Die Träger unterstützen die Landesbank bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.
Es besteht weder eine Verpflichtung der Träger noch ein Anspruch der Landesbank gegen die Träger, Mittel zur Verfügung
zu stellen.
(3) Die Träger der Landesbank am 18. Juli 2005 haften für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Verbindlichkeiten der Landesbank. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies
zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über
den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Die Träger werden ihren Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber
den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald sie bei deren
Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt haben, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen
der Landesbank nicht befriedigt werden können. Verpflichtungen der Landesbank aufgrund eigener Gewährträgerhaftung
oder vergleichbarer Haftungszusage oder einer durch die Mitgliedschaft in einem Sparkassenverband als Gewährträger
vermittelten Haftung sind vereinbart und fällig im Sinne der Sätze 1 bis 3 in dem gleichen Zeitpunkt wie die durch eine
solche Haftung gesicherte Verbindlichkeit. Mehrere Träger haften als Gesamtschuldner, im Innenverhältnis entsprechend
ihren Kapitalanteilen.
(4) Ein Träger der Landesbank kann unbeschadet von Absatz 5 allein oder gesamtschuldnerisch mit anderen Trägern
oder Dritten zeitlich befristete und betragsmäßig festgelegte Garantien gegen marktgerechte Gebühr übernehmen.
(5) Die Landesbank haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. Die Haftung der Träger ist auf
das satzungsmäßige Kapital beschränkt.
(6) Soweit ein Träger seinen gesamten Anteil am Stammkapital überträgt, kann er durch Erklärung gegenüber der
Landesbank als Träger ausscheiden. Die Erklärung bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Träger
scheidet mit Erteilung der Zustimmung aus; der ausgeschiedene Träger haftet im Außenverhältnis für bis dahin begründete
Verbindlichkeiten der Landesbank gemäß Absatz 3 entsprechend fort.
(7) Juristische Personen des öffentlichen Rechts können unter Beachtung der vorstehenden Absätze als weitere Träger
unter Beteiligung am Stammkapital durch Vertrag aufgenommen werden. Gleiches gilt für mit der Trägerschaft beliehene
Personen des Privatrechts, an denen ausschließlich Träger der Landesbank beteiligt sind. Die Beleihung erfolgt auf Antrag
des aufzunehmenden Trägers durch Verwaltungsakt der Rechtsaufsichtsbehörde.
§ 3. Stammkapital.
(1) Die Landesbank ist mit einem Stammkapital von 3.483.912.867,65 EUR ausgestattet.
(2) Das Stammkapital setzt sich zusammen aus
a. dem vor der Wirksamkeit der Kapitalerhöhung vom 22. Juni 2009 bestehenden und dem nach der Wirksamkeit der
Kapitalerhöhung vom 22. Juni 2009 geschaffenen Stammkapital von 2.320.212.867,65 EUR (Stammkapitalklasse A);
20507
L
U X E M B O U R G
b. dem Betrag des Stammkapitals von 1.163.700.000,- EUR, das mit Wirksamkeit der Kapitalerhöhung am 22. Juni 2009
gebildet wurde (Stammkapitalklasse B).
(3) Am Stammkapital der LBBW (Stammkapitalklassen A und B) in Höhe von 3.483.912.867,65 EUR sind beteiligt
a. der SVBW mit 1.412.173.351,77 EUR (40,534118 vom Hundert);
b. das Land mit 870.573.351,77 EUR (24,988379 vom Hundert);
c. die Stadt mit 659.566.164,11 EUR (18,931764 vom Hundert);
d. die Landesbeteiligungen BW mit 471.700.000,00 EUR (13,539374 vom Hundert);
e. die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank mit 69.900.000,00 EUR (2,006365 vom Hundert).
(4) Die Beteiligungen der Träger der LBBW am Stammkapital (A und B) und den beiden Stammkapitalklassen A und
B ergeben sich wie folgt:
Träger
Stammkapital
(A und B)
in EUR
(und Prozent)
Stamm-
kapital A
in EUR
Stamm-
kapital B
in EUR
SVBW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.412.173.351,77
(40,534118)
940.473.351,77
471.700.000,00
Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870.573.351,77
(24,988379)
870.573.351,77
0
Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659.566.164,11
(18,931764)
439.266.164,11
220.300.000,00
Landesbeteiligungen BW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
471.700.000,00
(13,539374)
0
471.700.000,00
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank . . . .
69.900.000,00
(2,006365)
69.900.000,00
0
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.483.912.867,65
(100,000000)
2.320.212.867,65 1.163.700.000,00
(5) Wenn und soweit die Satzung des SVBW bestimmt, dass seine Mitgliedssparkassen Anteile am Stammkapital
(Stammkapitalklassen A und B) unmittelbar aufbringen, werden diese Anteile ihm zugerechnet.
(6) Das Stammkapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden. Bei der Än-
derung ist festzulegen, auf welche Stammkapitalklasse(n) die Änderung erfolgt. Jedem Träger, der an der betroffenen
Stammkapitalklasse beteiligt ist, gebührt bei Erhöhungen ein seinem Anteil entsprechender Anteil am neuen Stammkapital
der jeweiligen Stammkapitalklasse. Soweit ein Träger von seinem Bezugsrecht innerhalb einer Stammkapitalklasse keinen
Gebrauch macht, wächst dieses den anderen Trägern dieser Stammkapitalklasse gegen einen entsprechenden Ausgleich
in dem Verhältnis zu, in welchem ihre Anteile in dieser Stammkapitalklasse zueinander stehen, sofern sie untereinander
nichts anderes vereinbaren.
(7) Die Landesbank kann von ihren Trägern und Dritten Genussrechtskapital, stille Einlagen sowie nachrangiges Haft-
kapital und andere Arten von Kapital nach Maßgabe des Gesetzes über das Kreditwesen aufnehmen.
§ 3a. Genehmigtes Kapital.
(1) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Stammkapital der LBBW einmalig oder mehr-
mals um bis zu insgesamt EUR 1.000.000.000,00 (in Worten: Euro eine Milliarde) gegen Bar- oder Sacheinlagen durch
Ausgabe neuer Anteile der Stammkapitalklasse A zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die neuen Anteile am Stammkapital
sind im Jahr ihres Entstehens zeitanteilig gewinnberechtigt, und zwar ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Einlageleistung.
(2) Das Genehmigte Kapital dient ausschließlich der Umwandlung der am 31.12.2012 bestehenden stillen Einlagen von
Trägern in Stammkapital. Der Vorstand darf das Genehmigte Kapital nur zu diesem Zweck ausüben. Zur Übernahme
neuer Anteile am Stammkapital darf der Vorstand nur die Träger zulassen, die am 31.12.2012 stille Einlagen halten, nämlich
SVBW, Land und Stadt. Das Bezugsrecht der anderen Träger und ein etwaiges Bezugsrecht Dritter ist ausgeschlossen.
(3) Den Ausgabebetrag der neuen Anteile am Stammkapital legt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest.
Der den Nennbetrag der neuen Anteile am Stammkapital übersteigende Ausgabebetrag ist als Agio nach § 272 Abs. 2 Nr.
1 HGB zu verbuchen. Über den weiteren Inhalt der mit den neuen Anteilen am Stammkapital verbundenen Rechte und
über die Bedingungen ihrer Ausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die mit den neuen
Anteilen am Stammkapital verbundenen Rechte dürfen nicht über die Rechte hinausgehen, die mit den gegenwärtig bes-
tehenden Anteilen der Stammkapitalklasse A verbunden sind.
§ 4. Aufgaben.
(1) Die Landesbank hat volle Geschäftsfreiheit. Sie kann alle Arten von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften
betreiben sowie alle sonstigen Geschäfte, die der Landesbank dienen.
(2) Die Landesbank stärkt den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie erbringt ihre Leistungen für die Bevölkerung, die
Wirtschaft und die öffentliche Hand unter Berücksichtigung der Markterfordernisse. Im Hinblick auf ihren öffentlichen
20508
L
U X E M B O U R G
Auftrag ist die Landesbank auch bestrebt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten soziale, ökologische, kulturelle und sonstige
gemeinnützige Vorhaben zu unterstützen.
(3) Die Landesbank ist Universalbank und internationale Geschäftsbank.
(4) Die Landesbank ist auch die Zentralbank der Sparkassen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Freistaat
Sachsen; zusammen mit den Verbundunternehmen der Sparkassen fördert und unterstützt sie die Wettbewerbsfähigkeit
der Sparkassen im Markt.
(5) Die Landesbank erfüllt auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart auch die Aufgaben einer Sparkasse in ents-
prechender Anwendung des § 6 Abs. 1 des Sparkassengesetzes.
(6) Die Landesbank ist auch Hausbank des Landes und der Stadt.
(7) Die Landesbank kann rechtlich unselbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts errichten, sich an Unternehmen
beteiligen und Verbänden als Mitglied beitreten. Sie kann sich ferner am Kapital von Kreditinstituten des öffentlichen
Rechts beteiligen und bei solchen Instituten Gewährträger oder Träger sein.
(8) Die Landesbank hat eine rechtlich unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung Baden-
Württembergische Bank („BW-Bank“) errichtet. Die BW-Bank übernimmt für Baden-Württemberg die Geschäftsfelder
des Privat- und Unternehmenskundengeschäfts der Landesbank und der bisherigen Baden-Württembergische Bank Ak-
tiengesellschaft mit einem besonderen Fokus auf das Mittelstandsgeschäft als operativ selbstständige Einheit innerhalb der
Landesbank. Sie erfüllt dabei auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart für die Landesbank auch die der Landesbank
nach Absatz 5 zugewiesenen Aufgaben einer Sparkasse. Im Rahmen der ihr zugewiesenen Aufgaben wird die BW-Bank
als Geschäftsbank tätig und kann alle Arten von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben. Sämtliche Erklä-
rungen und Rechtsgeschäfte für die BW-Bank berechtigen und verpflichten die Landesbank. Die Aufgaben und Organi-
sation der BW-Bank werden durch das von der Trägerversammlung am 6. Juli 2005 beschlossene Statut der BW-Bank
geregelt. Änderungen des Statuts werden von der Hauptversammlung als Satzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 LBWG beschlossen.
(9) Die Landesbank hat eine rechtlich unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung Rheinland-
Pfalz Bank („RP-Bank“) errichtet. Die RP-Bank übernimmt für Rheinland-Pfalz und die angrenzenden Wirtschaftsräume
als regionale Kundenbank das Geschäftsfeld des Unternehmenskundengeschäfts mit einem besonderen Fokus auf das
Mittelstandsgeschäft, das Private Banking und die Beratung institutioneller Kunden unter anderem in Fondsanlagen. Im
Rahmen der ihr zugewiesenen Aufgaben wird die RP-Bank als Geschäftsbank tätig und kann alle Arten von Bank- und
Finanzdienstleistungsgeschäften betreiben. Sämtliche Erklärungen und Rechtsgeschäfte für die RP-Bank berechtigen und
verpflichten die Landesbank. Die Aufgaben und Organisation der RP-Bank werden durch das von der Trägerversammlung
am 25. April 2008 beschlossene Statut der RP-Bank geregelt. Änderungen des Statuts werden von der Hauptversammlung
als Satzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 LBWG beschlossen.
(10) Die Landesbank hat eine rechtlich unselbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung „Sachsen
Bank“ errichtet. Die Sachsen Bank übernimmt für Sachsen und die angrenzenden Wirtschaftsräume als regionale Kun-
denbank das Geschäftsfeld des Unternehmenskundengeschäfts mit einem besonderen Fokus auf das Mittelstandsgeschäft
und das Geschäftsfeld Private Banking als operativ selbstständige Einheit innerhalb der Landesbank. Im Rahmen der ihr
zugewiesenen Aufgaben wird die Sachsen Bank als Geschäftsbank tätig und kann alle Arten von Bank- und Finanzdienst-
leistungsgeschäften betreiben. Sämtliche Erklärungen und Rechtsgeschäfte für die Sachsen Bank berechtigen und verp-
flichten die Landesbank. Die Aufgaben und Organisation der Sachsen Bank werden durch das von der Trägerversammlung
am 25. April 2008 beschlossene Statut der Sachsen Bank geregelt. Änderungen des Statuts werden von der Hauptver-
sammlung als Satzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 LBWG beschlossen.
§ 5. Pfandbriefe, Schuldverschreibungen, Mündelgeld.
(1) Die Landesbank ist berechtigt, Pfandbriefe, Kommunalobligationen und sonstige Schuldverschreibungen auszuge-
ben.
(2) Die im Umlauf befindlichen oder neu auszugebenden Pfandbriefe und sonstigen Schuldverschreibungen, die unter
das Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten fallen,
müssen den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend gedeckt sein.
(3) § 5 Abs. 5 der Satzung der Südwestdeutschen Landesbank Girozentrale in der Fassung vom 27. August 1992 sowie
§ 31 der Grundbestimmungen der Landesgirokasse - öffentliche Bank und Landessparkasse in der Fassung vom September
1992 gelten für die aufgrund dieser Vorschriften gebildeten gesonderten Deckungsmassen fort.
(4) Die Landesbank ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet.
§ 6. Organe, Pflichten.
(1) Organe der Landesbank sind die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.
(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bleibt
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit in den Organen der Landesbank bestehen. Der Vorstand kann im Einzelfall und für
bestimmte Zwecke, insbesondere Aussagen in gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, von der Verschwiegenheitsp-
flicht entbinden.
(3) Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vorstands, die ihre Pflichten verletzen, sind der Landesbank zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet.
20509
L
U X E M B O U R G
§ 7. Grundsätze der Geschäftsführung. Die Geschäfte der Landesbank sind nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu füh-
ren. Die der Landesbank obliegenden Aufgaben sind dabei auch zu berücksichtigen.
§ 8. Hauptversammlung. Die Hauptversammlung besteht aus den Trägern. Diese üben ihre Rechte in den Angelegen-
heiten der Landesbank in der Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg oder
diese Satzung nichts anderes bestimmen. Die Träger werden in der Hauptversammlung durch eine oder mehrere Per-
sonen vertreten.
§ 9. Aufgaben der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz über die Landesbank Baden-
Württemberg und in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, namentlich über
1. die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, die nicht von den Beschäftigten gewählt werden, sowie die Bestätigung
der Vertreter der Beschäftigten im Aufsichtsrat;
2. die Verwendung des Bilanzgewinns;
3. die Entlastung der Aufsichtsrats- und der Vorstandsmitglieder;
4. die Bestellung des Abschlussprüfers und des Prüfers nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes;
5. die Satzungen der Landesbank und deren Änderungen;
6. die Festsetzung und Änderung des Stammkapitals, die Ausgabe von Genussrechten und die Gewährung von stillen
Beteiligungen;
7. die Zustimmung zu Unternehmensverträgen im Sinne von §§ 291 und 292 des Aktiengesetzes und zur Kündigung
von Garantien im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung im Jahr 2009;
8. die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie die Aufwandsentschädigung der Beiräte.
§ 10. Sitzungen und Beschlüsse der Hauptversammlung.
(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate des Jahres statt, weitere Hauptver-
sammlungen, wenn das Wohl der Landesbank es erfordert und dann, wenn es der Aufsichtsrat oder ein Träger unter
Angabe der Verhandlungsgegenstände beantragt.
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand mit einer Frist von 30 Tagen einberufen, wobei der Tag der
Versammlung und der Tag der Einberufung nicht mitgerechnet werden. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter; ist auch dieser verhindert, ein anderes
vom Aufsichtsrat bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats.
(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn 50 vom Hundert des Stammkapitals vertreten sind. Die Beschlüsse
der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit), soweit die Sa-
tzung nichts anderes bestimmt. Beschlüsse der Hauptversammlung nach § 9 Nr. 2 sowie Nr. 5 bis Nr. 7 bedürfen
abweichend von Satz 2 einer Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen zählen nicht als
abgegebene Stimme.
(4) Die Stimmrechte der Träger richten sich nach der Höhe ihrer Beteiligung am Stammkapital; jeder Euro gewährt
eine Stimme.
§ 11. Geschäftsordnung der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.
§ 12. Aufsichtsrat, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern, die nach den §§13 und 14 bestellt werden.
(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter werden auf Vorschlag der Hauptversammlung vom Auf-
sichtsrat aus der Mitte des Aufsichtsrats gewählt, soweit das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg nichts
anderes bestimmt.
(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen zuverlässig sein und die zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion erfor-
derliche Sachkunde zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die die Landesbank betreibt, besitzen. Sie sind an
Weisungen nicht gebunden. Sie haben ihre Tätigkeit uneigennützig und verantwortungsbewusst auszuüben.
(4) Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats muss über Sachverstand in Rechnungslegung oder Abschlussprüfung
verfügen.
(5) Soweit das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg nichts anderes bestimmt, können Aufsichtsratsmit-
glieder nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Unabhängig von Satz 1 kann der stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die über
die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn seiner Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Neubestellung ist spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit durch-
zuführen. Wiederholte Bestellung ist möglich. Nach Ablauf der Amtszeit führen die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre
Tätigkeit bis zum Zusammentreten des neuen Aufsichtsrats fort.
§ 13. Mitgliedschaft im Aufsichtsrat.
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt, soweit sie nicht als Aufsichtsrats-
mitglieder der Beschäftigten nach § 14 zu wählen sind und das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg nichts
20510
L
U X E M B O U R G
anderes bestimmt. Sieben der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats, einschließlich des Vor-
sitzenden, müssen unabhängig sein. Jeder Träger hat das Recht, Wahlvorschläge zu unterbreiten.
(2) Ein Mitglied des Aufsichtsrats, das gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftlich seinen Rücktritt erklärt,
scheidet aus dem Aufsichtsrat aus.
(3) Aufsichtsratsmitglieder können vor Ablauf ihrer Amtszeit von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 75
vom Hundert der abgegebenen Stimmen abberufen werden. Ein Aufsichtsratsmitglied ist auf Antrag des Aufsichtsrats
oder eines Trägers von der Hauptversammlung abzuberufen, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund vorliegt.
§ 14. Beschäftigtenvertreter im Aufsichtsrat. Sieben Mitglieder des Aufsichtsrats werden als Vertreter der Beschäftigten
im Aufsichtsrat von den Beschäftigten der Landesbank gewählt und von der Hauptversammlung durch Wahl bestätigt,
soweit das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg nichts anderes bestimmt. Für die zu besetzenden Sitze wird
die dreifache Zahl von Beschäftigtenvertretern gewählt. Die Wahl erfolgt in entsprechender Anwendung des § 16 Abs. 1
Sätze 1, 3, 5 und 6, Abs. 2, 3 und 4 Sätze 1, 2 und 4, Abs. 5 des Sparkassengesetzes sowie der Sparkassenwahlordnung
mit der Maßgabe, dass
- in § 16 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des Sparkassengesetzes das Doppelte der nach Satz 2 zu wählenden Beschäf-
tigtenvertreter zugrunde zu legen sind,
- jeder Wahlberechtigte 21 Stimmen hat und
- der Personalrat oder im Falle des § 9 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) der Gesamtpersonalrat
der Landesbank spätestens zwölf Wochen vor Ablauf der Amtszeit mindestens drei wahlberechtigte Beschäftigte als
Wahlvorstand und je einen von ihnen als Vorsitzenden und als dessen Stellvertreter bestellt.
Wählbar sind Beschäftigte, die am Wahltag die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union be-
sitzen; im Übrigen gilt für die Wählbarkeit § 12 Abs. 1 und 2 LPVG entsprechend. Bei Verlust der Wählbarkeit scheidet
der Beschäftigtenvertreter aus dem Aufsichtsrat aus.
§ 15. Aufgaben des Aufsichtsrats.
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen. Ihm obliegt die Bestellung und Abberufung der Mitglieder
des Vorstands sowie die Bestellung und Abberufung des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden des Vors-
tands, ferner die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann stellvertretende
Vorstandsmitglieder bestellen; die stellvertretenden Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Vors-
tandsmitglieder. Der Aufsichtsrat wählt gemäß § 12 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden des Aufsichtsrats, soweit das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg nichts anderes bestimmt.
(2) Der Aufsichtsrat beschließt über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses;
2. die Einrichtung von Ausschüssen des Aufsichtsrats, insbesondere des Präsidial, Prüfungs- und Risikoausschusses
einschließlich der Geschäftsordnungen für die Ausschüsse;
3. die Geschäftsordnung des Vorstands und die Zustimmung zu der vom Vorstand vorgeschlagenen Geschäftsvertei-
lung;
4. die Beauftragung des Abschlussprüfers und des Prüfers nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes;
5. die Zustimmung zu folgenden Maßnahmen und Geschäften:
a. Änderung der Grundsätze der Geschäftspolitik;
b. vom Vorstand jährlich gemäß § 27 vorzulegender Wirtschaftsplan;
c. Errichtung von Auslandsniederlassungen;
d. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und von Unternehmen nach Maßgabe der Geschäft-
sordnung des Vorstands;
e. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Vorstands;
f. Hereinnahme von Kapital nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Vorstands, sofern dies nicht in die Zuständigkeit
der Hauptversammlung fällt;
g. bauliche Maßnahmen nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Vorstands;
h. weitere Maßnahmen und Geschäfte, die der Aufsichtsrat von seiner Zustimmung abhängig macht;
6. die ihm in dieser Satzung zugewiesenen sonstigen Aufgaben.
(3) Der Aufsichtsrat kann jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten der Landesbank verlangen. Er kann auch die
Bücher und Schriften der Landesbank sowie die Vermögensgegenstände einsehen und prüfen. Er kann damit auch einzelne
Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen.
(4) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
§ 16. Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats.
(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats beruft den Aufsichtsrat bei Bedarf, mindestens jedoch viermal im Jahr ein und
leitet dessen Sitzungen. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bestimmt das Nähere, insbesondere Form und Frist der
Einberufung.
20511
L
U X E M B O U R G
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit); Enthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimme.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bestimmt das Nähere.
§ 17. Ausschüsse des Aufsichtsrats.
(1) Der Aufsichtsrat bildet zu seiner Unterstützung folgende Ausschüsse:
a. Präsidialausschuss;
b. Prüfungsausschuss;
c. Risikoausschuss.
Er kann weitere Ausschüsse einrichten.
(2) Mitglieder der Ausschüsse müssen Mitglieder des Aufsichtsrats sein. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat endet auch die Mitgliedschaft in den Ausschüssen. Ein Mitglied eines Ausschusses, das gegenüber dem jeweiligen
Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich seinen Rücktritt erklärt, scheidet aus diesem Ausschuss aus. Die Vorsitzenden
der Ausschüsse und ihre Stellvertreter werden vom Aufsichtsrat aus der Mitte der Ausschüsse gewählt.
(3) Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
Weitere Einzelheiten regelt der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung des Ausschusses.
§ 18. Präsidialausschuss.
(1) Der Präsidialausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, nämlich dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, seinem Stellver-
treter und drei Mitgliedern des Aufsichtsrats, darunter ein nach § 14 der Satzung gewähltes oder nach § 19 Abs. 1 Nr. 2
des Gesetzes über die Landesbank Baden-Württemberg bestimmtes Mitglied.
(2) Der Präsidialausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Er beschließt über die Anstellung
und Entlassung der Vorstandsmitglieder, wobei die Festlegung der Vergütung dem Aufsichtsrat obliegt. Er vertritt die
Landesbank gegenüber dem Vorstand. Der Präsidialausschuss begleitet die Landesbank bei der Restrukturierung.
(3) Die nach § 13 der Satzung gewählten oder nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landesbank Baden-
Württemberg entsandten Aufsichtsratsmitglieder des Präsidialausschusses bilden den Nominierungsausschuss. Sie schla-
gen der Hauptversammlung geeignete Aufsichtsratsmitglieder vor, soweit sich aus dem Gesetz über die Landesbank
Baden-Württemberg nichts anderes ergibt.
§ 19. Prüfungsausschuss.
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus acht Mitgliedern, darunter ein Mitglied nach § 12 Abs. 4 und ein nach § 14 der
Satzung gewähltes oder nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Landesbank Baden-Württemberg bestimmtes
Mitglied. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses muss über eine besondere Expertise im Rechnungswesen für Banken
verfügen.
(2) Der Prüfungsausschuss überwacht den Rechnungslegungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems,
des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems sowie die Prüfung des Jahres- und des Konzernabs-
chlusses. Er überwacht und überprüft die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, insbesondere die von diesem für die
Landesbank neben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen. Er berichtet dem Aufsichtsrat über das Ergebnis der
Prüfung des Jahresabschlusses.
(3) Der Abschlussprüfer berichtet dem Prüfungsausschuss über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung gewonnenen
Erkenntnisse, insbesondere über wesentliche Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses. Er
erklärt gegenüber dem Prüfungsausschuss jährlich schriftlich seine Unabhängigkeit von der Landesbank, informiert den
Prüfungsausschuss jährlich über die von ihm gegenüber der Landesbank neben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leis-
tungen und erörtert mit dem Prüfungsausschuss die Risiken für seine Unabhängigkeit sowie die von ihm dokumentierten
Schutzmaßnahmen zur Minderung dieser Risiken.
§ 20. Risikoausschuss.
(1) Der Risikoausschuss besteht aus acht Mitgliedern, darunter ein nach § 14 der Satzung gewähltes oder nach § 19
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Landesbank Baden-Württemberg bestimmtes Mitglied. Der Vorsitzende und dessen
Stellvertreter müssen über bankfachliche Expertise verfügen.
(2) Der Risikoausschuss überwacht die Geschäftsführung des Vorstands einschließlich der in § 4 Abs. 8 bis 10 bes-
chriebenen Geschäftsfelder der unselbstständigen Anstalten im Hinblick auf die Risikoarten sowie die Wirksamkeit des
internen Kontrollsystems, des internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems. Dem Risikoausschuss ob-
liegt die Zustimmung zu Angelegenheiten des Aktivgeschäfts nach Maßgabe der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ge-
schäftsordnung für den Risikoausschuss. Er ist zudem über Kredite zu unterrichten, die über vom Aufsichtsrat in der
Geschäftsordnung festgelegte Merkmale verfügen.
(3) In dringenden Fällen kann die Gewährung von Krediten oder Risikovolumina durch den Vorstand ohne Zustimmung
des Risikoausschusses geschehen. Der Vorstand hat die Gründe und den wesentlichen Inhalt der Eilentscheidung dem
Risikoausschuss in der nächsten Sitzung mitzuteilen.
20512
L
U X E M B O U R G
§ 21. Sparkassenfachbeirat.
(1) Für die Zusammenarbeit der Landesbank als Zentralbank mit den Sparkassen in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Sachsen und für das kooperative Zusammenwirken zwischen Landesbank und Sparkassen sowie ihren Verbun-
dunternehmen wird ein Sparkassenfachbeirat eingerichtet.
(2) Der Sparkassenfachbeirat besteht aus 16 Mitgliedern mit Stimmrecht sowie einem beratenden Mitglied ohne
Stimmrecht. Sämtliche Mitglieder müssen Vorstandsvorsitzende von Sparkassen nach Absatz 1 oder Verbandsgeschäfts-
führer des SVBW oder des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz (SVRP) sein. Vom SVBW werden zehn Mitglieder mit
Stimmrecht und vom SVRP drei Mitglieder mit Stimmrecht sowie das beratende Mitglied ohne Stimmrecht entsandt.
Weitere Mitglieder mit Stimmrecht sind die jeweiligen Obleute der drei Sparkassenarbeitsgemeinschaften im Freistaat
Sachsen. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt, wobei die jeweiligen Obleute der drei Sparkassenarbeitsge-
meinschaften im Freistaat Sachsen durch ihre jeweiligen stellvertretenden Obleute vertreten werden.
(3) Die Mitglieder und ihre Stellvertreter werden für die Dauer von fünf Jahren entsandt. Die Neuentsendung ist
spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit durchzuführen. Die Mitglieder und ihre Stellvertreter können jederzeit
abberufen werden. Wiederholte Entsendung ist zulässig.
(4) Die Mitglieder des Sparkassenfachbeirats wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden des Sparkassenfachbeirats und
dessen Stellvertreter.
(5) Der Vorsitzende des Vorstands der Landesbank und ein für Sparkassenangelegenheiten zuständiges Vorstandsmit-
glied sowie deren Vertreter aus dem Vorstand nehmen an den Sitzungen des Sparkassenfachbeirats mit beratender Stimme
teil. Im Bedarfsfall kann der Sparkassenfachbeirat die Teilnahme weiterer Vorstandsmitglieder verlangen.
(6) Der Sparkassenfachbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung.
(7) Der Sparkassenfachbeirat kann zur Beratung der Vorstände der unselbstständigen Anstalten RP-Bank und Sachsen
Bank in sparkassenspezifischen Angelegenheiten in Rheinland-Pfalz und dem Freistaat Sachsen jeweils regionale Sparkas-
senfachbeiräte bilden, deren Mitglieder Vorstandsvorsitzende von Sparkassen aus den jeweiligen Ländern sein sollen.
Absätze 3, 4 und 6 gelten entsprechend.
§ 22. Aufgaben des Sparkassenfachbeirats.
(1) Der Sparkassenfachbeirat vertritt die Interessen der Sparkassen gegenüber der Landesbank und berät die Landes-
bank in ihrer Sparkassenzentralbankfunktion; er ist insoweit zuständig für
1. die Überwachung der Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen;
2. die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich der Preisgestaltung für die Sparkassen;
3. die Ergänzung des Produktangebots der Landesbank für die Sparkassen;
4. grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit und neue Vereinbarungen zwischen der Landesbank und den Sparkassen
sowie ihren Verbundunternehmen.
Der Sparkassenfachbeirat kann hierzu vom Vorstand sachdienliche Informationen verlangen.
(2) Der Vorstand legt dem Sparkassenfachbeirat alle notwendigen Unterlagen zu den Angelegenheiten nach Absatz 1
zur Beratung vor.
(3) Sofern kein Einvernehmen zwischen Sparkassenfachbeirat und Vorstand erreicht wird, können beide Seiten den
Aufsichtsrat zur Vermittlung anrufen.
(4) Die Bestellung und Abberufung des für Angelegenheiten der Sparkassen zuständigen Vorstandsmitglieds der Lan-
desbank bedarf der Anhörung des Sparkassenfachbeirats.
§ 23. Vorstand, Vorsitzender.
(1) Der Vorstand besteht aus mehreren Mitgliedern.
(2) Die Mitglieder des Vorstands werden für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt und privatrechtlich angestellt;
eine Wiederbestellung ist möglich. Über die Wiederbestellung von Mitgliedern des Vorstands ist frühestens zwölf und
spätestens sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen Bestellungsperiode zu beschließen. Mitglieder des Vorstands, die das
60. Lebensjahr überschritten haben, können längstens bis zum Ablauf des Monats bestellt oder wiederbestellt werden, in
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden; in besonders gelagerten Einzelfällen kann der Aufsichtsrat auch eine längere Bes-
tellung oder Wiederbestellung beschließen.
(3) Der Aufsichtsrat bestimmt einen Vorsitzenden des Vorstands und kann einen oder mehrere stellvertretende Vor-
sitzende des Vorstands bestimmen.
(4) Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein
solcher Grund ist insbesondere eine grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung, Ver-
trauensentzug durch die Hauptversammlung oder Unverträglichkeit, die eine kollegiale Zusammenarbeit im Vorstand
gefährdet oder ausschließt. Der Widerruf ist wirksam, bis seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist. Dies gilt für
den Widerruf der Bestellung zum stellvertretenden Mitglied sowie die Bestellung zum Vorsitzenden und zu stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Vorstands entsprechend.
20513
L
U X E M B O U R G
§ 24. Aufgaben des Vorstands.
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Landesbank in eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze und im
Unternehmensinteresse. Er vertritt die Landesbank. Bei ihrer Geschäftsführung haben die Vorstandsmitglieder die Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
(2) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der Landesbank zuständig, für die nicht nach dem Gesetz über die
Landesbank Baden-Württemberg oder auf Grund dieser Satzung eine andere Zuständigkeit bestimmt ist. Er ist Dienst-
vorgesetzter sämtlicher Beschäftigter der Landesbank, einschließlich ihrer Niederlassungen, Filialen, Börsenbüros, Re-
präsentanzen und rechtlich unselbstständiger Anstalten des öffentlichen Rechts.
(3) Der Vorsitzende des Vorstands unterrichtet den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dessen Stellvertreter über
wichtige Vorkommnisse.
§ 25. Vertretung, Zeichnungsbefugnis.
(1) Erklärungen im Namen der Landesbank werden durch zwei Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Vors-
tands abgegeben. Für den laufenden Geschäftsverkehr kann der Vorstand bestimmen, dass ein Mitglied oder ein
stellvertretendes Mitglied des Vorstands mit einem Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter gemeinsam die Landesbank ver-
treten können.
(2) Der Vorstand kann, soweit es die Sicherheit zulässt, bestimmen, dass bei bestimmten Geschäften ein Mitarbeiter
allein zur Vertretung berechtigt ist.
(3) Folgende schriftliche Erklärungen sind ohne Unterschrift rechtsverbindlich:
1. Scheckkarten und ähnliche in großer Zahl abgegebene Garantieerklärungen, auf denen der Inhaber im Zeitpunkt der
Ausgabe eingetragen ist;
2. maschinenmäßig erstellte und abgestimmte Verzeichnisse, Abrechnungen und abrechnungsähnliche Mitteilungen,
Rechnungsabschlüsse, Konten- und Depotauszüge;
3. Buchungsanzeigen und Mitteilungen über die Änderung von Zinssätzen, Provisionen, Gebühren, Zins- und Tilgungs-
raten;
4. andere Erklärungen und maschinenmäßig erstellte und mit einem Kontrollstempel versehene Empfangsbescheini-
gungen, wenn die Landesbank unter Angabe der Art der Erklärung durch Aushang oder Auflegung in den Kassenräumen
oder durch Vermerk im Vordruck hierauf hingewiesen hat.
(4) Die Zeichnungsbefugnis wird durch den Vorstand in einem Unterschriftenverzeichnis niedergelegt. Im Übrigen
werden die Namen und Unterschriften der Vertretungsberechtigten an der Stelle ausgehängt oder aufgelegt, bei der die
Vertretungsberechtigten tätig sind.
(5) Urkunden, die vom Vorstand oder von den mit seiner Vertretung beauftragten Personen ausgestellt und mit dem
Siegel versehen sind, gelten als Urkunden einer öffentlichen Behörde.
(6) Rechtsverbindliche Erklärungen der Landesbank können auch aufgrund einer Vollmacht durch einen oder mehrere
Beauftragte schriftlich oder mündlich abgegeben werden.
(7) Erklärungen und Urkunden, die den vorstehenden Vorschriften genügen, sind für die Landesbank ohne Rücksicht
auf die Einhaltung sonstiger satzungsmäßiger Bestimmungen im Einzelfall rechtsverbindlich.
(8) Die Vertretungsberechtigung wird für die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Vorstands durch den
Vorsitzenden des Präsidialausschusses, im Übrigen durch den Vorstand bescheinigt.
§ 26. Beiräte.
(1) Zur sachverständigen Beratung der Landesbank können ein Beirat oder mehrere Beiräte gebildet werden.
(2) Die Mitglieder werden durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats berufen und abberufen. Sie sind
ehrenamtlich tätig.
(3) Die Mitglieder der Beiräte können eine von der Hauptversammlung festgesetzte Aufwandsentschädigung erhalten.
(4) Für die Amtsniederlegung von Mitgliedern des Beirats gilt § 13 Abs. 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass der
Rücktritt schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden des Beirats zu erklären ist.
§ 27. Wirtschaftsplan. Der Vorstand stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der dem Aufsichtsrat spätestens bis zum
Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres zur Genehmigung vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan enthält auch eine fünf-
jährige Mittelfristplanung.
§ 28. Jahresabschluss und Geschäftsbericht.
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses, Lageberichts, Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts richtet sich nach den dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen und dem vom Aufsichtsrat beauftragten Abschluss-
prüfer unverzüglich zur Prüfung vorzulegen.
20514
L
U X E M B O U R G
(3) Der Vorstand hat den geprüften Abschluss zusammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht unverzüglich
nach Eingang des Prüfungsberichts dem Aufsichtsrat zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen; entsprechendes
gilt für die Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zur Kenntnisnahme.
(4) Die Landesbank erstellt jährlich einen Geschäftsbericht.
§ 29. Gewinnverwendung. Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung. Die Hauptver-
sammlung kann unterschiedliche Ausschüttungen für die in § 3 Abs. 2 geregelten Stammkapitalklassen A und B festlegen.
Sofern ein Ausschüttungsbeschluss für eine oder beide Stammkapitalklassen erfolgt, sind die Ausschüttungen innerhalb
der jeweiligen Stammkapitalklasse an die Träger im Verhältnis der dort bestehenden Anteile der Träger vorzunehmen.
Wenn und soweit die Satzung des SVBW bestimmt, dass seine Mitgliedssparkassen Anteile am Stammkapital (Stamm-
kapitalklassen A und B) unmittelbar aufbringen, sind die darauf entfallenden Ausschüttungen innerhalb der jeweiligen
Stammkapitalklasse unmittelbar an die Mitgliedssparkassen vorzunehmen.
§ 30. Auflösung. Im Fall der Auflösung der Landesbank ist die Liquidation vom Vorstand vorzunehmen, soweit die
Träger nichts anderes vereinbaren. Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen fällt den
Trägern entsprechend ihren Anteilen am Stammkapital zu.
§ 31. Siegel. Die Landesbank führt ein Siegel mit dem kleinen Landeswappen und der Umschrift „Landesbank Baden-
Württemberg“.
§ 32. Öffentliche Bekanntmachungen.
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Landesbank sind im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg vorzunehmen.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg können durch eine Auslegung an allen
Sitzen der Landesbank unter gleichzeitigem Hinweis auf diese Art der Bekanntmachung im Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg ersetzt werden.
(3) Auf die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen findet Absatz 2 keine Anwendung.
§ 33. In- und Außerkrafttreten.
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft; gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Südwestdeutschen Lan-
desbank Girozentrale außer Kraft.
(2) Änderungen dieser Satzung treten am Tage nach der Bekanntmachung (§ 32) im Staatsanzeiger für Baden-Würt-
temberg in Kraft, soweit nichts anderes bestimmt wird.
Es folgt die englische Übersetzung von Anlage 1 - Satzung der LBBW:
wobei darauf hingewiesen wird, dass ausschließlich die deutsche Fassung von Anlage 1 (Satzung der LBBW)
maßgeblich ist und die nachfolgende englische Übersetzung nur der Information dient.
The following is an English translation of Annex 1 - Ordinance of LBBW:
it being pointed out that solely the German version of Annex 1 (Ordinance of LBBW) shall be authoritative
and that the following English translation is only intended for information purposes.
Annex 1 - Ordinance of LBBW:
ORDINANCE
of
Landesbank Baden-Württemberg
- Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, and Mainz -
<i>Preamblei>
Landesbank Baden-Württemberg (Landesbank) was established through the merger of Südwestdeutsche Landesbank
Girozentrale, Landesgirokasse - öffentliche Bank und Landessparkasse, and Landeskreditbank Baden-Württemberg. The
legal basis of Landesbank is the Landesbank Baden-Württemberg Act (Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg
- LBWG) of 11 November 1998 [Baden-Württemberg Law Gazette (Gesetzblatt für Baden-Württemberg - GBl.) p. 589]
last amended by the law of 14 August 2010.
§ 1. Legal Status, Registered Offices. Landesbank Baden-Württemberg is an institution under public law with legal
capacity and with registered offices in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, and Mainz. The head office of the Chairman of the
Board of Managing Directors (Vorstand) is Stuttgart. Landesbank may establish and operate branches, offices, stock
exchange offices, and representative offices without regional restriction.
§ 2. Owners (Träger) and Liability.
(1) The Owners of Landesbank Baden-Württemberg are the Savings Banks Association of Baden-Württemberg (Spar-
kassenverband Baden-Württemberg - SVBW), the State of Baden-Württemberg (the State), the state capital Stuttgart
(the City), Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH (Landesbeteiligungen BW) and Landeskreditbank Baden-
Württemberg - Förderbank - (L-Bank).
20515
L
U X E M B O U R G
(2) The Owners shall support Landesbank in the execution of its duties according to the following provisions. The
Owners are neither obliged to provide funds nor does Landesbank have the right to claim the provision of funds from
the Owners.
(3) The Owners of Landesbank as at 18 July 2005 are responsible for honoring all liabilities of Landesbank existing at
this date. For liabilities agreed by 18 July 2001 this applies without time limit; for those agreed after this date and until 18
July 2005, this applies only if their maturity does not go beyond 31 December 2015. The Owners will immediately honor
their obligations arising from the guarantor's liability (Gewährträgerhaftung) vis-à-vis the creditors of liabilities agreed
until 18 July 2005 as soon as they have stated in due manner and in writing upon these liabilities falling due that the
creditors of these liabilities cannot be satisfied from the assets of Landesbank. The obligations of Landesbank resulting
from its own guarantor's liability or comparable liability undertaking or a liability arising from membership in a savings
banks association as guarantor are laid down and fall due under the terms of sentences (1) - (3) at the same moment as
the obligation secured by such an undertaking. Several Owners are jointly and severally responsible, in their internal
relationships according to their interests in the capital.
(4) Irrespective of paragraph 5, any Owner of Landesbank may accept, solely or jointly and severally with other Owners
or third parties, guarantees limited in time and amount for a fair market rate.
(5) Landesbank shall be liable to the full extent of its assets. The liability of the Owners shall be limited to the statutory
capital.
(6) Should an Owner transfer its entire interest in the nominal capital, it may withdraw as an Owner by submitting a
declaration to this effect to Landesbank. The declaration shall require the approval of the Supervisory Authority on Points
of Law (Rechtsaufsichtsbehörde). The withdrawal of the Owner shall become effective upon such approval; the former
Owner shall remain liable to third parties for obligations of Landesbank that were established at the time of its withdrawal
pursuant to paragraph 3.
(7) Under consideration of the foregoing paragraphs, legal entities under public law may be admitted by contract as
additional Owners provided that they acquire interests in the nominal capital. The same applies to persons in private law
that are appointed as Owners, in which only the Owners of Landesbank have an interest. The appointment shall be
effected upon request of the Owner to be admitted by an administrative act of the Supervisory Authority on Points of
Law.
§ 3. Nominal Capital.
(1) Landesbank has a nominal capital of EUR 3,483,912,867.65.
(2) The nominal capital consists of
a. the nominal capital of EUR 2,320,212,867.65, which existed before the capital increase took effect on 22 June 2009
and which was created after the capital increase took effect on 22 June 2009 (nominal capital category A);
b. the nominal capital of EUR 1,163,700,000.-, which was formed when the capital increase took effect on 22 June 2009
(nominal capital category B).
(3) The following hold stakes in the nominal capital of LBBW (nominal capital categories A and B) of EUR
3,483,912,867.65
a. the SVBW EUR 1,412,173,351.77 (40.534118 percent);
b. the State EUR 870,573,351.77 (24.988379 percent);
c. the City EUR 659,566,164.11 (18.931764 percent);
d. Landesbeteiligungen BW EUR 471,700,000.00 (13.539374 percent);
e. L-Bank EUR 69,900,000.00 (2.006365 percent).
(4) The interests of the Owners of LBBW in the nominal capital (A and B) and the two nominal capital categories A
and B are as follows:
Owner
Nominal capital
(A and B)
in EUR
(and percent)
Nominal
capital A
in EUR
Nominal
capital B
in EUR
SVBW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,412,173,351.77
(40.534118)
940,473,351.77
471,700,000.00
State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870,573,351.77
(24.988379)
870,573,351.77
0
City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
659,566,164.11
(18.931764)
439,266,164.11
220,300,000.00
Landesbeteiligungen BW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
471,700,000.00
(13.539374)
0
471,700,000.00
L-Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,900,000.00
(2.006365)
69,900,000.00
0
20516
L
U X E M B O U R G
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,483,912,867.65
(100.000000)
2,320,212,867.65 1,163,700,000.00
(5) If and to the extent that the ordinance of the SVBW requires that its member savings banks make direct contri-
butions to the nominal capital (nominal capital categories A and B), these interests shall be attributed to the SVBW.
(6) The nominal capital may be increased or decreased by resolution passed by the General Meeting (Hauptversamm-
lung). In this context, it has to be determined which nominal capital category/categories shall be increased or decreased.
When the nominal capital is increased, each Owner that holds an interest in the nominal capital category concerned shall
be entitled to an interest in the new nominal capital of the respective nominal capital category that corresponds to its
interest in the previous nominal capital. Inasmuch as an Owner does not exercise its preemptive right within one nominal
capital category, this preemptive right - unless otherwise agreed by the Owners - shall accrue to the other Owners of
this nominal capital category, in consideration of a compensatory payment, in the same proportion as the Owners hold
their pro-rata interests in the nominal capital.
(7) In accordance with the provisions of the German Banking Act (Gesetz über das Kreditwesen - KWG) Landesbank
may accept capital generated by profit-participation certificates (Genussrechtskapital), capital contributed by silent part-
ners (stille Einlagen), as well as subordinated liable capital and other types of capital from its Owners and third parties.
§ 3a. Authorized Capital.
(1) The Board of Managing Directors is, with the approval of the Supervisory Board, authorized to increase the nominal
capital of LBBW by up to a total amount of EUR 1,000,000,000.00 (in words: one billion euros), on one or more occasions,
by issuing new shares in the nominal capital category A against cash contributions or contributions in kind (authorized
capital). The new shares in the nominal capital shall participate in the profit on a pro rata temporis basis in the year of
their creation from the date the respective contribution is made.
(2) The Authorized Capital shall be used for the sole purpose of the conversion of the silent participation held by the
Owners in the nominal capital existing on 31 December 2012. The Board of Managing Directors may exercise the Au-
thorized Capital solely for this purpose. The Board of Managing Directors may permit only the Owners, namely SVBW,
State and City, which hold silent participations on 31 December 2012, to acquire new shares in the nominal capital. The
preemptive right of the other Owners and any preemptive right of a third party shall be excluded.
(3) The Board of Managing Directors shall, with the approval of the Supervisory Board, determine the issue price of
the new shares in the nominal capital. The issue price that exceeds the nominal value of the new shares in the nominal
capital shall be recorded as premium in accordance with section 272 para. 2 no. 1 of the German Commercial Code
(HGB). The Board of Managing Directors, shall, with the approval of the Supervisory Board, decide on the contents of
the rights associated with the new shares in the nominal capital. The rights associated with the new shares in the nominal
capital may not go beyond the rights granted in connection with the currently existing interests in the nominal capital
category A.
§ 4. Duties.
(1) Landesbank shall have full freedom to conduct business. It may engage in all types of banking and financial service
activities as well as in all other activities that are useful to Landesbank.
(2) Landesbank shall strengthen competition in the banking business. It shall provide its services in the interest of the
people, the economy, and the public sector, taking into account market requirements. With regard to its public function,
Landesbank shall also endeavor, to the extent it is able to do so, to support social, environmental, cultural, and other
public-interest projects.
(3) Landesbank is a universal bank and an international commercial bank.
(4) Landesbank is also the central bank for the savings banks (Sparkassen) in Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate,
and the Free State of Saxony; jointly with the associated enterprises of the savings banks, it promotes and supports the
competitiveness of the savings banks in the market.
(5) Landesbank also performs the duties of a savings bank in the territory of the state capital Stuttgart under analogous
application of section 6 para. 1 of the Savings Bank Act (Sparkassengesetz).
(6) Landesbank is also the principal banker of the State and of the City.
(7) Landesbank may create legally dependent institutions under public law, invest in enterprises, and become a member
of associations. In addition, it may acquire interests in the capital of credit institutions under public law and be a guarantor
or owner of such institutions.
(8) Landesbank established a legally dependent institution under public law entitled Baden-Württembergische Bank
(“BW-Bank”). As a unit operating independently within Landesbank, BW-Bank is now responsible for the retail and
corporate customers business areas of Landesbank and former Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft for
Baden-Württemberg, placing a special focus on medium-sized businesses. In this context, on behalf of Landesbank BW-
Bank also carries out the responsibilities of a savings bank in Stuttgart, the state capital of Baden-Württemberg, assigned
to Landesbank pursuant to paragraph 5. Within the scope of duties assigned to it, BW-Bank operates as a commercial
bank and may engage in all types of banking and financial service activities. Any and all statements and legal transactions
of BW-Bank entitle and commit Landesbank. The duties and organization of BW-Bank are governed by the Articles of
20517
L
U X E M B O U R G
Incorporation (Statut) of BW-Bank, adopted by the Owners' Meeting on 6 July 2005. Pursuant to section 8 para. 2 no. 5
of the Landesbank Baden-Württemberg Act, amendments of the Articles of Incorporation can only be adopted by res-
olution of the General Meeting.
(9) Landesbank established a legally dependent institution under public law entitled Rheinland-Pfalz Bank (“RP-Bank”).
RP-Bank, as a regional bank with a strong customer focus, is now responsible for the corporate customer business area,
placing a special focus on medium-sized businesses, in addition to private banking and the provision of advisory services
for institutional customers, also with regard to investments in funds, for Rhineland-Palatinate and the adjacent economic
areas. Within the scope of duties assigned to it, RP-Bank operates as a commercial bank and may engage in all types of
banking and financial service activities. Any and all statements and legal transactions of RP-Bank entitle and commit Land-
esbank. The duties and organization of RP-Bank are governed by the Articles of Incorporation (Statut) of RP-Bank, adopted
by the Owners' Meeting on 25 April 2008. Pursuant to section 8 para. 2 no. 5 of the Landesbank Baden-Württemberg
Act, amendments of the Articles of Incorporation can only be adopted by resolution of the General Meeting.
(10) Landesbank established a legally dependent institution under public law entitled “Sachsen Bank”. As a unit operating
independently within Landesbank, Sachsen Bank, as a regional bank with a strong customer focus, is now responsible for
the corporate customer business area, placing a special focus on medium-sized businesses, and the private banking business
area for Saxony and the adjacent economic areas. Within the scope of duties assigned to it, Sachsen Bank operates as a
commercial bank and may engage in all types of banking and financial service activities. Any and all statements and legal
transactions of Sachsen Bank entitle and commit Landesbank. The duties and organization of Sachsen Bank are governed
by the Articles of Incorporation (Statut) of Sachsen Bank, adopted by the Owners' Meeting on 25 April 2008. Pursuant
to section 8 para. 2 no. 5 of the Landesbank Baden-Württemberg Act, amendments of the Articles of Incorporation can
only be adopted by resolution of the General Meeting.
§ 5. Mortgage-Backed Bonds, Bonds, Money in Trust for Wards.
(1) Landesbank is authorized to issue mortgage-backed bonds (Pfandbriefe), public debt-backed bonds (Kommunalo-
bligationen), and other bonds (Schuldverschreibungen).
(2) Mortgage-backed bonds and other bonds that are outstanding or yet to be issued and that are subject to the
German Act on Mortgage-Backed Bonds and Similar Bonds Issued by Public-Law Credit Institutions (Gesetz über die
Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten) must be covered in accordance
with the provisions of that Act.
(3) Section 5 para. 5 of the ordinance of Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale in the version of 27 August 1992
and section 31 of the basic provisions of Landesgirokasse - öffentliche Bank und Landessparkasse in the version of Sep-
tember 1992 shall continue to apply to the separate cover asset pools created on the basis of these provisions.
(4) Landesbank qualifies for holding money in trust for wards (Mündelgeld).
§ 6. Executive Bodies, Responsibilities.
(1) The executive bodies of Landesbank are the General Meeting (Hauptversammlung), the Supervisory Board (Auf-
sichtsrat), and the Board of Managing Directors (Vorstand).
(2) The members of the Supervisory Board and of the Board of Managing Directors are obliged to maintain secrecy.
This obligation shall survive the termination of their service on Landesbank's executive bodies. The Board of Managing
Directors may waive the obligation to maintain secrecy in individual cases and for specific purposes, in particular to permit
testimony in judicial or administrative proceedings.
(3) Members of the Supervisory Board and of the Board of Managing Directors who violate their responsibilities shall
be jointly and severally liable to Landesbank for compensating any damage resulting therefrom.
§ 7. Principles Governing Business Operations. Landesbank shall conduct its business in accordance with economic
principles. In doing so, the duties incumbent upon Landesbank shall also be taken into account.
§ 8. General Meeting (Hauptversammlung). The General Meeting is comprised of the Owners. The Owners shall
exercise their rights with respect to Landesbank's affairs at sessions of the General Meeting, unless otherwise provided
for by the Landesbank Baden-Württemberg Act or this Ordinance. The Owners shall be represented at sessions of the
General Meeting by one or several persons.
§ 9. Duties of the General Meeting. The General Meeting shall pass resolutions on the matters expressly provided for
in the Landesbank Baden-Württemberg Act or in this Ordinance, more specifically on
1. the appointment of the members of the Supervisory Board who are not elected by the employees, and the confir-
mation of the employee representatives on the Supervisory Board;
2. the appropriation of the distributable profit;
3. the approval of past activities of the members of the Supervisory Board and the members of the Board of Managing
Directors;
4. the appointment of the auditors of the financial statements and the auditors pursuant to section 36 of the German
Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG);
5. the Ordinances of Landesbank and their amendments;
20518
L
U X E M B O U R G
6. the determination of and changes in the nominal capital, the issuance of profit-participation rights and the acceptance
of silent partners' contributions;
7. the approval of enterprise agreements within the meaning of sections 291 and 292 of the German Stock Corporation
Act (Aktiengesetz - AktG) and of the termination of guaranties in connection with the risk shield in the year 2009;
8. the remuneration of the members of the Supervisory Board and the representation allowance of the members of
any Advisory Boards (Beiräte).
§ 10. Sessions and Resolutions of the General Meeting.
(1) The Ordinary General Meeting shall be held within the first eight months of the year, while any further General
Meetings shall be held as needed in the interest of Landesbank or should the Supervisory Board or an Owner apply for
a General Meeting to be convened, stating the issues to be dealt with.
(2) The Board of Managing Directors shall convene General Meetings with 30 days notice, excluding both the day the
meeting is held and the day on which the meeting is convened. Any General Meeting shall be chaired by the Chairman of
the Supervisory Board, or, should he be prevented from attendance, his deputy; should the deputy also be prevented
from attendance, another member of the Supervisory Board determined by the Supervisory Board shall chair the General
Meeting.
(3) 50 percent of the nominal capital must be represented at a session of the General Meeting in order to constitute
a quorum. Resolutions passed at General Meetings shall require a majority of the votes cast (simple majority), unless
otherwise provided for in the Ordinance. In deviation from sentence 2, resolutions of the General Meeting pursuant to
clause 9 no. 2 and nos. 5 through 7 hereof shall require a majority of 75 percent of the votes cast. Abstentions shall not
count as votes.
(4) The Owners' voting rights shall depend on their respective interests in the nominal capital; each euro shall grant
one vote.
§ 11. Rules of Procedure of the General Meeting. The General Meeting may establish its own rules of procedure.
§ 12. Supervisory Board (Aufsichtsrat); Chairman of the Supervisory Board.
(1) The Supervisory Board consists of 21 members who shall be appointed in accordance with clauses 13 and 14 hereof.
(2) Upon nomination by the General Meeting, the Chairman of the Supervisory Board and his deputy shall be elected
by the Supervisory Board from among its members, unless otherwise provided for by the Landesbank Baden-Württem-
berg Act.
(3) The members of the Supervisory Board must be reliable and have the expertise required to assess and monitor
the transactions carried out by Landesbank in order to exercise the control function incumbent upon the Supervisory
Board. They shall not be bound by instructions. They must perform their duties conscientiously and without self-interest.
(4) At least one member of the Supervisory Board must have expert knowledge in accounting and/or the audit of
financial statements.
(5) Unless otherwise provided for by the Landesbank Baden-Württemberg Act, members of the Supervisory Board
may not be appointed for periods exceeding the end of the General Meeting that resolves upon the approval of past
activities relating to the fourth business year after the start of the term of office of the members concerned. Notwith-
standing sentence 1, the Deputy Chairman of the Supervisory Board may not be appointed for periods exceeding the end
of the General Meeting that resolves upon the approval of past activities relating to the second business year after the
start of his term of office. The business year in which the term of office commenced shall not be counted in. New
appointments must be made at least one month before the term of office expires. Reappointment is permissible. After
their term of office has expired, the members of the Supervisory Board shall continue in office until the new Supervisory
Board has been constituted.
§ 13. Membership in the Supervisory Board.
(1) The members of the Supervisory Board shall be appointed by the General Meeting, unless they are elected by the
employees as their representatives in accordance with clause 14 hereof and except where the Landesbank Baden-Würt-
temberg Act provides otherwise. Seven of the members of the Supervisory Board elected by the General Meeting,
including the Chairman, must be independent. Each Owner shall be entitled to propose candidates.
(2) A member of the Supervisory Board who tenders his or her written resignation from the Supervisory Board with
the Chairman of the Supervisory Board shall withdraw from the Supervisory Board.
(3) With a majority of 75 percent of the votes cast, members of the Supervisory Board may be recalled by the General
Meeting before their term of office has elapsed. Upon application of the Supervisory Board or of an Owner, the General
Meeting shall recall a member of the Supervisory Board for an important reason resting in the member him- or herself.
§ 14. Employee Representatives on the Supervisory Board. Seven members of the Supervisory Board shall be elected
by the employees of Landesbank as their representatives on the Supervisory Board and confirmed by vote of the General
Meeting, unless the Landesbank Baden-Württemberg Act provides otherwise. The number of elected employee repre-
sentatives shall equal three times the number of seats. The election shall take place under analogous application of section
20519
L
U X E M B O U R G
16 para. 1 sentences 1, 3, 5, and 6; paras. 2, 3 and 4 sentences 1, 2, and 4; and para. 5 of the Savings Bank Act as well as
the Savings Bank Election Regulations (Sparkassenwahlordnung) subject to the following:
- section 16 para. 2 sentence 2 and para. 3 sentence 1 of the Savings Bank Act shall be based on twice the number of
employee representatives to be elected pursuant to sentence 2;
- each person entitled to vote shall have 21 votes; and
- the Staff Council (Personalrat) or, in case of section 9 para. 2 of the State Staff Representation Act (Landesperso-
nalvertretungsgesetz -LPVG), Landesbank's Central Staff Council (Gesamtpersonalrat) shall appoint an Election Com-
mittee (Wahlvorstand) consisting of at least three employees entitled to vote and - from among such employees - one
person as a Chairman and one as his deputy at the latest 12 weeks before the term of office expires.
Employees who on the election day are citizens of a member state of the European Union shall be eligible to be elected;
above and beyond this, section 12 paras. 1 and 2 of the LPVG shall apply accordingly to the eligibility for election. Loss
of an employee representative's eligibility for election shall result in the termination of his or her term of office on the
Supervisory Board.
§ 15. Duties of the Supervisory Board.
(1) The Supervisory Board shall supervise the management of Landesbank's business. The Supervisory Board shall be
responsible for appointing and recalling members of the Board of Managing Directors, appointing and recalling the Chair-
man and the Deputy Chairmen of the Board of Managing Directors, as well as for determining the remuneration of
members of the Board of Managing Directors. The Supervisory Board may appoint deputy members of the Board of
Managing Directors; the deputy members shall have the same rights and duties as the members of the Board of Managing
Directors. In compliance with clause 12 para. 2 of this Ordinance, the Supervisory Board shall elect a Chairman and a
Deputy Chairman of the Supervisory Board, unless otherwise provided for by the Landesbank Baden-Württemberg Act.
(2) The Supervisory Board shall pass resolutions on:
1. the adoption of the annual financial statements;
2. the establishment of committees of the Supervisory Board, in particular the Chairman's Committee (Präsidialaus-
schuss), the Audit Committee (Prüfungsausschuss) and the Risk Committee (Risikoausschuss), as well as the rules of
procedure of these committees;
3. the rules of procedure of the Board of Managing Directors and the approval of the schedule of responsibilities
proposed by the Board of Managing Directors;
4. the engagement of the auditors of the financial statements and the auditors pursuant to section 36 of the German
Securities Trading Act;
5. the approval of the following measures and transactions:
a. changes to the principles of business policy;
b. the business plan to be presented annually by the Board of Managing Directors pursuant to clause 27;
c. the establishment of foreign branches;
d. the acquisition and sale of enterprises and shareholdings in enterprises subject to the rules of procedure of the
Board of Managing Directors;
e. the acquisition and sale of real property and buildings subject to the rules of procedure of the Board of Managing
Directors;
f. the acceptance of capital subject to the rules of procedure of the Board of Managing Directors, unless this falls within
the scope of authority of the General Meeting;
g. building measures in accordance with the rules of procedure of the Board of Managing Directors;
h. further measures and transactions that the Supervisory Board subjects to its approval;
6. other matters assigned to the Supervisory Board pursuant to this Ordinance.
(3) The Supervisory Board may at any time request information about all affairs of Landesbank. It may also inspect and
examine the books and records, and all assets of Landesbank. The Supervisory Board may also appoint individual members
to carry out the foregoing, or appropriate experts for specific tasks.
(4) The Supervisory Board shall establish its own rules of procedure.
§ 16. Meetings and Resolutions of the Supervisory Board.
(1) The Chairman of the Supervisory Board shall convene meetings of the Supervisory Board as needed, but at least
four times a year, and shall chair these meetings. The rules of procedure of the Supervisory Board shall specify further
details, with particular regard to the form and time period in which notifications of meetings shall be issued.
(2) At least half of the members of the Supervisory Board present at a meeting shall constitute a quorum. Resolutions
of the Supervisory Board shall require a majority of the votes cast (simple majority); abstentions shall not count as votes.
Each member shall have one vote. The rules of procedure of the Supervisory Board shall specify further details.
§ 17. Committees of the Supervisory Board.
(1) The Supervisory Board will establish the following committees for its own support:
20520
L
U X E M B O U R G
a. Chairman's Committee (Präsidialausschuss);
b. Audit Committee (Prüfungsausschuss);
c. Risk Committee (Risikoausschuss).
The Supervisory Board may establish further committees.
(2) Members of the committees must be members of the Supervisory Board. Membership in any committee of the
Supervisory Board shall end when the membership in the Supervisory Board ends. A committee member who tenders
his or her written resignation from the respective committee with the chairman of said committee shall withdraw from
the committee involved. The Supervisory Board shall elect the chairmen of the committees and their deputies from among
the members of the committees.
(3) At least half of the members of a committee who are entitled to vote must be present at a meeting to constitute
a quorum. The Supervisory Board shall stipulate further details in the respective rules of procedure of the committees.
§ 18. Chairman's Committee (Präsidialausschuss).
(1) The Chairman's Committee consists of five members, i.e., the Chairman of the Supervisory Board, his deputy and
three members of the Supervisory Board, one of whom shall be a member elected in accordance with clause 14 of this
Ordinance or a member stipulated pursuant to section 19 para. 1 no. 2 of the Landesbank Baden-Württemberg Act.
(2) The Chairman's Committee shall prepare the personnel decisions of the Supervisory Board. It shall decide upon
the employment and termination of employment of members of the Board of Managing Directors, whereas the Super-
visory Board is responsible for determining the remuneration of members of the Board of Managing Directors. The
Chairman's Committee shall represent Landesbank towards the Board of Managing Directors. It shall support Landesbank
it its restructuring efforts.
(3) The members of the Chairman's Committee who are members of the Supervisory Board elected in accordance
with clause 13 of this Ordinance or appointed pursuant to section 19 para. 1 no. 1 of the Landesbank Baden-Württemberg
Act shall form the Nomination Committee (Nominierungsausschuss). They shall propose suitable members of the Su-
pervisory Board to the General Meeting, unless otherwise provided for by the Landesbank Baden-Württemberg Act.
§ 19. Audit Committee (Prüfungsausschuss).
(1) The Audit Committee consists of eight members, among them one member pursuant to clause 12 para. 4 and one
member elected in accordance with clause 14 of this Ordinance or appointed pursuant to section 19 para. 1 no. 2 of the
Landesbank Baden-Württemberg Act. The chairman of the Audit Committee must have special expertise in the area of
bank accounting.
(2) In addition to supervising the audit of the annual financial statements and of the consolidated financial statements,
the Audit Committee shall supervise the accounting process and the effectiveness of the internal control system, of the
internal auditing system and of the risk management system. It shall supervise and check the independence of the auditors,
and notably any services provided in addition to the audit by the auditors for Landesbank. It shall report the result of the
audit of the annual financial statements to the Supervisory Board.
(3) The auditors shall report to the Audit Committee the most significant findings acquired during the audit, notably
findings on material weaknesses regarding Landesbank's internal control of the accounting process. Once a year the
auditors shall assure the Audit Committee in writing of their independence of Landesbank and inform the Audit Com-
mittee of the services provided by them for Landesbank in addition to the audit; furthermore, the auditors shall discuss
with the Audit Committee any risks endangering their independence as well as any protective measures to minimize these
risks documented by them.
§ 20. Risk Committee (Risikoausschuss).
(1) The Risk Committee consists of eight members, among them one member elected in accordance with clause 14
of this Ordinance or appointed pursuant to section 19 para. 1 no. 2 of the Landesbank Baden-Württemberg Act. The
chairman and his deputy must be experts in banking.
(2) The Risk Committee shall supervise the management of business by the Board of Managing Directors, including
the business areas of the dependent institutions described in clause 4 paras. 8 to 10, with regard to the risk types and
the effectiveness of the internal control system, of the internal auditing system and of the risk management system. The
Risk Committee shall be responsible for approving the lending operations in accordance with the rules of procedure of
the Risk Committee adopted by the Supervisory Board. It must also be informed of any loans that display the features
specified by the Supervisory Board in the rules of procedure.
(3) In urgent cases, the Board of Managing Directors may extend loans or enter into risk-carrying investments without
the approval of the Risk Committee. The Board of Managing Directors must inform the Risk Committee of the reasons
for and the material content of an urgent decision at its following meeting.
§ 21. Savings Bank Expert Advisory Council (Sparkassenfachbeirat).
(1) A Savings Bank Expert Advisory Council shall be created to further the cooperation between Landesbank, acting
as central bank, and the savings banks in Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate, and Saxony and to promote the
cooperative collaboration between Landesbank, the savings banks, and their associated enterprises.
20521
L
U X E M B O U R G
(2) The Savings Bank Expert Advisory Council shall consist of 16 members who are entitled to vote and one member
who performs an advisory function and is not entitled to vote. All members must be chairmen of boards of managing
directors of savings banks pursuant to paragraph 1, or executive secretaries of the SVBW or the Savings Banks Association
of Rhineland-Palatinate (Sparkassenverband Rheinland-Pfalz - SVRP). The SVBW shall appoint ten members who are
entitled to vote, whereas the SVRP shall appoint three members who are entitled to vote, in addition to the member
who performs an advisory function and is not entitled to vote. Further members who are entitled to vote shall be the
respective chairpersons of the three savings banks working groups in the Free State of Saxony. A deputy shall be appointed
for each member, with the respective chairpersons of the three savings banks working groups in the Free State of Saxony
being represented by their respective deputy chairpersons.
(3) The members and their deputies shall be appointed for a term of five years. New appointments must be made at
least one month before the term of office expires. The members and their deputies may be recalled at any time. Reap-
pointment is permissible.
(4) The members of the Savings Bank Expert Advisory Council shall elect the Chairman and the Deputy Chairman of
the Savings Bank Expert Advisory Council from among themselves.
(5) The Chairman of Landesbank's Board of Managing Directors, a member of the Board of Managing Directors re-
sponsible for savings bank matters, and their deputies from the Board of Managing Directors shall participate in the
meetings of the Savings Bank Expert Advisory Council in an advisory capacity. If needed, the Savings Bank Expert Advisory
Council may demand the participation of additional members of the Board of Managing Directors.
(6) The Savings Bank Expert Advisory Council shall establish its own rules of procedure.
(7) In order to render advisory services on savings bank-specific matters to the boards of managing directors of RP-
Bank and Sachsen Bank as legally dependent institutions, the Savings Bank Expert Advisory Council may form regional
savings bank expert advisory councils in Rhineland-Palatinate and the Free State of Saxony, respectively, whose members
shall be chairmen of the boards of managing directors of savings banks in the respective states. Paragraphs 3, 4, and 6
shall apply accordingly.
§ 22. Duties of the Savings Bank Expert Advisory Council.
(1) The Savings Bank Expert Advisory Council shall represent the interests of the savings banks in relation to Land-
esbank and advise Landesbank in its function as the central bank of the savings banks; in this connection it shall be
responsible for:
1. the supervision of compliance with agreements entered into;
2. the rendering of services to the savings banks, including the pricing thereof;
3. supplementing the products offered by Landesbank to the savings banks;
4. fundamental issues of cooperation and new agreements between Landesbank and the savings banks as well as their
associated enterprises.
The Savings Bank Expert Advisory Council may demand relevant information with regard to the aforementioned
matters from the Board of Managing Directors.
(2) The Board of Managing Directors shall submit all necessary documentation concerning the matters set forth in
paragraph 1 to the Savings Bank Expert Advisory Council for its consideration.
(3) In case no agreement can be reached between the Savings Bank Expert Advisory Council and the Board of Managing
Directors, either side may ask the Supervisory Board to mediate.
(4) The appointment and recall of the member of Landesbank's Board of Managing Directors who is responsible for
the matters of the savings banks shall require consultation with the Savings Bank Expert Advisory Council.
§ 23. Board of Managing Directors (Vorstand), Chairman.
(1) The Board of Managing Directors consists of several members.
(2) The members of the Board of Managing Directors shall be appointed for a maximum term of five years and shall
be employed subject to private law; reappointment is permissible. Resolutions on the reappointment of the members of
the Board of Managing Directors shall be passed at the earliest twelve months but at the latest six months before the
relevant term of office expires. Members of the Board of Managing Directors exceeding the age of sixty may only be
appointed or reappointed for a term ending with the end of the month in which they reach the age of sixty-five; the
Supervisory Board may decide to extend the appointment or reappointment in special individual cases.
(3) The Supervisory Board shall appoint one Chairman of the Board of Managing Directors; it may appoint one Deputy
Chairman or several Deputy Chairmen of the Board of Managing Directors.
(4) The Supervisory Board may revoke the appointment of a member of the Board of Managing Directors for good
cause. Such cause is, in particular, a serious breach of duty, inability to perform managing functions in an orderly manner,
withdrawal of confidence by the General Meeting, or incompatibility that endangers or prevents cooperation among the
members of the Board of Managing Directors. Any revocation shall be valid until its invalidity is established by court
decision. The foregoing shall also apply to the revocation of the appointment of deputy members as well as to the
revocation of the appointment of the Chairman and the Deputy Chairmen of the Board of Managing Directors.
20522
L
U X E M B O U R G
§ 24. Duties of the Board of Managing Directors.
(1) The Board of Managing Directors shall be fully accountable for managing the business of Landesbank in accordance
with applicable law and in the interest of the bank. It shall represent Landesbank. The members of the Board of Managing
Directors shall perform their management function with the care of a prudent and conscientious manager.
(2) The Board of Managing Directors shall be responsible for all matters of Landesbank, except for those for which
the Landesbank Baden-Württemberg Act or this Ordinance places authority elsewhere. The Board of Managing Directors
shall be the superior of all employees of Landesbank including its branches, offices, stock exchange offices, representative
offices, and legally dependent institutions under public law.
(3) The Chairman of the Board of Managing Directors shall inform the Chairman of the Supervisory Board and his
deputy about important occurrences.
§ 25. Representation, Authority to Sign.
(1) Two members or deputy members of the Board of Managing Directors may make statements in the name of
Landesbank. The Board of Managing Directors may decide that Landesbank may be represented in the ordinary course
of business by either one member or one deputy member of the Board of Managing Directors in each case acting in
conjunction with one Landesbank employee, or by two Landesbank employees acting jointly.
(2) The Board of Managing Directors may decide, safety permitting, that one employee alone is authorized to represent
Landesbank with respect to certain transactions.
(3) The following written documents shall be legally binding without signature:
1. check cards and similar guarantees issued in large numbers which bear the name of the owner at the time of issuance;
2. machine-generated and adjusted lists, settlements of accounts and similar statements, balances of accounts, state-
ments of accounts, and statements of securities accounts;
3. credit or debit notes and notices concerning changes of interest rates, commissions, fees, interest and redemption
installments;
4. other statements and machine-generated acknowledgments of receipt bearing a control stamp, provided that Land-
esbank has drawn due attention to the fact that the specific statements or acknowledgments in question are legally binding
without signature by posting a public notice or making the information otherwise publicly available in the Bank's customer
service areas, or by including an appropriate explanatory note on the printed form.
(4) The Board of Managing Directors shall record the authority to sign in a signature book. Furthermore, the names
and specimen signatures of the authorized representatives shall be posted or made otherwise publicly accessible at the
locations where the authorized representatives carry out their activities.
(5) Documents that are executed by the Board of Managing Directors or by persons authorized to represent the
Board of Managing Directors and which bear the Landesbank seal shall be deemed to be documents issued by a public
authority.
(6) Legally binding written or verbal statements of Landesbank may also be made on the basis of powers of attorney
by one or several authorized persons.
(7) Statements and documents that meet the foregoing requirements shall be legally binding for Landesbank irrespective
of whether or not they comply in a particular case with other provisions of this Ordinance.
(8) The transfer of authority to represent Landesbank to members and deputy members of the Board of Managing
Directors shall be certified by the Chairman of the Chairman's Committee; in all other cases, the Board of Managing
Directors shall certify such a transfer of authority.
§ 26. Advisory Boards (Beiräte).
(1) Landesbank may establish one or several advisory board/s to provide expert advice to Landesbank.
(2) The members shall be appointed and recalled by the Board of Managing Directors with the approval of the Super-
visory Board. They shall serve in an honorary capacity.
(3) The members of the advisory boards may receive a representation allowance as determined by the General Meeting.
(4) Clause 13 para. 2 shall apply accordingly to withdrawing members of the advisory boards subject to the proviso
that any resignation must be tendered in writing with the chairman of the advisory board concerned.
§ 27. Business Plan. The Board of Managing Directors shall prepare a business plan each year that must be submitted
to the Supervisory Board for approval at the latest by the end of the preceding business year. The business plan shall also
include a five-year medium-term plan.
§ 28. Annual Financial Statements and Annual Report.
(1) The business year is the calendar year.
(2) The preparation, audit, and publication of the annual financial statements, the management report, the consolidated
financial statements, and the consolidated management report shall comply with applicable law. The Board of Managing
Directors shall prepare the annual financial statements and the consolidated financial statements within the time period
20523
L
U X E M B O U R G
required by law and present them without delay to the auditors that were engaged by the Supervisory Board for their
audit.
(3) Upon receipt of the auditors' report the Board of Managing Directors shall submit the audited financial statements
together with the management report and the auditors' report without delay to the Supervisory Board for adoption of
the annual financial statements; the aforementioned shall apply accordingly to the consolidated financial statements and
the consolidated management report submitted for the cognizance of the Supervisory Board.
(4) Landesbank shall prepare an annual report each year.
§ 29. Appropriation of Profit. The General Meeting shall pass a resolution on the appropriation of the distributable
profit. The General Meeting may determine different distributions for the nominal capital categories A and B provided
for in clause 3 para. 2. Should a distribution be decided for one or two nominal capital categories, distributions within
the respective nominal capital category to the Owners shall be made in proportion to their respective interests in the
nominal capital.
If and to the extent that the ordinance of the SVBW requires that its member savings banks make direct contributions
to the nominal capital (nominal capital categories A and B), the distributions attributable thereto shall be made within the
respective nominal capital category directly to the member savings banks.
§ 30. Dissolution. In case of the dissolution of Landesbank, the liquidation shall be carried out by the Board of Managing
Directors, unless the Owners agree otherwise. The assets remaining after the satisfaction of all obligations shall be
distributed to the Owners in proportion to their respective interests in the nominal capital.
§ 31. Seal. Landesbank shall carry a seal with the small State crest and the circular inscription “Landesbank Baden-
Württemberg”.
§ 32. Public Announcements.
(1) Public announcements by Landesbank shall be published in the Official Gazette of Baden-Württemberg (Staatsan-
zeiger für Baden-Württemberg).
(2) In lieu of a publication in the Official Gazette of Baden-Württemberg, Landesbank may display public announcements
at all registered offices of Landesbank provided that reference to such method of publication is simultaneously made in
the Official Gazette of Baden-Württemberg.
(3) Paragraph 2 shall not apply to the public announcement of Ordinances.
§ 33. Effective Date and Repeal.
(1) This Ordinance shall become effective on 1 January 1999; simultaneously the existing ordinance of Südwestdeutsche
Landesbank Girozentrale shall be repealed.
(2) Amendments to this Ordinance shall become effective on the day following public announcement (clause 32) in
the Official Gazette of Baden-Württemberg (Staatsanzeiger für Baden-Württemberg), unless determined otherwise.
residence, they signed the present deed together with the notary.
Enregistré à Redange/Attert, le 13 février 2014. Relation: RED/2014/346. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. ELS.
Référence de publication: 2014024131/1501.
(140028661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.
Robust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 93.730.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2014007134/11.
(140006942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
20524
L
U X E M B O U R G
Parkway International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 152.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 80.415.
EXTRAIT
En date du 6 janvier 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 17, rue Glesener,
L-1631 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg avec effet au 20 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Référence de publication: 2014007045/14.
(140006787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Pil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.583.
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2013.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014007048/13.
(140007614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Actavis Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Watson Pharma 2 S.à r.l.).
Capital social: EUR 37.880,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.214.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of November,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Watson Pharma 2 S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.214, with a share capital amounting to thirty-
seven thousand eight hundred eighty Euro (EUR 37,880.-) (the Company).
The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on December 31, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°590
on March 19, 2010. The articles of association of the Company (the Articles) were amended most recently pursuant to
a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg on January 2, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°881 on
April 13, 2013.
THERE APPEARED:
Actavis Acquisition 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.490,
with a share capital amounting to seventy five thousand eight hundred fifty two Euro (EUR 75,852.-) (the Sole Shareholder),
The Sole Shareholder is hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
20525
L
U X E M B O U R G
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the Company's name from "Watson Pharma 2 S.à r.l." to "Actavis Holding 2 S.à r.l." and subsequent
amendment to article 1 of the articles of association of the Company;
2. Removal of Paul Bisaro, with immediate effect, from his function as class A manager of the Company and granting
of full and complete discharge;
3. Appointment of Adriaan Maurice Mulders as new class A manager of the Company;
4. Change of the financial year of the Company and subsequent amendment to article 12, first paragraph, of the articles
of association of the Company;
5. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and any employee of TMF Luxembourg S.A., acting individually, (i) to
proceed on behalf of the Company with the necessary amendments and (ii) to see to any formalities in connection
therewith, if any; and
6. Miscellaneous actions necessary to carry out the foregoing agenda items.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Watson Pharma 2 S.à r.l." to "Actavis Holding
2 S.à r.l." and subsequently resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:
" Art. 1. Name. The name of the company is "Actavis Holding 2 S.à r.l" (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (collectively, the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to remove Paul Bisaro, with immediate effect, from his function as class A manager of
the Company and resolves to grant him full discharge (quitus) for the performance of his mandate from the date of his
appointment until the date of his removal.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint, Adriaan Maurice Mulders, Vice President Tax, born on July 22, 1966 in
Horst, the Netherlands, with professional address at Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer, the Netherlands, as new
class A manager of the Company for an indefinite period of time.
In light of the foregoing, the composition of the board of managers of the Company is henceforth as follows:
- David A. Buchen, class A manager;
- Adriaan Maurice Mulders, class A manager;
- Patrick L.C. Van Denzen, class B manager; and
- Fabrice Rota, class B manager.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that it begins on January 1 and ends on
December 31 of each year.
The Sole Shareholder resolves to amend article 12, first paragraph, of the Articles accordingly so that it shall read as
follows:
" 12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of the following
year'"
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder acknowledges that the current financial year, having
started on November 1, 2013 shall end on December 31, 2013.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above
resolutions and resolves to authorize and empower any manager of the Company and any employee of TMF Luxembourg
S.A. to proceed on behalf of the Company with the necessary amendments to the shareholders' register of the Company.
20526
L
U X E M B O U R G
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at two thousand Euros (EUR 2,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-deuxième jour de novembre,
Pardevant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Watson Pharma 2 S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social
est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 151.214 et disposant d'un capital social de trente-sept mille huit cent quatre-vingt euros
(EUR 37.880,-) (la Société).
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°590 le 19
mars 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Carlo
Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg le 2 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°881 le 13 avril 2013.
A COMPARU:
Actavis Acquisition 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, dont le siège social est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.490 et disposant d'un capital social de soixante-
quinze mille huit cent cinquante-deux euros (EUR 75.852,-) (l'Associé Unique).
L'Associé Unique est ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de la dénomination de la Société de "Watson Pharma 2 S.à r.l." à "Actavis Holding 2 S.à r.l." et modi-
fication subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;
2. Révocation de Paul Bisaro, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de classe A de la Société et octroi d'une
pleine et entière décharge;
3. Nomination de Adriaan Maurice Mulders en tant que nouveau gérant de classe A de la Société;
4. Modification de l'exercice social de la Société et modification subséquente de l'article 12, premier paragraphe, des
statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de TMF Luxembourg S.A., agissant individuellement, (i) pour procéder
au nom de la Société aux modifications nécessaires et (ii) d'accomplir toutes les formalités y relatives, le cas échéant; et
6. Diverses actions nécessaires pour mener à bien l'ordre du jour qui précède.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de "Watson Pharma 2 S.à r.l." à "Actavis Holding
2 S.à r.l." et décide subséquemment de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Actavis Holding 2 S.à r.l." (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ensemble, la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts)."
20527
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de révoquer Paul Bisaro, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant de classe A de la
Société et décide de lui accorder pleine décharge (quitus) pour l'exercice de son mandat depuis la date de sa nomination
jusqu'à la date de sa révocation.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer, Adriaan Maurice Mulders, Vice Président Tax, né le 22 juillet 1966, à Horst, les
Pays-Bas, de résidence professionnelle au 51 Bleiswijkseweg, 2712 PB Zoetermeer, les Pays-Bas, en tant que nouveau
gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée.
Compte tenu de ce qui précède, la composition du conseil de gérance de la Société est désormais comme suit:
- David A. Buchen, gérant de classe A;
- Adriaan Maurice Mulders, gérant de classe A;
- Patrick L.C. Van Denzen, gérant de classe B; et
- Fabrice Rota, gérant de classe B.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société de sorte qu'il débute le 1
er
janvier et s'achève le
31 décembre de chaque année et décide subséquemment de modifier l'article 12, premier paragraphe, des Statuts de
sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:
" 12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
"
En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique prend acte que l'exercice social actuel, ayant débuté le 1
er
novembre 2013 s'achèvera le 31 décembre 2013.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus et
décide d'autoriser tout gérant de la Société et tout employé de TMF Luxembourg S.A. pour procéder au nom de la Société
aux modifications nécessaires dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à deux mille Euros (EUR 2.000.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont Acte, en foi de quoi le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent
acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2013. Relation: LAC/2013/54473. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Référence de publication: 2014002704/174.
(140001398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.
SBC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, Boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 156.486.
L'an deux mille treize, le vingt-trois décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
20528
L
U X E M B O U R G
Madame Anna Ivanovna SALEWSKI, conseiller financier et traductrice, née à Minsk (Biélorussie), le 3 juillet 1980,
demeurant professionnelle à L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong,
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle est la seule et unique associée actuelle de la
société à responsabilité limitée «SBC International S.à r.l.», (la «Société»), établie et ayant son siège social à L-1430
Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B.156.486, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 octobre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2702 du 8 décembre 2010. Les statuts n’ont pas été modifiés
depuis.
Que la Comparante en sa qualité d’associée unique, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est réunie
en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence d’un montant de 125,- EUR (cent vingt-
cinq euros) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) à un montant de douze
mille six cent vingt-cinq euros (12.625,- EUR) par la création et l’émission de 1 (une) part sociale nouvelle d’une valeur
nominale de 125,- EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune, disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes, toutes souscrites par l’associée unique, laquelle déclare les libérer par apport en nature de trois mille cent
soixante (3.160) actions du capital social de la société «Carolla Global S.A.», avec siège social à L-1430 Luxembourg, 6,
boulevard Pierre Dupong, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg numéro B 176.389.
<i>Evaluationi>
La valeur de l’Apport a été fixé à 212,400,08 EUR (deux cent douze mille euros et zéro huit cents) dont cent vingt-
cinq euros (125,- EUR) sont alloués au compte capital social, mille deux cent soixante-deux euros et cinquante cents
(1.262,50 EUR) sont alloués au compte réserve légale, et le solde de deux cent onze mille douze euros et cinquante-huit
cents (211.012,58 EUR) sont alloués au compte prime d’émission. Cet apport a été évalué par le souscripteur des nouvelles
parts sociales émises par la Société.
<i>Mise en oeuvre effective de l’apporti>
Madame Anna Ivanovna SALEWSKI, souscripteur, associée et gérant unique de la Société, et représentant permanent
de l’Administrateur Unique de «Carolla Global S.A.», ici présente, déclare expressément que:
(i) les actions présentement apportées sont toutes nominatives;
(ii) elle est seul propriétaire de tous les Actions;
(iii) les Actions sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) les Actions ne font l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(v) les Actions sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
(vi) «Carolla Global S.A.» est dûment constituée et existent valablement;
(vii) à sa connaissance, «Carolla Global S.A.» ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, disso-
lution ou de transfert des Actions à ses créanciers, et il n’existe aucun fait ni aucune circonstance à la date des présentes
qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;
(viii) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et appro-
bations nécessaires ont été obtenus afin d’autoriser le transfert des Actions; et
(ix) l’ensemble des formalités subséquentes au transfert des Actions requise en vertu de toute loi applicable sera
accompli afin que l’apport des Actions soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide, en conséquence de ce qui précède de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
L’assemblée générale décide, en conséquence de ce qui précède de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
en allemand:
« Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend sechshundert fünfundzwanzig Euro (12.625,- EUR), aufgeteilt
in eintausendeinhundert ein (101) Anteile von jeweils einhundert fünfundzwanzig Euro (125,-EUR).»
en français:
«Le capital social est fixé à douze mille six cent vingt-cinq euros (12.625,- EUR), représenté par cent et une (101) parts
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.»
DONT ACTE, fait et passé Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
20529
L
U X E M B O U R G
Signé: Anna Ivanovna SALEWSKI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2013. Relation GRE/2013/5425. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 7 janvier 2014.
Référence de publication: 2014003886/69.
(140003386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.
FLH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8023 Strassen, 5, rue des Anémones.
R.C.S. Luxembourg B 155.323.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2014.
Pour ordre
FIDU-CONCEPT SARL
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014006795/14.
(140007616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Fin Eleven S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 153.913.
<i>Extrait des résolutions des administrateurs prises en date du 6 janvier 2014i>
Les administrateurs de la Société ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg, Luxembourg
vers le 20 RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG avec effet au 6 janvier 2014
Luxembourg, le 6 janvier 2014.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014006783/14.
(140007319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
ID4Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 170.951.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ID4Group S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014006883/11.
(140007123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
International Cleaning Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 48.099.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire à la date du 26.11.2013,
que les mandats des administrateurs Mess. Xavier Laloux, Michel Laloux, Axel Cardon de Lichtbuer, Gatien Laloux, le
20530
L
U X E M B O U R G
mandat de l'administrateur délégué à la gestion journalière M. Xavier Laloux et le mandat du commissaire aux comptes,
M. Maximilien Laloux, arrivent à échéance et sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de
l'assemblée générale annuelle de l'an 2019.
Pour avis et extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2014006877/15.
(140006688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Icopal Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.500.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 131.124.
Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du Gérant de Classe A, Craig Sinfield-Hain, a fait l'objet d'un
changement. La nouvelle adresse est la suivante:
3, Domaine Brameschhof, L-8290 Kehlen, Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014006871/14.
(140007197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Magenta Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 167.206.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 Septembre 2013.
MAGENTA PROPERTIES S.à.r.l.
Christelle Ferry
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2014006972/14.
(140007310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
NPG Wealth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.727.450,40.
Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 68.938.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 20 décembre 2013.i>
En date du 20 décembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Stephen BRIGHT de son mandat de gérant de la Société avec effet au 31
décembre 2013;
- de nommer Monsieur Marc STEVENS, né le 10 mai 1961, à Schoten, Belgique, ayant comme adresse professionnelle:
38, Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2014.
A compter du 1
er
janvier 2014, le conseil de gérance de la société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Christopher L. BAKER
- Monsieur Jean-Luc JANCEL
- Monsieur David MORGAN
- Monsieur Thierry PORTE
- Monsieur Marc STEVENS
- Monsieur Paul WOLFF
20531
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Michel WOLTER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2014.
NPG Wealth Management S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014007027/26.
(140006978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Montefiore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 56.589.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 19 décembre 2013i>
Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 01/01/1972 à Thionville (F), avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg a été nommée en tant que représentant permanent de la société FMS SERVICES S.A., en remplace-
ment de Monsieur Daniel FELLER.
<i>Pour la société
i>MONTEFIORE S.A.
Référence de publication: 2014007005/13.
(140007526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Mieti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 58.008.
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 18 décembre 2013 il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle du 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg vers le 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MIETI S.A.
Société anonyme
Signatures
Référence de publication: 2014007000/14.
(140007577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
MyTravel Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 83.824.
EXTRAIT
En date du 6 janvier 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 17, rue Glesener,
L-1631 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg avec effet au 20 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Référence de publication: 2014006987/14.
(140006785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
20532
L
U X E M B O U R G
Marowinia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.484.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 19 décembre 2013i>
Monsieur Michel DI BENEDETTO, né le 16/09/1969 à Mont Saint Martin (F), avec adresse professionnelle au 3, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg a été nommé en tant que représentant permanent de la société FMS SERVICES S.A., en
remplacement de Monsieur Daniel FELLER.
<i>Pour la société
i>MAROWINIA S.A., SPF
Référence de publication: 2014006994/13.
(140007606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
NDT European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.094.
La dénomination sociale de l'associé NDT Global Systems & Services Limited, avec siège social au Montague Sterling
Centre East Bay Street, Butterfield Bank (Bahamas) Limited, Third Floor, Nassau, Bahamas, a changé et est à présent:
NDT Global Limited.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2014.
Référence de publication: 2014007015/13.
(140006755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Nima Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 133.860.
Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/01/2014.
<i>Pour: NIMA FINANCE S.Ai> .
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2014007022/15.
(140007381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Newbell & Kesson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2145 Luxembourg, 121, rue Cyprien Merjai.
R.C.S. Luxembourg B 97.831.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13/01/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014007021/12.
(140006781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
20533
L
U X E M B O U R G
Optical Center Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 108.414.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Pour extrait conforme
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014007035/14.
(140007057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
UKP Consult S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 94B, Waisstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 148.970.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014006380/9.
(140005926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
UKP Consult S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 94B, Waisstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 148.970.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014006379/9.
(140005906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
De Butz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3871 Schifflange, 1, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 27.005.
L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
ont comparu:
1.- Madame Arlette WARSZAWSKI, retraitée, née à Esch-sur-Alzette le 06 juin 1955, demeurant au 71, rue Marie
Muller-Tesch, L-4250 Esch-sur-Alzette;
2.- Madame Monique MARSCHAL, indépendante, née à Schifflange le 24 mars 1959, demeurant au 20, rue Pierre
Clement, L-4916 Bascharage;
ici représentées par Monsieur Jean-Paul Defay, indépendant, demeurant au 82, rue Prince Jean, L-4463 Soleuvre,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui données, lesquelles procurations, après avoir signées «ne va-
rietur» par le mandataire des personnes comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes à des
fins d'enregistrement.
Lesquelles personnes comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, et agissant en leur qualité de seules et
uniques associées de la société «DE BUTZ S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social au 1, rue de la Paix, L-3871 Schifflange,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 27 005,
constituée suivant acte notarié daté du 06 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
en 1988, sous le numéro 26 et page 1206 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié
reçu le 29 décembre 1989, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 28 juillet 1990,
sous le numéro 252 et page 12054,
20534
L
U X E M B O U R G
ont requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions prises chacune séparément, à l'unanimité
et sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
Les associées, par leur représentant susnommé, DECIDENT la dissolution anticipée de la Société «DE BUTZ S.à r.l.»
et prononcent sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées DECIDENT de nommer aux fonctions de seul liquidateur de la Société:
Monsieur Jean-Paul DEFAY, indépendant, née à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 1957, demeurant au 82, rue Prince
Jean, L-4463 Soleuvre, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées DECIDENT d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les
cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de nommer encore aux fonctions de commissaire-vérificateur de la Société présentement mise
en liquidation:
Madame Claudine GATTI, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 1967, avec adresse profession-
nelle au 16, rue de Differdange, L-4437 Soleuvre, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête
des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les personnes comparantes, ici représentées comme il est dit
ci-avant, ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.P. DEFAY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17192. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2014005963/59.
(140005781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Immeurope S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 41.027.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014006105/9.
(140006109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Polyusus Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 183.031.
<i>Extrait de Transferts de Parts Socialesi>
Capvis General Partner IV Ltd. a transféré à Capvis General Partner III Ltd., avec siège social au 28, New Street, JE2
3TE St. Helier, Jersey, immatriculée au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 95863,
20535
L
U X E M B O U R G
125,000 parts sociales de classe A,
125,000 parts sociales de classe B,
125,000 parts sociales de classe C,
125,000 parts sociales de classe D,
125,000 parts sociales de classe E,
125,000 parts sociales de classe F,
125,000 parts sociales de classe G,
125,000 parts sociales de classe H,
125,000 parts sociales de classe I,
125,000 parts sociales de classe J.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007089/22.
(140007096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Formax, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 13, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 183.103.
STATUTS
L'an deux mil treize, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
- Madame Evelyne DEBBAUT, née le 18 février 1978 à Stavelot (B) demeurant à B-4190 Ferrières, Les Arsins 4
- Monsieur Pierre Yves BERNARD, né le 26 juin 1973 à Chênée (B), demeurant à B-4190 Ferrières, Les Arsins 4
Lesquels comparants, présents ou tel que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une
société à responsabilité limitée, qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «FORMAX».
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Winseler.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société agissant tant pour elle-même que pour compte de tiers, a pour objet toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement aux activités suivantes:
- Consultant en matière de conduite automobile au sens large; en ce compris les voitures, les camions, les bus et les
cars de tourisme;
- La location de véhicules avec ou sans chauffeur (vélos, motos, autos, camions, bus, cars);
- L'organisation d'activités diverses, événements, manifestations, sportives ou autre(s), loisirs, portes ouvertes;
- L'organisation de séminaires, formations et cours en communication, transport et logistique;
- La messagerie et la livraison express (documents, colis);
- La prise en mains et remise des clés de véhicules tous types pour le compte des concessions automobiles, concessions
poids-lourds et bus/cars.
- Les reportages photographiques, pour compte de clients privés ou professionnels, mais également à des fins de
publication dans des magazines spécialisés de la presse belge ou étrangère;
- La sélection et le recrutement de personnel;
- La formation et la remise à niveau de chauffeurs de camions (théorie et pratique) et de chauffeurs de bus/cars (théorie);
- Les tests et comparatifs de nouveaux véhicules (voitures, camions), sur circuits ou sur routes;
- La démonstration de ces mêmes véhicules pour compte de tiers (concessions, usines, garages,...);
- La rédaction d'articles relatifs aux tests réalisés sur circuits ou sur routes; ces articles étant destinés à des fins de
publications dans des magazines spécialisés ou à des fins de formation du personnel;
- Tous types de travaux de secrétariat pour compte de tiers, encodage, mailing, prospection commerciale.
- Représentation autonome;
20536
L
U X E M B O U R G
- Importation et exportation de tous produits, biens et objets quelconques;
- Les enquêtes de satisfaction clients (plus communément appelées: le «mystery shopping»);
Elle peut faire, au Luxembourg ou à l'étranger, d'une façon générale et sans que cette énumération soit limitative,
toutes opérations civiles et commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, en relation quelconque
avec son activité sociale susmentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport
ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer pour elle une
source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €) divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre
de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord
du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.
En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.
En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs
sont définis dans l'acte de nomination.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Année sociale - Bilan
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,
pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.
20537
L
U X E M B O U R G
Dissolution - Liquidation
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives
ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Disposition générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Madame Evelyne DEBBAUT, prénommée, soixante quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Monsieur Pierre-Yves BERNARD, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total des parts: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l'instant les associées, représentant l'intégralité du capital social, prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-9647 Doncols, 13, Duerfstrooss.
2.- Le nombre des gérants est fixé à un.
3.- L'assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée,
- Monsieur Pierre-Yves BERNARD, prénommé.
4.- La société sera valablement engagée par la signature du gérant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1000.- EUR.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Debbaut, Bernard, Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2013, Relation: WIL/2013/848, Reçu soixante-quinze euros (75 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 27 décembre 2013.
Référence de publication: 2014002959/129.
(140002554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.
Eozen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 55.944.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13/01/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014006734/12.
(140007121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
20538
L
U X E M B O U R G
Interlux Platre, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9636 Berlé, 14, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 167.860.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO S.A.
Signature
Référence de publication: 2014006903/11.
(140007558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Luxbela, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 13, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 164.903.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014006963/10.
(140007365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Management Assistances & Advisors, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3961 Ehlange, 7A, Am Brill.
R.C.S. Luxembourg B 151.060.
<i>Extrait de l'acte de cession de part sociales du 13.01.2014.i>
L'associé unique:
FIACCOM s.a., 7a, am Brill, L-3961 Ehlange/Mess, inscrit au registre de commerce sous le numéro B86307, représenté
par Monsieur Marc KOPPES, né le 12/09/1955 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 7a, am Brill, L-3961
Ehlange/Mess,
accepte la cession de vingt (20) parts sociales de mille euros (EUR 1.000,-) chacune,
à Monsieur Marc SCHMIT, commerçant, né le 28 janvier 1967 à Esch/Alzette demeurant au L-4026 ESCH/ALZETTE,
173, rue de Belvaux
La totalité des vingt (20) parts sociales est dorénavant répartie comme suit:
Monsieur Marc SCHMIT, 20 parts sociales
Ehlange/Mess, le 13.01.2014.
Référence de publication: 2014006992/18.
(140007052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
OR TP SA - Demolition, Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 51, rue Romain Fandel.
R.C.S. Luxembourg B 135.456.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 février 2013i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Madame Sandra Sabine ELMERICH, demeurant 20, rue Charles IV, L-1309 Luxembourg
La société sera engagée par la signature conjointe de Monsieur Jonathan MARIE DIT LACOUR avec un autre admi-
nistrateur.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 7 janvier 2014.
Référence de publication: 2014007038/15.
(140007341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
20539
L
U X E M B O U R G
Vicem Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 132.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014006399/9.
(140006336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Orium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ORIUM S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014007040/12.
(140006777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Pioneer Alternative Investment Funds (Lux), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 140.708.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre
2013, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2013, LAC/2013/60647.
Qu'a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé organisée «PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS (LUX)», ayant son siège social à L-1160 Luxem-
bourg, 16, Boulevard d'Avranches, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 140.708, constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, en date du 16 juillet 2008, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2113 du 1
er
septembre 2008.
La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 31 octobre 2013.
Les livres des comptes et documents de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante:
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., 16 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Référence de publication: 2014007049/22.
(140007366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Private Estate Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 34.402.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 16 décembrei>
<i>2013.i>
En date du 16 décembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a pris les résolutions
suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Germaine BRABANTS de son mandat de délégué à la gestion journalière de la
Société avec effet au 31 décembre 2013;
20540
L
U X E M B O U R G
- de nommer Monsieur Marc STEVENS né le 10 mai 1961 à Schoten, Belgique, ayant son adresse professionnelle à 38,
Parc d'Activités de Capellen, L-8308 Capellen, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 1
er
janvier
2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2014.
A compter du 1
er
janvier 2014, le conseil d'administration de la Société se compose des personnes suivantes:
- Stephen BRIGHT
- Serge MOREL
- Thierry PORTE
- Marc STEVENS
- Paul WOLFF
- Michel WOLTER
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de la Société tenue en date du 16 décembre 2013.i>
En date du 16 décembre 2013, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Marc STEVENS en tant que nouveau délégué à la gestion journalière de la Société avec effet
au 1
er
Janvier 2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année
2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2014.
Private Estate Life S.A.
Signature
Référence de publication: 2014007052/32.
(140006980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Ocean Dream S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 114.324.
Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 janvier 2014 au siège social de
la Société, il a été décidé:
- D'accepter, avec effet immédiat, les démissions de:
* Monsieur Eric Scussel résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de
ses fonctions d'administrateur;
* Monsieur Riccardo Zorzetto résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg
de ses fonctions d'administrateur.
- De nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat
* Monsieur Thomas Dewé résidant professionnellement au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;
* Mlle Manuela D'Amore résidant professionnellement au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
leur mandat ayant comme échéance celui de leur prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCEAN DREAM S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2014007030/22.
(140006691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Noma Star Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 173.277.
EXTRAIT
Il est à noter que 75.310 parts sociales ont été transférées de Madame Lorenza Franco vers ARGOS S.p.A. SOCIETA
FIDUCIARIA DI REVISIONE, R.E.A. (Registro delle Imprese di Milano) MI-1624733, ayant son siège social au Via Paleocapa
n.6 20123 Milan (Italie) en date du 8 novembre 2013.
Argos S.p.A détient désormais 75.310 parts sociales de la société Noma Star S.à r.l.
20541
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014007024/13.
(140007612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Procter & Gamble International Funding SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.825.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 11 décembrei>
<i>2013i>
En date du 11 décembre 2013, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:
- de renouveler le mandat des membres du conseil de surveillance de la Société pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de la Société qui aura lieu en 2014:
* Madame Elena Morrisova
* Monsieur Klaus Lindner
* Monsieur Herwig Meskens
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2014.
Procter & Gamble International Funding SCA
Signature
Référence de publication: 2014007053/19.
(140007195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Picard Bondco, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 154.899.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 9 janvier 2014i>
En date du 9 janvier 2014, l'actionnaire unique a pris acte des démissions de Monsieur Paul COOPER, en tant qu'Ad-
ministrateur A de la société et de Madame Elizabeth TIMMER en tant qu'Administrateur B de la société et ce avec effet
rétroactif au 19 décembre 2013.
L'actionnaire unique a décidé de nommer Monsieur Richard LEWIS, né le 4 février 1967 à Cardiff, Royaume-Uni, ayant
pour adresse professionnelle 21, Grosvenor Place, Londres SW1X 7HF, Royaume-Uni, en tant qu'Administrateur A de
la société et ce avec effet rétroactif au 19 décembre 2013 et de nommer Monsieur Carsten Sons, né le 16 novembre
1975 à Düsseldorf, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
en tant qu'Administrateur B de la société et ce avec effet rétroactif au 19 décembre 2013.
Les nouveaux mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 mars
2015, qui se tiendra en 2015.
Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Administrateurs A:i>
- Richard Lewis
- Javier Ferran
<i>Administrateurs B:i>
- Richard Brekelmans
- Michael Verhulst
- Carsten Söns
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2014.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014007047/30.
(140006715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
20542
L
U X E M B O U R G
Promotions Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 108.697.
Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse du Gérant de Classe A, Craig Sinfield-Hain, a fait l'objet d'un
changement. La nouvelle adresse est la suivante:
3, Domaine Brameschhof, L-8290 Kehlen, Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014007099/13.
(140007173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Rose Velte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 100.444.
J'ai l'honneur de vous remettre par la présente ma démission en tant qu'administrateur de votre estimée société avec
effet au 10 janvier 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 10 janvier 2014.
SARAFIAN Martine.
Référence de publication: 2014007136/11.
(140006939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Sol Designer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9167 Mertzig, 10, rue Fred A. Gilson.
R.C.S. Luxembourg B 151.893.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007190/9.
(140007111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
SALT AND PEPPER by Jaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6161 Bourglinster, 2, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 59.598.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007159/9.
(140006975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.
R.C.S. Luxembourg B 7.910.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007128/9.
(140007204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Raum & Wohnen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 147.771.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
20543
L
U X E M B O U R G
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007123/9.
(140007372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
ProLogis European Finance XI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007097/9.
(140007140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Rubik Ventures, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 101.600,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 119.544.
Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007120/9.
(140006953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
ProLogis Poland XXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 88.260.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007057/9.
(140007139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
ProLogis UK CCXXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.280.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007058/9.
(140007135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Platheg, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 31.693.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014007079/9.
(140006974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
20544
Actavis Holding 2 S.à r.l.
De Butz S.à r.l.
Eozen S.A.
Fin Eleven S.A.
FLH S.à r.l.
Formax
Icopal Holdings S.à r.l.
ID4Group S.à r.l.
Immeurope S.A.
Interlux Platre
International Cleaning Company S.A.
LBBW Luxemburg S.A.
Luxbela
Magenta Properties S.à r.l.
Management Assistances & Advisors
Marowinia S.A., SPF
Mieti S.A.
Montefiore S.A.
MyTravel Licensing S.à r.l.
NDT European Holdings S.à r.l.
Newbell & Kesson S.à r.l.
Nima Finance S.A.
Noma Star Sàrl
NPG Wealth Management S.à r.l.
Ocean Dream S.A.
Optical Center Luxembourg S.à r.l.
Orium S.A.
OR TP SA - Demolition
Parkway International S.à r.l.
Picard Bondco
Pil S.à r.l.
Pioneer Alternative Investment Funds (Lux)
Platheg
Polyusus Lux III S.à r.l.
Private Estate Life S.A.
Procter & Gamble International Funding SCA
ProLogis European Finance XI S.àr.l.
ProLogis Poland XXIII S.à r.l.
ProLogis UK CCXXX S.à r.l.
Promotions Holdings S. à r.l.
Raum & Wohnen S.A.
Rémy Cointreau Luxembourg S.A.
Robust S.A.
Rose Velte S.A.
Rubik Ventures
SALT AND PEPPER by Jaco S.A.
SBC International S.à r.l.
Sol Designer S.à r.l.
UKP Consult S. à r. l.
UKP Consult S. à r. l.
Vicem Real Estate S.A.
Watson Pharma 2 S.à r.l.