logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 372

11 février 2014

SOMMAIRE

11 Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17856

Adeo s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17847

aeris CAPITAL Blue Ocean S.à r.l. . . . . . . .

17846

Batir Mon Habitation S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

17844

Belron OPS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17842

BI-Invest Compartment S. à r.l.  . . . . . . . . .

17851

Cablux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17849

Chasselas Investissements S.A.  . . . . . . . . . .

17845

CityDent s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17850

CODINTER S.A., Société de Gestion de

Patrimoine Familial, SPF  . . . . . . . . . . . . . .

17845

Coeli SICAV I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17817

Compagnie Européenne de Participations

Industrielles S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17844

COMPANY Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . .

17847

Comptabilité, Fiscalité S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

17850

Corporate and Technological Investments

Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17848

CWEI (Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17812

CWEI (Luxembourg) Investment Manage-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17817

Cypress Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

17848

Danama Films, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17851

DDN Architecte s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17837

Deldeg Multi-Projects S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

17850

Dennemeyer Trust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17831

Dynasty Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17847

Edge II Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17835

Euro-Bâtiments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17856

European Sporting Goods Sàrl  . . . . . . . . . .

17849

Evasion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17851

Financière Berlaimont S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

17848

Financière Bozo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17849

Finbelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17840

Hondsschoul Um Bierg Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

17852

Inventif S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17856

Knightrider S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17832

L.A. Invest SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17855

La Varenne Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17835

Medtronic CV Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

17837

Meridian Group Investments S.à r.l.  . . . . .

17812

Newfound Bay Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17839

Pamplona PE Holdco 6 S.A.  . . . . . . . . . . . . .

17841

Potsdamer 180-184 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

17810

Proprio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17846

Psoriaid S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17853

River Melody Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17854

RM Properties S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17853

Son Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17840

Tea Properties S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17853

Te Ora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17854

Tiger Holding Five S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

17845

Tilo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17854

Toyama Financial Services S.A.  . . . . . . . . .

17854

Transcar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17853

Transvialux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17853

17809

L

U X E M B O U R G

Potsdamer 180-184 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.605.

In the year two thousand and thirteen, on the third of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Potsdamer  Holding  180-184  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  having  its

registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxemboug trade and companies
register under no. B 176.569 (the “Sole Shareholder”),

here represented by Ms Sabine Verena ARNOLD, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given

under private seal on November 22 

nd

 , 2013.

Said proxy, being signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to document the following:
I. That it is the sole shareholder of Potsdamer 180-184 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
having a corporate capital of one million five hundred and twenty thousand euro (EUR 1,520,000), registered with the
Luxembourg trade and companies register under number B 176.605, incorporated pursuant to a deed of Maître Marc
LOESCH, notary residing in Mondorf, Grand Duchy of Luxembourg, on April 3 

rd

 , 2013, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 1326 of June 5 

th

 , 2013, the articles of incorporation of which have not

been amended since (the “Company”).

II. That all the fifteen thousand and two hundred (15,200) shares are represented at the present extraordinary general

meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the
Sole Shareholder declares having had full prior knowledge.

III. That the agenda of the present meeting is the following:
1. Reduction of the issued share capital of the Company from its present amount of one million five hundred and

twenty thousand euro (EUR 1,520,000) for an amount of one million four hundred and seventy thousand euro (EUR
1,470,000) (the “Share Capital Reduction Amount”) to fifty thousand euro (EUR 50,000) by cancellation of fourteen
thousand and seven hundred shares (14,700), the Share Capital Reduction amount to be repaid to the Sole Shareholder
in accordance with the provisions of article 69 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and
pursuant to such payment terms agreed between the Company and the Sole Shareholder.

2. Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company.
After duly considering each item of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the issued share capital of the Company from its present amount of one

million five hundred and twenty thousand euro (EUR 1,520,000) for an amount of one million four hundred and seventy
thousand euro (EUR 1,470,000) to fifty thousand euro (EUR 50,000) by cancellation of fourteen thousand and seven
hundred (14,700) shares, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.

The Sole Shareholder resolves that the Company shall repay the Share Capital Reduction Amount to the Sole Share-

holder in accordance with the provisions of article 69 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as
amended.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of

association of the Company to henceforth read as follows:

« Art. 5. Share Capital. The Company’s subscribed share capital is fixed at fifty thousand euro (EUR 50,000), repre-

sented by five hundred (500) ordinary Shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each.”

<i>Close of meeting

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital decrease

are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

17810

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the above named appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, such proxy holder signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le trois décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Potsdamer Holding 180-184 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 176.605 ("L'Associée Unique"),

représentée par Mademoiselle Sabine Verena ARNOLD, dont l’adresse professionnelle se situe à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 22 novembre 2013.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Lequel comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Qu’elle est l’unique associée de Potsdamer 180-184 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les

lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ayant un
capital social d’un million cinq cent et vingt mille euros (1.520.000.- EUR), inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.605, constituée suivant acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire
de résidence à Mondorf, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1326 du 5 juin 2013, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors (la "Société").

II. Qu’il apparaît que l’ensemble des quinze mille deux cents (15.200) parts sociales sont représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l’actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.  Réduction  du  capital  social  émis  de  la  Société  d’un  montant  d’un  million  quatre  cent  soixante-dix  mille  euros

(1.470.000.- EUR) (le "Montant de la Réduction de Capital") afin de le porter de son montant actuel d’un million cinq cent
et vingt mille euros (1.520.000.- EUR) à cinquante mille euros (50.000.- EUR) par l’annulation de quatorze mille sept cents
(14.700) parts sociales, le Montant de la Réduction de Capital étant remboursable conformément aux dispositions de
l’article 69 de loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et conformément aux conditions de paiement
convenues entre l’Associé Unique et la Société.

2. Par conséquent, modification de l’article 5 des statuts de la Société.
Après avoir passé en revue les points à l’ordre du jour, l’Associée Unique prends les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associée Unique décide de réduire le montant du capital social émis de la Société d’un montant d’un million quatre

cent soixante-dix mille euros (1.470.000.- EUR) (le "Montant de la Réduction de Capital") afin de le porter de son montant
actuel d’un million cinq cent et vingt mille euros (1.520.000.- EUR) à cinquante mille euros (50.000.- EUR) par l’annulation
du quatorze mille sept cents (14.700) parts sociales, d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

L’Associée Unique décide que la Société remboursera le Montant de la Réduction de Capital conformément aux

dispositions de l’article 69 de loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, L’Associée Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société

pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinquante mille euros (50.000.- EUR)

représenté par cinq cents (500) Parts Sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune."

<i>Clôture

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

17811

L

U X E M B O U R G

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette réduction

du capital social sont estimés à mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par leur nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. V. Arnold et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56069. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176075/124.
(130214364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

CWEI (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 164.928.

Les statuts coordonnés au 20/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 06/01/2014.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2014002131/12.
(140001980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Meridian Group Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 17.034,06.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.116.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of November.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Meridian Group Investments S.à r.l., a Luxem-

bourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 175 116 (the
Company). The Company was incorporated on 17 December 2012 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
No. 797 of 4 January 2013, amended for the last time by a deed of 17 October 2013 of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

The Meeting is opened chaired by Mr Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as Secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Thibaud Herberigs, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.
The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of shares

they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed by
the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

17812

L

U X E M B O U R G

The powers of attorney of the Shareholders that are represented at the Meeting, after having been signed "ne varietur"

by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be
filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau thus having been formed, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. The present extraordinary general meeting has been convened by notices sent to all the shareholders on November

7, 2013.

II. It appears from the attendance list that out of 298,519 Class A1 Shares, 1,951 Class A2, Shares, 547.284 Class B1

Shares, 3,577 Class B2 Shares, and 1 Class C1 Share, 298,519 Class A1 Shares, 1,951 Class A2, Shares, 547.284 Class B1
Shares, 3,577 Class B2 Shares are present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can
validly deliberate on all the items of the agenda.

III. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1 To increase the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 7.42 (seven Pounds Sterling forty two

pence Sterling) with the issuance of 131 (one hundred thirty one) new Class A2 shares and 240 (two hundred forty) new
Class B2 shares, each such Class A2 and Class B2 shares having a par value of GBP 0.02 (two pence Sterling) each;

2 To accept:
(a) the subscription for the 131 (one hundred thirty one) new Class A2 shares by Queensgate with payment of total

share premium of GBP 3,930 (three thousand nine hundred thirty Pounds Sterling) which shall be attached to the new
Class A2 shares;

(b) the subscription for the 196 (one hundred ninety six) new Class B2 shares by London Arena with payment of total

share premium of GBP 529,094.16 (five hundred twenty nine thousand ninety four Pounds Sterling sixteen Pence) which
shall be attached to the new Class B2 shares;

(c) the subscription for the 44 (forty four) new Class B2 shares by LBR with payment of total share premium of GBP

118,776.24 (one hundred eighteen thousand seven hundred seventy six Pounds Sterling twenty four Pence) which shall
be attached to the new Class B2 shares;

(d) the payment of item (a) to (c) above in cash.
3 To amend article 6.1 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase of the Company.
4 To amend the share register of the Company in order to reflect the above share capital increase with power and

authority to any manager of the Company, any lawyer or employee of King &amp; Wood Mallesons SJ Berwin to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares on the share register
of the Company.

5 Miscellaneous.
After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 7.42 (seven

Pounds Sterling forty two pence Sterling) with the issuance of 131 (one hundred thirty one) new Class A2 shares and
240 (two hundred forty) new Class B2 shares, each such Class A2 and Class B2 shares having a par value of two pence
Sterling (GBP 0.02) each.

<i>Second resolution

Therefore, the Shareholders resolve to record:
(a) the subscription for the 131 (one hundred thirty one) new Class A2 shares by Queensgate with payment of total

share premium of GBP 3,930 (three thousand nine hundred thirty Pounds Sterling) which shall be attached to the new
Class A2 shares;

(b) the subscription for the 196 (one hundred ninety six) new Class B2 shares by London Arena with payment of total

share premium of GBP 529,094.16 (five hundred twenty nine thousand ninety four Pounds Sterling sixteen Pence) which
shall be attached to the new Class B2 shares;

(c) the subscription for the 44 (forty four) new Class B2 shares by LBR with payment of total share premium of GBP

118,776.24 (one hundred eighteen thousand seven hundred seventy six Pounds Sterling twenty four Pence) which shall
be attached to the new Class B2 shares; and

(d) the payment of item (a) to (c) above in cash.

<i>Intervention - Subscriptions - Payment

The Shareholders, hereby represented by Thibaud Herberigs, pre-named, by virtue of the aforemented proxies, declare

each to subscribe individually as follows:

(a) Queensgate shall subscribe for the 131 (one hundred thirty one) new Class A2 shares with payment of total share

premium of GBP 3,930 (three thousand nine hundred thirty Pounds Sterling) which shall be attached to the new Class
A2 shares so that the total paid for such shares is equal to GBP 3,932.62 (three thousand nine hundred thirty two Pounds
Sterling sixty two pence);

17813

L

U X E M B O U R G

(b) London Arena shall subscribe for the 196 (one hundred ninety six) new Class B2 shares with payment of total

share premium of GBP 529,094.16 (five hundred twenty nine thousand ninety four Pounds Sterling sixteen Pence) which
shall be attached to the new Class B2 shares so that the total paid for such shares is equal to GBP 529,098.08 (five hundred
twenty nine thousand ninety eight Pounds Sterling eight Pence); and

(c) LBR shall subscribe for the 44 (forty four) new Class B2 shares with payment of total share premium of GBP

118,776.24 (one hundred eighteen thousand seven hundred seventy six Pounds Sterling twenty four Pence) which shall
be attached to the new Class B2 shares so that the total paid for such shares is equal to GBP 118,777.12 (one hundred
eighteen thousand seven hundred seventy seven Pounds Sterling twelve Pence).

The total amount of six hundred and fifty-one thousand eight hundred seven Pounds Sterling and eighty-two Pence

(GBP 651,807.82) is as now available the Company as has been proved to the undersigned notary.

Out of the amount of six hundred and fifty-one thousand eight hundred seven Pounds Sterling and eighty-two Pence

(GBP 651,807.82) an amount of seven Pounds Sterling forty-two Pence (GBP 7.42) has been allocated to the share capital
and an amount of six hundred and fifty-one thousand eight hundred Pounds Sterling and forty Pence (GBP 651.800,40)
to the share premium account.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the

above resolutions, so that it shall read henceforth as follows:

Art. 6.1. The Company's subscribed share capital is set amount of GBP 17,034.06 (seventeen thousand thirty four

Pounds six pence), represented by 298,519 (two hundred ninety eight thousand five hundred nineteen) class A1 shares,
2,082 (two thousand eighty two) class A2 shares, 547,284 (five hundred forty seven thousand two hundred eighty four)
class B1 shares, 3,817 (three thousand eight hundred seventeen) class B2 shares, 1 (one) class C1 shares, each of such
class A1 shares, class A2 shares, class B1 shares, class B2 shares, and a class C1 Share having a nominal value of GBP 0.02
(two pence Sterling)."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empower and authorize any manager of the Company and any lawyer or employee of King &amp; Wood Mallesons SJ
Berwin to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares
in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire résident à Luxembourg.

S’est tenue

une assemble générale extraordinaire («l’Assemblée») des associés de la société Meridian Group Investments S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 20, rue de le Poste, L-2346 Lu-
xembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro
B 175 116 (la «Société»). La Société a été constituée le 17 décembre 2012 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer,
notaire  de  résidence  à  Luxembourg  (Grand-Duché  de  Luxembourg),  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations numéro 797 du 4 Janvier 2013 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte daté du
17 octobre 2013 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en
cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Thibaud Herberigs, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés comme le Bureau de l’Assemblée.

17814

L

U X E M B O U R G

Les associés de la Société (les Associés) présents ou représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre de parts sociales

qu’ils détiennent sont mentionnés sur une liste de présence, qui restera annexée au présent acte après avoir été signée
par les mandataires des associés et les membres du Bureau.

Les procurations des Associés qui sont représentés à l’Assemblée, après avoir été signées "ne varietur" par le man-

dataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec
celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis envoyés à tous les associés en date du

7 novembre 2013.

II.- Il ressort de la liste de présence que sur les 298.519 parts sociales de classées A1, 1.951 parts sociales classées A2,

547.284 parts sociales classées B1, 3.577 parts sociales classées B2 et 1 part sociale classée C1, 298.519 parts sociales de
classées A1, 1.951 parts sociales classées A2, 547.284 parts sociales classées B1, 3.577 parts sociales classées B2 sont
présentes ou représentées à l’Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement
sur tous les points à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1 Augmentation du capital social de la Société d’un montant total de 7,42 GBP (sept livres Sterling quarante-deux

pence) par la création et l’émission de 131 (cent trente et une) nouvelles parts sociales de classe A2 et 240 (deux cent
quarante) nouvelles parts sociales de classe B2, chaque part sociale de classe A2 et B2 ayant une valeur nominale de 0,02
GBP (deux pence) chacune.

2 Acceptation de:
(a) La souscription à 131 (cent trente et une) nouvelles parts sociales de classe A2 par Queensgate dont la prime

d'émission s'élève à 3.930 GBP (trois mille neuf cent trente livres Sterling) laquelle sera attachée aux parts sociales de
classe A2;

(b) La souscription à 196 (cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales de classe B2 par London Arena dont la

prime d'émission s'élève à 529.094,16 GBP (cinq cent vingt-neuf mille quatre-vingt-quatorze livres Sterling et seize pence)
laquelle sera attachée aux parts sociales de classe B2;

(c) La souscription à 44 (quarante-quatre) nouvelles parts sociales de classe B2 par LBR dont la prime d'émission s'élève

à 118.776,24 GBP (cent dix-huit mille sept cent soixante-seize livres Sterling et vingt-quatre pence) laquelle sera attachée
aux parts sociales de classe B2; et

(d) La libération des sommes figurant aux points (a) à (c), ci-dessus, en numéraire;
3 Modification de l’article 6.1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'y refléter l'augmentation de capital social

spécifiée au point (2) ci-dessus.

4 Modification du registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter l’augmentation de capital visée ci-dessus, avec

pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de l’étude King &amp; Wood Mallesons SJ
Berwin, de procéder, sous sa seule signature et pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement
émises dans le registre de parts sociales de la Société.

5 Divers.
Après délibération l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de 7,42 GBP (sept livres Sterling

quarante-deux pence) par la création et l’émission de 131 (cent trente et une) nouvelles parts sociales de classe A2 et
240 (deux cent quarante) nouvelles parts sociales de classe B2, chaque part sociale de classe A2 et B2 ayant une valeur
nominale de 0,02 GBP (deux pence) chacune.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, les Associés décident d'enregistrer:
(a) La souscription à 131 (cent trente et une) nouvelles parts sociales de classe A2 par Queensgate dont la prime

d'émission s'élève à 3.930 GBP (trois mille neuf cent trente livres Sterling) laquelle sera attachée aux parts sociales de
classe A2;

(b) La souscription à 196 (cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales de classe B2 par London Arena dont la

prime d'émission s'élève à 529.094,16 GBP (cinq cent vingt-neuf mille quatre-vingt-quatorze livres Sterling et seize pence)
laquelle sera attachée aux parts sociales de classe B2;

(c) La souscription à 44 (quarante-quatre) nouvelles parts sociales de classe B2 par LBR dont la prime d'émission s'élève

à 118.776,24 GBP (cent dix-huit mille sept cent soixante-seize livres Sterling et vingt-quatre pence) laquelle sera attachée
aux parts sociales de classe B2; et

(d) La libération en numéraire des souscriptions du point (a) à (c).

17815

L

U X E M B O U R G

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les Associés, ici représentés par Thibaud Herberigs, en vertu de procurations dont mention ci-avant, déclarent chacun

souscrire comme suivant:

(a) Queensgate souscrit à 131 (cent trente et une) nouvelles parts sociales de classe A2 dont la prime d'émission

s'élève à 3.930 GBP (trois mille neuf cent trente livres Sterling) laquelle sera attachée aux parts sociales de classe A2, soit
un paiement total de 3.932,62 GBP (trois mille neuf cent trente-deux livres Sterling et soixante-deux pence) pour telle
souscription;

(b) London Arena souscrit à 196 (cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales de classe B2 dont la prime d'émission

s'élève à 529.094,16 GBP (cinq cent vingt-neuf mille quatre-vingt-quatorze livres Sterling et seize pence) laquelle sera
attachée aux parts sociales de classe B2, soit un paiement total de 529.098,08 GBP (cinq cent vingt-neuf mille quatre-
vingt-dix-huit livres Sterling et huit pence) pour telle souscription; et

(c)  LBR  souscrit  à  44  (quarante-quatre)  nouvelles  parts  sociales  de  classe  B2  dont  la  prime  d'émission  s'élève  à

118.776,24 GBP (cent dix-huit mille sept cent soixante-seize livres Sterling et vingt-quatre pence) laquelle sera attachée
aux parts sociales de classe B2, soit un paiement total de 118.777,12 GBP (cent dix-huit mille sept cent soixante-dix-sept
livres Sterling et douze pence) pour telle souscription.

Le montant total de six cent cinquante et un mille huit cent sept Livres Sterling et quatre-vingt-deux pence (GBP

651.807,82) est dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Du  montant  de  six  cent  cinquante  et  un  mille  huit  cent  sept  Livres  Sterling  et  quatre-vingt-deux  pence  (GBP

651.807,82), un montant de sept Livres Sterling et quarante-deux pence (GBP 7,42) est alloué au capital social et le
montant de six cent cinquante et un mille huit cents Livres Sterling et quarante pence (GBP 651.800,40) au compte des
primes d’émission.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 6.1 des Statuts, afin d'y refléter les résolutions ci-dessus. Il aura désormais

la teneur suivante:

Art. 6.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à GBP 17.034,06 (dix-sept mille trente-quatre livres Sterling

et six pence) représenté par 298.519 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent dix-neuf) parts sociales classées A1,
2.082 (deux mille quatre-vingt-deux) parts sociales de classe A2, 547.284 (cinq cent quarante-sept mille deux cent quatre-
vingt-quatre) parts sociales de classe B1, 3.817 (trois mille huit cent dix-sept) parts sociales de classe B2, 1 (une) part
sociale de classe C1, chaque part sociale de Classe A1, Classe B1, Classe C1, Classe A2, Classe B2 ayant une valeur
nominale de deux pence Sterling (0,02 GBP) chacune."

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre de parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus,

et confère pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de l’étude King &amp; Wood Mallesons
SJ Berwin, de procéder, sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales nouvellement
émises dans le registre de parts sociales de la Société et d'effectuer toutes les formalités y afférentes.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.500,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original

du présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES, T. HERBERIGS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53753. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003742/242.
(140003312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

17816

L

U X E M B O U R G

CWEI (Luxembourg) Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 178.710.

Les statuts coordonnés au 20/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 06/01/2014.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2014002133/12.
(140001817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Coeli SICAV I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 184.100.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth of January.
Before the undersigned Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Coeli Asset Management S.A., a public limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Luxembourg companies register under number R.C.S. B 175.733, having its registered office at 370,
Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

duly represented by Corinna Schibgilla, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 22 January 2014.
The aforementioned proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall

remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of

Incorporation of a "société anonyme":

Art. 1. Establishment and name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become

owners of shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme qualifying as "société d'investissement à
capital variable" under the name of "Coeli SICAV I'' (hereinafter the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time. The Company may be dissolved by a

resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of these articles
of incorporation (the "Articles of Incorporation") as defined in Article 30 hereafter.

Art. 3. Object. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities as

well as in any other assets and financial instruments authorized by the law of 17 December 2010 concerning undertakings
for collective investment, as amended (the "Law of 2010") with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders the results of the management of its portfolio.

Generally, the Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful in the ac-

complishment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part 1 of the Law of 2010.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of

Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad, by resolution of the board of directors of the Company (the "Board of Directors").

The registered office of the Company may be transferred by resolution of the Board of Directors to any other place

in the municipality of Luxembourg. If and to the extent permitted by the law, the Board of Directors may decide to
transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political events have occurred or are imminent,

that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be transferred temporarily abroad
until  the  complete  cessation  of  these  abnormal  circumstances.  Such  temporary  measure  shall  have  no  effect  on  the
nationality of the Company which, the temporary transfer of its registered office notwithstanding, shall remain a Luxem-
bourg company.

Art. 5. Share capital, Sub-Funds, Classes of shares. At any time, the share capital of the Company shall be equal to the

total net asset value of the different Sub-Funds (as defined hereafter). The minimum share capital of the Company shall
be as required by the Law of 2010 the equivalent of EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand euro).

17817

L

U X E M B O U R G

The initial capital is set at EUR 31,000 (thirty one thousand euro) divided into 310 (three hundred and ten) fully paid up
Shares of no par value.

As the Board of Directors shall determine, the capital of the Company, which has an umbrella structure, may be divided

into different portfolios of securities and other assets permitted by law with specific investment objectives and various
risk or other characteristics (the "Sub-Funds" and each a "Sub-Fund"). The Sub-Funds may be denominated in different
currencies as the Board of Directors shall determine. With regard to third parties, there is no cross liability between
Sub-Funds and each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities reasonably attributable to it. Within each
Sub-Fund, the Board of Directors may decide to issue different classes of Shares (the "Classes" and each a "Class") which
may differ, inter alia, with respect to their charging structure, dividend policies, hedging policies, investment minima,
currency of denomination or other specific features, as the Board of Directors may decide to issue. The Board of Directors
may decide if and from what date Shares of any such Classes shall be offered for sale, those shares to be issued on the
terms and conditions as shall be decided by the Board of Directors. Where the context so requires, references in these
Articles of Incorporation to "Sub-Fund(s)" shall be references to "Class(es)".

The Company is incorporated with multiple sub-funds as provided for in article 181 of the Law of 2010. The assets of

a specific Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with
the creation, the operation or the liquidation of that Sub-Fund.

The proceeds of any issue of shares of a specific Class shall be invested in the Sub-Fund corresponding to that Class

of shares, in various transferable securities, as well as in any other assets and financial instruments authorized by the Law
of 2010 and according to the investment policy as determined by the Board of Directors for a given Sub-Fund, taking into
account the investment restrictions foreseen by the Law of 2010 and regulations.

Consolidated accounts of the Company, including all Sub-Funds, shall be expressed in the reference currency of the

share capital of the Company, the Euro.

Art. 6. Form of the shares. The Board of Directors shall decide, for each Sub-Fund, whether to issue shares in bearer

and/or registered form. In the case of registered shares, unless a shareholder elects to obtain share certificates, he will
receive instead a confirmation of his shareholding.

In respect of bearer shares, certificates will be in such denominations as the board of directors shall decide.
Upon decision of the Board of Directors, fractions of shares may be issued for registered shares as well as bearer

shares, which shall be registered to the credit of the shareholders' securities account at the custodian bank or at corre-
spondent banks dealing with the financial services of the shares of the Company. For each Sub-Fund, the Board of Directors
shall restrict the number of decimals which shall be mentioned in the prospectus ("the Prospectus") of the Company.
Portions of shares shall be issued with no voting rights but shall give right to a distribution of the net assets of the relevant
Sub-Fund, if any, for the portion represented by these fractions.

All registered shares issued by the Company shall be entered in the register of shareholders which shall be kept by

the Company or by one or more persons designated to this effect by the Company. The register of shareholders will
indicate the name of each shareholder, his residence or elected domicile and the number of registered shares held by
him. Every transfer of (a) registered share(s) shall be entered in the register of shareholders.

Every shareholder wishing to receive registered shares must provide the Company with one address to which all

notices and announcements may be sent. This address shall be entered in the register of shareholders as the elected
domicile. In the event that the shareholder does not provide such an address, a notice to this effect may be entered in
the register of shareholders and the shareholder's address shall be deemed to be at the registered office of the Company
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may at any time change his
address as entered in the register of shareholders by means of a written notification sent to the registered office of the
Company, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

Bearer shares may at the request of the holder of such shares be converted, within such limits and conditions as may

be determined by the Board of Directors, into registered shares and vice versa.

Such conversion may entail payment by the shareholder of the costs incurred for such exchange.
Before shares are issued in the form of bearer shares and before registered shares are converted into bearer shares,

the Company may require, in a manner that the Board of Directors deems satisfactory, evidence that the issue or con-
version of the shares shall not result in such shares being held by a "US person" (as defined hereafter).

Every share shall be fully paid-up.
The Company will recognise only one holder in respect of a share in the Company unless otherwise determined by

the Board of Directors and disclosed in the Prospectus of the Company. In the event of joint ownership or bare ownership
and usufruct, the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one
person shall have been designated to represent the joint owners or bear owners and usufructaries vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or

other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

17818

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Issue of shares. The Board of Directors is authorized without limitation to issue at any time new and fully paid-

up shares in the Company without reserving to existing shareholders of the Company any preferential right to subscribe
to shares to be issued.

The Board of Directors may reduce the frequency at which shares shall be issued in a Sub-Fund. The Board of Directors

may, in particular, decide that shares of a Sub-Fund shall only be issued during one or several determined periods or at
such other frequency as provided for in the Prospectus of the Company, but at least twice a month.

Whenever the Company offers shares for subscription, the subscription price per share shall be equal to the net asset

value per share of the relevant class (the "Net Asset Value"), as determined in compliance with Article 12 hereunder, on
the applicable valuation day (the "Valuation Day") (as defined in the Prospectus of the Company). Such price may be
increased by any applicable sales commissions as described in the Prospectus of the Company. The subscription price so
determined shall be payable as stipulated in the Prospectus of the Company.

Subscription requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these

Articles of Incorporation.

The  Board  of  Directors  may  delegate  to  any  director,  officer  or  any  duly  authorized  agent  the  power  to  accept

subscriptions, to receive in payment the subscription price of new shares to be issued and to deliver them to the share-
holders.

In the event that the subscription price of the shares to be issued will not be paid by the shareholder concerned, the

Company may cancel the issue of such shares thereby reserving the right to claim expenses and commissions in relation
to such issue.

The Company may accept to issue shares against a contribution in kind of securities in compliance with the conditions

set forth by Luxembourg law and in particular, the obligation to deliver a valuation report by the auditor of the Company
if and to the extent required by Luxembourg law or by the board of directors of the Company, and provided that such
securities comply with the investment objectives, policies and restrictions of the relevant Sub-Fund.

Art. 8. Redemption of shares. Any shareholder may request the Company to redeem all or part of his shares in

accordance with the requirements set forth by the Board of Directors in the Prospectus of the Company and within the
limits provided by the Law of 2010 and by these Articles of Incorporation.

Unless otherwise provided for in the sales documents, any shareholder may request the redemption of all or part of

his shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the sales documents and
within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by such shareholder in written
form, subject to the conditions set out in the sales documents of the Company, at the registered office of the Company
or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares, together with the
delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued).

The redemption price per share shall be payable within a period as determined by the Board of Directors and men-

tioned in the Prospectus of the Company, in accordance with a policy determined by the Board of Directors from time
to time, provided that the redemption form have been received by the Company subject to the provisions hereunder.

The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per share of the relevant Class, as determined by the

provisions of Article 12 of these Articles of Incorporation less any redemption charges and/or commissions at the rate
as may be provided by the Prospectus of the Company. The redemption price may be rounded up or down to the nearest
unit of the relevant currency as the Board of Directors shall determine. From the redemption price there may further
be deducted any deferred sales charge if such shares form part of a Class in respect of which a deferred sales charge has
been contemplated in the sales documents.

The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class

or Classes.

The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised

person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.

If, as a result of any request for redemption, the number or the total Net Asset Value of shares held by a shareholder

in a Class of shares shall fall below such number or such value as determined by the Board of Directors and disclosed in
the Prospectus of the Company from time to time, the Company may request such shareholder to redeem the total
number or the full amount of his shares belonging to such Class of shares.

The  Company  may  accept  to  deliver  transferable  securities  and  money  market  instruments  against  a  request  for

redemption in kind, provided that the relevant shareholder formally agrees to such delivery, that all Luxembourg law
provisions have been respected, and in particular the obligation to present an evaluation report from the auditor of the
Company. The value of such transferable securities and money market instruments shall be determined according to the
principle used for the calculation of the Net Asset Value. The Board of Director must make sure that the redemption in
kind of such shares shall not be detrimental to the other shareholders of the Company. The specific costs for such
redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne by the shareholder requesting
the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the Board considers that the
redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.

All redeemed shares of the Company shall be cancelled.

17819

L

U X E M B O U R G

No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the Board, be for an amount

of less than that of the minimum holding amount as determined from time to time by the Board.

If a redemption or conversion would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub-

Fund or Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such shareholder
may be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such SubFund
or Class.

The Board may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the

minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the sales documents
of the Company.

Redemption requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these

Articles of Incorporation.

If the aggregate total number of redemption/conversion requests received for one relevant Sub-Fund at a given Valu-

ation Day exceeds a percentage of the Net Asset Value of the concerned Sub-Fund as determined by the Board of
Directors and set out in the Prospectus of the Company, the Board of Directors may decide to proportionally reduce
and/or postpone such redemption/conversion requests, so as to reduce the number of shares redeemed/converted as
at that day down to the relevant percentage of the Net Asset Value of the concerned Sub-Fund. Any redemption/con-
version request so reduced or postponed shall be received in priority to other redemption/conversion requests received
at the next applicable Valuation Day, subject to the above mentioned limit of the relevant percentage % of the Net Asset
Value.

In normal circumstances the Board of Directors will maintain an adequate level of liquid assets in every Sub-Fund in

order to meet redemption requests.

Art. 9. Conversion of shares. Except when specific restrictions are decided by the Board of Directors and mentioned

in the Prospectus of the Company, any shareholder is authorized to request the conversion within the same Sub-Fund
or between Sub-Funds of all or part of his shares of one Class into shares of the same or of another Class.

The price for the conversion of shares shall be calculated at the Net Asset Value by reference to the two relevant

Classes, on the same Valuation Day and taking into account of the conversion charges, if any, applicable to the relevant
Classes.

The Board of Directors may set such restrictions that it shall deem necessary as to the frequency, terms and conditions

of conversions of shares.

If, as a result of a conversion of shares, the number or the total Net Asset Value of the shares held by a shareholder

in a specific Class of shares should fall under such number or such value as determined by the Board of Directors, the
Company may request that such shareholder convert all of his shares of such Class. The shares which have been converted
shall be cancelled.

Conversion requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 14 of these

Articles of Incorporation.

Art. 10. Restrictions to the ownership of shares in the Company. The Company may restrict or prevent the ownership

of shares in the Company to any individual person or legal entity if such ownership is a breach of the Law or is in other
ways jeopardizing the Company.

More specifically, the Company shall have the power to restrict or prevent the ownership of shares by any person,

firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may
result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may
become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such
persons, firms or corporate bodies to be determined by the Board of Directors being herein referred to as "Prohibited
Persons"). For such purposes the Company may:

A) decline to issue shares and register the transfer of shares where it results or may result that the issue, or the

transfer of such share would lead to the beneficial ownership of such shares by a Prohibited Persons;

B) request any person who is entered in the shareholders' register, or any other person who wishes to register the

transfer  of  shares,  to  provide  the  Company  with  all  the  necessary  information  which  it  shall  deem  appropriate  and
supported by affidavit in order to determine whether or not these shares are owned or shall be owned by Prohibited
Persons,

C) decline to accept the vote of any Prohibited Person or any person who is precluded from holding shares in the

Company at any meeting of shareholders of the Company;

D) proceed with a compulsory redemption of all or part of such shares if it appears that a Prohibited Person, whether

alone or together with other persons, is the owner of shares in the Company or has provided the Company with forged
certificates and guarantees or has omitted to provide the information and guarantees as determined by the Board of
Directors. In this event, the following procedure shall be applied:

1) The Company shall send a notice (the "Redemption Notice") to the shareholder entered in the register as the owner

of the shares; the Redemption Notice shall specify the shares to be redeemed, the redemption price to be paid and the

17820

L

U X E M B O U R G

place at which the redemption price is payable. The Redemption Notice shall be sent by registered mail addressed to the
shareholder's last known address or to the address entered in the register of the shareholders. Immediately after the
close of business on the date specified in the Redemption Notice, the shareholder shall cease to be the owner of the
shares mentioned in such notice, his name shall no longer appear in the shareholders' register and the relevant shares
shall be cancelled. The said shareholder shall thereupon forthwith obliged to deliver to the Company the share certificate
or certificates (if issued) representing the shares specified in the Redemption Notice.

2) The price at which the shares mentioned in the Redemption Notice shall be redeemed, shall be an amount equal

to the net asset value of the shares of the Company according to Article 12 hereof, less any redemption charge payable
in respect thereof.

Where it appears that, due to the situation of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any

of its agents and/or any other intermediary may result in either the Company, any of its agents and/or any other inter-
mediary to be liable to a foreign authority for the payment of taxes or other administrative charges, the Company may
further withhold or retain, or allow any of its agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption
Price an amount sufficient to cover such potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any
of its agents and/or any other intermediary with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being un-
derstood (i) that in some cases the amount so withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority,
in which case such amount may no longer be claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered
may extend to any damage that the Company, any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of
their obligation to abide by confidentiality rules;

3) Payment of the redemption price shall be made to the shareholder appearing as the owner of the shares in the

currency of denomination of the relevant Sub-Fund or Class except in times of exchange rates restrictions, and such price
shall be deposited with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice). Such bank shall
thereafter transfer such price to the relevant shareholder as indicated in the Redemption Notice.

Upon payment of the price pursuant to these conditions, no person interested in the shares specified in the Redemption

Notice shall have any future interest in these shares and shall have no power to make any claim against the Company and
its assets, except the right for the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price deposited (with no
interest) at the bank.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by the present Article shall not be questioned or invalidated

in any case, on the ground that there is insufficient evidence of ownership of shares or that a share was owned by another
person than appeared to the Company when sending the Redemption Notice, provided that the Company exercised its
powers in good faith.

"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection

with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires
shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.

U.S. Persons as defined in these Articles and in the Memorandum may constitute a specific category of Prohibited

Persons.

Where it appears to the Company that any Prohibited Person is a U.S. Person, who either alone or in conjunction

with any other person is a legal or beneficial owner of shares, the Company may compulsorily redeem or cause to be
redeemed from any shareholder all shares held by such shareholder without delay, notably if the U.S. Person fails to
provide the Company with any information the Company requests in relation to any legal reporting obligation of the
Company. In such event, Clause D (1) here above shall not apply.

"U.S. person" shall mean citizens or residents of the USA, a partnership organized or existing in any state, territory

or possession of the USA or other areas subject to its jurisdiction, an estate or trust the income of which is subject to
United States federal income tax regardless of its source, or any corporation or other entity organized under the law of
or existing in the USA or any state, territory or possession thereof or other areas subject to its jurisdiction.In addition
to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of Shares of a Sub-Fund to the institutional
investors within the meaning of Article 174 (2) of the Law of 2010 ("Institutional Investor(s)"). The Board of Directors
may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a Sub-Fund reserved for Institu-
tional  Investors  until  such  time  as  the  Company  has  received  sufficient  evidence  that  the  applicant  qualifies  as  an
Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a Sub-Fund reserved to Institutional Investors is
not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant Shares into Shares of a Sub-Fund which is
not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Sub-Fund with similar characteristics) or com-
pulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of
Directors will refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be
entered into the register of shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares
of a Sub-Fund restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an
Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Insti-
tutional  Investor,  and  who  holds  Shares  in  a  Sub-Fund  restricted  to  Institutional  Investors,  shall  hold  harmless  and
indemnify the Company, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant Sub-Fund and the Company's
agents  for  any  damages,  losses  and  expenses  resulting  from  or  connected  to  such  holding  circumstances  where  the

17821

L

U X E M B O U R G

relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representa-
tions to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of such
status.

Art. 11. Termination and merger of Sub-Funds or Classes. A Sub-Fund or a Class may be terminated by resolution of

the Board of Directors under the following circumstances:

- if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below a level at which the Board of Directors considers that its

management may not be easily ensured; or

- in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies; or
- if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that

may adversely affect the ability of a Sub-Fund or a Class to operate in an economically efficient manner, and with due
regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund or a Class should be terminated.

A) In such event, the assets of the Sub-Fund or the Class shall be realized, the liabilities discharged and the net proceeds

of realization distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class against such
evidence of discharge as the Board of Directors may reasonably require. The Company shall send a notice to the share-
holders of the relevant Sub-Fund or Class of shares before the effective date of such termination. Such notice shall indicate
the reasons for such termination as well as the procedures to be enforced. Unless otherwise stated by the Board of
Directors, shareholders of such Sub-Fund or Class of shares may continue to apply for the redemption or the conversion
of their shares free of charge, but on the basis of the applicable Net Asset Value, taking into account the estimated
liquidation expenses.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of

shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power,
upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the
shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization
expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements
for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or
represented and voting at such meeting.

The assets that were not distributed to their owners upon redemption shall be deposited with the Caisse de Consig-

nation in Luxembourg on behalf of their beneficiaries.

B) A Sub-Fund or a Class may merge with one or more other Sub-Funds or Classes by resolution of the Board of

Directors if the Net Asset Value of a Sub-Fund or a Class is below at a level at which the Board of Directors considered
that its management may not be easily ensured or in the event of changes or in the event of special circumstances beyond
its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of
prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a SubFund or a Class
to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-
Fund or a Class should be merged.

The notification of such decision shall be similar to the one described above in paragraph A of this Article (such

notification shall, in addition, include the characteristics of the new Sub-Fund or Class). Every shareholder of the relevant
SubFunds, or Classes shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own shares without
any cost during a period of one month before the effective date of the merger. At the end of the one-month period, the
decision shall bind all shareholders who have not used the possibility of requesting the redemption or conversion of their
shares without any cost.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, a contribution of the

assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the Company may in any other
circumstances be decided upon by a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the
Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation
by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

C) In the event that the Board of Directors believes it is required in the interests of the shareholders of the relevant

Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which
would justify it, the reorganization of one Sub-Fund, by means of a division into two or more SubFunds, may be decided
by the Board of Directors. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in ac-
cordance with applicable laws and regulations.

D) The Board of Directors may also decide to consolidate or split Classes or split or consolidate different Classes of

shares within a Sub-Fund. Such decision will be notified in the same manner as described above under A) and in accordance
with applicable laws and regulations.

E) If within a Sub-Fund different Classes of shares have been issued as described in Article 5 of these Articles of

Incorporation, the Board of Directors may decide that the shares of one Class be converted into shares of another Class
at the time where the features applicable to the shares of a given Class are no more applicable to such Class. Such
conversion shall be carried out without costs for the shareholders, based on the applicable Net Asset Values. Any share-

17822

L

U X E M B O U R G

holder of the relevant Class shall have the possibility to request for redemption of his shares without any cost for a period
of one month before the effective date of such compulsory conversion.

Art. 12. Net Asset Value. The Net Asset Value of the shares of each Sub-Fund and Class of shares of the Company as

well as the issue and redemption prices shall be determined by the Company, or by any third party entrusted by the
Company to calculate the Net Asset Value pursuant to a periodicity to be defined by the Board of Directors, but at least
twice a month. Such Net Asset Value shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund or Class or
in any other currency as the Board of Directors may determine. The Net Asset Value shall be calculated by dividing the
net assets of the relevant Sub-Fund by the number of shares issued in such Sub-Fund taking into account, if needed, the
allocation of the net assets of this Sub-Fund into the various Classes of shares in this Sub-Fund (as described in Article 6
of these Articles).

The day on which the Net Asset Value shall be determined the ("Valuation Day") will be defined in the Prospectus of

the Company.

I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-

rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);

4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,

insofar as the same have not been written off;

7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The assets of each Sub-Fund shall be valued in the following manner:
1) The value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes and accounts receivables, prepaid expenses,

dividends and interests matured but not yet received shall be represented by the par-value of these assets except however
if it appears that such value is unlikely to be received. In the latter case, the value shall be determined by deducting a
certain amount to reflect the true value of these assets.

2) The value of transferable securities, money market instruments and/or financial derivative instruments listed on an

official Stock Exchange or dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognized and open to the
public (a "Regulated Market") as defined by laws and regulations in force is based on the latest known price and if such
transferable securities are dealt in on several markets, on the basis of the latest known price on the main market for such
securities. If in the opinion of the Board of Directors the latest known price is not representative, the value shall be
determined based on a reasonably foreseeable sales price to be determined prudently and in good faith.

3) In the event that any transferable securities or/and money market instruments are not listed or dealt in on any stock

exchange or any other Regulated Market operating regularly, recognized and open to the public as defined by laws and
regulations in force, the value of such assets shall be assessed on the basis of their foreseeable sales price estimated
prudently and in good faith.

4) The liquidating value of derivative contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean

their net liquidating value determined by the Board of Directors in a fair and reasonable manner, on a basis consistently
applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts traded on
exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on
exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Com-
pany; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which
net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the
Board of Directors may deem fair and reasonable.

5) Credit default swaps will be valued at their present value of future cash flows by reference to standard market

conventions, where the cash flows are adjusted for default probability. Interest rate swaps will be valued at their market
value established by reference to the applicable interest rates' curve. Other swaps will be valued at fair market value as
determined in good faith pursuant to the procedures established by the board of directors and recognised by the auditor
of the Company.

6) The value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market

and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof,
increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will
be valued by the amortized cost method, which approximates market value.

17823

L

U X E M B O U R G

7) Units of UCITS and/or other UCI will be evaluated at their last available net asset value per unit or, if such price is

not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of Directors
on a fair and equitable basis.

8) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to

procedures established by the Board of Directors.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the

reference currency of such Sub-Fund at rates last quoted by major banks. If such quotations are not available, the rate of
exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board of Directors.

The Board of Directors, or any appointed agent, at its sole discretion, may permit some other method of valuation to

be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

Every other asset shall be assessed on the basis of the foreseeable realization value which shall be estimated prudently

and in good faith.

II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses, management fees, including

incentive fees - if any -, custodian fees, and corporate agents' fees);

4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day as determined from

time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider appropriate.

6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which shall comprise but not be limited to fees (investment management fees and performance
fees, if any) payable to its investment managers, fees and expenses payable to its Auditor and accountants, Custodian (as
defined  in  Article  28  herein  below)  and  its  correspondents,  administrative  agent  and  paying  agent,  any  listing  agent,
domiciliary agent, any distributor(s) and permanent representatives in places of registration, as well as any other agent
employed by the Company, the remuneration of the Directors and officers of the Company and their reasonable out-of-
pocket  expenses,  insurance  coverage,  and  reasonable  travelling  costs  in  connection  with  board  meetings,  fees  and
expenses for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of
the Company with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other
country, reporting and publishing expenses including the costs of preparing, printing, advertising and distributing Pros-
pectuses,  explanatory  memoranda,  periodical  reports  or  registration  statements,  and  the  costs  of  any  reports  to
shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, the costs for the publication of the issue, conversion, if
any, and redemption prices and all other operating expenses, the costs for the publication of the issue and redemption
prices, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex.
The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated
amount payable for yearly or other periods.

III. The assets shall be allocated as follows:
1) the proceeds from the issue of each Share are to be applied in the books of the relevant Sub-fund to the pool of

assets established for such Sub-fund and the assets and liabilities and incomes and expenditures attributable thereto are
applied to such SubFund subject to the provisions set forth hereafter;

2) where any asset is derived from another asset, such asset will be applied in the books of the relevant Sub-fund from

which such asset was derived, meaning that on each revaluation of such asset, any increase or diminution in value of such
asset will be applied to the relevant Sub-Fund;

3) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in

connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability will be allocated to the relevant Sub-Fund;

4) where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund,

such asset or liability will be allocated to all Subfunds prorata to the Sub-fund's respective net asset value at their respective
launch dates;

5) upon the payment of dividends to the Shareholders in any Sub-fund, the net asset value of such Sub-fund shall be

reduced by the gross amount of such dividends.

IV. For the purpose of valuation under this article:
(a) shares of the relevant Sub-fund in respect of which the Board has issued a redemption notice or in respect of which

a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account on the relevant Valuation
Day, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

17824

L

U X E M B O U R G

(b) all investments, cash balances and other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the currency of

denomination in which the net asset value of the relevant Sub-fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares;

(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Day, to the extent practicable; and

(d) where the Board is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the result of

requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the value may, at the discretion of the Board
be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices. Similarly, should any sub-
scription or conversion of shares result in a significant purchase of assets in the Company, the valuation may be done at
the actual offer price of the underlying assets and not the last available price.

All valuation principles and calculations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting

principles.

If the Board of Directors considers that the Net Asset Value calculated on a given Valuation Day is not representative

of the true value of the Company's shares, or if, since the calculation of the Net Asset Value, there have been significant
fluctuations on the stock exchanges concerned, the Board of Directors may decide to take into account these circum-
stances and to actualize the Net Asset Value on that same day. In these circumstances, all subscription, redemption and
conversion requests received for that day will be handled on the basis of the actualized Net Asset Value with care and
good faith.

Art 13. Pooling of assets. The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner

described in the sales documents of the shares of the Company, that (i) all or part of the assets of the Company or of
any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings
for collective investment and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the
Company be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

Art. 14. Suspension of calculation of the Net Asset Value per share, of the issue, conversion and redemption of

shares. Without prejudice to the legal causes of suspension, the Board of Directors of the Company may suspend at any
time the determination of the Net asset Value per share of one or several Sub-Funds and the issue, redemption and
conversion of shares in the following cases:

a) when any of the principal stock exchanges, on which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Funds

is quoted, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted;

b) when the market of a currency, in which a substantial portion of the assets of one or more Sub-Fund(s) or Class

(es) is denominated, is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or re-
stricted;

c) when any breakdown arises in the means of communication normally employed in determining the value of the

assets of one or more Sub-Fund(s) or Class(es) of the Company or when for whatever reason the value of one of the
Company's investments cannot be rapidly and accurately determined;

d) when exchange restrictions or restrictions on the transfer of capital render the execution of transactions on behalf

of the Company impossible, or when purchases or sales made on behalf of the Company cannot be carried out at normal
exchange rates;

e) when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control, responsibility

and influence of the Company prevent the Company from disposing of the assets, or from determining the Net Asset
Value, of one or more Sub-Fund(s) or Class(es) in a normal and reasonable manner;

f) as a consequence of any decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Fund(s);
g) in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution

to wind up the Company or any Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to wind up
one or more Sub-Funds, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the shareholders, of
the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Company or a Sub-Fund is to be proposed,
or of the decision of the Board of Directors to merge one or more Sub-Funds;

h) where the master UCITS of a feeder Sub-Fund temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription

of its units/shares, whether on its own initiative or at the request of its competent authorities, or

i) any other circumstances beyond the control of the Board of Directors as determined by the Directors in their

discretion.

In case of suspension of such calculation, the Company shall immediately inform in an appropriate manner the share-

holders who have requested the subscription, redemption or conversion of shares in this or these Sub-Funds.

Any suspension of the calculation of the Net Asset Value of the shares in one or several Sub-Funds shall be published,

if appropriate, by any appropriate ways.

During the suspension period, shareholders may cancel any application filed for the subscription, redemption or con-

version of shares. In the absence of such cancellation, the shares shall be issued, redeemed or converted by reference to
the first calculation of the Net Asset Value carried out following the close of such suspension period.

17825

L

U X E M B O U R G

In exceptional circumstances which may be detrimental to the shareholders' interests (for example large numbers of

redemption, subscription or conversion requests, strong volatility on one or more markets in which the Sub-Fund(s) or
Class(es) is (are) invested), the Board of Directors reserves the right to postpone the determination of the Net Asset
Value of this (these) Sub-Fund(s) or Class(es) until the disappearance of these exceptional circumstances and if the case
arises and to postpone subscription, redemption or conversion requests, until any essential sales of securities on behalf
of the Company have been completed.

In such cases, subscriptions, redemption requests and conversions of shares which were suspended simultaneously

will be satisfied on the basis of the first Net Asset Value calculated thereafter.

Art. 15. General meetings of shareholders. The meeting of shareholders of the Company validly set up shall represent

all the shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of
the Sub-Fund and Classes of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the operations of the Company.

The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office

of the Company or at any such other place in the municipality of the registered office, as shall be specified in the notice
of meeting, on the last Wednesday in the month of April at 2.00 p.m. (Luxembourg time). If this day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The
annual general meeting can be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional
circumstances require this relocation.

The other general meetings of shareholders shall be held at a date, time and place specified in the convening notices.
Decisions concerning the general interest of the Company's shareholders are taken during a general meeting of all the

shareholders and decisions concerning specific rights of the shareholders of one Sub-Fund or Class of Shares shall be
taken during a general meeting of this Sub-Fund or of this Class of Shares. Two or several Sub-Funds or Classes may be
treated as one single Sub-Fund or Class if such Sub-Funds or Classes are affected in the same way by the proposals
requiring the approval of shareholders of the relevant Sub-Funds or Classes.

The  quorum  and  notice  periods  required  by  law  shall  govern  the  convening  and  the  conduct  of  the  meetings  of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise the voting rights attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by
this shareholder at the Record Date.

Each whole share of each Sub-Fund and of each Class, regardless of its net asset value, is entitled to one vote, subject

to the restrictions contained in these Articles of Incorporation. Shareholder may vote either in person or through a
written proxy to another person who need not to be a shareholder and may be a Director, or by means of a dated and
duly completed form which must include the information as set out herein.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

Shareholders may also vote by proxy. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening

notice that the proxy must include information in addition to the following information: the name of the Company, the
name of the shareholder as it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda
of the meeting; an instruction as to how the shareholder wishes the proxyholder to vote.

In order for the votes expressed by such proxy to be taken into consideration for the determination of the quorum,

the proxy must be received by the Company or its appointed agent before the date specified therein.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing

their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.

Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and secured debtors shall be respectively represented by a

single and same person. Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at meetings
of shareholders shall be passed by a simple majority of the validly cast votes of shareholders, which for the avoidance of
doubt shall not include abstention, nil vote and blank ballot paper.

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors, pursuant to a notice setting forth the name of the

Company, the location, date, and time of the meeting, presence and quorum requirements and the agenda, published in
accordance with the Luxembourg law.

The agenda is prepared by the Board of Directors which, if the meeting is convened following a written demand from

the shareholders, as it is foreseen by law, shall take into account the items that shall be asked to be examined by the
meeting.

17826

L

U X E M B O U R G

Nevertheless, if all shareholders are present or represented and if they state that they know the agenda, the meeting

may be held without prior publication.

The minutes of general meetings are signed by the members of the bureau and by the shareholders who so request.

Copies or extracts of such minutes, which need to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by:

- either 2 directors;
- or by the persons authorized by the Board of Directors.

Art. 16. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members.

The members of the Board of Directors shall not necessarily be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected at the annual general meeting of shareholders and for the first time after the incorpo-

ration of the Company, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and
qualify. The Directors shall be eligible for re-election.

If a legal entity is appointed as Director, such legal entity must designate a physical person as its permanent represen-

tative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove
its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

In this respect, a third party shall have no right to demand the justification of powers; the mere qualification of rep-

resentative or of delegate of the legal entity being sufficient.

The term of office of outgoing directors not re-elected shall end immediately after the general meeting which has

proceeded to their replacement.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general

meeting of the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement, dismissal or otherwise, the remaining

Directors may appoint, at the majority of votes, a Director to temporarily fill such vacancy until the next meeting of
shareholders which shall ratify such appointment.

Art. 17. Chairmanship and Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman

and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also appoint a secretary who need not be
a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the
shareholders.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place, date and time indicated

in the notice of meeting.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
Any Director may act at any meeting by appointing another Director as his proxy, in writing, by telefax or any other

similar written means of communication. Any director may represent one or more of his colleagues. Directors may also
cast their vote in writing by telefax or any other similar written means of communication.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company

by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors meets under the presidency of its chairman, or in his absence, the Board of Directors may

appoint another director to chair such meetings.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the total number of directors is present or

represented. Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting. In the
event that, at any Board of Directors meeting, the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman
or in his absence the chairman pro tempore of the meeting shall have a casting vote.

Any Director may participate at a meeting of the Board of Directors by conference call or video-conference or by

other similar means of communication whereby all persons participating in a meeting can hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons at the meeting. The participation to a meeting by such
means of communication is equivalent to a physical presence at such meeting. A meeting held through such means of
communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

Notwithstanding the clauses mentioned here above, a resolution from the Board of Directors may also be passed via

a circular resolution. This resolution shall be approved by all the Directors whose signatures shall be either on a single
document or on several copies of it. Such a resolution shall have the same validity and force as if it had been taken during
a meeting of the Board of Directors, legally convened and held.

The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by the chairman or in his absence, by the chairman

pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes, intended to be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary, or by any two Directors or by any person
authorized by the Board of Directors.

Art. 18. Powers of the Board of Directors. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors

or by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of

17827

L

U X E M B O U R G

Directors. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting
of shareholders are within the scope of competence of the Board of Directors.

Art. 19. Investment Policy. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to

determine the investment policies and strategies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course of conduct of
the management and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors
in compliance with applicable laws and regulations, including in particular in compliance with the provisions of Part I,
chapter 5 of the Law of 2010.

Within those restrictions, the Board of Directors may decide that investments be made in:
a) Transferable Securities or Money Market Instruments (within the meaning of the Law of 2010);
b) shares or units of other UCI, including shares or units of a master fund qualified as a UCITS;
c) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than twelve (12) months;

d) financial derivative instruments;
e) Shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company, under the conditions provided for by the Law of

2010.

The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities

recognized by the Luxembourg supervisory authority.

The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any Regulated Market of a state of Europe,

being or not a Member State, a state of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.

The Company may also invest in recently issued Transferable Securities and Money Market Instruments, provided that

the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated
Market and that such admission be secured within one year of issue.

In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets

attributable to each Sub-Fund in Transferable Securities and/or Money Market Instruments issued or guaranteed by an
EU member state, its local authorities, another member state of the OECD, such non-member state(s) of the OECD as
set out in the Prospectus, or public international bodies of which one or more member states of the EU are members
being provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund,
securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue cannot exceed 30% of the total
net assets attributable to that Sub-Fund.

The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the

Prospectus, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis
with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds;
or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company be co-managed amongst themselves on a
segregated or on a pooled basis.

Investments of each Sub-Fund of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned sub-

sidiaries, as the Board of Directors may from time to time decide and as described in the Prospectus. Reference in these
Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held
directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

The Company is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to Transferable Securities and Money

Market Instruments provided that such techniques and instruments may be used for hedging purposes, for the purpose
of efficient portfolio management or for investment purposes and (ii) to employ techniques and instruments intended to
provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.

Art. 20. Daily Management. The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company,

including a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers con-
sidered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any
time by the Board of Directors. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed,
unless otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given them by the Board
of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its

powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities
which need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers,
authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of
the Board of Directors or not) as it thinks fit.

Art. 21. Representation - Judicial acts and actions - Commitments of the Company. The Company will be legally

represented:

- either by the chairman of the Board of Directors; or
- jointly by two Directors; or

17828

L

U X E M B O U R G

- by the representative(s) in charge of the daily management and/or the general manager and/or the general secretary

acting together or separately, up to the limit of their powers as determined by the Board of Directors.

Besides, the Company will be validly committed by specially authorized agents within the limits of their mandates.
Legal actions, in a capacity as either claimant or defendant, shall be followed up in the name of the Company by a

member of the Board of Directors or by the representative appointed to that effect by the Board of Directors.

The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any

Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 22. Invalidation Clause and Transactions with Connected Persons. No contract or other transaction between the

Company and other companies or firms shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors
or officers of the Company is interested in such other firm or company or by the fact that he would be a director, partner,
manager or employee of it. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any
company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not be prevented, by reason
of such an affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter provided, from considering, voting and
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company would have a personal interest in a transaction of the

Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and he shall not
consider or vote on any such transaction; and such transaction and such Director's or manager's personal interest shall
be reported to the next general meeting of shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving Coeli AB or any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or
entity as may from time to time be determined by the Board of Directors unless such a "personal interest" is considered
to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.

All transactions carried out by or on behalf of the Company must be at arm's length and executed on the best available

terms.

Art. 23. Indemnifications. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such
person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the event of a settlement, any indemnity shall
be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall
not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 24. Auditor. In accordance with the Law, the Company shall appoint an independent auditor ("Réviseur d'Entre-

prises agréé"). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and serve until its
successor shall have been elected and shall be remunerated by the Company.

Art. 25. Custody of the assets of the Company. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank

which shall satisfy the requirements of the Luxembourg laws and the Law of 2010 (the "Custodian"). All securities, cash
and other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the
Company and its shareholders the responsibilities provided by the laws.

In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use their best endeavours to find within

two months a corporation to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such corporation
to be custodian in place of the retiring Custodian. The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian
but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with
this provision to act in the place thereof.

Art. 26. Investment advisers and managers. The Company may conclude under its overall control and responsibility

one or several management or advisory agreements with any Luxembourg or foreign entity by which such entity or any
other previously approved company shall provide the Company with advice, recommendations and management services
regarding the investment policy of the Company in accordance with the Law of 2010 and with the present Articles of
Incorporation. In the event of termination of said agreements in any manner whatsoever, the Company will, if applicable,
change its name forthwith upon the request of any investment adviser(s) or manager(s) to another name not resembling
the one specified in Article 1 hereof.

Art. 27. Accounting year - Annual and periodical report. The accounting year of the Company shall begin on January

st

 of each year and shall terminate on the last day of December of same year. The consolidated accounts of the Company

shall be expressed in Euros.

17829

L

U X E M B O U R G

Where there shall be different Sub-Funds, as provided for by Article 5 of these Articles of Incorporation, and if the

accounts within such sub-funds are kept in different currencies, such accounts shall be converted into Euros and added
together for the purpose of determining the accounts of the Company.

Art. 28. Allocation of the annual result. Upon the Board of Directors' proposal and within legal limits, the general

meeting of shareholders of the Class(es) issued in any Sub-Fund shall determine how the results of such Sub-Fund shall
be allocated and may from time to time declare or authorize the Board of Directors to declare distributions.

For each Class or Classes of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends

in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses re-

corded  in  the  register  of  shareholders.  Payments  of  distributions  to  holders  of  bearer  shares  shall  be  made  upon
presentation of the dividend coupon to the agent or agents thereto designated by the Company.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place as the Board of Directors shall determine.
The Board of Directors may decide to distribute dividends in the form of new shares in lieu of cash dividends upon

such terms and conditions as may be set forth by the Board of Directors.

Any declared distribution that has not been claimed by its beneficiary within five years of its attribution may not be

subsequently reclaimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the relevant Class(es) of shares.

The Board of Directors has all powers and may take all measures necessary for the implementation of this provision.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
The payment of revenues shall be due for payment only if the currency regulations enable to distribute them in the

country where the beneficiary lives.

Art. 29. Dissolution. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting subject to the

quorum and majority requirements referred to in Article 30 of the present Articles of Incorporation.

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who

may be physical persons or legal entities represented by physical persons, designated by the general meeting of share-
holders which shall determine their powers and their compensations.

If the capital of the Company falls below two thirds of the minimum legal capital, the Directors must submit the question

of the dissolution of the Company to the general meeting for which no quorum shall be prescribed and which shall decide
by simple majority of the shares present or represented at the meeting. If the capital falls below one fourth of the minimum
legal capital, no quorum shall be prescribed but the dissolution may be resolved by shareholders holding one fourth of
the shares presented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets

have fallen below respectively two thirds or one fourth of the minimum capital.

The net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidators to the holders of

shares of each Class of each Sub-Fund in proportion of the rights attributable to the relevant Class of shares.

Art. 30. Amendments to the Articles of Incorporation. The present Articles of Incorporation may be amended from

time to time by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements required by Lux-
embourg law and by the provisions of the present Articles of Incorporation. Any amendment affecting the rights of the
holders of Shares of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of any other Class or Sub-Fund shall be subject, to the said
quorum and majority requirements in respect of each such relevant Class or Sub-Fund.

Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be subject to the 1915 Law

amended and to the Law of 2010."

<i>Transitional Dispositions

1)  The  first  accounting  year  shall  begin  on  the  date  of  the  formation  of  the  Company  and  shall  terminate  on  31

December 2014.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed and paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
- Coeli Asset Management S.A., pre-qualified, subscribes for three hundred and ten (310) shares that are allocated to

the share class I EUR of the Company's sub-fund Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund for a total subscription price of
thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR).

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is as of now

available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

17830

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26,

26-3 and 26-5 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have
been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever as a result of the formation of the Company

are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>First Extraordinary General Meeting of Shareholders

The above named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has imme-

diately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, it has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as members of the Board of Directors for a period ending at the annual general

meeting to be held on

- Paul Guillaume, Chairman, born on 10 February 1959 in Luxembourg, with professional address in 370, Route de

Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Johan Lindberg, Director, born on 17 July 1966 in Brännkyrka, Sweden, with professional address in 370, Route de

Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Lukas Lindkvist, Director, born on 23 May 1973 in Stockholm,Sweden, with professional address in Sveavägen 24-16,

111 57 Stockholm, Sweden; and

- Frits F. Carlsen, Director, born on 4 September 1958 in Copenhagen, Denmark, with professional address in 5, An

Den Azingen, L-5380 Uebersyren, Luxembourg.

2. The address of the Company is set at 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
3. The number of auditors is set at one.
4. The following is appointed as independent auditor for the same period:
PriceWaterhouseCoopers S.C., Luxembourg, 400, Route d'Esch, L-1014 Luxembourg
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English on the request of the same appearing persons.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first

names, civil status and residences, the said persons appearing before the Notary signed together with the Notary, the
present original deed.

Signé: C. SCHIBGILLA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 janvier 2014. Relation: LAC/2014/4567. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2014.

Référence de publication: 2014020086/827.
(140023063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Dennemeyer Trust, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 19.114.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 20 Décembre 2013.

Daniel Diwo.

Référence de publication: 2014002159/10.
(140002172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

17831

L

U X E M B O U R G

Knightrider S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.125.000,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 143.155.

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "Knightrider S.à r.l.", a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
registered  with  the  Luxembourg  Register of  Commerce  and Companies  (the  "RCSL") under the number B  143.155
incorporated by a deed of Maître Paul FRIEDERS, then notary residing in Luxembourg on 18 November 2008 published
in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 2922 of 8 December 2008 (the "Com-
pany"). The articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned
notary, on 16 August 2013, not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Matthias PONS, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

shares held by each shareholder are shown on an attendance list signed by the shareholders present, the proxyholders
of the shareholders represented, the bureau of the meeting and the undersigned notary. The said list shall remain annexed
to the present deed to be filed with the registration authorities.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the bureau of the meeting

and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list, that all the one million one hundred and twenty-five thousand (1,125,000) shares

are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide on all the items of
the agenda of which the shareholders have been duly informed ahead of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the merger whereby SSBM Beteiligungs GmbH, a German private limited liability company, having its

registered office at Färbergraben 18, D - 80331 Munich, registered with the trade register of the Local Court (Amtsgericht)
of Munich under number HRB 183673 shall merge into the Company, its parent company holding the entire share capital
of SSBM Beteiligungs GmbH, by way of absorption by the Company of SSBM Beteiligungs GmbH and without liquidation
of SSBM Beteiligungs GmbH (the "Merger") (SSBM Beteiligungs GmbH and the Company being referred to as the "Merging
Companies") as contemplated by (i) the joint merger proposal and (ii) the explanatory memorandum drawn up by the
managing directors of SSBM Beteiligungs GmbH.

2. Acknowledgement of the express waiver by all the shareholders of the Company in accordance with Article 265

(3) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "LSC"), of the requirement
to have an explanatory memorandum on the Merger from the board of managers of the Company.

3. Effectiveness of the Merger.
IV. The provisions of the LSC relating to mergers have been respected as follows:
1. The merger proposal as jointly drawn up by the board of managers of the Company and the managing directors of

SSBM Beteiligungs GmbH and notarized by the undersigned notary on the 2 

nd

 of October 2013 (the "Merger Proposal"),

has been filed with the RCSL and has been published in the Mémorial on the 9 

th

 of October 2013 hence at least one (1)

month before the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company convened in connection
with the Merger at the date hereof and in the official German gazette.

2. The publication of the Merger Proposal has indicated the arrangements made for the exercise of the rights of the

creditors of each of the Merging Companies and the address at which complete information on those arrangements may
be obtained free of charge.

3. An explanatory memorandum has been drawn up by the managing directors of SSBM Beteiligungs GmbH describing

the reasons for the Merger, the anticipated consequences for the respective activities of each of the Merging Companies
and any legal, economic and social related implications of the Merger ("Explanatory Memorandum").

4. In accordance with Article 278 of the LSC, no examination of the terms and conditions of the Merger by an inde-

pendent auditor is required.

5. The respective documents required pursuant to Article 267 and Article 278 of the LSC, have been deposited at the

registered office of the Company, for inspection by the shareholders at least one (1) month prior to the date hereof. An
attestation from the Company certifying as to the availability of these documents, after having been signed ne varietur by

17832

L

U X E M B O U R G

the bureau of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.

V. After this has been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the chairman

submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, after having reviewed the Merger Proposal, resolved to approve the Merger as contemplated by the

Merger Proposal and the Explanatory Memorandum.

<i>Second resolution

The meeting acknowledged the express waiver by all the shareholders of the Company, in accordance with Article

265 (3) of the LSC, of the requirement to prepare an explanatory memorandum on the Merger from the board of managers
of the Company.

<i>Third resolution

The meeting resolved to state that the Merger will be effective between the Merging Companies and vis-à-vis third

parties on the date of publication of this notarial deed in the Mémorial.

<i>Declaration

In accordance with Article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence

and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the
Merger.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Luxembourg,  on  the  date  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German translation of above text:

Im Jahr zweitausend und dreizehn, am elften November,
vor Maître Francis KESSELER, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
wurde die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Knightrider S.à r.l., eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 23, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg  und  registriert  im  luxemburgischen  Handels-  und  Gesellschaftsregister  (das  „HGR")  unter  Nummer  B
143.155, gegründet am 18. November 2008 durch Urkunde von Maître Paul FRIEDERS, damalig Notar mit Amtssitz in
Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial"), Nummer 2922 vom 8.
Dezember 2008 (die "Gesellschaft"), abgehalten. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrere Male und zum letzten Mal
am 16. August 2013 vor dem unterzeichnenden Notar abgeändert. Diese Änderung ist bisher noch nicht im Mémorial
veröffentlicht.

Der Versammlung sitzt Marcus PETER, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxembourg, vor.
Der Vorsitzende ernennt Frédéric LEMOINE, Avocat à la Cour, mit Wohnsitz in Luxemburg, als Protokollführer.
Die Versammlung wählt Matthias PONS, Juristin, mit Wohnsitz in Luxemburg, als Stimmzähler.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl der

Aktien, die von jedem Aktionär gehalten werden, sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen, welche von den anwesenden
Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, dem Vorsitz der Versammlung und dem unterzeichnenden
Notar unterzeichnet wurde. Diese Liste bleibt der vorliegenden Urkunde beigeheftet, um zusammen mit ihr bei den
Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, bleiben der vorliegenden Urkunde beigeheftet, nachdem sie vom Vorsitz

der Versammlung und dem unterzeichnenden Notar „ne varietur" paraphiert wurden, um zusammen mit ihr bei den
Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.

II. Die Anwesenheitsliste zeigt, dass alle eine Million einhundertfünfundzwanzigtausend (1.125.000) Aktien bei dieser

außerordentlichen Hauptversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung hinsichtlich aller Tagesordnungspunkte,
über welche die Aktionäre vor der Versammlung ordnungsgemäß informiert wurden, gültig entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Genehmigung der Verschmelzung wobei die SSBM Beteiligungs GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

deutschen Rechts mit Sitz in München und Geschäftsadresse in Färbergraben 18, 80331 München registriert beim Han-

17833

L

U X E M B O U R G

delsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 183673 mit der Gesellschaft, ihrer Muttergesellschaft
welche die gesamten Gesellschaftsanteile der SSBM Beteiligungs GmbH hält, im Wege der Aufnahme der SSBM Beteili-
gungs GmbH durch die Gesellschaft, ohne Liquidation der SSBM Beteiligungs GmbH verschmelzen soll (die „Verschmel-
zung")  (  die  SSBM  Beteiligungs  GmbH  und  die  Gesellschaft  zusammen  die  „Verschmelzenden  Gesellschaften"),  wie
vorgesehen  in  (i)  dem  gemeinsamen  Verschmelzungsplan  und  (ii)  dem  Verschmelzungsbericht  erstellt  durch  die  Ge-
schäftsführung der SSBM Beteiligungs GmbH.

2. Bestätigung des ausdrücklichen Verzichts der Aktionäre der Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 265 (3)

des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das
„LGG"), auf das Erfordernis einen Verschmelzungsbericht, vorbereitet durch den Vorstand der Gesellschaft, zu erhalten.

3. Wirksamkeit der Verschmelzung.
IV. Die Regelungen des LGG hinsichtlich Verschmelzungen wurden wie nachfolgend respektiert:
1. Der Verschmelzungsplan, wie gemeinsam durch den Vorstand der Gesellschaft und durch die Geschäftsführer der

SSBM Beteiligungs GmbH erstellt und durch den unterzeichnenden Notar am 2. Oktober 2013 beglaubigt (der „Ver-
schmelzungsplan"), wurde beim HGR eingereicht und im Memorial am 9. Oktober 2013, mindestens einen (1) Monat vor
dem Datum der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, einberufen im Zusammenhang
mit der Verschmelzung zum heutigen Datum, und im offiziellen deutschen Amtsblatt veröffentlicht.

2. Die Veröffentlichung des Verschmelzungsplans gibt die Vorkehrungen, die zur Ausübung der Rechte aller Gläubiger

der Verschmelzenden Gesellschaften getroffen wurden, sowie die Adresse, unter welcher vollständige Informationen
über dieser Vorkehrungen kostenlos angefragt werden können, an.

3. Ein Verschmelzungsbericht wurde durch die Geschäftsführung der SSBM Beteiligungs GmbH erstellt und beschreibt

die Gründe für die Verschmelzung, die erwarteten Konsequenzen für die entsprechenden Aktivitäten für jede der Ver-
schmelzenden  Gesellschaften,  sowie  jede  rechtliche,  wirtschaftliche  und  soziale  Auswirkung  der  Verschmelzung  (der
„Verschmelzungsbericht").

4. In Übereinstimmung mit Artikel 278 LGG ist eine Prüfung der Bedingungen der Verschmelzung durch einen unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer nicht erforderlich.

5. Die entsprechenden Dokumente, wie gemäß Artikel 267 und Artikel 278 LGG verlangt, wurden am Sitz der Ge-

sellschaft zum Zweck der Prüfung durch die Aktionäre mindestens einen (1) Monat vor dem heutigen Datum hinterlegt.
Eine Bescheinigung der Gesellschaft welche die Verfügbarkeit der entsprechenden Dokumente bestätigt, bleibt der vor-
liegenden Urkunde beigeheftet, nachdem sie vom Vorsitz der Hauptversammlung und dem unterzeichnenden Notar „ne
varietur" paraphiert wurden, um zusammen mit ihr bei den Registrierungsbehörden eingereicht zu werden.

V. Nachdem dies durch den Vorsitzenden dargelegt und durch die Mitglieder der Versammlung bestätigt wurde, legt

der Vorsitzende den Mitgliedern der Versammlung die folgenden Beschlüsse zur Abstimmung vor:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, nach Überprüfung des Verschmelzungsplans, die Verschmelzung, wie durch den Ver-

schmelzungsplan und den Verschmelzungsbericht vorgesehen, zu genehmigen.

<i>Zweiter Beschluss

In Übereinstimmung mit Artikel 265 (3) LGG, bestätigt die Versammlung den ausdrücklichen Verzicht aller Aktionäre

der Gesellschaft auf das Erfordernis der Vorbereitung eines Verschmelzungsberichts durch den Vorstand der Gesellschaft.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dass die Verschmelzung zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber

dritten Parteien vom Datum der Veröffentlichung dieser Urkunde im Mémorial wirksam ist.

<i>Erklärung

In Übereinstimmung mit Artikel 271(2) LGG, erklärt der unterzeichnende Notar, dass er nach luxemburgischen Recht

die Existenz und die Gültigkeit der Rechtshandlungen und Formalitäten, die der Gesellschaft hinsichtlich der Realisierung
der Verschmelzung auferlegt wurden, überprüft und bescheinigt hat.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen

der oben erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung
abgefasst ist. Auf Verlangen derselben oben erschienenen Personen soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem eng-
lischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich sein.

WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg, am Tag wie zu Anfang dieses Dokuments erwähnt, ausgefertigt

wurde.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und

Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, haben diese erschienen Personen diese Urkunde zusammen mit dem Notar
unterzeichnet.

Signé: Peter, Lemoine, Pons, Kesseler.

17834

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15164. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014020272/171.
(140022778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Edge II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.440.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68978 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014002173/10.
(140001316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

La Varenne Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.

R.C.S. Luxembourg B 46.422.

L'an deux mille treize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de La Varenne Group S.A., une société ano-

nyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, route Nationale 1, L-6776 Grevenmacher, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B46422 (la «So-
ciété»), constituée suivant acte reçu de Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, le 28 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 19 avril 1994, sous le
numéro 148. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu de Maître
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 2 décembre 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 décembre 2013, sous le numéro 3185.

L'Assemblée est présidée par Mme Sofia Da Chao, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette,

Grand-Duché de Luxembourg (le Président).

Le Président nomme Mme Brigitte Martin, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Mme. Claudia Rouckert, employée privée,, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires
des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires

et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que dix mille (10.000) actions de la Société, sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital

social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée
et peut statuer sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation de la Fusion;
3. Approbation du rapport d'échange;
4. Date d'effet de la Fusion;
5. Renonciation aux (i) aux rapports des conseils d'administration sur le Projet Commun de Fusion prévus à l'article

265 de la Loi et (ii) à un examen du Projet Commun de Fusion par des experts indépendants et aux rapports prévus à
l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;

17835

L

U X E M B O U R G

6. Déclaration concernant les documents listés sous les points a) à c) au paragraphe 1 de l'article 267 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;

7. Déclaration concernant les résolutions d'associés sur la Fusion de la Société Absorbée;
8. Augmentation de capital;
9. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>1. Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>2. Deuxième résolution

L'Assemblée APROUVE (A) la fusion (la «Fusion») par absorption entre la Société comme société absorbante et

Carème Restaurants SàRL, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, Route Nationale 1, L-6776
Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B163967 (la «Société Absorbée» ensemble avec la Société les «Sociétés Fusionnantes») comme société
absorbée et (B) le projet commun de fusion documenté par acte du notaire instrumentant en date du 18 novembre 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 novembre 2013 sous le numéro 2959 (le «Projet
Commun de Fusion») et décide de procéder à la Fusion conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

<i>3. Troisième résolution

L'Assemblée ACTE et APPROUVE que le rapport d'échange des actions déterminé dans le Projet Commun de Fusion

et fixé à dix mille (10.000) actions de la Société Absorbée pour trois cent quatre-vingt-onze actions (391) de la Société.
Les associés de la Société Absorbée recevront en échange du transfert de l'universalité de patrimoine de la Société
Absorbée à la Société, trois cent quatre-vingt-onze (391) nouvelles actions nominatives sans valeur nominale (les «Nou-
velles Actions») dans la Société.

<i>4. Quatrième résolution

L'Assemblée ACTE et APPROUVE que la Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes d'un point de vue légal

à la date d'aujourd'hui à minuit (la «Date d'Effet»).

D'un point de vue comptable et fiscal, la Fusion sera effective à partir du 1 

er

 septembre 2013 à 00h01.

A partir de la Date d'Effet et conformément à l'article 274 de la Loi, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée

suite à sa dissolution sans liquidation, seront transférés de plein droit à la Société sans exception ni réserves. L'Assemblée
ACTE et APPROUVE que les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société à leur valeur nette
comptable.

<i>5. Cinquième résolution

L'Assemblée CONFIRME AVOIR ACCEPTE DE RENONCER (i) aux rapports des conseils d'administration sur le

Projet Commun de Fusion prévus à l'article 265 de la Loi et (ii) à un examen du Projet Commun de Fusion par des experts
indépendants et aux rapports prévus à l'article 266 de la Loi.

<i>6. Sixième résolution

L'Assemblée DECLARE que les documents listés sous les points a) à c) au paragraphe 1 de l'article 267 de la Loi ont

été mis à disposition des actionnaires de la Société pendant la durée requise.

<i>7. Septième résolution

L'Assemblée DECLARE que des résolutions d'associés ont déjà été prises aujourd'hui au niveau de la Société Absorbée

pour approuver la Fusion et le Projet Commun de Fusion avec effet à la Date d'Effet.

<i>8. Huitième résolution

Suite à l'apport de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société comme décrit ci-dessus et résultant de

la Fusion, l'Assemblée DECIDE d'AUGMENTER, avec effet à la Date d'Effet, le capital social de la Société d'un montant
de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) afin de l'élever de son montant actuel de trois cent dix-neuf mille cinq cent
soixante-treize euros (319.573 EUR) à trois cent trente deux mille et soixante-treize euros (332.073 EUR) par la création
et l'émission des Nouvelles Actions.

Les Nouvelles Actions sont entièrement souscrites et libérées par les actionnaires de la Société Absorbée conformé-

ment au rapport d'échange mentionné ci-dessus.

17836

L

U X E M B O U R G

<i>Rapport du réviseur concernant les actifs et passifs apportés suite à la Fusion

Monsieur Marco Claude, réviseur d'entreprises agréé (Grant Thornton Lux Audit S.A.), a établi en date du 30 décembre

2013, un rapport conformément à l'article 26-1 de la Loi, sur les méthodes d'évaluation utilisées et la description de tous
les actifs et passifs de la Société Absorbée à apporter suite à la Fusion. Ledit rapport qui restera ci - annexé, conclut
comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale de

l'apport ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie».

<i>9. Neuvième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée DECIDE d'AMENDER le premier paragraphe de l'article 5

des Statuts, qui devra désormais se lire comme suit:

«Le capital social est fixé à trois cent trente deux mille et soixante-treize euros (332.073 EUR) représenté par dix

mille trois cent quatre-vingt-onze (10.391) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément.

<i>Déclarations

Le notaire soussigné déclare qu'il est en mesure de vérifier et d'attester l'existence et la légalité des actes et formalités

incombant à la Société pour laquelle il acte ainsi que du projet commun de fusion.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Martin, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2014 Relation: EAC/2014/584. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014020293/118.
(140023062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2014.

Medtronic CV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 145.752.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 20 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 2 janvier 2014.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014002427/13.
(140001692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

DDN Architecte s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 17, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 184.193.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Damien DEFOIN, architecte, né à Ixelles, Belgique, le 4 mai 1967 et demeurant à B-1330 Rixensart, Belgique,

2, rue de la Chapelle.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DDN ARCHI-

TECTE s.à r.l.

17837

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. La Société a pour objet l'exploitation d'un bureau d'architecte.
La société peut exécuter toutes prestations consultatives, d'assistance, de contrôle, de direction, de coordination,

d'expertise et d'études dans le domaine de l'architecture.

Elle peut opérer tous les actes, transactions ou opérations se rapportant directement ou indirectement, en tout ou

en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou favoriser la réalisation, le développement et l'extension.

La société peut prendre des participations dans toutes sociétés dont l'objet est identique, similaire, connexe ou com-

plémentaire au sien.

Elle peut accorder des prêts et fournir une assistance financière sous toute forme aux sociétés dans lesquelles elle

participe.

Elle peut exercer toutes activités commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement

ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation sous réserve de l'alinéa qui suit.

La société DDN ARCHITECTE S.à r.l. s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et

porter atteinte à l'indépendance professionnelle de l'activité libérale d'architecte et elle s'engage à respecter toutes les
dispositions législatives et réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.

Art. 4. La Société commence le jour de la signature du présent acte et elle est constituée pour une durée illimitée.
De manière générale, la société pourra passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réali-

sation de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée
sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

17838

L

U X E M B O U R G

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent
Euros (EUR 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-

ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et

déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

<i>Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Damien DEFOIN préqualifié.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quatorze.

<i>Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-1750 Luxembourg, 12, Avenue Victor Hugo.
2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Damien DEFOIN, architecte, né à Ixelles, Belgique, le 4 mai

1967 et demeurant à B-1330 Rixensart, 2, rue de la Chapelle.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être

identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: D. DEFOIN, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 31 janvier 2014. Relation: CAP/2014/377. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 5 février 2014.

Référence de publication: 2014020707/111.
(140024227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Newfound Bay Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 140.424.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 23 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

17839

L

U X E M B O U R G

Mersch, le 6 janvier 2014.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014002479/13.
(140001733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Finbelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 77.948.

Son Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 82.424.

L'an deux mille quatorze, le trente janvier.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) FINBELUX S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.948, constituée suivant acte notarié en
date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 7 mars 2001.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 16 mars 2011, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1274 du 11 juin 2011.

2) SON HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.424, constituée sous la dénomi-
nation BOND INVESTMENTS N.V. suivant acte notarié en date du 27 janvier 1992, dont le siège social a été transféré
au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte notarié en date du 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1162 du 13 décembre 2001.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 30 décembre 2010,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1155 du 30 mai 2011.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Nicolas MONTAGNE, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue

Joseph Hackin,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administration des deux sociétés

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'Administration desdites sociétés en date du 27 janvier
2014.

Des extraits des résolutions des Conseils d’Administration, après avoir été paraphés ne varietur par le représentant

des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité
de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet

de fusion ci-après:

PROJET DE FUSION:

1) Les sociétés participant à la fusion:
FINBELUX S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.948, constituée suivant acte notarié en date
du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 7 mars 2001, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 16 mars 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1274 du 11 juin 2011;

comme société absorbante (ci-après "la Société Absorbante"),
et
SON HOLDING S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.424, constituée suivant acte notarié en
date du 27 janvier 1992, dont le siège social a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte notarié en date
du 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1162 du 13 décembre 2001, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 30 décembre 2010, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1155 du 30 mai 2011;

comme société absorbée (ci-après "la Société Absorbée").
2) La Société Absorbante détient 90.700 (quatre-vingt-dix mille sept cents) actions ayant une valeur nominale de EUR

10,00 (dix Euros) chacune, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de la Société Absorbée qui s’élève à EUR

17840

L

U X E M B O U R G

907.000,00 (neuf cent sept mille Euros) et conférant tous les droits de vote dans la Société Absorbée. Le capital social
de la Société Absorbée est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été
émis par la Société Absorbée.

3) La Société Absorbante entend absorber la Société Absorbée par voie de fusion par absorption conformément aux

articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LSC") en
neutralité fiscale.

4) La Société Absorbée et la Société Absorbante ne comptent ni d’actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs

de titres autres que des actions.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle

la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est considérée du point de vue juridique comme accomplie
entre parties est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées tant du point de vue comptable

que du point de vue fiscal comme accomplies pour compte de la Société Absorbante a été fixée également à un mois
après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes

les obligations de la Société Absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la Société Absorbante.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires des sociétés qui fusionnent.
9) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société
Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) LSC et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie
intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit

de la Société Absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la
convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion

de la Société Absorbante et la Société Absorbée deviendra définitive entre parties un mois après la publication du présent
projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article
274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’en-

semble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

b) la Société Absorbée cesse d’exister;
c) l’annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.
12) Décharge sera accordée aux administrateurs et aux commissaires de la Société Absorbée pour l’exécution de leur

mandat pour l’exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société

Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l’article

271 (2) LSC.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. MONTAGNE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2014. LAC/2014/4787. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014020778/101.
(140023861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2014.

Pamplona PE Holdco 6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 131.827.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

17841

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Référence de publication: 2014002520/10.
(140001904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Belron OPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.237.

In the year two thousand thirteen, on the eighteenth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Belron OPS S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée",

having its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B number
156.237, incorporated by deed on the 20 

th

 of October 2010, published in the Memorial C number 2575 of November

25 

th

 , 2010.

The meeting is presided by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairwoman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Fons MANGEN, Expert-Comptable,

residing in Ettelbruck.

The chairwoman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, all the one hundred and thousand (100.000) shares, representing the whole

capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

- Reduction of the issued share capital of the Company from one billion five hundred and ninety three million seven

hundred and fifty-nine thousand Euro (EUR 1,593,759,000) to one billion five hundred and eighty-two million one hundred
and twenty-six thousand Euro (EUR 1,582,126,000) by reduction of the nominal value of the shares of the Company from
fifteen thousand nine hundred and thirty-seven Euro and fifty-nine Euro cents (EUR 15,937.59) per share to fifteen thou-
sand eight hundred and twenty-one Euro and twenty-six Euro cents EUR 15,821.26) per share; payment of the amount
corresponding to the reduction of the nominal value of the shares to the sole shareholder; consequential amendment of
article 5 of the articles of incorporation of the Company.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution:

The meeting decides to decrease the share capital by an amount of eleven million six hundred thirty-three thousand

Euro (EUR 11,633,000), in order to bring it from its current amount of one billion five hundred and ninety three million
seven hundred and fifty-nine thousand Euro (EUR 1,593,759,000) to one billion five hundred and eighty-two million one
hundred and twenty-six thousand Euro (EUR 1,582,126,000), by way of reimbursement to the sole shareholder of an
amount of eleven million six hundred thirty-three thousand Euro (EUR 11,633,000) and by reduction of the nominal value
of the shares of the Company from fifteen thousand nine hundred and thirty-seven Euro and fifty-nine Euro cents (EUR
15,937.59) per share to fifteen thousand eight hundred and twenty-one Euro and twenty-six Euro cents (EUR 15,821.26)
per share.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments,

(to the nominal value reduction) and the shareholder's reimbursement.

Reimbursement delay: The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69

of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the
effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty)
days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

<i>Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend 5, paragraph 1 of the Articles of Incor-

poration to read as follows:

« Art. 5. First paragraph. The issued share capital of the Company is set at one billion five hundred eighty-two million

one hundred twenty-six thousand (EUR 1,582,126,000), divided into one hundred thousand (100,000) Shares with a par
value of fifteen thousand eight hundred twenty-one euros and twenty-six cents (EUR 15,821.26.-) each."

17842

L

U X E M B O U R G

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille treize, le dix-huit décembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Belron OPS S.à

r.l.», ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 156.237, constituée suivant acte reçu le 20 octobre 2010, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C numéro 2575 du 25 novembre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fons MANGEN, Expert-

Comptable, demeurant à Ettelbriick. La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les cent mille (100.000) parts sociales, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Réduction du capital social de la Société de un milliard cinq cent quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante-neuf

mille  Euro  (EUR  1,593,759,000)  à  un  milliard  cinq  cent  quatre-vingt-deux  millions  cent  vingt-six  mille  Euro  (EUR
1,582,126,000) par la réduction de la valeur nominale des parts sociales de la Société de quinze mille neuf cent trente-
sept euros et cinquante-neuf cents (EUR 15,937.59) par part sociale à quinze mille huit cent vingt et un euros et vingt-
six cents (EUR 15,821.26) par part sociale; paiement du montant correspondant à la réduction de la valeur nominale des
parts sociales à l'associé unique; modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de onze millions six cent trente-trois mille

euros (EUR 11.633.000.-), pour le ramener de son montant actuel de un milliard cinq cent quatre-vingt-treize millions
sept cent cinquante-neuf mille Euro (EUR 1,593,759,000) à un milliard cinq cent quatre-vingt-deux millions cent vingt-six
mille Euro (EUR 1,582,126,000), par remboursement à l'associé unique d'un montant de onze millions six cent trente-
trois mille euros (EUR 11.633.000.-), et par réduction de la valeur de chaque part sociale en la ramenant de quinze mille
neuf cent trente-sept euros et cinquante-neuf cents (EUR 15,937.59) par part sociale à quinze mille huit cent vingt et un
euros et vingt-six cents (EUR 15,821.26) par part sociale.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil de gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent (à la

réduction de la valeur nominale partout où il appartiendra) et au remboursement aux associés.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Alinéa 1 

er

 .  Le capital social émis de la Société est fixé à un milliard cinq cent quatre-vingt-deux millions

cent vingt-six mille Euro (EUR 1,582,126,000) divisé en cent mille (100.000) Parts sociales d'une valeur nominale de quinze
mille huit cent vingt et un euros et vingt-six cents (EUR 15,821.26) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

17843

L

U X E M B O U R G

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F.MANGEN, R.UHL, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58518. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2014000033/116.
(130223475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 31.682.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 23 décembre 2013, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2013, LAC/2013/60552, aux droits de soixante-
quinze  euros  (75.-  EUR),  que  la  société  anonyme  établie  à  Luxembourg  sous  la  dénomination  de  "COMPAGNIE
EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.H. (en liquidation)", R.C.S. Luxembourg numéro B 31682,
ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Me Maître Norbert MULLER, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 37 du 31 janvier 1990.

Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les livres et documents de la société resteront conserver pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation

auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005935/21.
(140006432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Batir Mon Habitation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 100.338.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s'est tenue à Luxembourg, le

<i>08.11.2013 et lors de laquelle l'administrateur délégué a été chargé de faire enregistrer et publier les décisions suivantes:

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur suivant:
Monsieur Christian DAUBENFELD, né le 18/10/1966 à GREVENMACHER, demeurant à 6, rue des Ecoles L-3461

DUDELANGE

Est nommé comme nouvel administrateur pour une durée de six ans:
Madame PETRY Marie Josée, née le 21/03/1958 à ETTELBRUCK, demeurant à L-8387 KOERICH, 15, Cité um Boe-

schen

Le mandat des administrateurs:
Monsieur RISCH Christophe, né le 14/09/1986 à LUXEMBOURG, demeurant à L-8387 KOERICH, 15 Cité um Boe-

schen

et
Monsieur RISCH Philippe, né le 01/03/1952 à NIEDERFEULEN demeurant à L-8325 CAPELLEN, 58, rue de la Gare
ont été prolongés pour une durée de 6 ans
Le mandat de l'administrateur délégué:
Monsieur RISCH Philippe, né le 01/03/1952 à NIEDERFEULEN, demeurant à L-8325 CAPELLEN, 58, rue de la Gare
a été prolongé pour une durée de 6 ans
Le mandat du commissaire aux comptes:
EUROFISC S.A. inscrit aux registre de commerce sous le numéro B 42577, avec siège social à L-1880 Luxembourg,

69, rue Pierre Krier

17844

L

U X E M B O U R G

a été prolongé pour une durée de 6 ans
Le siège social de la société est transféré de 204, route d'Arlon L-8070 STRASSEN à 204, route d'Arlon L-8010

STRASSEN

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Philippe RISCH
<i>L'administrateur délégué

Référence de publication: 2014005859/33.
(140005911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Chasselas Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 77.076.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 janvier 2014.

Démission de Monsieur Reinald Loutsch en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014005920/13.
(140005903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

CODINTER S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 15.317.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2013 a reconduit le mandat d'administrateur de:
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
- Monsieur Nico BECKER, administrateur de sociétés, demeurant à L-6139 Junglinster;
- Madame Nathalie THUNUS, administrateur de sociétés, demeurant à B-6780 Messancy, 132, route d'Arlon;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2016.
L'Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire de Monsieur Guy SCHOSSELER, expert-comptable,

dont l'adresse professionnelle est à L-2546 Luxembourg, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire
annuelle de 2016.

Pour extrait conforme
CODINTER S.A.
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme

Référence de publication: 2014005928/21.
(140006154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Tiger Holding Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 136.045.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67988 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014002659/10.
(140001244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

17845

L

U X E M B O U R G

Proprio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 85.960.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Référence de publication: 2014002533/10.
(140001888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

aeris CAPITAL Blue Ocean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 320.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 150.267.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
fand die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (die „Generalversammlung") der aeris CAPITAL

Blue Ocean S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend
nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx am 11.
Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 196 vom 29. Januar 2010, letztmalig abgeändert gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, vorbenannt, vom 10. Oktober 2012, und mit Gesellschaftssitz in 2, rue
Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer
B 150267 statt.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Christoph Junk, Privatangestellter, beruflich ansässig in Lu-

xemburg,

welcher Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Protokollführerin bestellt.
Die Generalversammlung bestellt Frau Karolina Richard, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zur Stim-

menzählerin.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis der Gesellschafter beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den

Gesellschaftern bzw. deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, der Protokollführerin, der Stimmenzählerin und
dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde „ne varietur" para-

phiert beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Sämtliche dreitausend zweihundert (3 200) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, sind in ge-

genwärtiger  Generalversammlung  vertreten.  Die  so  anwesenden  Gesellschafter  erklären  sich  ordnungsgemäß  zu  der
gegenwärtigen Versammlung eingeladen und verzichten auf die Einhaltung weiterer Förmlichkeiten. Somit ist gegenwärtige
Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
- Verlegung des Gesellschaftssitzes von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg nach 1c, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2013;

- Entsprechende Abänderung des Artikels 4 Satz 1 der Satzung in der deutschen und englischen Version.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

<i>1. Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c,

rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, mit Wirkung ab dem 1. Dezember 2013 zu verlegen.

<i>2. Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 4 Satz 1 der deutschen und englischen Version der Gesellschaftssatzung

abzuändern, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

Bisheriger Artikel 4 Satz 1 in der englischen Version:

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg."
Neuer Artikel 4 Satz 1 in der englischen Version:

17846

L

U X E M B O U R G

"  Art. 4.  The  registered  office  of  the  Company  is  established  in  the  municipality  of  Schuttrange,  Grand-Duchy  of

Luxembourg."

Bisheriger Artikel 4 Satz 1 in der deutschen Version:

„ Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg."
Neuer Artikel 4 Satz 1 in der deutschen Version:

„ Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg."
Die übrigen Passagen der Gesellschaftssatzung bleiben unberührt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgeschehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch

Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. JUNK, A. SIEBENALER, K. RICHARD und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59457. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 8. Januar 2014.

Référence de publication: 2014004018/64.
(140003913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

COMPANY Consulting S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 180.781.

La convention de domiciliation du siège social de la société anonyme COMPANY Consulting, inscrite au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180781 sis à L-1660 Luxembourg, 70, Grand- Rue, conclue
le 7 octobre 2013, avec le domiciliataire Etude Hellal &amp; Lahorgue, a été dénoncée le 27 novembre 2013 avec effet immédiat.

Le 27 novembre 2013.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014005938/11.
(140005948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Adeo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52A, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 173.213.

Suite à une cession de parts sociales intervenue le 6 janvier 2014, Monsieur Guy COLSOUL, demeurant à B-5310

Eghezée, Place de Taviers, 52, est devenu propriétaire de la totalité des cent (100) parts sociales de la société à respon-
sabilité Adeo s.à r.l..

Steinfort, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005798/11.
(140005800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Dynasty Holdings S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 156.785.

Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce de Luxembourg que la société Dynasty Holdings S.A, enre-

gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156 785 n'est plus domiciliée chez
SGG S.A. au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg depuis le 12 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2013.

Référence de publication: 2014005959/11.
(140006367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

17847

L

U X E M B O U R G

Financière Berlaimont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 169.607.

Le siège social de la société a été transféré au L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014006025/11.
(140006586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Cypress Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 183.096.

By resolution of the sole shareholder dated 6 

th

 January 2014, in replacement of Mr Pascal Carasso who has resigned,

a new manager of the Company has been appointed with immediate effect:

Mr Kamran Abbas-Vahid, born on 15 

th

 June 1973 in Neuilly-sur-Seine (France), residing professionally at 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg.

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Par résolutions de l'associé unique en date du 6 janvier 2014, en remplacement de Mr Pascal Carasso démissionnaire,

un nouveau gérant de la Société a été nommé avec effet immédiat:

Mr Kamran Abbas-Vahid, né le 15 juin 1973 à Neuilly-sur-Seine (France), résidant professionnellement à 6A route de

Trèves, L-2633 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005949/18.
(140006116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Corporate and Technological Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 78.003.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 23 décembre 2013

<i>au 55-57, rue de Merl L-2146 Luxembourg

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du

23 décembre 2013 au 55-57, rue de Merl L-2146 Luxembourg que:

<i>«Première résolution:

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 2a Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg au 55-57 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution:

L'Assemblée prend note du changement d'adresse professionnelle de Maître Mario DI STEFANO en qualité de liqui-

dateur de la Société du 2a, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 55-57, rue de Merl L-2146 Luxembourg.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014005944/22.
(140006051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

17848

L

U X E M B O U R G

Cablux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 144, Millewé.

R.C.S. Luxembourg B 81.990.

<i>Assemblée générale ordinaire du 23/04/2013 extrait des résolutions

1) Renouvellement du mandat d'administrateur de Mesdames Corinne NICOLODI et Nathalie NICOLAS et de Mes-

sieurs Jean-Marc NICOLODI et Didier NICOLAS, jusqu'à l'assemblé générale qui se tiendra en l'année 2019.

2) Monsieur Didier NICOLAS est nommé Président du conseil d'administration.
3) Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Paul GRANGIER jusqu'à l'assemblée générale

qui se tiendra en 2019

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014005902/14.
(140006238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

European Sporting Goods Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.598.627,60.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 71.714.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé BRIDGEPOINT CAPITAL (NO-

MINEES) LIMITED, au 95, Wigmore Street, Londres, W1U 1FB, Royaume-Uni, et ce avec effet au 16 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014006018/14.
(140005814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Financière Bozo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 152.041.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 janvier 2014

L'assemblée, après lecture des lettres de démission de leur fonction d'administrateur de:
- Monsieur Leonardo MIOCCHI, résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-

bourg,

- Monsieur Alfio RICIPUTO, résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg

et

- Monsieur Sébastien SCHAACK, résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-

bourg,

décide d'accepter leur démission avec effet au 31 décembre 2013.
L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, avec effet au 31 décembre 2013:
- Madame Emmanuelle BRULE, née le 21 juin 1978 à Châtellerault (France), résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Madame Gaëlle KWIATKOWSKI, née le 14 juillet 1982 à Thionville (France), résidant professionnellement au 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg;

- Monsieur Dominique AUDIA, née le 16 mars 1965 à Metz (France), résidant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg;

leur mandat ayant la même échéance que celle de leurs prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

17849

L

U X E M B O U R G

FINANCIERE BOZO S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014006026/28.
(140006614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Deldeg Multi-Projects S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 128.324.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juillet 2013

L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire les mandats d'Administrateurs de M. Pierre Delandmeter, Mme Bé-

nédicte Degeest et M. Yannick Deschamps ainsi que le mandat de Commissaire aux comptes de la Fiduciaire Vincent la
Mendola jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014005964/12.
(140005881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Comptabilité, Fiscalité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 84.531.

Aux fins de mise à jour des données actuellement reprises au Registre de Commerce et des Sociétés concernant la

société, le gérant souhaite informer toute personne intéressée du fait suivant:

Monsieur Philippe Lambert, gérant de la société, demeure désormais à L-8362 Grass, 6, Rue des Champs.

<i>Pour la Gérance
Signatures

Référence de publication: 2014005899/12.
(140006403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

CityDent s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.372.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage. en date

du 16 décembre 2013, numéro 2013/2619 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 24 décembre 2013, relation: CAP/
2013/4936 de la société à responsabilité limitée "CityDent s.à r.l.", avec siège social à L-2560 Luxembourg. 48-50, rue de
Strasbourg, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 125 372, constituée suivant acte reçu par Maître Alex
WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 12 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 931 du 21 mai 2007,
ce qui suit:

- Monsieur Claude FISCHER, préqualifié, seul associé, a déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société

prédite, avec effet au 16 décembre 2013,

- la société dissoute n'a plus d'activités.
- l'associé a déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'il assume tous les éléments

actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse

suivante: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

Bascharage, le 7 janvier 2014.

Pour extrait conforme
Alex WEBER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2014005895/26.
(140006548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

17850

L

U X E M B O U R G

BI-Invest Compartment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.120.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé en date du 31 décembre 2013 de nommer:
- Monsieur Rohan Maxwell, né le 11 novembre 1977 à Tameside (Royaume-Uni), résidant professionnellement au 5,

via Nassa, CH-6900 Lugano (Suisse), en tant que gérant de la Société avec effet au 2 janvier 2014 et ce, pour une durée
illimitée.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2014005865/16.
(140006189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Evasion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 60.

R.C.S. Luxembourg B 170.592.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 06 janvier 2014:
1) L'intégralité du capital social est représentée.
2) Suite aux cessions de parts sociales intervenues en dates du 22 novembre 2013 et du 27 décembre 2013, Monsieur

Fabien VALLETTE et Monsieur Pascal VANDORSELAER ont cédé l'entièreté de leurs parts sociales de la société (soit
42 parts chacun) à Monsieur Jérôme VINCENT, domicilié Maison 60a à L-9956 HACHIVILLE.

Le capital est donc représenté de la manière suivante:

Monsieur Jérôme VINCENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 parts / 126 parts

3) L'Assemblée Générale accepte les démissions de Messieurs VALLETTE Fabien et VANDORSELAER Pascal de leurs

postes de gérants.

4) L'Assemblée Générale prend connaissance du nouveau domicile de Monsieur Jérôme VINCENT, gérant de la société:

Maison 60a à L-9956 HACHIVILLE.

Fait à Hachiville, le 06 janvier 2014.

<i>Pour la société EVASION S.à R.L.
J. VINCENT
<i>Gérant

Référence de publication: 2014006020/22.
(140006651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Danama Films, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 148.956.

La soussignée United International Management S.A., R.C.S. Luxembourg B 142.022 a dénoncé le siège social de la

société à responsabilité limitée DANAMA FILMS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 148.956, établi en ses locaux au 5, Avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Cette dénonciation prend effet au 1 

er

 janvier 2014.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014005961/12.
(140005843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

17851

L

U X E M B O U R G

Hondsschoul Um Bierg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 7, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 132.018.

DISSOLUTION

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Madame Josette HILBERT, commerçante, née à Ettelbruck le 5 août 1954 (matricule 1954 08 05 140), demeurant à

L-7465 Nommern, 7, Rue Principale.

Laquelle comparante, agissant en qualité d’associée unique représentant l’intégralité du capital social, a déclaré et a

requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. la société à responsabilité limitée HONDSSCHOUL UM BIERG SARL (matricule 2007 2448 252), avec siège social

à L-7465 Nommern, 7, Rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 132.018, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2440 du 27 octobre 2007.

II. le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €) divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune, entièrement souscrit et libéré.

L’associée représentant l’intégralité du capital social déclare:
III. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. que ladite société a cessé toute activité commerciale.
V. Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, la partie comparante prononce

la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

VI. Elle se désigne comme liquidateur de la société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de

la société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et qu'enfin, par
rapport à un éventuel passif de la société actuellement inconnu et donc non encore payé, elle assume irrévocablement
l'obligation de le payer de sorte que tout le passif de la société est réglé.

VII. L'actif restant éventuel sera attribué à l’associé.
VIII. La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée et l’annulation du registre des actionnaires

et des actions est prononcée.

IX. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par l’associé au gérant de la Société

pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

X. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l’adresse privée de l’associé.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cents euros (700,00 €).

<i>Déclaration

L’associé déclare que les fonds de la société ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux articles

506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'elle connue à la comparante, connue du notaire

instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Josette HILBERT, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2013. Relation: DIE/2013/15847. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

<i>Le Receveur (signé): pd Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014004458/51.
(140004127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

17852

L

U X E M B O U R G

RM Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 76.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014005643/13.
(140004793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Psoriaid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 52.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014005627/10.
(140005151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Transvialux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 176.341.

Je viens par la présente vous informer de ma démission de mon mandat de gérant technique au sein de l'entreprise

Transvialux.

Elvange, le 10 janvier 2013.

Niacadie Olivier.

Référence de publication: 2014005725/10.
(140005658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Transcar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 10, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 115.935.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005723/9.
(140005289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Tea Properties S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 110.577.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Septembre 2013.

TEA PROPERTIES S.à r.l.
Christelle Ferry
<i>Gérante

Référence de publication: 2014005702/14.
(140005561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

17853

L

U X E M B O U R G

Te Ora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 140.840.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 décembre 2013, les actionnaires ont pris les décisions

suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Bernard Herman, Administrateur A, avec adresse professionnelle au 10, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Jean Van Der Speck, Administrateur A, avec adresse professionnelle au 10, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Manfred Schneider, Administrateur B, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 octobre 2019 et qui se tiendra en 2019;

2. Suite à une fusion par absorption et un changement de dénomination, le commissaire aux comptes est Alter Domus

Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, son mandat est renouvelé pour une
période arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se
clôturant au 31 octobre 2019 et qui se tiendra en 2019;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005712/21.
(140005112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

River Melody Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 155.791.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Septembre 2013.

RIVER MELODY S.à r.l.
Christelle Ferry
<i>Gérante

Référence de publication: 2014005634/14.
(140004949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Toyama Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 147.864.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005722/9.
(140004818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Tilo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 63.003.

Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014005719/11.
(140005488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

17854

L

U X E M B O U R G

L.A. Invest SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg E 4.864.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Luigi MANDERSCHEID, indépendant, demeurant à L-2111 Luxembourg, 12, rue Guillaume de Machault.
2.- Monsieur Andrea MURGIA, indépendant, demeurant à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Mariette SCHOU, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-6475 Echternach, 9 Rabatt,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 16 décembre 2013 respectivement 17 décembre

2013,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société civile immobilière L.A. INVEST SCI, avec siège social à L-1463 Luxembourg,

21, rue du Fort Elisabeth, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E 4.864 (NIN
2012 7002 216).

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 août 2012 publié au

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2434 du 29 septembre 2012.

III.- Que le capital social de la société s'élève à mille Euros (€ 1.000.-), représenté par cent (100) parts sociales de dix

Euros (€ 10.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Luigi MANDERSCHEID, indépendant, demeurant à L- 2111 Luxembourg,
12, rue Guillaume de Machault, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Andrea MURGIA, indépendant, demeurant à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
V.- Que la société civile immobilière L.A. INVEST SCI n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature

qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, les comparants, représentés comme dit ci-avant décident de dissoudre la société

civile immobilière L.A. INVEST SCI.

En conséquence de cette dissolution, les associés, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateurs de la

société, déclarent que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et tout le passif de la société civile immobilière L.A. Invest SCI a été réglé

et qu'ils demeureront responsables, au prorata de leur participation dans le capital social, de toutes dettes et de tous
engagements financiers éventuels, présentement inconnus, de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront
de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée et est à considérer comme faite et clôturée;
- décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société pour l'exercice de leur fonction;
- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante:

L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes;

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2491. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

17855

L

U X E M B O U R G

Echternach, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182637/57.
(130222866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Inventif S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 52.910.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société anonyme INVENTIF
S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, Boulevard du Prince Henri, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
<i>Le liquidateur
2 avenue du X septembre
L-2550 Luxembourg

Référence de publication: 2014006463/17.
(140006805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Euro-Bâtiments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 20, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 95.706.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement en date du 11 décembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme EURO-BATIMENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-8832 ROMBACH, 20, route de

Bigonville, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 95706;

Le même jugement ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Claude WIRTH, juge près le Tribunal d'Arrondisse-

ment de et à Diekirch et liquidateur Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Ils ordonnent aux créanciers de faire leur déclaration de créances au greffe du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch.

Pour extrait conforme
Raphaël SCHWEITZER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH

Référence de publication: 2014006454/21.
(140006559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

11 Invest, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 167.948.

Nous, agent domiciliataire de la société 11 INVEST (R.C.S. Luxembourg B 167948) déclarons par la présente, la dé-

nonciation du siège, 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg de la dite société, avec effet au 7 janvier 2014,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
ABAX TRUST

Référence de publication: 2014006426/11.
(140006278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

17856


Document Outline

11 Invest

Adeo s.à r.l.

aeris CAPITAL Blue Ocean S.à r.l.

Batir Mon Habitation S.A.

Belron OPS S.à r.l.

BI-Invest Compartment S. à r.l.

Cablux S.A.

Chasselas Investissements S.A.

CityDent s.à r.l.

CODINTER S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

Coeli SICAV I

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H.

COMPANY Consulting S.A.

Comptabilité, Fiscalité S.à r.l.

Corporate and Technological Investments Holding S.A.

CWEI (Europe) S.A.

CWEI (Luxembourg) Investment Management S.à r.l.

Cypress Services S.à r.l.

Danama Films, S.à r.l.

DDN Architecte s.à r.l.

Deldeg Multi-Projects S.A.

Dennemeyer Trust

Dynasty Holdings S.A.

Edge II Holding S.à r.l.

Euro-Bâtiments S.A.

European Sporting Goods Sàrl

Evasion

Financière Berlaimont S.à r.l.

Financière Bozo S.A.

Finbelux S.A.

Hondsschoul Um Bierg Sàrl

Inventif S.A.

Knightrider S.à r.l.

L.A. Invest SCI

La Varenne Group S.A.

Medtronic CV Luxembourg S.à r.l.

Meridian Group Investments S.à r.l.

Newfound Bay Limited

Pamplona PE Holdco 6 S.A.

Potsdamer 180-184 S.à r.l.

Proprio S.A.

Psoriaid S.A.

River Melody Sàrl

RM Properties S.C.A.

Son Holding S.A.

Tea Properties S.à.r.l.

Te Ora S.A.

Tiger Holding Five S.à r.l.

Tilo S.A.

Toyama Financial Services S.A.

Transcar S.à r.l.

Transvialux S.à r.l.