logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 293

1

er

 février 2014

SOMMAIRE

Ametos SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14024

Baffo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14063

Barlanto Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

14018

Becht s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14064

BIOCARDEL Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

14064

Boss Concept IPC Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . .

14026

BZ Fine Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14027

Cameron Lux III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14032

Clarihen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14063

Claxon Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14063

DJE Lux Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14028

Duomos Investment Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14053

Ellipse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14024

Ember VRM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14058

Figae Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14028

Fonds Direkt Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14029

FondsSelector SMR Sicav  . . . . . . . . . . . . . . .

14027

Glendevon King Global Fund SICAV-SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14062

Goodman Industrial Real Estate Germany

I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14061

G&P Invest Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14031

Henneaux Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

14061

Hilconstruct S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14060

Hosco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14061

Hosco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14062

Hotel Moris S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14063

Iason Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14062

I.E.T.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14063

Immobilière Mamer Concept  . . . . . . . . . . .

14062

Intfideco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14032

Lacuna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14031

MB Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14049

Mediterranée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14025

Monteland Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

14018

Multiadvisor Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14038

Novamil Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14026

Pro Fonds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14038

PVV SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14039

Raiba Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14025

Serrano S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14025

Seven Lux Sicav-Sif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14040

Shire Luxembourg Finance S.à r.l.  . . . . . . .

14047

WE Finance and Services (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14029

Widriss International S.A., SPF . . . . . . . . . .

14039

YAPITAL Financial A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . .

14064

14017

L

U X E M B O U R G

Barlanto Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.236.950,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.073.

Monteland Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.188.150,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.074.

DRAFT TERMS OF MERGER

This merger is to be carried out by way of absorption of the Company Ceasing to Exist by its sister company, the

Absorbing Company. The Company Ceasing to Exist shall be referred together with the Absorbing Company as the
Merging Companies.

The board of managers of Barlanto Holding S.à r.l. and of Monteland Holding S.à r.l. have decided to draw up the

following draft terms of the merger in accordance with the provisions of article 261 and seq. of the law of August 10,
1915 on commercial companies, as amended (the Law).

1. Description of the contemplated merger. The board of managers of the Merging Companies propose to carry out

a merger which will imply the transfer of all assets and liabilities of the Company Ceasing To Exist to the Absorbing
Company, in accordance with the provisions of articles 259 and 274 of the Law (the Merger).

The Merging Companies belong to the same group of companies and the contemplated Merger is part of an internal

restructuring of the group aiming at realigning the activities and streamlining the group structure.

The Absorbing Company and the Company Ceasing to Exist are both fully owned by the same shareholders, i.e. Mr

Carlos Francisco Aremayo and Ms Josefa Baeza Hernandez.

The Merger will be carried out on the basis of the latest available annual accounts of the Merging Companies established

as per December 31, 2012 (the Annual Accounts).

The board of managers of the Merging Companies mutually undertake to take all required steps in order to carry out

the Merger, in accordance with the conditions detailed hereafter and set out, hereby, in these draft terms of Merger.

In accordance with article 272 of the Law, the Merger will take effect between the Merging Companies when the

concurring decisions of said companies shall have been adopted, i.e. on the date of the last general meeting of the sha-
reholders of the Merging Companies approving the proposed Merger (the Effective Date).

The Merger shall only take effect towards third parties after the publication of the minutes of the general meetings of

shareholders of each of the Merging Companies, in accordance with article 9 and article 273 (1) of the Law.

2. Information provided under article 261 (2) of the Law.
a) Type of legal entity, name and registered office of the Merging Companies.
- The Absorbing Company
Barlanto Holding S.à r.l. is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and orga-

nized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, has its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
under number B 114.073 and has a share capital of EUR 4,236,950 (four million two hundred thirty six thousand nine
hundred fifty euro).

The Absorbing Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a

deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 25, 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° 861 of May 2, 2006.

The articles of association of the Absorbing Company have been amended for the last time pursuant to a deed of

Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 17, 2009, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° 2176 of November 6, 2009.

- The Company Ceasing To Exist
Monteland Holding S.à r.l. is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, has its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is registered with the Register of Commerce and Companies of
Luxembourg under number B 114.074 and has a share capital of EUR 6,188,150 (six million one hundred eighty eight
thousand one hundred fifty euro).

The Company Ceasing To Exist has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant

to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 25,
2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° 864 of May 3, 2006.

14018

L

U X E M B O U R G

The articles of association of the Company Ceasing To Exist have been amended for the last time pursuant to a deed

of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 17, 2009,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° 2176 of November 6, 2009.

b) Share exchange ratio
1) The Absorbing Company
The subscribed share capital of the Absorbing Company is set at EUR 4,236,950 (four million two hundred thirty-six

thousand nine hundred fifty euro) consisting of 169,478 {one hundred sixty-nine thousand four hundred seventy-eight)
shares in registered form, having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, ail subscribed and fully paid-up.

Carlos Francisco Aremayo holds 50% (fifty percent) of the shares of the Absorbing Company, i.e. 84,739 (eighty-four

thousand seven hundred thirty-nine) shares.

Josefa Baeza Hernandez holds 50% (fifty percent) of the shares of the Absorbing Company, i.e. 84,739 (eighty-four

thousand seven hundred thirty-nine) shares.

2) The Company Ceasing To Exist
The subscribed share capital of the Company Ceasing To Exist is set at EUR 6,188,150 (six million one hundred eighty

eight thousand one hundred fifty euro) consisting of 247,526 (two hundred forty seven thousand five hundred twenty
six) shares in registered form, having a par value of EUR 25 (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid-up.

Carlos Francisco Aremayo holds 50% (fifty percent) of the shares of the Company Ceasing to Exist, i.e. 123,763 (one

hundred twenty-three thousand seven hundred sixty-three) shares.

Josefa Baeza Hernandez holds 50% (fifty percent) of the shares of the Company Ceasing to Exist, i.e. 123,763 (one

hundred twenty-three thousand seven hundred sixty three) shares.

3) The share exchange ratio
In exchange for the contribution of all assets and liabilities of the Company Ceasing To Exist, the Absorbing Company

will increase its share capital by an amount of EUR 3,050.- (three thousand and fifty euro) so as to raise it from its present
amount of EUR 4,236,950 {four million two hundred thirty six thousand nine hundred fifty euro) to EUR 4,240,000 (four
million two hundred forty thousand euro) through the issuance of 122 (one hundred twenty two) new shares having a
nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each, of the same kind and carrying the same rights and obligations as the
existing shares of the Absorbing Company.

The newly issued shares of the Absorbing Company will be entirely allocated as follows to the shareholders of the

Company Ceasing To Exist:

a) sixty-one shares (61) shares to Mr Carlos Francisco Aremayo; and
b) sixty-one shares (61) shares to Ms Josefa Baeza Hernandez.
The articles of association of the Absorbing Company dealing with its share capital and the shares in issuance will be

amended accordingly.

On the basis of the above share exchange ratio, an amount of EUR 4,467,374.29 (four million four hundred sixty seven

thousand three hundred seventy four euro and twenty-nine euro cent) representing the merger premium (i.e. the diffe-
rence between the par value of the newly issued shares of the Absorbing Company and the book value of the Company
Ceasing To Exist as per the Annual Accounts) shall be recorded as merger premium in the accounts of the Absorbing
Company.

No cash payment will be granted to the shareholder of the Company Ceasing To Exist.
The above share exchange ratio has been conventionally determined by the board of managers of the Merging Com-

panies, based on the following elements:

- the shareholders of the Merging Companies are the same;
- the shareholding of the Merging Companies is proportional, namely each of the shareholders of the Company Ceasing

to Exist holds exactly the same percentage of the share capital of the Acquiring Company; and

- given the fact that the shareholding in both Merging Companies is and shall be identical, before and after the Merger

there is no risk of creating a dilution that would be detrimental to any shareholder of the Merging Companies.

c) Terms for the delivery of the shares in the Absorbing Company
The newly issued shares will be registered in the shareholder register of the Absorbing Company as of the Effective

Date of the Merger.

As a result of the Merger, the Company Ceasing To Exist shall cease to exist and all its shares in issue will be cancelled.
d) Date as of which the newly issued shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition

regarding such right

The newly issued shares will entitle its holders to participate in the profits of the Absorbing Company as from the

Effective Date of the Merger and, from that date onwards, such holders acquire all rights attached to these shares, including
the right to dividends, or any other distribution, to be distributed out of the profit of the current accounting period and/
or out of the accumulated reserves and carried forward profits or otherwise. This right is not subject to any special
condition.

14019

L

U X E M B O U R G

e) Date as of which the operations of the Company Ceasing To Exist shall be treated, for accounting purposes, as

being carried out on behalf of the Absorbing Company

The operations of the Company Ceasing To Exist shall be treated, for accounting purposes, as being carried out on

behalf of the Absorbing Company as from January 1, 2014.

f) Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to holders of securities other

than shares

All shares of the Company Ceasing to Exist are identical and confer the same rights and advantages to their holder so

that no special rights and no compensations will be granted at the expense of the Absorbing Company to anyone.

No guarantee or measures will be granted or taken by the Absorbing Company.
g) Special benefits granted to the experts referred to in article 266 of the taw, to the members of the board of managers

of the Merging Companies and to any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of the Law.

Neither the experts referred to in article 266 of the Law, if any, nor the members of the board of managers of the

Merging Companies and any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of the Law, shall be entitled to receive
any special benefits in connection with or as a result of the Merger.

3. Consequences of the Merger.
3.1 The Merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law and in particular, as a result

of the Merger, the Company Ceasing To Exist shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

3.2 Subject to the provisions of Article 274 (2) of the Law with respect to the enforceability vis-à-vis third parties, the

Absorbing Company will become the owner of the assets contributed by the Company Ceasing To Exist as they exist on
the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Company Ceasing To Exist.

3.3 The Absorbing Company shall pay, as of the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance

premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.

3.4 As of the Effective Date, the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the

Company Ceasing To Exist.

3.5 The rights and claims comprised in the assets of the Company Ceasing To Exist shall be transferred to the Absorbing

Company with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be
subrogated, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Company Ceasing To Exist with respect
to all assets and against all debtors without any exception.

3.6  The  Absorbing  Company  shall  incur  all  debts  and  liabilities  of  any  kind  of  the  Company  Ceasing  To  Exist.  In

particular, it shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Company Ceasing To
Exist.

3.7 All corporate documents of the Company Ceasing To Exist shall be kept at the registered office of the Absorbing

Company for as long as prescribed by the Law.

3.8 The mandates of the members of the board of managers of the Company Ceasing To Exist will be terminated on

the Effective Date of the Merger. Full discharge will be given to the members of the board of managers for the performance
of their respective mandates.

3.9 The mandates of the members of the board of managers of the Absorbing Company will not be affected by the

Merger.

4. Additional provisions.
4.1 The cost of the Merger will be incurred by the Absorbing Company.
4.2 The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the Merger in accordance

with the legal and statutory requirements of both Merging Companies.

4.3 The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger

as well as the transfer of all assets and liabilities of the Company Ceasing To Exist to the Absorbing Company.

4.4 Pursuant to article 267 of the Law, the shareholders of the Merging Companies shall be entitled to inspect the

applicable following documents at the registered office of the said companies, at least one month before the date of the
general meetings of the shareholder to be called to decide on the terms of the Merger:

- the draft terms of the Merger;
- the Annual Accounts for the last three financial years, if any;
- where appropriate, an accounting statement drawn up as at a date which must not be earlier than the first day of

the third month preceding the date of the joint draft terms of merger, if the last annual accounts relate to a financial year
which ended more than six months before that date,

- where appropriate, the reports of the administrative or management bodies of the merging companies referred to

in Article 265 of the Law; and

- where applicable, the reports referred to in Article 266 of the Law;
A copy of the applicable above mentioned documents will be granted free of charge upon request.

14020

L

U X E M B O U R G

4.5 The present document has been drawn up in Luxembourg on January 17, 2014, in two originals, in order to be

registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to be published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations, at least one month prior to the date of the general meetings of the shareholder of each
of the Merging Companies to be called to decide on the terms of the Merger, in accordance with article 262 of the Law.

4.6 The present document is worded in English followed by a French translation. In case of discrepancies between the

English and the French versions, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Cette fusion est à réaliser par absorption de la Société Absorbée par sa société soeur, la Société Absorbante. La

Société Absorbée et la Société Absorbante sont dénommées ci-après les Sociétés qui Fusionnent).

Le conseil de gérance de Barlanto Holding S.à r.l. et le conseil de gérance de Monteland Holding S.à r.l. ont décidé par

les présentes d'établir ce projet commun de fusion, conformément aux dispositions des articles 261 et suivants de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

1 Description de la fusion envisagée. Le conseil de gérance des Sociétés qui Fusionnent proposent de réaliser une

fusion qui entraînera le transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante en conformité
avec les dispositions de l'article 259 et 274 de la Loi (la Fusion).

Les Sociétés qui Fusionnent appartiennent au même groupe de sociétés, la Fusion étant considérée comme une res-

tructuration interne dudit groupe ayant pour but de réaligner les activités et simplifier la structure du groupe.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont entièrement détenues par les mêmes actionnaires étant M. Carlos

Francisco Aremayo and Mme Josefa Baeza Hernandez.

La Fusion se réalisera sur la base des derniers comptes annuels disponibles des Société qui Fusionnent, établis à la date

du 31 décembre 2012 (les Comptes Annuels).

Le conseil de gérance de chacune des Sociétés qui Fusionnent décident mutuellement d'entreprendre toutes les étapes

nécessaires à la réalisation de la Fusion, conformément aux conditions détaillées ci-après et établies dans le présent projet
de Fusion.

Conformément à l'article 272 de la loi, la Fusion prendra effet entre la Société Absorbée et ta Société Absorbante

lorsque les décisions concordantes desdites sociétés auront été adoptées, c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée
générale des actionnaires des Sociétés qui Fusionnent approuvant le projet de Fusion (la Date de Prise d'Effet).

La Fusion prendra seulement effet envers les tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des

actionnaires des Sociétés qui Fusionnent, conformément aux l'article 9 et article 273 (1) de la Loi.

2. Informations fournies par l'article 261 (2) de la Loi.
a) Type de personne morale, dénomination sociale et siège social des Sociétés qui Fusionnent
- La Société Absorbante
Barlanto Holding S.à r.l. est une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles De Gaulle, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et elle est
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.073 et a un capital social
de EUR 4.236.950 (quatre millions deux cent trente-six mille neuf cent cinquante euros).

La Société Absorbante a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg I suivant un acte notarié de

Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 Janvier 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 861 du 2 mai 2006.

Les statuts de la Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 septembre 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2176 du 6 novembre 2009.

- La Société Absorbée
Barlanto Holding S.à r.l. est une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles De Gaulle, Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg et elle est
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.074 et a un capital social
de EUR 6.188.150 (six millions cent quatre-vingt-huit mille cent cinquante euros).

La Société Absorbée a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte notarié de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 Janvier 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 864 du 3 mai 2006.

Les statuts de la Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 septembre 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2176 du 6 novembre 2009.

b) Rapport d'échange des actions/actions
1) La Société Absorbante

14021

L

U X E M B O U R G

Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à EUR 4.236.950 (quatre millions deux cent trente-six mille

neuf cent cinquante euros) composé de 169.478 (cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-dix-huit) actions sous
forme nominatives ayant une valeur nominal de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

Carlos Francisco Aremayo détient 50% (cinquante pour cent) des actions de la Société Absorbante équivalent à 84.739

(quatre-vingt-quatre mille sept cent trente-neuf) actions.

Josefa Baeza Hernandez détient 50% (cinquante pour cent) des actions de la Société Absorbante équivalent à 84.739

(quatre-vingt-quatre mille sept cent trente-neuf) actions.

2) La Société Absorbée
Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à EUR 6.188.150 (six million cent quatre-vingt-huit mille

cent cinquante euros) composé de 247.526 (cent soixante-neuf mille quatre cent soixante-dix-huit) actions sous forme
nominatives ayant une valeur nominal de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Carlos Francisco Aremayo détient 50% (cinquante pour cent) des actions de la Société Absorbante équivalent à 123.763

(cent vingt-trois sept cent soixante-trois) actions.

Josefa Baeza Hernandez détient 50% (cinquante pour cent) des actions de la Société Absorbante équivalent à 123.763

(cent vingt-trois sept cent soixante-trois) actions.

3) Rapport d'échange des actions
En contrepartie de l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, la Société Absorbante

(a) augmentera son capital social d'un montant de EUR 3.050 (trois mille cinquante euros) afin de le porter de son montant
actuel de EUR 4.236.950 (quatre million deux cent trente-six mille neuf cent cinquante euro) à EUR 4,240,000 (quatre
million deux cent quarante mille euros) par l'émission de 122 (cent vingt-deux) nouvelles actions ayant une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, de même nature et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes
de la Société Absorbante.

Les nouvelles actions de la Société Absorbante seront affectées de la manière suivante aux associés de la Société

Absorbée:

a) Soixante-une (61) actions à Mr Carlos Francisco Aremayo;
b) Soixante-une (61) actions à Ms Josefa Baeza Hernandez.
Les statuts de la Société Absorbante concernant son capital social et l'émission d'actions seront modifiés en consé-

quence.

Sur la base du rapport d'échange des actions ci-dessus, un montant de EUR 4.467.374,29 (quatre million quatre cent

soixante-sept mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-neuf centimes d'euros) représentant la prime d'émission
(c'est-à-dire la différence entre la valeur nominale des actions nouvelles émises de la Société Absorbante et la valeur
comptable de la Société Absorbée selon les Comptes Annuelles) sera enregistré dans les comptes de la Société Absor-
bante en tant que prime de fusion dans les comptes de la Société Absorbante.

Aucun paiement en espèces ne sera accordé à l'actionnaire de la Société Absorbée.
c) Conditions de délivrance d'actions dans la Société Absorbante
Les actions nouvellement émises seront enregistrées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante à

compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion.

En conséquence de la fusion, la société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées.
d) Date à partir de laquelle les actions nouvellement émises seront porteuses du droit de participation aux bénéfices

et toute condition particulière relative à ce droit

Les actions nouvellement émises permettront à leur détenteur de participer aux bénéfices de la Absorbante à compter

de la Date de Prise d'Effet de la Fusion et ces détenteurs auront tous les droits attachés à ces nouvelles actions, y compris
le droit aux dividendes ou tout autre distribution découlant des bénéfices de l'année fiscale et/ou des réserves accumulées
et de profits reportés ou autre. Ce droit n'est soumis à aucune condition particulière.

e) Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant

réalisées au nom de la Société Absorbante

Les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées au nom de

la Société Absorbante à compter du 1 

er

 janvier 2014.

f) Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de titres

autres que des actions

Toutes les actions de la Société Absorbée seront identiques aux nouvelles actions émises et conféreront les mêmes

droits et avantages à son détenteur de sorte qu'aucun droit spécial et aucune compensation ne seront accordés aux frais
de la Société Absorbante à quiconque.

Aucune garantie ou mesure sera accordée ou prise par la Société Absorbante.

14022

L

U X E M B O U R G

g) Avantages spéciaux accordés aux experts mentionnés à l'article 266 de la Loi, aux membres du conseil de gérance

et du conseil d'administration des Sociétés qui Fusionnent et à toute personne (le cas échéant) mentionnée à l'article 261
(2) g) de la Loi

Ni les experts mentionnés à l'article 266 de la Loi (le cas échéant), ni les membres des conseils d'administration des

Sociétés qui Fusionnent, ni toute personne (le cas échéant) mentionnée à l'article 261 (2) g) de la Loi, ne seront autorisés
à recevoir des avantages spéciaux en rapport avec ou par suite de la Fusion.

3. Conséquences de la Fusion.
3.1 La fusion déclenchera de plein droit (ipso jure) toutes les conséquences détaillées à l'article 274 de la Loi et en

particulier, suite à la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées.

3.2 Sous réserve des dispositions de l'Article 274 (2) de la Loi concernant la force exécutoire envers les tiers, la société

Absorbante deviendra propriétaire des actifs apportés par la Société Absorbée tels qu'ils existent à la Date de Prise d'Effet
avec aucun droit de recours contre la Société Absorbée quel qu'il soit.

3.3 La Société Absorbante paiera, à compter de la Date de Prise d'Effet, tous les impôts, cotisations, droits taxes et

primes d'assurance qui seront ou pourront devenir exigibles en relation avec la possession des actifs qui ont été apportés.

3.4 A compter de la Date de Prise d'Effet, la Société Absorbante exécutera tous les contrats et obligations quels qu'ils

soient de la Société Absorbée.

3.5 Les droits et créances afférents aux actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec

tous les titres, soit réels (in rem), soit personnels, attachés à ceux-ci. La Société Absorbante sera donc subrogée, sans
novation, à tous les droits, qu'ils soient réels (in rem) ou personnels, de la Société Absorbée, à l'égard de tous ses actifs
et contre tous ses débiteurs sans exception aucune.

3.6 La Société Absorbante paiera toutes tes dettes de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée. Elle paiera

en particulier, le montant principal et les intérêts des dettes de toute nature qui incombent à la Société Absorbée.

3.7 Tous les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante

aussi longtemps que prescrit par la Loi.

3.8 Les mandats des membres du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé de la Société Absorbée

prendront fin à la Date de Prise d'Effet de la Fusion. Pleine décharge sera accordée aux membres du conseil d'adminis-
tration et au réviseur d'entreprises agrée pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

3.9 Les mandats des membres du conseil d'administration et du ou des réviseur(s) d'entreprises agrée(s) de la Société

Absorbante ne seront pas affectés par la Fusion.

4. Dispositions supplémentaires.
4.1 Le coût de la Fusion incombera à la Société Absorbante.
4.2 Les soussignés entreprennent réciproquement de prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de réaliser la

Fusion conformément aux exigences légales et statutaires des deux Sociétés qui Fusionnent.

4.3 La Société Absorbante effectuera toutes les démarches nécessaires et requises à la réalisation de cette Fusion ainsi

que le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

4.4 Conformément à l'article 267 de la Loi, l'actionnaire des Sociétés qui Fusionnent aura droit de regard sur les

documents suivants au siège social desdites sociétés, au moins un mois avant la date des assemblées générales de l'ac-
tionnaire qui seront convoquées afin de se prononcer sur les conditions de cette Fusion:

- le projet de Fusion;
- les comptes annuels des trois dernières années des Sociétés qui Fusionnent, le cas échéant;
- le cas échéant, un bilan intérimaire, établi à la date qui ne doit pas être avant le premier jour du troisième mois

précédant la date de publication du Projet de Fusion dans le Mémorial C, si les derniers comptes annuels des Sociétés
qui Fusionnent font référence à une année qui s'est terminée plus de 6 mois avant cette date;

- le cas échéant, les rapports écrits détaillés des organes de direction des Sociétés qui Fusionnent conformément à

l'article 265 de la Loi;

- le cas échéant, les rapports tels que mentionnés à l'article 266 de la Loi.
Une copie des documents mentionnés ci-dessus sera délivrée sur demande.
4.5 Le présent document a été établi le 17 janvier 2014 à Luxembourg, en deux originaux, aux fins d'être enregistré

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et d'être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations, un mois au moins avant la date des assemblées générales de l'actionnaire de chacune des Sociétés qui
Fusionnent appelées à se prononcer sur les conditions de la Fusion, conformément à l'article 262 de la Loi.

4.6 Le présent document est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre les

versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Barlanto Holding S.à r.l.
Represented by Luxembourg Corporation Company S.A.
Ms. Catherine Noens and Mr. Fabio Spadoni

14023

L

U X E M B O U R G

<i>Class A Attorneys-in-fact
Monteland Holding S.à r.l.
Josefa Baeza Hernandez
<i>Class A manager
Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Class B manager
Ms. Catherine Noens and Mr. Fabio Spadoni
<i>Class A Attorneys-in-fact

Référence de publication: 2014014500/345.
(140016700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 2 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014, verlangten

ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können  müssen  Aktionäre,  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per

Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007279/755/29.

Ellipse S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 27.320.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra extraordinairement le <i>11 février 2014 à 14 heures dans les locaux de l'Etude Tabery &amp; Wauthier, 10

rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la non-tenue de l'Assemblée Générale Annuelle à la date statutairement prévue compte tenu de la

non-disponibilité des comptes annuels au 30/06/2013;

2. Ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel Administrateur et décharge;
3. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
4. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30/06/2013;
5. Affectation du résultat;

14024

L

U X E M B O U R G

6. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
7. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
8. Délibération conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;
9. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014006430/322/22.

Serrano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 février 2014 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2013;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation de deux Administrateurs et décharge accordée aux Administrateurs démissionnaires;
6. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014014410/19.

Raiba Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 22.357.

Notice is hereby given that the

ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company, 42, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on Wednesday, <i> February 19 

<i>th

<i> , 2014  at 14.30 for the following purposes:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. Presentation and approval of the annual accounts as at December 31 

st

 , 2009, December 31 

st

 , 2010, December

31 

st

 , 2011 and December 31 

st

 , 2012 ; allocation of results;

3. Resignation of the Directors and discharge to be given;
4. Discharge to the Statutory Auditor;
5. Appointment of new Directors;
6. Deliberation regarding the prospects of a future for the Company and its management and operations

<i>For the Board of Directors.

Référence de publication: 2014016122/1017/19.

Mediterranée S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.752.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>18 février 2014 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012

14025

L

U X E M B O U R G

3. Ratification de la cooptation d'un administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014016998/795/18.

Novamil Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.958.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting held

extraordinarily on December 27 

th

 , 2013 could not validly act on said item.

The Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>February 17, 2014 at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

- Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the modified

Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014007276/795/17.

Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Die Aktionäre der Boss Concept IPC Sicav werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht
erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalver-
sammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens bis zum 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Boss Concept IPC Sicav (DZ PRIVATBANK

S.A.) unter Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007280/755/29.

14026

L

U X E M B O U R G

BZ Fine Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 157.402.

Die Aktionäre des BZ Fine Funds werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 11.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 2 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014, verlangten

ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können  müssen  Aktionäre,  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle des BZ Fine Funds (DZ PRIVATBANK S.A.) per

Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007281/755/29.

FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 12.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere um
Ergänzungen in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte, die Sicherheitenstellung sowie den Einsatz von Total Return
Swaps und anderen Derivaten mit ähnlichen Eigenschaften.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014, verlangten

ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können  müssen  Aktionäre,  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

14027

L

U X E M B O U R G

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der FondsSelector SMR SICAV (DZ PRIVAT-

BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007284/755/31.

Figae Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.788.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting held

exceptionally on January 3 

rd

 , 2014 could not validly act on said item.

The Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>February 17, 2014 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

- Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the modified

Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014007291/795/17.

DJE Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 131.326.

Die Aktionäre der DJE LUX SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 12.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014, verlangten

ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können  müssen  Aktionäre,  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der DJE LUX SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)

per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007282/755/29.

14028

L

U X E M B O U R G

Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 12.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht
erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalver-
sammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)

unter Fax-Nr: 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007283/755/29.

WE Finance and Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 57.450.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre janvier,
par devant Maître Marc LOESCH, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné,

ont comparu:

1. WAALFIN HOLDING S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché du Luxem-

bourg,  ayant  son  siège  social  au  17,  rue  Beaumont,  étage  3,  L-1219  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57449,

et
2. Monsieur Ronald DE WAAL, né le 13 février 1952, à Bussum (Pays- Bas), résidant professionnellement au 136

Ertbruggestraat, B-2110 Wijnegem,

les deux ici représentés par Madame Mette Garby, gérant de la Société, résidant professionnellement au 154, rue

Albert Unden, L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données en date du 23 janvier 2014.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et leur mandataire et le notaire ins-

trumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes valablement représentés requièrent le notaire instrumentant de déclarer que:
I. Les associés, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment convoqués et qu'ils ont eu connaissance de l'ordre

du jour préalablement à l'Assemblée Générale Extraordinaire, aucune convocation n'était donc nécessaire.

L'assemblée est de ce fait régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer et décider de tous les points à

l'ordre du jour.

II. Les associés détiennent la totalités des parts de WE Finance and Services (Luxembourg) S.à r.l., une société à

responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
57.450, constituée selon un acte notarié daté du 16 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

14029

L

U X E M B O U R G

Associations (le «Mémorial») le 24 mars 1997 sous le numéro 143. Les statuts de la Société ont depuis été modifiés pour
la dernière fois par l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 13 janvier 2000, publié au Mémorial le 9
mars 2000 sous le numéro 198.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation de la fusion transfrontalière entre la Société et la société De Waal International Management NV, telle

que décrite dans le projet commun de fusion, annexé ci-joint;

2. Approbation du rapport spécial du conseil de gérance de la Société sur le projet de fusion;
3. Approbation de la composition actuelle du conseil de gérance, suite à la fusion susmentionnée;
4. Divers.
IV. En vertu du projet commun de fusion adopté selon un acte sous seing privé en date du 5 décembre 2013, publié

au Mémorial C le 19 décembre 2013 sous le numéro 3229, la Société, en tant que société absorbante, est considérée
comme fusionnant par absorption de la société De Waal International Management NV, une société anonyme constituée
et existante sous les lois belges, ayant son siège social au Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem, Belgique (la «Société
Absorbée»), immatriculée auprès du Registre des Personnes Morales d'Anvers sous le numéro 0430.952.093.

Les parties comparantes, représentées comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés, après réception du certificat émis suite à l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la Société

Absorbée daté du 20 janvier 2014 confirmant qu'il a été satisfait à toutes les exigences légales relatives à la fusion en
Belgique, et après avoir attentivement examiné les documents listés dans la résolution ci-dessous, approuvent la fusion
transfrontalière, telle qu'envisagée dans le projet de fusion publié au Luxembourg au Mémorial le 19 décembre 2013 sous
le numéro 3229, et en Belgique au Moniteur belge le 18 décembre 2013, sous le numéro 13189843, qui se réalisera et
prendra effet à l'égard des tiers à partir de la date de publication du procès-verbal de la présente assemblée générale
extraordinaire approuvant la fusion et le projet commun de fusion conformément aux articles 9 et 273 ter paragraphe 1
de la Loi Luxembourgeoise.

<i>Seconde résolution

Les associés approuvent le rapport spécial du conseil de gérance de la Société sur le projet de fusion expliquant, inter

alla, d'un point de vue juridique et économique la fusion envisagée entre la Société et la Société Absorbée.

<i>Troisième résolution

Les associés approuvent qu'une fois la fusion devenue effective, la composition du conseil de gérance de la Société

restera inchangée et se composera donc de Madame Mette Garby, de Monsieur Victor Hoogstraal, de Monsieur Thomas
Plattner et de Monsieur Ronald De Waal, nommés pour une durée indéterminée.

<i>Quatrième résolution

Les associés confirment que la rédaction du projet de fusion transfrontalière ainsi que du procès-verbal de la présente

assemblée générale extraordinaire en langue française leur convient, et qu'ils comprennent que la rédaction des différents
documents en langue française est justifiée par des soucis de compréhension pour la Société Absorbée.

<i>Déclaration

Conformément à l'article 271 (2) de la Loi Luxembourgeoise, le notaire instrumentant déclare qu'il a vérifié et confirmé

l'existence de la validité des mesures et formalités exigées par la Loi Luxembourgeoise par rapport à la Société et au
projet commun de fusion.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mises à sa charge en raison de la fusion s'élève approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom,

état civil et lieu de résidence, ledit mandataire signe ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Garby, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 27 janvier 2014. REM/2014/242. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

14030

L

U X E M B O U R G

Mondorf-les-Bains, le 27 janvier 2014.

Référence de publication: 2014014384/82.
(140016501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.

G&amp;P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 111.408.

Die Aktionäre der G&amp;P Invest SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 , um 13.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht
erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalver-
sammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der G&amp;P Invest SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)

unter Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007286/755/29.

Lacuna, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 74.776.

Die Aktionäre der Lacuna werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 13.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere um
Ergänzungen in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte, die Sicherheitenstellung sowie den Einsatz von Total Return
Swaps und anderen Derivaten mit ähnlichen Eigenschaften.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014, verlangten

ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die
Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-

Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

14031

L

U X E M B O U R G

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können  müssen  Aktionäre,  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der zweiten Außerordentlichen General-
versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Lacuna (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax

00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007287/755/31.

Intfideco, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 24.884.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été

atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 27 décembre 2013, l'assemblée n'a pas pu
statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 2014 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014007292/795/19.

Cameron Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.441.

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of December.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

CAMERON LUX II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under
registration number B 90.440, represented by Me Cécile JAGER, attorney at law, residing in Howald (Grand Duchy of
Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal on December 20, 2013.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity CAMERON LUX II S.à r.l., is the sole member in CAMERON LUX m S.à r.l., incorporated on

December 17, 2002, with registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 90.441, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 115 on February 5, 2003 (the "Company"), by deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact that:
I.  the  provisions  of  the  law  dated  10  August  1915  on  commercial  companies  as  amended  (the  "Law")  have  been

respected:

1. the joint merger proposal (the "Merger Plan") of a reverse merger established by the respective boards of managers

of  the  Company  and  of  Cameron  Lux  V  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under registration number B 155.711 (together the "Merging Companies"), has been duly filed with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November

14032

L

U X E M B O U R G

15, 2013 under number 2870, i.e. more than one month before the date of the present meeting convened to decide of
the Merger Plan.

2. Cameron Lux II S.à r.l., in its capacity as sole member of the Company, has been entitled to inspect the documents

required under article 267 of the Law at the registered office of the Company at least one month before the date of the
meeting convened to decide on this Merger Plan.

II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Approval of the Merger Plan;
2. Acknowledgment of the Merger Plan as consisting of the plan of reorganisation for U.S. federal income tax purposes;
3. Approval of the reverse merger between Cameron Lux V S.à r.l., as absorbing company and the Company, as

absorbed company, whereby following to the dissolution without liquidation of the Company, all its assets and liabilities
are transferred to Cameron Lux V S.à r.l. by operation of law in accordance with article 274 of the Law (the "Reverse
Merger");

4. Approval of the use of the net book value for the implementation of the present Reverse Merger in compliance

with the provisions of article 170 (2) of the Luxembourg income tax law;

5. Approval of the net book value of the Company being an amount of five hundred eighteen million three hundred

ninety eight thousand four hundred sixty one Euros (EUR 518,398,461.-) as evidenced by the interim accounts of the
Company as at 30 November 2013;

6. Acknowledgment of the qualification of the Reverse Merger as a non-recognition reorganisation described under

Internal  Revenue  Code  section  368  (a)  (1)  for  U.S.  federal  income  tax  purposes  and,  accordingly,  (a)  to  the  extent
reporting is required, acknowledgment of the report to be issued by each of the Merging Companies for U.S. federal
income tax purposes and (b) acknowledgment of the engagement of the Merging Companies to not take any action
inconsistent with such treatment;

7. Acknowledgment of the business purposes of the Reverse Merger consisting in (i) the realignment of the capital

structure of the tiered Luxembourg structure, (ii) the elimination of companies within the global holding company struc-
ture in order to simplify statutory audit and income tax filing obligations, (iii) the transfer of subsidiaries and intercompany
receivables from the Company to Cameron Lux V S.à r.l. allowing for more optimized access and redistribution of cash
and (iv) the maintain and the creation of multiple, optimized offshore cash valves;

8. Approval of the waiver of any and all requirements with respect to (i) the preparation by the board of managers of

each of the Merging Companies of a detailed written report established for consideration by the sole member of each of
the Merging Companies, explaining the rationale behind the Reverse Merger, the Merger Plan, and setting forth and
outlining the legal and economic grounds for the Merger Plan, in particular for the share exchange ratio and (ii) the
information referred to in article 265 (2) of the Law regarding any material change in respect of the assets and liabilities
of the Merging Companies which may occur between the date of the preparation of the Merger Plan and the date of the
adoption of the resolutions of the sole member of each of the Merging Companies resolving upon, inter alia, the com-
pletion of the Reverse Merger, as provided for by article 265 (3) of the Law;

9. Approval of the waiver of the requirement to have the Merger Plan examined by one or several independent experts

and of the preparation of written reports by such independent experts for consideration by the sole member of each of
the Merging Companies regarding, inter alia, the determination of the exchange ratio, as provided for by article 266 (5)
of the Law;

10. Approval of the transfer of all the assets and liabilities of the Company to Cameron Lux V S.à r.l.;
11. Acknowledgment of the effectiveness of the Merger from (i) an accounting perspective as of 30 November 2013,

(ii) from a legal perspective between the Merging Companies as of the date of the present meeting and (iii) vis-à-vis third
parties at time of publication of the present resolutions in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

12. Acknowledgment of the dissolution of the Company;
13. Granting of authorisation to any manager of the Company or to any lawyer of the law firm Bonn Steichen &amp;

Partners, to carry out any action necessary or incidental in relation to the resolutions to be taken on the basis of the
present agenda;

14. Miscellaneous.
After due consideration, the sole member took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolved to approve the Merger Plan.

<i>Second resolution

The sole member resolved to acknowledge the Merger Plan as consisting of the plan of reorganisation for U.S. federal

income tax purposes.

14033

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The sole member resolved to approve the reverse merger between Cameron Lux V S.a r.l., as absorbing company

and the Company, as absorbed company, whereby following to the dissolution without liquidation of the Company, all
its assets and liabilities are transferred to Cameron Lux V S.a r.l. by operation of law in accordance with article 274 of
the Law (the "Reverse Merger").

<i>Fourth resolution

The sole member resolved to approve the use of the net book value for the implementation of the present Reverse

Merger in compliance with the provisions of article 170 (2) of the Luxembourg income tax law.

<i>Fifth resolution

The sole member resolved to approve the net book value of the Company being an amount of five hundred eighteen

million three hundred ninety eight thousand four hundred sixty one Euros (EUR 518,398,461.-) as evidenced by the interim
accounts of the Company as at 30 November 2013.

<i>Sixth resolution

The sole member resolved to acknowledge the qualification of the Reverse Merger as a non-recognition reorganisation

described under Internal Revenue Code section 368 (a) (1) for U.S. federal income tax purposes and, accordingly, (a) to
the extent reporting is required, acknowledge the report to be issued by each of the Merging Companies for U.S. federal
income tax purposes and (b) acknowledge the engagement of the Merging Companies to not take any action inconsistent
with such treatment.

<i>Seventh resolution

The sole member resolved to acknowledge the business purposes of the Reverse Merger consisting in (i) the realign-

ment of the capital structure of the tiered Luxembourg structure, (ii) the elimination of companies within the global
holding company structure in order to simplify statutory audit and income tax filing obligations, (iii) the transfer of sub-
sidiaries and inter company receivables from the Company to Cameron Lux V S.à r.l. allowing for more optimized access
and redistribution of cash and (iv) the maintain and the creation of multiple, optimized offshore cash valves.

<i>Eighth resolution

The sole member resolved to approve the waiver of any and all requirements with respect to (i) the preparation by

the board of managers of each of the Merging Companies of a detailed written report established for consideration by
the sole member of each of the Merging Companies, explaining the rationale behind the Reverse Merger, the Merger
Plan, and setting forth and outlining the legal and economic grounds for the Merger Plan, in particular for the share
exchange ratio and (ii) the information referred to in article 265 (2) of the Law regarding any material change in respect
of the assets and liabilities of the Merging Companies which may occur between the date of the preparation of the Merger
Plan and the date of the adoption of the resolutions of the sole member of each of the Merging Companies resolving
upon, inter alia, the completion of the Reverse Merger, as provided for by article 265 (3) of the Law.

<i>Ninth resolution

The sole member resolved to approve the waiver of the requirement to have the Merger Plan examined by one or

several independent experts and of the preparation of written reports by such independent experts for consideration by
the sole member of each of the Merging Companies regarding, inter alia, the determination of the exchange ratio, as
provided for by article 266 (5) of the Law.

<i>Tenth resolution

The sole member resolved to approve the transfer of all the assets and liabilities of the Company to Cameron Lux V

S.à r.l.

<i>Eleventh resolution

The sole member resolved to acknowledge the effectiveness of the Merger from (i) an accounting perspective as of

30 November 2013, (ii) from a legal perspective between the Merging Companies as of the date of the present meeting
and (iii) vis-à-vis third parties at time of publication of the present resolutions in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

<i>Twelfth resolution

The sole member resolved to acknowledge the dissolution of the Company.

<i>Thirteenth resolution

The sole member resolved to grant authorisation to any manager of the Company or to any lawyer of the law firm

Bonn Steichen &amp; Partners, to carry out any action necessary or incidental in relation to the resolutions to be taken on
the basis of the present resolutions.

14034

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

In accordance with provisions of article 271 (2) of the Law, the undersigned notary declares that he has verified and

certifies the existence and the validity of (i) any and all legal acts and formalities required to be carried out by the Company
and (ii) the Merger Plan.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at two thousand euro (EUR 2,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned. The undersigned notary, who understands and speaks

English, states herewith that at the request of the appearing person the present deed is worded in English, followed by a
French version; at the request of the same appearing person, in case of divergences between the English and the French
text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand Duchy of Luxembourg), on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

CAMERON LUX II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 90.440, représentée par Maître Cécile JAGER,
Avocat à la Cour, ayant sa résidence à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration émise sous
seing privé le 20 décembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne représentant la partie comparante sus-

mentionnée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La société prénommée, CAMERON LUX II S.à r.l. est l'associé unique de CAMERON LUX III S.à r.l., constituée le 17

décembre 2002, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 90.441, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 115
du 5 février 2003 (la «Société»), suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ladite partie comparante a demandé au notaire instrumentant d'acter que:
I. les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") ont été

respectées à savoir:

1. Le projet commun de fusion (le "Projet de Fusion") d'une fusion inversée établi par les conseils de gérance respectifs

de la Société et de Cameron Lux V S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155.711 (ci-après
ensemble les "Parties à la Fusion"), a été dûment enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 15 novembre 2013 sous le numéro 2870,
soit plus d'un mois avant la présente assemblée générales appelée à se prononcer sur le Projet de Fusion.

2. Cameron Lux II S.à r.l. en sa capacité d'associé unique de la Société a eu le droit d'inspecter au siège social de la

Société, un mois avant la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur le Projet de Fusion, les documents mentionnés
l'article 267 de la Loi.

II. La présente assemblée a pour ordre du jour (l'"Ordre du jour") les points suivants:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du Projet de Fusion;
2. Constatation du Projet de Fusion comme constituant le plan de restructuration pour les besoins de l'imposition du

revenu conformément aux lois fédérales des Etats-Unis;

3. Approbation de la fusion inversée entre Cameron Lux V S.à r.l., en qualité de société absorbante et la Société en

qualité de société absorbée par laquelle suite à la dissolution sans liquidation de la Société, tous les actifs et passifs sont
transférés à Cameron Lux V S.à r.l. par effet de la loi conformément à l'article 274 de la Loi (la «Fusion Inversée»);

4. Approbation de l'utilisation de la valeur nette comptable pour l'exécution de la présente Fusion Inversée confor-

mément aux dispositions de l'article 170 (2) de la loi de l'impôt sur le revenu luxembourgeois;

14035

L

U X E M B O U R G

5. Approbation de la valeur nette comptable de la Société étant d'un montant de cinq cent dix-huit millions trois cent

quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante et un Euros (EUR 518.398.461,-) tel que mentionné dans les comptes
intérimaires de de la Société au 30 novembre 2013;

6. Constatation de la qualification de la Fusion Inversée comme restructuration non-reconnue telle que décrite, pour

les besoins de l'imposition du revenu selon les lois fédérales américaines, par l'article 368 (a) (1) du Code des Impôts et
par conséquent (a) dans la mesure où un rapport est requis, approbation du rapport devant être émis par les Parties à
la Fusion pour les besoins de l'imposition du revenu selon les lois fédérales américaines et (b) constatation de l'engagement
des Parties à la Fusion de ne rien faire pouvant porter atteinte à ce traitement fiscal;

7. Constatation des raisons commerciales justifiant la Fusion Inversée consistant en (i) un réalignement de la structure

du capital des différentes sociétés luxembourgeoises, (ii) la disparition de sociétés dans la structure globale de détention
pour simplifier l'audit et des obligations de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu, (iii) le transfert de filiales et de
droits à recevoir intra-groupe de la Société à Cameron Lux V S.à r.l. permettant une meilleure optimisation, un meilleur
accès et une meilleure distribution des liquidités et (iv) le maintien et la création de plusieurs sources de liquidités à
l'étranger;

8. Approbation de la renonciation à toute exigence relative à (i) la préparation par le conseil de gérance de chacune

des Parties à la Fusion d'un rapport écrit détaillé à l'intention de l'associé unique de chacune des Parties à la Fusion,
précisant la raison de la Fusion Inversée, du Projet de Fusion, ainsi qu'expliquant et justifiant d'un point de vue juridique
et économique le Projet de Fusion et en particulier le rapport d'échange des parts sociales, et (ii) l'information prévue à
l'article 265 (2) de la Loi concernant tout changement matériel de l'actif et du passif des Parties à la Fusion qui pourrait
survenir entre la date de la préparation du présent Projet de Fusion et la date de l'adoption des résolutions de l'associé
unique de chacune des Parties à la Fusion se prononçant, entre autres, sur la réalisation de la Fusion Inversée, confor-
mément à l'article 265 (3) de la Loi;

9. Approbation de la renonciation à l'obligation de faire procéder à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs

experts indépendants et la préparation de rapports écrits par ledit (lesdits) expert(s) indépendant(s) à l'intention de
l'associé unique de chacune des Parties à la Fusion et concernant, entre autres, la détermination du rapport d'échange,
conformément à l'article 266 (5) de la Loi;

10. Approbation du transfert des actifs et passifs de la Société à Cameron Lux V S.à r.l.;
11. Constatation de la prise d'effet de la Fusion Inversée (i) d'un point de vue comptable au 30 novembre 2013, (ii)

d'un point de vue juridique, entre les Parties à la Fusion, à la date de la présente assemblée et (iii) vis-à-vis des tiers à
compter de la publication des présentes résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

12. Constatation de la dissolution de la Société;
13. Pouvoir donné à tout gérant de la Société ou à tout avocat de l'étude Bonn Steichen &amp; Partners d'effectuer, le cas

échéant, toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises dans le cadre du présent agenda; et

14. Divers.
Après considération, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a approuvé le Projet de Fusion.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a constaté que le Projet de Fusion constitue le plan de restructuration pour les besoins de l'imposition

du revenu conformément aux lois fédérales des Etats-Unis.

<i>Troisième résolution

L'associé unique a approuvé la fusion inversée entre Cameron Lux V S.à r.l., en qualité de société absorbante et la

Société, en qualité de société absorbée par laquelle suite à la dissolution sans liquidation de la Société, tous les actifs et
passifs sont transférés à Cameron Lux V S.à r.l. par effet de la loi conformément à l'article 274 de la Loi (la «Fusion
Inversée»).

<i>Quatrième résolution

L'associé unique a approuvé l'utilisation de la valeur nette comptable pour l'exécution de la présente Fusion Inversée

conformément aux dispositions de l'article 170 (2) de la loi de l'impôt sur le revenu luxembourgeois.

<i>Cinquième résolution

L'associé unique a approuvé la valeur nette comptable de la Société étant d'un montant de cinq cent dix-huit millions

trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante et un Euros (EUR 518.398.461,-) tel que mentionné dans les
comptes intérimaires de la Société au 30 novembre 2013.

14036

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'associé unique a constaté la qualification de la Fusion Inversée comme restructuration non-reconnue telle que décrite,

pour les besoins de l'imposition du revenu selon les lois fédérales américaines, par l'article 368 (a) (1) du Code des Impôts
et par conséquent (a) dans la mesure où un rapport est requis, a approuvé le rapport devant être émis par les Parties à
la Fusion pour les besoins de l'imposition du revenu selon les lois fédérales américaines et (b) a constaté l'engagement
des Parties à la Fusion de ne rien faire pouvant porter atteinte à ce traitement fiscal.

<i>Septième résolution

L'associé unique a constaté les raisons commerciales justifiant la Fusion Inversée consistant en (i) un réalignement de

la structure du capital des différentes sociétés luxembourgeoises, (ii) la disparition de sociétés dans la structure globale
de détention pour simplifier l'audit et des obligations de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu, (iii) le transfert de
filiales et de droits à recevoir intra-groupe de la Société à Cameron Lux V S.à r.l. permettant une meilleure optimisation,
un meilleur accès et une meilleure distribution des liquidités et (iv) le maintien et la création de plusieurs sources de
liquidités à l'étranger.

<i>Huitième résolution

L'associé unique a approuvé la renonciation à toute exigence relative à (i) la préparation par le conseil de gérance de

chacune des Parties à la Fusion d'un rapport écrit détaillé à l'intention de l'associé unique de chacune des Parties à la
Fusion, précisant la raison de la Fusion Inversée, du Projet de Fusion, ainsi qu'expliquant et justifiant d'un point de vue
juridique et économique le Projet de Fusion et en particulier le rapport d'échange des parts sociales, et (ii) l'information
prévue à l'article 265 (2) de la Loi concernant tout changement matériel de l'actif et du passif des Parties à la Fusion qui
pourrait survenir entre la date de la préparation du présent Projet de Fusion et la date de l'adoption des résolutions de
l'associé unique de chacune des Parties à la Fusion se prononçant, entre autres, sur la réalisation de la Fusion Inversée,
conformément à l'article 265 (3) de la Loi.

<i>Neuvième résolution

L'associé unique a approuvé la renonciation à l'obligation de faire procéder à l'examen du Projet de Fusion par un ou

plusieurs experts indépendants et la préparation de rapports écrits par ledit (lesdits) expert(s) indépendant(s) à l'intention
de l'associé unique de chacune des Parties à la Fusion et concernant, entre autres, la détermination du rapport d'échange,
conformément à l'article 266 (5) de la Loi.

<i>Dixième résolution

L'associé unique a approuvé le transfert des actifs et passifs de la Société à Cameron Lux V S.à r.l.

<i>Onzième résolution

L'associé unique a décidé de prendre acte de la prise d'effet de la Fusion Inversée (i) d'un point de vue comptable au

30 novembre 2013, (ii) d'un point de vue juridique, entre les Parties à la Fusion, à la date de la présente assemblée et (iii)
vis-à-vis des tiers à compter de la publication des présentes résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

<i>Douzième résolution

L'associé unique a décidé de constater la dissolution de la Société.

<i>Treizième résolution

L'associé unique a décidé de donner pouvoir à tout gérant de la Société ou à tout avocat de l'étude Bonn Steichen &amp;

Partners d'effectuer, le cas échéant, toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises dans le cadre
du présent agenda.

<i>Déclaration

Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifie

l'existence et la validité de (i) tous les actes et formalités devant être accomplies par la Société et (ii) du Projet de Fusion.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à DEUX MILLE EUROS (EUR 2.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à

tous employés de l'Etude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

14037

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Jager, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17392. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014014522/301.
(140016860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Multiadvisor Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 58.249.

Die Aktionäre der Multiadvisor Sicav werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 13.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht
erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalver-
sammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Multiadvisor Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)

unter Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007288/755/29.

Pro Fonds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 45.890.

Die Aktionäre der Pro Fonds (Lux) werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht
erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich. Die

14038

L

U X E M B O U R G

Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum.
Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalver-
sammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Pro Fonds (Lux) (DZ PRIVATBANK S.A.)

unter Fax-Nr.: 00352/44 903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Januar 2014.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007289/755/29.

PVV SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 82.676.

Die Aktionäre der PVV SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>18. Februar 2014 um 14.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 4 der Satzung

Die Vorgaben aus dem CSSF Rundschreiben 13/559 werden umgesetzt.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 18. Februar 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2014 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde.
Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich. Die Punkte der Tage-
sordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse
werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können  müssen  Aktionäre,  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der
Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung)
am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalver-
sammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 13. Februar 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der PVV SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter

Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014007290/755/29.

Widriss International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 35.684.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>10 février 2014 à 10.00 heures à Esch/Alzette, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre la société en liquidation,
2. Nomination de M. Mohammad Ghoneim comme liquidateur,
3. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014012025/1023/14.

14039

L

U X E M B O U R G

Seven Lux Sicav-Sif, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 183.840.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighth of January.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

Seven Capital Management, a company incorporated in France, registered with the Register of Commerce and Com-

panies  of  Paris  under  number  491390464,  having  its  registered  office  at  39  Rue  Marbeuf,  75  008  Paris  France,  and
authorized as a management company by the French Autorité des Marchés Financiers under number GP-06000045,

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, having professional address in Esch/Alzette, by

virtue of a proxy given under private seal, dated 3 January 2014;

Hereinafter referred to as the "Party".
The above mentioned proxy, being initialed ne varietur by the appearing party, and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has, in the capacity of which it acts, requested the notary to draw up the following articles of

Association (the Articles of Association) of a public limited company ("société anonyme") (the "Company"), the incor-
poration of which such party has approved.

Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares

hereafter  issued,  a  company  in  the  form  of  a  public  limited  company  ("société  anonyme"),  formed  as  an  investment
company with variable capital ("SICAV") and Specialized Investment Fund, governed by the present articles of association
(the "Articles" or "Articles of Association") and by current Luxembourg laws, and notably by the Law on Commercial
Companies of 10 August 1915 (the "1915 Law") and the law on Specialized Investment Funds of 13 February 2007 (the
"2007 Law").

Art. 2. Name. The Company's name is Seven Lux SICAV-SIF.

Art. 3. Purpose. The Company's exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread

the investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according
to its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law and applicable Luxembourg
Supervisory Authority's (the "CSSF") circulars.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company's private placement

memorandum.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in

particular, without limitation, grant any assistance, loans, advances or guarantees and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders.

In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indi-

rectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted
by the 2007 Law.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, in the Grand

Duchy of Luxembourg. If and to extent permitted by law, the board of directors of the Company (the "Board") may
decide to transfer the registered office of the Company within the municipality by a resolution of the Board. The Board
shall further have the right to set up branches, offices, administrative centers and agencies wherever it shall deem fit,
either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board determines that extraordinary political, economical or social developments or events have occurred

or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration.
The Company may be terminated at any time by a decision of the general meeting of shareholders in the manner

required for the amendment of these Articles of Association.

The life of the Company does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any of its shareholders or members of the Board of Directors.

14040

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Share Capital. The initial share capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000) divided

into thirty-one (31) fully paid up Shares, with no par value. The Company's share capital shall at any time be equal to its
net asset value, as determined in accordance with Article twelve (12) hereafter.

The minimum subscribed capital of the Company, which must be achieved within 12 (twelve) months as from the date

on which the Company has been authorized as a Specialized Investment Fund by the CSSF, shall be one million two
hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-) as required by the 2007 Law.

Art. 7. The sub-funds and classes of shares. The Company is a multi-compartment structure consisting of one or several

sub-funds, each one representing a specific portfolio of assets and liabilities. There is no cross liability between sub-funds.
Each sub-fund is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to it. The investment objective
and policy as well as other specific features of each sub-fund will be set forth in the Company's private placement me-
morandum. The Board of Directors may decide to create at any time additional sub-funds or to close an existing sub-
fund.

The Board of Directors may decide to issue, within each sub-fund, separate classes of shares, which may carry different

rights and obligations, inter alia with regard to their distribution policy and right to revenues, their fee structure, their
minimum initial subscription and holding amounts or their target investors. The specific features of the classes within each
sub-fund will be set forth in the Company's private placement memorandum. The Board of Directors may create at any
time additional classes or close an existing class.

Art. 8. Form of shares / Register of shareholders. Shares will only be issued in registered form. All issued shares of

the Company shall be registered in the register of shareholders. Such register shall contain the name and address of each
shareholder, the number of shares held by it and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the shareholder's name in the register of shares evidences its right of ownership over such regis-

tered shares. The shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. The shareholder may, at any time,
change its address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its
registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

Fractions of shares may be issued, up to three decimal places.

Art. 9. Shareholders. The holding of shares is exclusively restricted to «Well-Informed Investors» as defined in the

2007 Law.

The Board of Directors shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose

notably of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of
Association, the private placement memorandum of the Company, the law or requirement of any country or governmental
authority, or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company
incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise
have incurred or suffered. For such purposes the Board of Directors may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share where it appears to it that such registration

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share being held by a person who is precluded
from holding shares of the Company;

b) at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders to furnish it with any infor-

mation, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or
beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares of
the Company; and

c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares of the Company is a legal

or beneficial owner of shares or holds shares, cause the Company compulsorily to repurchase from any such shareholder
all shares held by such shareholder.

Art. 10. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price

per share at which such shares shall be issued shall be the net asset value thereof as determined in accordance with the
provisions of Article 12 hereof on the basis of the fair value principle. The Board of Directors may also decide that an
issue commission has to be paid. The allotment of Shares is conditional upon payment and if timely payment has not been
received within the settlement period, the subscription may lapse and be cancelled at the cost of the investor or the
investor's financial intermediary. If payment is not received in full, the relevant allotment of Shares may be reduced
accordingly. The Board of Directors may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class
of share of any sub-fund.

Subscriptions received before a certain hour ("cut-off time") on a specific date (which does not need to be the valuation

date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the net asset value determined
for the applicable valuation date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of
Directors from time to time, they shall be processed at the net asset value determined for the following valuation date.
The investor will bear any taxes or other expenses attaching to the application.

The Board of Directors may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities to any

shareholder who agrees to comply with any conditions set forth by the Board of Directors from time to time including,

14041

L

U X E M B O U R G

but not limited to, the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company which shall be available
for inspection, and provided that such securities comply with the investment restrictions and policies of the relevant sub-
fund, as set forth in the Company's private placement memorandum. Any costs incurred in connection with a contribution
in kind of securities, including the auditor's costs for preparing any valuation report required, shall be borne by the
shareholder making such contribution.

The Board of Directors reserves the right to accept or refuse any application of subscription for shares in whole or

in part.

Art. 11. Transfer and conversion of shares. Any transfer of shares to the existing shareholders or to any third party

shall require the prior written approval of the Board of Directors and the Board of Directors may in its discretion and
without indicating any reason decline to approve or register such transfer.

The Board shall not accept any transfer of shares to any transferee who may not be considered as an eligible investor

within the meaning of the Law.

The shareholder wishing to transfer its shares in the Company will be responsible for all costs associated with any

attempted or realized transfer.

Shareholders are not allowed to pledge or grant a security interest in any of their shares without the prior consent

of the Board of Directors.

Unless otherwise provided for within the Company's private placement memorandum, (i) shares of a sub-fund may

not be converted for shares in another sub-fund and (ii) shares of a sub-fund may be converted for shares in another
class of shares of the same sub-fund, subject to the prior written approval of the Board of Directors.

Art. 12. Net asset value. The net asset value of the Company shall be determined as often as the Board of Directors

may think useful, but in no event less than once a year.

The net asset value will be expressed in Euro and shall be determined by the Board of Directors on the basis of the

fair valuation of the underlying assets of the Company as provided by the Board of Directors on each valuation date by
aggregating the value of all assets of the Company and deducting all liabilities of the Company.

If needed, the net asset value may be calculated by using swing pricing methodology to ensure a fair treatment between

investors.

Art. 13. Suspension. The Board of Directors may temporarily suspend the calculation of the net asset value during:
a) any period when, in the reasonable opinion of the Board of Directors, a fair valuation of the assets of the Company

is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

b) any period when any of the principal markets (where applicable) on which a substantial proportion of the investments

of the Company are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are
restricted or suspended; or

c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned

by the Company would be impractical; or

d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the

price or value of any of the investments or the currency price or values on any such stock exchange; or

e) when, following redemption requests, it has not proved possible to dispose of the assets of the concerned sub-fund

(s) as necessary as a consequence of the markets' liquidity; or

f) in any other case where deemed necessary by the Board of Directors in the exclusive interest of the Company or

of its shareholders.

Art. 14. Redemption of shares. The Company is an open-ended Specialized Investment Fund. However, the Board of

Directors may decide, depending on the investment strategy and objectives of each sub-fund, to launch closed-ended sub-
funds.

Redemptions will be made in accordance with the principles set forth in the private placement memorandum of the

Company for each sub-fund.

The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the Board

of Directors. The allotment of Company's assets in respect of redemption for consideration in kind shall be fair and not
detrimental to the interests of the other shareholders of the Company. In compliance with the provisions of the 2007
and 1915 Laws, any redemption for consideration in kind shall be subject to the confirmation by an auditor's special report
of the valuation of the Company of the Company's assets to be allocated, the costs of which shall be borne by the
Company.

Redemption of shares shall be made at a price, which is determined by the Board of Directors to be the fair value for

the shares to be redeemed by applying the principles described in the Company's private placement memorandum. The
rules relating to distributions as set forth in the Company's private placement memorandum of the Company are fur-
thermore applicable.

The Company may decide to compulsorily redeem at its sole discretion the shares wholly or in part in particular in

the following circumstances:

14042

L

U X E M B O U R G

a) the shares are held by shareholders not authorized to buy or own shares in the Company, e.g. a shareholder that

no longer qualifies as «Well-Informed Investor» as defined in the 2007 Law or such shareholder (or an affiliate of the
same) that becomes a U.S. person as referred to in the Company's private placement memorandum;

b) in the event that a shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or

goes into liquidation;

c) in case of liquidation or merger of sub-funds or classes of shares;
d) the shares that are held in breach of any law or regulation or otherwise in circumstances having, or which may have,

adverse regulatory, tax or fiscal consequences for the Company or the shareholders or otherwise be detrimental to the
interests of the Company;

e) in all other circumstances as the Board of Directors may deem appropriate in accordance with the terms and

conditions set out in this Articles or in the Company's private placement memorandum.

Except in the cases c) and e) above the Board of Directors may impose such penalty as it deems fair and appropriate.
All redeemed shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.

Art. 15. Board of Directors. The Company will be managed by the Board of Directors of the Company, composed of

not less than three (3) members. The members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)

years and shall hold office until their successor are elected. A Director may be removed with or without cause and
replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and elect, by majority of vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.

Art. 16. Chairman. The Board of Directors shall elect from among its members a Chairman and may choose from

among its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a Director, who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board
of Directors shall meet upon call by the Chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or

another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore
by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-

Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.

The Board of Directors shall from time to time appoint any officer or agent of the Company considered necessary for

the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The
officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties granted to them by the
Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours

in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by email, telefax or any
other similar or electronic communication means from each Director. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which

appointment shall be in writing or by email, telefax or any other similar or electronic communication means.

Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference,

provided that the vote be confirmed in writing or by email, telefax or any other similar or electronic communication
means. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the
Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or

represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented
at such meeting, the Chairman having a casting vote.

Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by facsimile or any other similar or electronic communication means.

Art. 17. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his

absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.

Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two (2) Directors or the secretary or an assistant
secretary.

14043

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Power. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration,

disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles
of Association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 19. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management

and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the
Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The Board may further decide to create either at the level of the Company or for a specific sub-fund any committee

the members of which need not be Directors. The Board shall organize such committee functioning and determine the
powers of their members as further described in the private placement memorandum of the Company.

Art. 20. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers or agent or daily manager
or employee of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, daily manager or employee of such
other company or firm. Any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company who serves as a director,
officer, agent, daily manager or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company may have, in any transaction

of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such Director, officer, agent, daily manager or
employee shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director's, officer's, agent's, daily manager's or employee's interest therein
shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by
the Board of Directors in its discretion.

Art. 21. Signature. The Company shall be bound by the joint signature of any two (2) Directors or by the individual

signature(s) of any duly authorised Director or officer, or agent or daily manager of the Company or by the individual
signature of the Chairman or any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

Art. 22. Indemnification. The Company will indemnify any Director, officer or member of any committee referred to

above and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director, officer or
member of any committee of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder
or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a
settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing
right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 23. General meetings of shareholders. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the

entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders of the Company.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. It may also be called upon the

written request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

Upon request of shareholders representing at least one tenth of the share capital, one or more new items shall be

added to the agenda of any general meeting of shareholders. Such demand shall be addressed to the registered office of
the Company by registered mail at least five (5) days before such meeting.

The annual meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, on the

last day of April each year at 3.00 pm Luxembourg time. The first annual meeting shall be held in 2015.

If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the next banking day.
Other meetings of shareholders, including meetings of shareholders of one specific sub-fund or class of shares, may

be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company unless otherwise provided herein.

14044

L

U X E M B O U R G

Any shareholder may participate in a general meeting of shareholders by video conference, or by conference call or

similar means of communication equipment which enables his/her identification and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting. The means of communication used must allow all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such
persons in the meeting. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to
attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each whole share of the Company is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of

Association. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a proxy to another person in writing or by
facsimile transmission or any other similar or electronic communication means, who need not be a shareholder and who
may be a Director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the

votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles, in which case the resolution
will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast.

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on 1 

st

 January and closes on 31 

st

 December of the same

year.

Art. 25. Accounts. Each year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company. The annual

accounts shall be approved by the annual general meeting of shareholders upon proposal of the Board of Directors. The
accounts shall be expressed in Euro.

Art. 26. Supervision. The operations of the Company and its financial situation shall be supervised by one independent

auditor qualifying as a «réviseur d'entreprises agréé» who shall be appointed by the shareholders. The independent auditor
shall be remunerated by the Company and shall remain in office until its successor is appointed. The independent auditor
shall fulfill all duties prescribed by the 2007 Law.

Art. 27. Distribution. Subject to permitted re-investments, and the requirements of Luxembourg law, distributions

shall be payable by the Company on its shares upon decision by the Board of Directors in accordance with the Company's
private placement memorandum.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the net asset value of the Company would

fall below EUR 1,250,000.- (one million two hundred fifty thousand Euros). Dividends not claimed within five years of
their due date will lapse and revert to the relevant class of shares.

Art. 28. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a financial institution, which shall satisfy

the requirements of the 2007 Law. The custodian shall assume towards the Company and the shareholders the respon-
sibilities set out in the 2007 Law (notably in article 16 of the 2007 Law), the custodian agreement and any other law
applicable.

In the event of termination of the custodian agreement or the resignation of the custodian, the Board of Directors

shall use its best endeavors to find a financial institution to act as custodian and upon doing so the Board of Directors
shall appoint such financial institution to be custodian in place of the former custodian.

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several

liquidators (whether natural persons or legal entities approved by the CSSF) named pursuant to a general meeting effecting
such dissolution and at which meeting the liquidators' powers and compensation shall be determined. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the 1915 Law.

The net proceeds of liquidation in respect of each sub-fund or, as the case may be, of each class within each sub-fund,

shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of the relevant class in proportion to their holding of such
shares in such sub-fund or class, and whether such proceeds shall be distributed in cash or kind.

If the Company's share capital (i.e. the aggregate of all sub-funds) falls below two-thirds of the minimum capital (EUR

1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to a general meeting for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by a simple majority of the validly
cast votes.

If the Company's share capital falls below one quarter of the minimum capital increased by the share premium (EUR

1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to the general meeting for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by the shareholders owning one
quarter of the validly cast votes.

The aforesaid meetings shall be convened within forty days of the date at which it was ascertained that the net assets

fell below two-thirds or one quarter of the minimum capital, respectively. Moreover, the Company may be terminated
by resolution of the general meeting in accordance with the pertinent provisions of these Articles of Association.

14045

L

U X E M B O U R G

The resolutions of the general meeting of shareholders or of a court of law pronouncing the termination and winding-

up of the Company are to be published in compliance with applicable laws. The choice of which newspapers are to carry
the publication is made at the discretion of the liquidator(s).

The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of the

Company shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

Art. 30. Termination, liquidation and merger of sub-funds or classes of shares. The Board of Directors may decide to

close one or more classes or sub-funds (having or not a limited duration) in the best interests of the shareholders, if there
has been a substantial modification in the political, economic, regulatory or monetary situation pertinent to a class or
sub-fund, which, in the opinion of the Board of Directors renders this decision necessary, or where such action is required
in order to protect the interests of shareholders, or if for any reason whatsoever, the value of the net assets of a sub-
fund falls below an amount determined in the Company's private placement memorandum and the Board of Directors
determines that the interests of the shareholders of that same class or sub-fund demand such action to be taken.

The Company shall serve a notice in writing to the shareholders of the relevant class or sub-fund, which will indicate

the reasons and the procedure for the redemption operations.

The Company shall base these redemptions on the net asset value taking into account liquidation expenses.
The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class

or sub-fund shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

All redeemed Shares may be cancelled.
A termination contemplated above may be combined with a contribution to one or several sub-fund(s) or class(es)

within the Company or to one or several other sub-fund(s) or class(es) of another undertaking for collective investment
(under the corporate or the contractual type form) in the best interests of the shareholders.

Where the undertaking for collective investment that will receive the contribution is a mutual fund (fonds commun

de placement), the decision to contribute will only be binding on shareholders who have agreed to make a contribution.

A sub-fund may exclusively be contributed to a foreign undertaking for collective investment with the unanimous

approval of the shareholders of the relevant sub-fund or under the condition that only the assets of the consenting
shareholders shall be so contributed.

Art. 31. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the 2007 Law for which no specific

provision is made in these Articles of Association.

Art. 32. Definitions and Interpretation. References to articles are to the Articles of these Articles of Association.

Words importing gender include each gender. References to persons include bodies corporate, firms and unincorporated
associations. The singular includes the plural and vice versa. Headings of articles are included for convenience only and
do not affect their interpretation. References to all or any part of any statute or statutory instrument include any statutory
amendment, modification or re-enactment in force from time to time and references to any statute include any statutory
instrument or regulations made under it. Any reference to the Company, the Board of Directors, agents, etc, includes a
reference to its or their duly authorized agents or delegates.

<i>Transitional measures

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date hereof and end on 31 

st

 December 2014.

The first annual general meeting shall be held in 2015.

<i>Subscription and Payment

The initial capital of the Company amounts to thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) and has been subscribed as

follows:

Seven Capital Management: thirty-one (31) shares.
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in the 1915 Law, and

confirms that these conditions have been observed.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its incorporation amount approximately to three thousand euro (EUR 3,000.-).

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly

convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

14046

L

U X E M B O U R G

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote

and with the approval of the Board of Directors:

<i>First resolution

The following persons are elected as member of the Board of Directors for a period ending at the annual general

meeting of shareholders to be held in 2015:

- Mr Johann SCHWIMMAN, born on 28 September 1964 in Suresnes (France), having professional address at 39, rue

Marbeuf, 75008 Paris, France, as Director and Chairman of the Board of Directors;

- Mr Bertrand GIBEAU, born on 8 July 1979 in Limoges (France), having professional address at 51, rue Sainte Anne,

75002 Paris, France, as independent Director; and

- Mr Aymeric LECHARTIER, born on 11 February 1972 in Fontainebleau (France), having professional address at 107

Fleet Street, London EC4A 2AB, United Kingdom, as Director.

<i>Second resolution

The address of the registered office of the Company is set at 5 allée Scheffer L-2520, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

Has  been  elected  as  approved  statutory  auditor  (réviseur  d'entreprise  agréé)  until  the  annual  general  meeting  of

shareholders to be held in 2015:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
B.P. 1443
400, route d'Esch
L-1014 Luxembourg
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English only.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2014. Relation: EAC/2014/796. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014015090/421.
(140017349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Shire Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.103.063,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.573.

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

Shire Ireland Finance Limited, a company incorporated under Irish law, having its registered office at 5, Riverwalk,

Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, acting through its Luxembourg branch, Shire Ireland Finance Limited,
Luxembourg Branch (the "Branch"), having its registered address at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, duly
represented by Mr. Regis Galiotto residing professionally at 101 Rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal, in its capacity as sole shareholder of "Shire Luxembourg Finance S.à r.l.", a "société à responsabilité
limitée", having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 181.573 (the "Company"), incorporated
by a notarial deed enacted on 5 November 2013, not yet published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Who declared and requested the notary to state that:
I. An extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company has been held on 12 December 2013 in

front of the undersigned notary, such notarial deed being in process of registration and not yet published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "EGM").

14047

L

U X E M B O U R G

II. The EGM has approved among others the increase of the share capital of the Company (the "Capital Increase") by

an amount of USD 8,078,061 (eight million seventy-eight thousand sixty-one United States Dollars) so as to raise it from
its current amount of USD 25,002 (twenty-five thousand two United States Dollars) to USD 8,103,063 (eight million one
hundred three thousand sixty-three United States Dollars) by the issuance of (i) 2 (two) new mandatory redeemable
preferred shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to payment of a share premium
amounting  to  USD  1,779,509,705  (one  billion  seven  hundred  seventy-nine  million  five  hundred  nine  thousand  seven
hundred five United States Dollars), payable on the mandatory redeemable preferred share premium account of the
Company, and (ii) 8,078,059 (eight million seventy-eight thousand fifty-nine) new ordinary shares with a nominal value of
USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 32,412,235
(thirty-two million for hundred twelve thousand two hundred thirty five United States Dollars), out of which an amount
of USD 810,306 (eight hundred ten thousand three hundred six United States Dollars) shall be allocated to the legal
reserve of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind (the "Contribution") of a claim held
by the Branch of an amount of USD 1,820,000,000 (one billion eight hundred twenty million United States Dollars) (the
"Claim").

III. Completions of the Capital Increase and of the Contribution were conditional to the Branch becoming the holder

of the Claim to be contributed to the Company (the "Condition Precedent").

IV. The undersigned notary acknowledges that the Condition Precedent has been fulfilled on 31 December 2013,

evidence of which has been given to the undersigned notary.

V. The undersigned notary therefore acknowledges that the Capital Increase and the Contribution are effective as

from 31 December 2013 in accordance with the resolutions of the EGM.

VI. As a consequence of the foregoing, the first paragraph of Article 8 of the articles of association of the Company is

restated as follows:

« Art. 8. The Company's share capital is set at USD 8,103,063 (eight million one hundred three thousand sixty-three

United States Dollars) represented by 8,103,059 (eight million one hundred three thousand fifty-nine ordinary shares
with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "Ordinary Shares ") and 4 (four) MRPS with a nominal
value of USD 1 (one United States Dollar) each.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this Deed have been estimated at about two thousand Euros (EUR 2,000.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille treize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

«Shire Ireland Finance Limited», une société de droit irlandais, ayant ayant son siège social au 5 Riverwalk, Citywest

Business Campus, Dublin 24, agissant par sa succursale, Shire Ireland Finance Limited, Luxembourg Branch (la «Succur-
sale»),  ayant  son  adresse  au  7A,  rue  Robert  Stümper,  L-2557  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  dûment
représentée par M. Régis Galiotto, résidant professionnellement au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, en sa capacité d'associé unique de «Shire Luxembourg Finance S.à r.l.», une société
à responsabilité limitée ayant son siège social sis au 7A, boulevard Royal, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.573 (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, du 5 novembre 2013, non encore publié au Mémorial
C, recueil des Sociétés et Associations.

Qui a déclaré et demandé au notaire de constater que:
I. Une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société a eu lieu le 12 décembre 2013 par devant

le notaire soussigné, cet acte notarié étant en cours d'enregistrement et n'a pas encore été publié au Mémorial C, recueil
des Sociétés et Associations (l'«AGE»).

II. L'AGE a approuvé, entre autres, l'augmentation du capital social de la Société (l'«Augmentation de capital») d'un

montant de 8.078.061 USD (huit millions soixante-dix-huit mille soixante et un Dollars Américains) pour le porter de
son montant actuel de 25.002 USD (vingt-cinq mille deux Dollars Américains) à 8.103.063 USD (huit millions cent trois
mille soixante-trois Dollars Américains) par l'émission (i) de 2 (deux) parts sociales préférentielles avec rachat obligatoire
d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un

14048

L

U X E M B O U R G

montant de 1.779.509.705 USD (un milliard sept cent soixante-dix-neuf millions cinq cent neuf mille sept cent cinq Dollars
Américains), payable sur le compte de prime d'émission des parts sociales préférentielles avec rachat obligatoire de la
Société, et (ii) de 8.078.059 (huit millions soixante-dix-huit mille cinquante-neuf) nouvelles parts sociales ordinaires d'une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant
de 32.412.235 USD (trente-deux millions quatre cent douze mille deux cent trente-cinq Dollars Américains), dont un
montant de 810.306 USD (huit cent dix mille trois cent six Dollars Américains) seront alloués à la réserve légale de la
Société, la totalité devant être entièrement libérée au moyen d'un apport en nature (l'«Apport») consistant en une créance
détenue par la Succursale d'un montant de 1.820.000.000 USD (un milliard huit cent vingt millions de Dollars Américains)
(la «Créance»).

III. La réalisation de l'Augmentation de Capital et de l'Apport étaient soumise à la réalisation de la condition suivante:

que la Succursale devienne le détenteur de la Créance devant être apportée à la Société (la «Condition Suspensive»).

IV. Le notaire soussigné constate que la Condition Suspensive a été réalisée le 31 décembre 2013, preuve en ayant été

communiquée au notaire soussigné.

V. Le notaire soussigné constate en conséquence que l'Augmentation de Capital et l'Apport sont effectifs au 31 dé-

cembre 2013 en application des résolutions de l'AGE.

VI. En conséquence de ce qui précède, le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société est modifié comme

suit:

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 8.103.063 USD (huit millions cent trois mille soixante-trois Dollars

Américains), représenté par 8.103.059 (huit millions cent trois mille cinquante-neuf) parts sociales ordinaires ayant une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Parts Ordinaires») et 4 (quatre) MRPS (telles que définies
ci-dessous) ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»

<i>Estimation des frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent Acte, ont été estimés à deux mille Euros (2.000.- Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité par l'assemblée, celle-ci est ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la comparante, il a signé avec nous, notaire, l'original du

présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes comparantes,
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1294. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Référence de publication: 2014015093/117.
(140016986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

MB Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9659 Heiderscheidgrund, 5, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 182.693.

STATUTEN

Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtwohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herrn Johan Henk BLEEKSMA, Geschäftsmann, geboren am 2. April 1953 in Nieuwer-Amstel (NL), wohnhaft in Vrij-

heid 71, B-2320 Hoogstraten, hier vertreten durch Herr Gianpiero SADDI, privatangestellter, wohnhaft in Strassen, durch
eine Vollmacht vom 25.11.2013 welche gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleibt.

Welcher Komparent den amtierenden Notar dazu angehalten hat die Gründungsurkunde einer anonymen Gesellschaft

zu beurkunden, welche der Komparent gründete, und von welcher er die Satzung wie folgt bestimmt:

Art. 1. Es ist durch den Komparenten, und unter all jenen welche in der Folge Eigentümer der hiernach ausgegebenen

Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft gegründet, unter dem Namen „MB Investment S.A.".

14049

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann aufgelöst werden durch eine Entscheidung der Gene-

ralversammlung der Aktionäre welche mit der Mehrheit abstimmt wie für Satzungsänderungen erforderlich.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Esch-sur-Süre.
Er kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt

werden, sowie durch Entscheidung einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wie in Angelegenheiten
einer Satzungsänderung abstimmend, in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Sitz
kann ins Ausland verlegt werden, durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrats, wenn außergewöhnliche Umstände
militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur der normalen Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz im
Wege stehen, oder imminent sind, und dies bis zur Beendigung solcher Umstände.

Unbeschadet einer solchen Verlegung ins Ausland, welche immer nur temporärer Natur sein kann, bleibt die Natio-

nalität der Gesellschaft immer luxemburgisch.

Unter jeglichen Umständen kann die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland, sowie die Annahme einer

ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, immer nur durch den einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter sowie
aller Anleiheeigner erfolgen, welche zum diesem Zwecke in einer außerordentlichen Generalversammlung versammelt
sein müssen.

Die Gesellschaft mag per Beschluss des Verwaltungsrats sowohl im Großherzogtum Luxemburg, wie auch im Ausland,

Tochtergesellschaften, Zweitsitze, Zweigstellen, Agenturen und Büros eröffnen.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,

der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die
Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die  Gesellschaft  kann  sich  an  der  Gründung  und  Entwicklung  jeder  finanziellen,  industriellen  oder  kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbe-

weglichen,  kommerziellen  und  industriellen  Operationen  machen,  welche  sie  für  nötig  hält  zur  Verwirklichung  und
Durchführung ihres Zweckes.

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) unterteilt in dreihun-

dertzehn Aktien (310) mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR), alle voll und ganz gezeichnet.

Die Aktien können als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgestellt werden, je nach Wahl der Aktionäre.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder

heruntergesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine Satzungsänderung vor-
geschrieben, abgehalten wird.

Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.

Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern verwaltet. Die

Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Dauer von nicht mehr als sechs (6) Jahren gewählt. Sie sind wieder
wählbar. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten und eventuell einen Vizepräsidenten.

Wenn durch Abtritt, Sterbefall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird,

können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen provisorisch durch eine andere Person ersetzen. In diesem
Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.

Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist,

können die Funktionen des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt
der einzige Aktionär sein muss.

Wenn eine juristische Person zum Verwaltungsrat bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen permanenten Vertreter

zu bestimmen, welcher die Aufgabe hat diese Mission auszuführen und dies im Namen und für Rechnung derjenigen
juristischen Person.

Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Mission

in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Schadensersatzp-
flicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig
dessen Nachfolger bestimmt.

Die Ernennung und die Beendigung der Funktionen des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der

Veröffentlichung als würde er die Mission in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen.

Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Personen welche den Sitzungen dieses Organs beiwohnen, haben die

Verpflichtung nichts nach außen bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliche Infor-
mationen anbetrifft über welche sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Veröffentlichung der Gesellschaft

14050

L

U X E M B O U R G

Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme der Fälle wo eine Veröffentlichung verlangt oder erlaubt ist, sei es entweder
durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie

jegliche Transaktionen durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein kön-
nen, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten
sind. Er kann zum Zwecke einer Arbitrage Kompromisse zeichnen, gütliche Einigungen per Transaktion eingehen, sowie
auch jegliche Verzichte oder Aufhebungen von Sicherheiten, gegen Zahlung oder ohne Zahlung, verfügen.

Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der

Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Vertreter, welche alle nicht Aktionär sein müssen, delegieren.

Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift einer
hierfür durch den Verwaltungsrat bestimmten Person.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht jede Informationen zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herange-

tragen werden.

Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Dinge an ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von

speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich darüber der ordentli-
chen Generalversammlung Rechenschaft, sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet,
die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden, zu geben.

Art. 8. Die gerichtlichen Anträge, sowohl wenn die Gesellschaft klagt oder beklagt wird, werden immer im Namen

der Gesellschaft alleine, vertreten durch ihren Verwaltungsrat, ausgeführt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat versammelt sich so oft wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Versamm-

lungen werden durch den Präsidenten, und in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder einberufen.

Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei Sitzungen vertreten lassen, dies durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.

Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefällt. Im Falle eines Patts hat der Präsident

nicht die entscheidende Stimme.

Im Falle von Dringlichkeit können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Telekom-

munikationstechniken abgeben.

Der Verwaltungsrat kann mit Hilfe einer Videokonferenz abstimmen. Die Abstimmung wird vom Gesellschaftssitz aus

geschaltet. Das Protokoll der Abstimmung anlässlich einer Videokonferenz, wird am Sitz der Gesellschaft durch den
Sekretär des Verwaltungsrates erstellt.

Er wird den Verwaltungsratsmitgliedern innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Sitzung zugestellt. Jedes

Mitglied kann dem Sekretär schriftlich seine Zustimmung oder seine Einwände mitteilen.

Wenn im Laufe einer Videokonferenz eine substantielle Uneinigkeit zwischen den Teilnehmern entsteht, kann jedes

Verwaltungsratsmitglied die Vertagung jenes Punktes der Tagesordnung, welcher Anlass zur Uneinigkeit gibt, auf eine
kommende Sitzung des Verwaltungsgrates vertagen lassen, welche dann innerhalb von dreißig (30) Tagen abgehalten
werden muss, und anlässlich derselben die Mitglieder physisch zugegen oder vertreten sein müssen. Der erste Absatz
dieses Artikels findet dann Anwendung.

Sofern keine abweichende und striktere Bestimmung des internen Reglements Anwendung findet, sind diejenigen Ver-

waltungsratsmitglieder welche an einer Videokonferenz teilnehmen als präsent zu werten, zum Zwecke der Ausrechnung
des Quorums sowie der erforderlichen Mehrheit der Teilnahme, sofern die Identität des Teilnehmers an der Videokon-
ferenz  oder  durch  eine  anderes  Telekommunikationsmittel  festgestellt  werden  kann.  Diese  technischen  Mittel  zur
Identifikation müssen eine effektive und kontinuierliche Teilnahme an der Sitzung, deren Abstimmungen kontinuierlich
übertragen werden, gewährleisten.

Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz ab-

gehalten.

Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement geben, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und

welches die zusätzlichen Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gilt.

Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen

werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann
per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder ihre Stimme dafür abgibt.

Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden

mit der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, mit den Unterschriften von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern gefasst.

14051

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs (6) Jahre

nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest. Sie können wiedergewählt werden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwal-

tungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat das Recht eine Generalversammlung einzuberufen sofern er dies als opportun ansieht.

Er ist dazu verpflichtet eine solche innerhalb eines Monats einzuberufen, sofern Aktionäre welche mindestens zehn Pro-
zent des Gesellschaftskapitals darstellen ihn dazu schriftlich auffordern, und gleichzeitig die gewünschte Tagesordnung
darlegen.

Die Einberufung jeglicher Generalversammlungen beinhaltet die Tagesordnung.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um jegliche Geschäfte zu tätigen oder zu ratifizieren

sofern dieselben die Interessen der Gesellschaft berühren.

Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen, können

der Tagesordnung ein oder mehrere neuen Punkte hinzufügen lassen. Die dementsprechende Anträge müssen der Ge-
sellschaft an deren Sitz per Einschreibebrief mitgeteilt werden, dies mindestens fünf Tage vor Abhalten der Versammlung.

Die Auszüge der Protokolle der Generalversammlungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrates, sonst

durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates als konform attestiert.

Art. 13. Jeder Aktionär hat das Recht entweder persönlich oder durch einen Vertreter, welch letzterer nicht selbst

Aktionär sein muss, an Abstimmungen teilzunehmen. Jede Aktie gibt das Recht zu einer Stimme.

Art. 14. Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem zweiten Montag des Monats Mai um 14.00 Uhr, entweder

am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben zu
bestimmen.  Sollte  dieser  Tag  ein  gesetzlicher  Feiertag  sein,  dann  wird  die  Versammlung  am  nächst  darauf  folgenden
Werktag zur selben Uhrzeit abgehalten.

Die alljährliche Generalversammlung ist dazu berufen die Konten und die jährlichen Geschäftsberichte anzunehmen,

sowie sich über die Entlastung der Gesellschaftsorgane auszudrücken.

Sie bestimmt über die Verwendung und die Ausschüttung des Nettogewinns. Vom Nettogewinn werden fünf Prozent

(5%) dazu verwendet einen gesetzlichen Reservefonds zu speisen; diese Speisung des gesetzlichen Reservefonds ist nicht
mehr obligatorisch wenn diese Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat, muss allerdings wieder bis zur
vollständigen Auffüllung aufgenommen werden wenn immer und aus welchem Grund auch immer, die gesetzliche Reserve
beansprucht wurde.

Der Rest steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat ist dazu befugt im Laufe eines Geschäftsjahres Vorauszahlungen auf Dividende zu zahlen, dies unter

den Bedingungen und Bestimmungen wie im Gesetz verankert.

Art. 15. Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bes-

timmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.

<i>Übergangsbestimmung

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Gründung und endet am 31. Dezember 2014.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahr 2015 abgehalten.
3) Der erste Delegierte des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung ernannt.

<i>Zeichnung

Das Gesellschaftskapital und dessen 310 (dreihundertzehn) Aktien wurden alle durch den Komparenten, Johan Henk

BLEEKSMA, vorbenannt, gezeichnet.

Alle Aktien, welche auf diese Art gezeichnet wurden, sind zu 100% (hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so dass die

Summe von 31.000.- EUR (einunddreißigtausend Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem Notar per
Banknachweis bescheinigt wurde.

<i>Erklärung

Der Notar erklärt die Erfüllung der Bedingungen wie in Artikel 26 des Gesetzes über Handelsgesellschaften ausgeführt,

überprüft zu haben, und erklärt ausdrücklich, dass dieselben erfüllt sind.

<i>Kostenveranschlagung

Der Summe der Kosten, Auslagen, Gehälter sowie Lasten, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft

bei dieser Gründung entstehen, betragen ungefähr 1.400.- EUR (eintausendvierhundert Euro).

14052

L

U X E M B O U R G

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Und im selben Augenblick hat der Komparent, welcher die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertritt, sich in einer

außerordentlichen Generalversammlung konstituiert, zu welcher er sich regelkonform einberufen erklärt, und er hat
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf eins (1), diejenige der unabhängigen Wirtschaftsprüfer

wird festgelegt auf einen (1).

2. Die Mandate des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresge-

neralversammlung des Jahres 2015.

3. Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herrn Johan Henk BLEEKSMA, Geschäftsmann, geboren am 2. April 1953 in Nieuwer-Amstel (NL), wohnhaft in Vrij-

heid 71, B-2320 Hoogstraten.

4. Zum Kommissar wird ernannt:
Karin Francis J. VAN LEEUWEN, geboren am 24. Januar 1964 in Den Helder (NL), wohnhaft in Vrijheid 71, B-2320

Hoogstraten.

5. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: Millewee 5, L-9659 Heiderscheidgrund

Worüber  Urkunde,  verhandelt  und  aufgenommen  in  Luxemburg,  am  Tag,  Monat  und  Jahr,  wie  am  Anfang  dieser

Urkunde geschrieben.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an den Komparenten hat derselbe diese mit Uns Notar zusammen unterschrieben.
Signé: J. H. Bleeksma et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 décembre 2013. Relation: LAC/2013/55105. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Référence de publication: 2013178046/210.
(130217459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Duomos Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 182.753.

STATUTS

L'an deux mille treize, le six décembre.
Par devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Duomos Sprl, société de droit belge dont le siège social se situe au 52 rue Gachard à B-1050 Bruxelles, Belgique,

immatriculée auprès du registre de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE-466-295-133,

ici représentée par Monsieur Thomas de Mevius, domicilié au 52 rue Gachard à B-1050 Bruxelles, en vertu d'une

procuration délivrée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Duomos Investment Management S.à r.l." (la Société). La Société

est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-

14053

L

U X E M B O U R G

traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et

immobilières incluant notamment, mais non exclusivement: des actions cotées ou non; des parts de fonds, des obligations,
bons de caisses, warrants, options et titre analogues; des métaux précieux, des oeuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots;
des terrains et constructions; en général: la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier,
sous quelque forme que ce soit dans toute valeur mobilière et immobilière; luxembourgeoise ou étrangère. La Société
réalise l'allocation, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des brevets, des marques de fabrique ou de commerce, des
dessins ou des modèles.

La Société a également pour objet les activités de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, de conseil

en marketing, organisation financière ou administrative. Dans la mesure où conformément aux dispositions de la loi du
5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, ces activités requièrent un agrément, elles ne peuvent être
déployées à moins que la Société ait demandé et obtenu les autorisations nécessaires.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure

14054

L

U X E M B O U R G

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les  décisions  du  Conseil  seront  valablement  prises  à  la  majorité  des  voix  des  gérants  présents  ou  représentés.  Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes

circonstances par les signatures conjointes de deux gérants en cas de Conseil de gérance.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée

14055

L

U X E M B O U R G

à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l'Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la

municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation.

Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

14056

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) décembre

2014.

<i>Souscription et Libération

Duomos Sprl représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme

nominative, d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et les libérer intégralement par un apport en
numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.200,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant l'intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée illimitée:
- Thomas de Mevius, né à Uccle, Belgique le 22 Février 1978 demeurant au 52 rue Gachard à B-1050 Bruxelles, Belgique.
- Fons Mangen, né à Ettelbruck, Luxembourg le 17 Juin 1958 demeurant au 147 rue de Warken à L-9088 Ettelbruck,

Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 9B Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: T. DE MEVIUS, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56108. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2013178666/241.
(130218678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.

14057

L

U X E M B O U R G

Ember VRM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 176.837.

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of December.
Before Us, Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

VSK Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at

Maples Corporate Services Limited, Ugland House building, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Company
Register of the Cayman Islands under number 277117 (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr Olivier Van Raemdonck, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to
the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Ember VRM

S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg by a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, of 12 April 2013, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1440 of 18 June 2013, with registered office at 11-13
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, with a corporate capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
and registered with the Luxembourg Company Register under number B 176.837 (the "Company"). The Company's
articles of incorporation (the "Articles of Association") have not been amended since the Company's incorporation.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the

following resolutions on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-) so as to raise it from

its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to an amount of thirteen thousand five hundred
Euros (EUR 13,500);

2. To issue one thousand (1,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the rights and

privileges set out in the Company's Articles of Association and entitling to dividends as from the day of the decision of
the Sole Shareholder on the proposed capital increase;

3. To accept the subscription by the Sole Shareholder to one thousand shares all with a nominal value of one euro

(EUR 1.-), and full payment of these new shares by a contribution of (i) one thousand euro (EUR 1,000.-) to the capital
of the Company and (ii) the payment of a share premium in the amount of five hundred seventy-one thousand five hundred
Euros (EUR 571,500.-).

4. To amend the first paragraph of article 5 of the Company's Articles of Association so as to reflect the resolutions

to be adopted under the preceding items;

5. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of one thousand Euros (EUR

1,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to an amount of
thirteen thousand five hundred Euros (EUR 13,500).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue one thousand (1,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)

each, having the rights and privileges set out in the Company's Articles of Association and entitling to dividends as from
the day of the decision of the Sole Shareholder on the proposed capital increase, and to accept the subscription and
payment as follows:

<i>Third resolution

<i>Subscription / Payment

Thereupon now appeared Mr Olivier Van Raemdonck, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and

attorney-in-fact of the Sole Shareholder.

The appearing person declared to subscribe, in the name and on behalf of the Sole Shareholder prenamed, to one

thousand (1,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and full payment of these new shares by a
contribution in cash of (i) one thousand euro (EUR 1,000.-) to the capital of the Company together with the payment of
a share premium, in the overall amount of five hundred seventy-one thousand five hundred Euros (EUR 571,500.-).

14058

L

U X E M B O U R G

Evidence of the aggregate payment in cash of the total subscription price for a amount of five hundred seventy-two

thousand five hundred Euros (EUR 572,500.-) was shown to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Associations to reflect the

resolutions taken above:

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at thirteen thousand five hundred Euros (EUR 13,500.-),

divided into thirteen thousand five hundred (13,500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed, are estimated at approximately one thousand nine hundred euros (EUR 1,900.-).

<i>Declaration

The undersigned notary is proficient in English and states herewith that on request of the above appearing person's

proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person's proxy
holder and in case of any discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person's proxy holder, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le douze décembre.
Par devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence au Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

VSK Holdings Limited, une société à responsabilité établie et régie par les lois des Îles Cayman, ayant son siège social

à Maples Corporate Services Limited, bâtiment Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, enregistrée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés des Îles Cayman sous le numéro 277117 (F'Assorié Unique");

représentée par Mr Olivier Van Raemdonck, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation qui, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent
acte aux fins de formalisation.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les parts

sociales émises par Ember VRM S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, par
acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence au Luxembourg, le 12 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1440 du 18 juin 2013, ayant son siège social à 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.837 (la " Société"). Les statuts de la Société n'ont pas
encore été modifiés depuis la constitution de la Société (les "Statuts").

La partie comparante a requis le notaire soussigné de formalisé les résolutions suivantes à prendre sur base de l'agenda

suivant:

<i>Agenda

1. Augmenter le capital social de la Société par un montant de mille Euros (EUR 1.000.-) afin de l'augmenter de son

montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) à un montant de treize mille cinq cents Euros (EUR
13.500.-);

2. Emettre mille (1.000) parts sociales de la Société, chacune ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-), ayant les

droits et privilèges tels que définis par les Statuts modifiés de la Société et bénéficiant de dividendes à partir du jour de
la décision de l'Associé Unique concernant l'augmentation de capital proposée;

3. Accepter la souscription par l'Associé Unique au mille (1.000) parts sociales de la Société et libération intégrale de

ces nouvelles parts sociales par un apport (i) d'un montant de mille euros (EUR 1.000.-) affecté au capital de la Société
et (ii) le paiement d'une prime d'émission s'élevant à un montant de cinq cent soixante et onze mille cinq cents Euros
(EUR 571.500.-).

4. Modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions à adopter sous

les points précédents;

5. Divers.

14059

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital de la Société par un montant de mille Euros (EUR 1.000.-) afin de

l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) à un montant de treize mille cinq cents
Euros (EUR 13.500.-).

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a décidé d'émettre mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR

1.-) chacune ayant les droits tels que définis dans les Statuts de la Société et bénéficiant de dividendes à partir du jour de
la décision de l'Associé Unique concernant l'augmentation de capital proposée.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription / Paiement

Ensuite, a comparu Mr Olivier Van Raemdonck, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

de l'Associé Unique.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, susmentionné à mille (1.000) parts

sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-), et la libération entière de ces nouvelles parts sociales
en vertu d'une contribution en numéraire de (i) mille Euros (EUR 1.000.-) au capital social de la Société et (ii) le paiement
d'une prime d'émission pour un montant de cinq cent soixante et onze mille cinq cents Euros (EUR 571.500.-).

La preuve de paiement en numéraire du prix total de souscription pour un montant de cinq cent soixante douze mille

cinq cents Euros (EUR 572.500.-) ayant été démontrée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la société afin de refléter les

résolutions prises ci-dessus:

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à treize mille cinq cents Euros (EUR 13.500.-) divisé en

treize mille cinq cents (13.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille neuf cents euros (EUR 1.900.-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire du

comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du
mandataire du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

DONT ACTE, fait et passé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumen-

taire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Van Raemdonck, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57205. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2014002174/147.
(140001678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Hilconstruct S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 69, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 141.736.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014003012/10.
(140002519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

14060

L

U X E M B O U R G

Goodman Industrial Real Estate Germany I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 36.800,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 117.231.

Le bilan au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Goodman Industrial Real Estate Germany I S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014002978/12.
(140002451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Henneaux Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 50.446.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 31 décembre 2013 au siège social de la société

<i>Résolutions

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Benoît Henneaux, employé, demeurant à

B-Vesqueville, le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Henneaux, employé, demeurant à B-Vesqueville et le
mandat d'administrateur de monsieur Guy Dechambre, employé, demeurant à B-Vesqueville et ce jusqu'à l'assemblée à
tenir en 2018. L'Assemblée décide également de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Léon Hen-
neaux.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Benoît Henneaux, ingénieur com-

mercial, demeurant à B-Vesqueville. Son mandat s'achèvera lors de la tenue de l'Assemblée Générale de 2018.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de la société Compagnie Européenne de

Révision ayant son siège social au 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel. Son mandat s'achèvera lors de la tenue de
l'Assemblée Générale de 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFC Benelux Sàrl
Signature

Référence de publication: 2014003006/22.
(140001847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Hosco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 132.907.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 janvier 2014.

<i>Pour HOSCO S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014003018/15.
(140002457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

14061

L

U X E M B O U R G

Hosco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 132.907.

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 décembre 2013 a ratifié la décision prise par le Conseil d'Admi-

nistration du 14 juin 2013 de coopter Madame Viviane HENGEL au poste d'Administrateur de la société, en remplacement
de Monsieur Yves BIEWER.

Le mandat de l'Administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.
Lors de cette assemblée générale, la démission de Madame Viviane HENGEL ainsi que la nomination de Madame Tanja

BERNAT, domiciliée professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été acceptées. Son mandat
s'achèvera lors à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 06 janvier 2014.

<i>Pour: HOSCO S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Cindy Szabo

Référence de publication: 2014003016/20.
(140002455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Glendevon King Global Fund SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV

- Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 152.497.

Les comptes annuels au 30 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014002976/10.
(140002492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Iason Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 105.111.

Par décision de l'associé unique en date du 3 janvier 2014 il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Leonardo Miocchi avec effet au 31 décembre 2013 de sa fonction de gérant.
- De nommer gérant avec effet immédiat, Monsieur Emmanuel Briganti, employé privé, et demeurant professionnel-

lement au 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg. Son mandat est fixé pour une durée indéterminée.

- De transférer le siège social de son adresse actuel au 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg.

IASON FINANCE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014003023/15.
(140002271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Immobilière Mamer Concept, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8291 Meispelt, 38, rue de Kopstal.

R.C.S. Luxembourg B 66.589.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2014003026/11.
(140002517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

14062

L

U X E M B O U R G

Hotel Moris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, route de Diekirch - place des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 130.155.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014003019/9.
(140002318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

I.E.T.M., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.835.

Les comptes annuels au 30/06/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Heinerscheid, le 07/01/2014.

Référence de publication: 2014003021/10.
(140002724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Baffo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 109.129.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration du 6 janvier 2014

1. Le Conseil d'administration décide d'accepter la démission de Monsieur Hassane DIABATE, en tant qu'administra-

teur.

2. Le Conseil d'administration coopte Monsieur Natale CAPULA, né à Villa San Giovanni (Italia) le 1 

er

 Novembre

1961, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée en remplacement de l'administrateur
démissionnaire: Monsieur Hassane DIABATE, né à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 4 avril 1971. La prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires ratifiera cette cooptation et le mandat de Monsieur Natale CAPULA viendra à échéance lors de
l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

Fait à Luxembourg, le 6 janvier 2013.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2014002832/18.
(140002703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Clarihen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 6, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 166.808.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AREND &amp; PARTNERS S.à r.l.
12, rue de la Gare
L-7535 MERSCH
Signature

Référence de publication: 2014002876/13.
(140002636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Claxon Participations S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 69.171.

BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES a dénoncé le siège social de la société CLAXON PARTICIPATIONS S.A., société

anonyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 69.171, avec siège social au 30
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

14063

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2014002877/13.
(140002651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Becht s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 30, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 58.730.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014002839/9.
(140002653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

BIOCARDEL Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.849.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société BIOCARDEL EUROPE S.A., qui s'est tenue à Lu-

<i>xembourg en date du 21 janvier 2013.

L'assemblée décide:
1. De prolonger le mandat de commissaire aux comptes de Lux Services S.à r.l., avec siège social à L-1260 Luxembourg,

92 rue de la Bonnevoie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
87808 jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2017

2. De prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur René Delarue, né à Oran en Algerie le 27 février 1944,

demeurant professionnellement à Châteauguay, J6J1E3, 211 Gordon jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2017

3. De prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel roque, né à Alès le 23 novembre 1973, demeurant

à L-1330 Luxembourg, 4a, bd GD Charlotte jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2017

Senningerberg, le 20 décembre 2013.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014002841/19.
(140002050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

YAPITAL Financial A.G., Société Anonyme.

Capital social: EUR 6.000.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.278.

<i>Auszug der Beschlussfassungen der Alleinaktionärin vom 28. November 2013

Die Alleinaktionärin hat per Beschluss vom 28. November 2013 und auf Grundlage von Artikel 7 der Gesellschafts-

satzung,  Herrn  Dr.  Rainer  HILLEBRAND,  geboren  am  01.04.1956  in  Johannesburg  (Südafrika),  mit  Berufsadresse  in
Wandsbeker Straße 3-7, 22172 Hamburg (Deutschland), mit sofortiger Wirkung zum zusätzlichen Verwaltungsratsmit-
glied der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahre 2014 bezüglich der
Abnahme der Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 28. Februar 2014, zu ernannt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014001870/15.
(140000292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

14064


Document Outline

Ametos SICAV

Baffo S.A.

Barlanto Holding S.à r.l.

Becht s.à r.l.

BIOCARDEL Europe S.A.

Boss Concept IPC Sicav

BZ Fine Funds

Cameron Lux III S.à r.l.

Clarihen S.à r.l.

Claxon Participations S.A.

DJE Lux Sicav

Duomos Investment Management S.à r.l.

Ellipse S.A.

Ember VRM S.à r.l.

Figae Invest S.A.

Fonds Direkt Sicav

FondsSelector SMR Sicav

Glendevon King Global Fund SICAV-SIF

Goodman Industrial Real Estate Germany I S.à r.l.

G&amp;P Invest Sicav

Henneaux Luxembourg S.A.

Hilconstruct S.A.

Hosco S.A.

Hosco S.A.

Hotel Moris S.à r.l.

Iason Finance S.à r.l.

I.E.T.M.

Immobilière Mamer Concept

Intfideco

Lacuna

MB Investment S.A.

Mediterranée S.A.

Monteland Holding S.à r.l.

Multiadvisor Sicav

Novamil Invest S.A.

Pro Fonds (Lux)

PVV SICAV

Raiba Finance S.A.

Serrano S.A.

Seven Lux Sicav-Sif

Shire Luxembourg Finance S.à r.l.

WE Finance and Services (Luxembourg) S.à r.l.

Widriss International S.A., SPF

YAPITAL Financial A.G.