This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 143
16 janvier 2014
SOMMAIRE
ATG Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6846
Car Classifieds Bangladesh S.C.Sp. . . . . . . .
6831
Cottonita Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
6863
C.P.S.L. (Concrete Project Services Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6864
DAVIN Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . . .
6826
Decopress SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6826
Delta Information Technologies S.A. . . . .
6826
Deltservice S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6826
Directsearch (Luxembourg) Sàrl . . . . . . . .
6827
Dojolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6826
Double Benefit Bonds S.A. . . . . . . . . . . . . . .
6830
DSV HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6844
Electricité SAND Jacques S.à r.l. . . . . . . . .
6850
EMDP LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6827
Energylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6844
Entreprise de Construction Erpelding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6843
Eurofinancial Investment S.à r.l. . . . . . . . . .
6841
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A. . . . .
6841
Fibart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6843
Fu Dou Lou Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6843
Gare Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6849
Illinois Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6843
Leisure Park Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
6833
Marcuni S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6863
Minpark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6844
Mittelmeer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6863
Noble Offshore (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
6825
Noramco International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
6842
Nord Lux Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6825
Promotion Marechal Nico S.à r.l. . . . . . . . .
6830
Real Estate Classifieds Asia Extra S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6850
Sagis Gallica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6832
Services Touristiques S.A. . . . . . . . . . . . . . .
6845
Sibret Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6844
Simple Global Education S.A. . . . . . . . . . . .
6818
Siola S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6864
Skydeck S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6832
SL Lux Investment S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .
6845
Société Immobilière de l'Arsenal . . . . . . . .
6845
Spa Di Lantigos S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6830
Supercell S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6844
Thea Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6861
The Simpleshow Company S.A. . . . . . . . . .
6818
Wistaria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6864
Zimfi SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6864
6817
L
U X E M B O U R G
The Simpleshow Company S.A., Société Anonyme,
(anc. Simple Global Education S.A.).
Siège social: L-8080 Bertrange, 12, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 178.763.
Im Jahre zweitausenddreizehn, am fünfzehnten Tag des Monats November.
Vor der unterzeichnenden Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft namens „Simple Global Education
S.A." abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Ge-
sellschaftssitz in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Nummer B 178763 (die "Gesellschaft"), gegründet am 5. Juli 2013, gemäß einer
notariellen Urkunde von Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association unter Nummer 2198, vom 9. September 2013 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") wurde zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître Jean-Paul Meyers, Notar
mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association
unter Nummer 2365, vom 25. September 2013 veröffentlicht wurde. Den Vorsatz hat Frau Andrea Donde. Zur Sekretärin
wird ernannt Frau Sonja Mayer-Fisch und die Versammlung nennt Frau Donder, vorbennant, als Stimmzählerin. Die Ge-
sellschafter der Gesellschaft sind hier vertreten durch Frau Andrea DONDER, aufgrund von vier Vollmachten ausgestellt
unter Privatschrift (die „Vertreterin"), welche Vollmachten welche „ne varietur" paraphiert, gegenwärtiger Urkunde bei-
gebogen wird, um mit derselben einregistriert zu werden.
Im Anschluss erklärte die Vertreterin und bat den Notar festzustellen dass:
I.- Die vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angegeben
sind (die "Aktionäre"). Diese Liste und die von der Vertreterin und dem Notar unterschriebene Vollmacht werden dieser
Urkunde ne varietur beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.
II.- Die Anwesenheitsliste zeigt, dass alle 80.000 (achtzigtausend) Namensaktien der Gesellschaft, die 100% des Ak-
tienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung vertreten sind, so dass die
Versammlung rechtsgültig konstituiert wurde und verbindlich über alle Angelegenheiten der Tagesordnung entscheiden
kann, über welche die Aktionäre im Voraus informiert wurden.
III.- Die Aktionäre erklären, dass sie sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert be-
trachten und auf die Einhaltung sämtlicher Einberufungsverfahren, d.h. insbesondere auf die Einberufung durch einges-
chriebenen Brief, verzichten.
IV.- Die Aktionäre erklären, dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 3.444,875 (dreitausendvierhundertvierundvierzig
Euro und achthundertfünfundsiebzig Cents) um es von seinem bisherigen Betrag in Höhe von EUR 31.000,- (einunddreißig-
tausend Euro) auf einen Gesamtbetrag von EUR 34.444,875 (vierunddreißigtausendvierhundert-vierundvierzig Euro und
achthundertfünfundsiebzig Cents) zu erhöhen und dies durch die Schaffung und Ausgabe von 8.890 (achttausendachthun-
dertneunzig) Namensaktien mit einem Nominalwert von jeweils EUR 0,3875 (dreitausendachthundert-fünfundsiebzig
Cents) (die „Neuen Aktien"), zusammen mit der Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von insgesamt 3.996.555,125 (drei-
millionenneunhundertsechsundneunzigtausendfünfhundertfünfund-fünfzig Euro und einhundertfünfundzwanzig Cents),
was einem Aufgeld in Höhe von EUR 449,55626 (vierhundertneunundvierzig Euro und fünfundfünfzigtausendsechshun-
dertsechsundzwanzig Cents) pro Aktie (das „Aufgeld") entspricht;
2. Zeichnung und vollständige Zahlung der Neuen Aktien einschließlich des Aufgeldes durch SCENTAN 0INVEST-
MENTS PTE. LTD, eine Gesellschaft nach dem Recht von Singapur, gegründet und bestehend unter den Gesetzen
Singapurs, registriert bei der Behörde über die Buchhaltung und die Regelung von Gesellschaften (Accounting and cor-
porate regulatory authority) unter der Nummer 20138099R, mit Geschäftssitz in 8, Eu Tong Seng Street #13-82 The
Central Singapore 059818 ("Scentan") in bar (EUR 4.000.000,00);
3. Entsprechende Änderung des Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung") wie folgt:
" 5.1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 34.444,875 (vierunddreißigtausendvierhundertvierundvierzig
Euro und achthundertfünfundsiebzig Euro Cents), eingeteilt in 88.890 (achtundachtzigtausendachthundertundneunzig)
Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 0,3875.
5.2. Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsauf-
gelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses
Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, zum Ausgleich
von Verlusten, zur Auszahlung an die Aktionäre oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage, sowie
für jede andere Maßnahme, soweit diese einstimmig von den Aktionären beschlossen wurde, verwendet werden."
6818
L
U X E M B O U R G
Die verbleibenden Regelungen des Artikels 5 der Satzung bleiben unberührt;
4. Änderung von Artikel 19.2 der Satzung wie folgt:
" 19.2. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird von den Delegierten durchgeführt, deren Mandat und
Vertretungsbefugnisse vom Verwaltungsrat festgelegt werden.
Die Gesellschaft wird darüber hinaus gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Per-
sonen, denen vom Verwaltungsrat besondere Vollmacht erteilt wurde, aber nur innerhalb der Grenzen dieser besonderen
Vollmacht, gebunden."
Die verbleibenden Regelungen des Artikels 19 der Satzung bleiben unberührt;
5. Änderung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg-Stadt nach Bertrange und daraus folgende Änderung des Artikel
2.1 der Satzung wie folgt:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bertrange (Großherzogtum Luxemburg)."
6. Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft von "SIMPLE GLOBAL EDUCATION S.A." in "The Simpleshow Com-
pany S.A." und daraus folgende Änderung des Artikel 1 der Satzung wie folgt:
"Namen: "The Simpleshow Company S.A.".";
7. Hinzufügen einer englischen Übersetzung der Satzung, welche Vorrang vor der deutschen Fassung haben soll;
8. Abberufung von Herrn Andreas Drexler, geboren am 19. November 1966 in Gomadingen, Deutschland, mit beru-
flicher Anschrift in Neuer Jungfernstieg 20, D-20354 Hamburg als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung;
9. Ernennung von Herrn Noriaki Okubo, managing director of Scentan Investments, geboren am 28 Oktober 1973 in
Tokyo, Japan, mit beruflicher Anschrift in 63A Tanjong Pagar road, Singapore, mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des
Verwaltungsrates für eine Dauer von 5 (fünf) Jahren, d.h. sein Mandat endet mit der Jahresversammlung welche im Jahre
2019 stattfinden wird;
10. Ermächtigung der Delegierten der Gesellschaft, den auf dem Aufgeldkonto der Gesellschaft befindlichen Geldbetrag
für Zwecke der täglichen Geschäftsführung, einschließlich des internationalen Roll-Outs, im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen zu verwenden;
11. Verschiedenes.
Nach sorgfältiger Beratung wurden sodann die folgenden Beschlüsse gefasst um jegliche Problematik der Dezimalzahlen
des Kapitals hinter dem Komma auszuschliessen und sich mit dem Gesetz in Einklang zu bringen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, den Nominalwert jeder Aktie zu annullieren und das Kapital der Gesellschaft um einen
Betrag von EUR 3.444,88 (dreitausendvierhundertvierundvierzig Euro und achtundachtzig Cents) zu erhöhen um es von
seinem bisherigen Betrag in Höhe von EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) auf einen Gesamtbetrag von EUR
34.444,88 (vierunddreißigtausendvierhundertvierundvierzig Euro und achtundachtzig Cents) zu erhöhen und dies durch
die Schaffung und Ausgabe von 8.890 Neuen Aktien ohne Nominalwert zusammen mit der Zahlung eines Aufgeldes in
Höhe von insgesamt 3.996.555,12 (dreimillionenneunhundertsechsundneunzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig Euro und
zwölf Cents).
<i>Zweiter Beschlussi>
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Aktionäre verzichten auf ihr Zeichnungsvorrecht.
Sämtliche achttausendachthundertneunzig (8.890) neuen Aktien wurden von der SCENTAN INVESTMENTS PTE.
LTD, eine Gesellschaft nach dem Recht von Singapur, gegründet und bestehend unter den Gesetzen Singapurs, registriert
bei der Behörde über die Buchhaltung und die Regelung von Gesellschaften (Accounting and corporate regulatory au-
thority) unter der Nummer 20138099R, mit Geschäftssitz in 8, Eu Tong Seng Street #13-82 The Central Singapore 059818
gezeichnet,
hier vertreten durch Frau Andrea DONDER, vorgenannt gemäss einer Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift, welche
„ne varietur" paraphiert, gegenwärtiger Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert zu werden.
Sämtliche achttausendachthundertneunzig (8.890) neuen Aktien wurden zu hundert (100%) Prozent zum Gesamtpreis
von dreitausendvierhundertvierundvierzig Euro und achtundachtzig Cents (EUR 3.444,88) gezeichnet und eingezahlt, zu-
sammen mit der Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von insgesamt 3.996.555,12 (dreimillionenneunhundertsechsundneun-
zigtausendfünfhundertfünfundfünfzig Euro und zwölf Cents).
Der Gesellschaft steht somit vorgenannter Betrag von vier Millionen Euro (EUR 4.000.000.-) ab heute zur Verfügung,
so wie dies dem amtierenden Notar bewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich annimmt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, Artikel 5 der Satzung wie folgt zu ändern:
6819
L
U X E M B O U R G
" 5.1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 34.444,88 (vierunddreißigtausendvierhundertvierundvierzig
Euro und achtundachtzig Euro Cents), eingeteilt in 88.890 (achtundachtzigtausendachthundert-undneunzig) Aktien ohne
Nominalwert.
5.2. Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsauf-
gelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses
Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Aktien, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, zum Ausgleich
von Verlusten, zur Auszahlung an die Aktionäre oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage, sowie
für jede andere Maßnahme, soweit diese einstimmig von den Aktionären beschlossen wurde, verwendet werden."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, Artikel 19.2 der Satzung wie folgt zu ändern:
" 19.2. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird von den Delegierten durchgeführt, deren Mandat und
Vertretungsbefugnisse vom Verwaltungsrat festgelegt werden.
Die Gesellschaft wird darüber hinaus gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Per-
sonen, denen vom Verwaltungsrat besondere Vollmacht erteilt wurde, aber nur innerhalb der Grenzen dieser besonderen
Vollmacht, gebunden."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, den Gesellschaftssitz von Luxemburg-Stadt nach 12, route de Longwy, L-8080 Bertrange,
zu verlegen und Artikel 2.1 der Satzung wie folgt zu ändern:
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bertrange (Großherzogtum Luxemburg)."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, die Bezeichnung der Gesellschaft von "SIMPLE GLOBAL EDUCATION S.A." in "The Sim-
pleshow Company S.A." sowie Artikel 1 und Artikel.2.Sitz. der Satzung wie folgt zu ändern:
I. Art.1. Bezeichnung. Namen. "The Simpleshow Company S.A.".
II. Art.2. Sitz. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft (nachfolgend die Gesellschaft") gegründet, die den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt. Die Aktien der Gesellschaft
können von einem einzelnen Aktionär oder von mehreren Aktionären gehalten werden. Die Gesellschaft firmiert unter
dem Namen " The Simpleshow Company S.A.".
<i>Siebter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, der Satzung eine englische Übersetzung hinzuzufügen. Diese englische Übersetzung soll
Vorrang vor der deutschen Fassung haben und wie folgt lauten-
„Name - Company base - Duration - Purpose
I. Art. 1. Designation. Name "The Simpleshow Company S.A. "
II. Art. 2. Registered office. Herewith a public company limited by shares (hereinafter the "Company") is incorporated,
which is subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the provisions of these articles of association. The
shares of the company may be held by one or more shareholders. The company operates under the name "The Simple-
show Company".
2.1 The registered office of the Company is in the municipality of Bertrange (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 The registered office can be changed to any other address within the municipality by resolution of the board of
directors, and to any other address within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the general meeting.
2.3 The delegate(s) of the board of directors have the power to establish branches, agencies and offices in the Grand
Duchy of Luxembourg as well as abroad.
2.4 If extraordinary events of a political, economic or social character occur or are imminent that might impair the
normal business at the registered office or smooth communication between such office and foreign countries, the reg-
istered office may temporarily be established abroad while preserving the Luxembourg nationality until the final
restoration of normal circumstances.
III. Art. 3. Duration. The duration of the Company is indefinite.
IV. Art. 4. Purpose of the Company.
4.1 Purpose of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in companies or entities of
any form, and the management of such participations. The Company may especially acquire all securities and rights through
the purchase of equity, by contribution, by way of subscription, purchase or exchange or any other form, any stock, shares
or other securities, bonds, debentures, and other debt and deposit receipts, generally any securities and financial instru-
ments that were issued by public or private companies, including partnerships of any kind. It may participate in the
6820
L
U X E M B O U R G
incorporation, development, management and control of any company or any entity. The Company may also invest in
the acquisition, management and trade in patents, trademark rights, the acquisition and allocation of licenses, sub-licenses
and similar rights under any name, and where necessary enforce the protection of the rights resulting from the acquisition
of these patents, trademark rights, licenses, sub-licenses and similar rights against any third party in case of infringement.
4.2 Purpose of the Company is also the acquisition and sale of products in the field of e-learning / e-education. The
Company carries out its activities entirely or partially through participations in other companies. Thus, the purpose of
the Company is also the acquisition of participations in whatever form in other domestic and foreign companies that are
operating in the fields of e-learning / e-education and all fields which serve this corporate purpose, as well as the man-
agement, control and development of these investments and making all other forms of investment.
4.3 Purpose of the Company is furthermore the taking over of the management of companies in the field of e-learning /
e-education.
4.4 The Company may grant the companies, in which it holds direct or indirect participations, or companies belonging
to the same group of companies as the Company, any kind of assistance, loans, advances and guarantees.
4.5 In addition, the Company may generally perform all transactions of industrial, commercial, financial, movable and
immovable nature, that are directly or indirectly related to or in conjunction with its purpose or with any similar or
related purposes, which can promote the expansion and development of the corporate purpose. In particular, the Com-
pany may take up loans.
Share capital - Shares
V. Art. 5. Share Capital.
5.1 The subscribed share capital amounts to EUR 34,444.88 EUR (thirty-four thousand four hundred fourty-four euros
and eighy-eight cents), divided into 88,890 (eighty-eight thousand eight hundred and ninety) shares without nominal value.
5.2 In addition to the share capital, a share premium account may be set up, into which any share premiums that are
paid for one share in addition to its nominal value are paid in. The amount of this share premium account may be used
for the payment of shares bought back by the Company from its shareholders, to cover losses, to make distributions to
the shareholders or to allocate funds to the legal reserve, as well as for any other means for as long as this has been
unanimously resolved by the shareholders.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or decreased in one or more steps through a
resolution of the general meeting. The resolution of the general meeting requires all votes. If the subscribed capital of
the Company is increased by means of a contribution in cash, each shareholder is entitled, but not obliged, to participate
in the capital increase in proportion to its participation in the existing share capital of the Company.
5.4 The Company may acquire its own shares in accordance with legal provisions.
VI. Art. 6. Shares.
6.1 Shares are in registered form.
6.2 The Company will recognize only one owner per share. In the event that a share belongs to more than one person,
the Company has the right to suspend the exercise of all the rights which are connected to this share, until a single owner
is designated to the Company; the same rules are applied in the event of a conflict between a usufructuary ("usufruitier")
and an owner ("nu-propriétaire") or between a pledgor and pledgee.
Share transfers - Lockup period
VII. Art. 7. Disposability.
7.1 The shares are freely transferable in principle, but subject to the following provisions of the articles of association.
7.2 The shareholders agree that they will hold their shares in the Company until at least 31 July 2016 ("lockup period").
The transfer of shares as well as any other disposal of shares (collectively "disposals") before expiration of the lockup
period are only permitted in accordance with Article 8, and after expiration of the lockup period only in accordance with
Article 9.
VIII. Art. 8. Before Expiration of the Lockup Period. A transfer of shares by a shareholder ("shareholder willing to sell")
before the expiration of the lockup period to another shareholder or to a third party is permitted only if all other
shareholders agree in writing beforehand.
IX. Art. 9. After Expiration of the Lockup Period. After expiration of the lockup period, the transfer of shares by a
shareholder willing to sell is permitted only in accordance with the following provisions:
9.1 The shareholder willing to sell has to offer the shares to be sold by him to the other shareholders for purchase,
stating the purchase price and other terms of purchase in writing by registered letter with acknowledgement of receipt.
9.2 If the other shareholders inform the shareholder willing to sell in writing within 6 (six) weeks from the receipt of
the offer that they are willing to accept the shares offered to them at these conditions, separate purchase and transfer
agreements between the shareholder willing to sell and the shareholder willing to purchase will come into effect upon
the receipt of the written statement by the shareholder willing to sell. If several shareholders accept the offer, the
shareholders willing to purchase acquire the shares in proportion of their shareholding in the Company. If a shareholder
6821
L
U X E M B O U R G
does not exercises his purchase right in a timely manner, his purchase right goes to that shareholder or shareholders
who have exercised their right to purchase in a timely manner in proportion to their shareholdings in the company. The
shareholder willing to sell shall notify all shareholders eligible to purchase within 2 (two) weeks after the deadline set by
out in the first sentence, which amount of shares a shareholder has acquired.
9.3 The full and unconditional payment of the purchase price and the entry in the register of shareholders is a condition
precedent to the transfer of the shares.
9.4 If no shareholder exercises the purchase right pursuant to paragraph 9.2, the shareholder willing to sell is entitled
to sell the shares to a third party for the price specified in section 9.1 or for a higher purchase price and under the
conditions offered to the shareholders or under conditions which are more favourable to the shareholder willing to sell;
all contractual agreements have to be contemplated separately. The shareholder willing to sell has to notify the other
shareholders in writing of the purchase price and the terms of purchase; considerations, which are not measured in
monetary terms are to be considered in terms of value. Upon request of another shareholder, the shareholder willing to
sell has to disclose all conditions agreed upon with the third party and submit the entire contract documentation to a
person designated by the other shareholder who is professionally sworn to secrecy. Should the person who is profes-
sionally committed to secrecy confirm that the requirements of the first sentence have been fulfilled, the shareholder
willing to sell is entitled to sell and transfer his shares to the third party. Otherwise, the shareholder willing to sell is not
entitled to do so.
9.5 Any other form of disposal is only permissible with the prior written consent of all shareholders.
X. Art. 10. Shareholders' Agreement. A transfer of shares in the Company requires in any case that the transferee
unconditionally joins the shareholders' agreement entered into by the shareholders and entirely accepts all rights and
obligations of the transferor arising from or in connection with the shareholders' agreement.
General meeting
XI. Art. 11. Convening the Meeting.
11.1 The convening of every general meeting is subject to legal requirements. This requirement may be waived if all
the shareholders are present or represented and if they declare having had knowledge of the items figuring on the agenda
in advance.
11.2 Every shareholder may exercise his voting right in person or through a representative, who does not need to be
a shareholder.
11.3 Every share entitles to one vote.
XII. Art. 12. Resolutions.
12.1 The resolutions of the general meeting are adopted by a simple majority of the votes cast, unless the law or these
articles of association provide for a different majority.
12.2 Resolutions which concern
12.2.1 Capital increases and decreases, issuance of option rights to future shares;
12.2.2 Mergers, divisions, change of form or other changes in the legal form of the Company;
12.2.3 the extension of the corporate purpose;
12.2.4 the conclusion of business contracts, particularly domination and / or profit transfer agreements;
12.2.5 Resolution on the allocation of profits in derogation of Article 13;
12.2.6 the dissolution of the Company;
12.2.7 other changes to the articles of association require a unanimous decision by the general meeting.
XIII. Art. 13. Powers.
13.1 The general meeting of shareholders has the broadest powers to discuss on all matters of the Company and to
take all resolutions pertaining thereto.
13.2 It decides on the allocation of the annual net profits.
13.3 Each year, 5% (five percent) of the net profits will be used for the creation of the legal reserve. This obligation
will be cancelled once the legal reserve has reached 10% (ten per cent) of the subscribed share capital. The obligation to
allocate funds to the legal reserve revives as soon as the reserve falls below 10% (ten per cent) of the subscribed share
capital.
13.4 As part of the allocation of profits, an amount equal to the annual net profits of the Company is distributed to
the shareholders in proportion to their shareholdings in the Company, to the extent that this is not contrary to section
17.3 of the shareholders' agreement or unless a deviating unanimous decision of the general meeting has been taken.
13.5 The board of directors is authorized to make advance payments on dividends in accordance with legal provisions.
6822
L
U X E M B O U R G
Board of directors
XIV. Art. 14. Term of Office.
14.1 The Company is managed by a board of directors, which in the case of only one individual shareholder may be
composed of at least 1 (one) member, in the case of several shareholders, the board of directors is composed of at least
three (3) members, who do not need to be shareholders.
14.2 The members of the board of directors are appointed by the general meeting of shareholders, which determines
their number and compensation, if any.
14.3 The appointment of the members of the board of directors shall be made for 5 (five) years and ends with the
general meeting, which decides on the discharge for the fifth year after the beginning of the term. Even after this time a
member of the board of directors remains in office until his successor is appointed. A multiple appointment of a member
of the board of directors is permitted.
14.4 Members of the board of directors may resign by giving written notice to the Chairman of the board of directors
with notice to the general meeting with a notice period of 4 (four) weeks.
14.5 If a member of the board of directors resigns before the expiry of his term of office, the remaining members of
the board of directors may appoint an interim successor. The next general meeting shall make the final appointment.
XV. Art. 15. Powers.
15.1 The board of directors has the broadest powers to perform all acts which are necessary for the realisation of
the corporate purpose or which promote this purpose. Any powers not expressly reserved by law or these articles of
association to the general meeting, fall within the competence of the board of directors.
15.2 The board of directors shall adopt its by-laws. The board of directors may establish committees whose compe-
tences are governed by the by-laws or pursuant to a resolution of the board of directors.
15.3 The board of directors may appoint a chairman and one or more deputy chairman/chairmen from among its
members.
15.4 In the event that a chairman or a deputy chairman resigns before the expiry of their term of office, the election
of a new chairman or deputy shall be done forthwith for the remaining term of office of the resigning member. The
successor shall be appointed at the beginning of the next meeting before the discussion of any other item on the agenda.
A special announcement of these elections in the convening notice is not required.
XVI. Art. 16. Meetings.
16.1 The meetings of the board of directors are usually held once every calendar quarter. The chairman of the board
of directors shall convene the meetings of the board of directors. He may instruct the delegates of the board of directors
to handle the convening.
16.2 The meeting shall be convened within a notice period of two (2) weeks in writing, by telex or electronic notice
(e-mail, etc.). In urgent cases, the notice period may be reduced to 3 (three) days. In calculating the notice period, the
date of dispatch of the notice and the day of the meeting are not included.
16.3 Each member of the board of directors has the right to request the convening of a meeting of the board of
directors. If the chairman of the board of directors does not comply with such a request within two (2) weeks, the
respective member of the board of directors is entitled to convene a meeting of the board of directors himself.
16.4 In the convening notice time and place of the meeting and the items on the agenda have to be indicated in such
a concrete manner that absent members of the board of directors can make use of their right to vote in writing. Especially
in transactions requiring approval, the required documents shall be made available in such a timely manner that each
member can prepare himself in an adequate manner for the subject-matter concerned. Items which have been commu-
nicated to the chairman of the board of directors by members of the board of directors no later than 1 (one) week before
the meeting, in case of convening of the meeting of the board of directors within a period of less than 2 (two) weeks no
later than 1 (one) day before the meeting, have to be put on the agenda.
16.5 In case that the convening of the meeting has not been done properly or items figuring on the agenda have not
been properly announced, a resolution may only be taken if no member of the board of directors objects. In such a case,
absent members of the board of directors shall be given the opportunity to agree with or to object to the resolution
subsequently within a reasonable period to be determined by the chairman. In this case, the resolution only becomes
effective if the absent members of the board of directors have agreed or not objected within such period.
XVII. Art. 17. Resolutions.
17.1 The board of directors shall only have a quorum if two-thirds of its members are present or represented; the
representation by another member of the board of directors, who has been authorised in writing or by telegraph, is
permitted. A member of the board of directors may represent one or more members of the board of directors.
17.2 In addition, the voting by a member of the board of directors can be done in writing for as long as the members
of the board of directors concerned can be clearly identified.
6823
L
U X E M B O U R G
17.3 In urgent cases written circular resolutions that are approved and signed by all the members of the board of
directors have the same effect as resolutions passed at the meeting of the board of directors. Such signatures may be
placed on one document or multiple copies of an identical resolution and be transmitted in writing or by telegraph.
XVIII. Art. 18. Majority. The resolutions taken by the board of directors shall be adopted by simple majority of the
votes cast, unless law, the articles of association or the shareholders' agreement provide otherwise. Abstentions are
considered as votes cast, but are not to be included in determining whether a decision has been taken with the required
majority.
Delegates
XIX. Art. 19. Delegates.
19.1 The board of directors may delegate its powers concerning the daily management and the representation of the
Company to one or more delegates (the "Delegates"), which may be members of the board of directors ("administrateurs
délégués"), but do not have to be.
19.2 The daily management of the Company is conducted by the Delegates whose mandates and powers of repre-
sentation are established by the board of directors.
The Company is further engaged towards any third person by the joint or sole signature of any person to whom special
power had been conferred by the board of directors but only within the limits of such special power.
19.3 The board of directors of the Company shall at its first meeting adopt by-laws for the Delegates.
19.4 The appointment and dismissal of a Delegate is done by means of a resolution of the board of directors with a
majority of two thirds of the votes cast.
Auditor
XX. Art. 20. Term of office. The Company is supervised by an auditor (commissaire aux comptes), which is appointed
by the general meeting. His term, which shall not exceed six (6) years, as well as any compensation shall be determined
by the general meeting. The auditor may at any time be revoked by the general meeting.
XXI. Art. 21. Rights. The auditor has an unlimited right of inspection and supervision over the entire activity of the
company. He may inspect the books, correspondence, logs, and generally all the documents of the Company at its reg-
istered office. He shall report to the annual regular general meeting on its findings and proposals, which are appropriate
in his view. The report also includes an indication of how the inventory of the Company has been verified.
Financial year - Annual financial statements
XXII. Art. 22. Financial Year. The financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.
XXIII. Art. 23. Annual Financial Statements.
23.1 Each year, at the end of the financial year, the Board will prepare the balance sheet in accordance with the legal
provisions.
23.2 The board of directors presents the annual financial statements together with its report and other documents,
which are required in accordance with legal provisions, to the auditor for inspection, who then drafts his report. The
presentation by the board of directors to the auditor shall be made in such a sufficient time that the report of the auditor
can be deposited at the time referred to in paragraph 23.3 at the Company's registered office for inspection by the
shareholders.
23.3 The balance sheet, the reports of the board of directors and of the auditor and all those documents which are
required by law, will be deposited 15 (fifteen) days before the annual general meeting at the registered office of the
Company where the shareholders can inspect these documents during normal office hours.
23.4 To the extent permitted under the legal provisions, the board of directors may give to shareholders upon request
information about the affairs of the Company and grant access to the books and records.
XXIV. Art. 24. General meeting.
24.1 The annual general meeting is held on the 6
th
day of June at 11:00 a.m. at the registered office of the Company
or at any other place specified in the convening notice of meeting.
24.2 If such day is a public holiday or a Sunday, the meeting will be held on the following business day.
Dissolution and liquidation
XXV. Art. 25. In case of dissolution of the Company, the liquidation is carried out by one or several liquidators, who
may be natural or legal persons and who are appointed by the general meeting. The general meeting decides on the
dissolution and determines the powers and remuneration of the liquidator / the liquidators.
Final provisions - Governing law
XXVI. Art. 26. The provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, including amendments, shall
apply to all areas where the present articles of association do not contain any other regulations."
6824
L
U X E M B O U R G
<i>Achter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, Herrn Andreas Drexler, geboren am 19. November 1966 in Gomadingen, Deutschland,
mit beruflicher Anschrift in Neuer Jungfernstieg 20, D-20354 Hamburg als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger
Wirkung abzuberufen.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, Herrn Noriaki Okubo, managing director of Scentan Investments, geboren am 28 Oktober
1973 in Tokyo, Japan, mit beruflicher Anschrift in 63A Tanjong Pagar road, Singapore, mit sofortiger Wirkung zum Mitglied
des Verwaltungsrates für eine Dauer von 5 (fünf) Jahren zu ernennen. Sein Mandat endet mit der Jahresversammlung
welche im Jahre 2019 stattfinden wird.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Aktionäre beschließen, dass die Delegierten der Gesellschaft den auf dem Aufgeldkonto der Gesellschaft befind-
lichen Geldbetrag für Zwecke der täglichen Geschäftsführung, einschließlich des internationalen Roll-Outs, im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen verwenden dürfen.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung vorgesehen ist und niemand mehr etwas vorbringen möchte, wird die Ver-
sammlung abgeschlossen.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit
Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: A. Donder et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 novembre 2013. Relation: LAC/2013/52663. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75.-).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Référence de publication: 2013165720/407.
(130202769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2013.
Noble Offshore (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.511.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
<i>Pour Noble Offshore (Luxembourg) S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2013178075/12.
(130216953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Nord Lux Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 108.803.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 17/12/2013.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2013178097/13.
(130216881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
6825
L
U X E M B O U R G
Dojolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 111.447.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2013.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2013178662/14.
(130217819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
DAVIN Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 101.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2013178670/10.
(130218516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Decopress SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 139.401.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2013178671/10.
(130218034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Delta Information Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8245 Mamer, 9B, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 110.023.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013178672/10.
(130218145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Deltservice S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 63.051.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013178673/10.
(130218538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
6826
L
U X E M B O U R G
Directsearch (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 11, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 83.886.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013174688/9.
(130213318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
EMDP LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 2, Chemins des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 182.497.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Patrick DUSSART, employé, né à Jemappe (Belgique), le 22 mars 1967, demeurant à B-6567 Merbes-sainte-
Marie, 36, rue François Bovesse
ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les
statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils constituent par la présente.
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à res-
ponsabilité limitée, telle qu'amendées ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "EMDP LUX S.à r.l.", (ci-après la "Société").
Art. 3. Le siège social est établi à Winseler.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social de l'accord des associés.
Art. 4. La Société a pour objet tous travaux de menuiserie et de construction dont:
- Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équi-
pements pour magasins, dormants de portes et fenêtres,...
Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds etc., en bois ou en matière plastique
Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., en bois ou en matière plastique
Montage de portes blindées et de portes coupe-feux, en bois ou en matière plastique
Montage de serres, de vérandas etc., en bois ou en matière plastique
Montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique: portes, fenêtres, dormants de portes et fenêtres, escaliers,
placards de cuisines équipées, équipements pour magasins etc.
Montage de cloisons mobiles; revêtement de murs, de plafonds etc., métallique
Montage de portes de garage métallique, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc.,
Montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique
Montage de serres, de vérandas métalliques, etc.,
Montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique
Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation, en verre
Montage de cloisons sèches à base de plâtre.
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Sciage et rabotage du bois.
Sciage, rabotage et façonnage du bois.
Travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées,
dérochement, destruction à l'explosif,...
6827
L
U X E M B O U R G
Travaux de plâtrerie, application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour
l'intérieur ou l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés
Production et montage de pièces forgées pour la construction: rampes d'escalier, balustrades,...
Fabrication de bassins pour piscines et pataugeoires.
Installation de piscines privées.
Pose de revêtements en bois de sols et de murs.
Pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de: parquets et autres revêtements de sols en bois,
revêtement de cloison en bois.
Nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux.
Autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.d.a.
Et services en matière de décoration d'intérieur, ainsi que la vente d'accessoires et d'objets relatifs à l'aménagement
d'intérieur.
Vente et placement de monuments funéraires.
La Société a également pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que par l'aliénation par vente, échange et toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La Société pourra prendre part à l'établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles,
liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,
sous réserve des dispositions légales afférentes.
D'une façon générale, la Société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- €), représenté par cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une seule part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits
afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et le créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. L'associé qui désire céder toutes ou partie de ses parts ou les héritiers d'un associé décédé devront en informer
la gérance par lettre recommandée, en indiquant le nombre de parts qu'ils se proposent de céder, le prix qu'ils en
demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l'acquisition de ces parts.
Cette lettre devra également contenir l'offre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder les parts
concernées aux autres associés au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de la part telle que
confirmée le cas échéant par une expertise d'un réviseur d'entreprises indépendant.
Dans la huitaine de la réception de cette lettre, la gérance transmet par lettre recommandée aux autres associés cette
proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces parts proportionnellement au nombre
de parts dont ils sont propriétaires.
L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer la gérance dans le mois de la réception de la
lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi, il sera déchu de son droit de préférence.
Dans la huitaine de l'expiration de ce dernier délai, la gérance avisera l'associé désireux de céder ses parts ou à l'héritier
ou aux héritiers de l'associé décédé, une lettre recommandée indiquant le nom des associés qui entendent exercer leur
droit de préférence, et le nombre de parts dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre de parts que la Société
rachètera elle-même.
A partir de la réception de cette lettre, l'associé, ou le ou les héritiers de l'associé décédé, seront libres de céder au
cessionnaire indiqué dans leur offre de cession de parts qu'ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les
autres associés ou la Société.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
6828
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
des assemblées générales.
Art. 11. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et rémunérations. Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs,
associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la Société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de
nomination.
Les pouvoirs du gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de la nomination. Le mandat de gérant lui est
confié jusqu'à révocation par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
La gérance ne peut constituer une hypothèque sur un immeuble social ni un nantissement sur un fonds de commerce
de la Société sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés, représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un
bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire dès que ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Tout associé peut prendre, au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l'assemblée ordinaire annuelle.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
La liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la
majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Patrick DUSSART.
Les parts sociales ayant été souscrites et libérées entièrement par les souscripteurs prédit moyennant un versement
en numéraire à hauteur de douze mille cinq cents euros (12 500,- EUR), de sorte que ladite somme de se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément;
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cent trente euros.
6829
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutionsi>
Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, s' est réuni en assemblée générale extraordinaire,
et a pris les résolutions suivantes:
1) Monsieur Marc EFFINIER, administrateur de société, né à Naninne, (Belgique), le 19 septembre 1961, demeurant à
L-9647 DONCOLS 2, Chemins des Douaniers est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée.
2) La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.
4) L'adresse du siège social de la Société est établie à L-9647 Doncols, 2, Chemins des Douaniers.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le mandataire des comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de
la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme
en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le mandataire des comparants.
DONT ACTE, fait et passé à junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2013. Relation GRE/2013/4771. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 décembre 2013.
Référence de publication: 2013174720/173.
(130213187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Double Benefit Bonds S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.410.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 5 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société DOUBLE BENEFIT
BONDS S.A..
Maître Tom Berend
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013174679/14.
(130213455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Spa Di Lantigos S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 68.409.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013177301/10.
(130215958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Promotion Marechal Nico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.472.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6830
L
U X E M B O U R G
<i>Pour PROMOTION MARECHAL NICO S.à.r.l.i>
Référence de publication: 2013177189/10.
(130216315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Car Classifieds Bangladesh S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 182.305.
Excerpts of the limited partnership agreement (the "Partnership Agreement") of Car Classifieds Ban-
gladesh S.C.Sp., a special limited partnership, executed on 27 November 2013
1. Partners who are jointly and severally liable. Classifieds (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 180.455 (the "General Partner").
2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: "Car Classifieds Bangladesh S.C.Sp." (the "Partnership").
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services
of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned
business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and Signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner.
The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement
and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (negligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 27
November 2013, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der
Car Classifieds Bangladesh S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (special Limi-
ted Partnership), abgeschlossen am 27. November 2013
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Classifieds (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 180.455 (die "Komplementärin").
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: " Car Classifieds Bangladesh S.C.Sp.".
(ii) Zweck der Gesellschaft
6831
L
U X E M B O U R G
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und
Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen an-
deren Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvert-
rages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin
gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 27. November 2013 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2013172044/77.
(130209575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.
Skydeck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.046.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2013, statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2012, que:
Suite à la démission de:
- Madame Mireille GEHLEN
Est élu en remplacement du Gérant démissionnaire et ceci pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 7 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013178219/17.
(130216517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Sagis Gallica S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 65.856.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 22 novembre 2013.i>
A savoir:
1. La nomination de Janet Rowe, avec adresse au Campagne L’Abbé, F-83111 Ampus, France, en tant qu’administrateur,
pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
6832
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013178230/14.
(130217002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Leisure Park Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 145.089.
In the year two thousand and thirteen, on the eight day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Leisure Park Holdings S.A., a public
limited liability company (société anonyme) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 145.089 (the Company).
The Company was incorporated on February 5, 2009 pursuant to a deed enacted by Maître Paul Bettingen, notary
residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 663, page 31792, dated March 26, 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have been
amended for the last time pursuant to a deed dated December 20, 2012 enacted by the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 591, page 28340, dated March 11, 2013.
The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints as secretary (the Secretary) and the Meeting elects as scrutineer, Solange Wolter, notary's
clerk, with professional address at Luxembourg (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Board of the Meeting.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and request the notary to record that:
I. The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of
shares they hold are shown on an attendance list, signed by the representative(s) of the Shareholders, the members of
the Board of the Meeting and the undersigned notary. The aforesaid list shall remain attached to the present minutes and
registered therewith. The proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the Board of the Meeting and
by the notary and shall be attached in the same way to the present deed.
II. As appears from the attendance list, the twenty million three hundred fifty-five thousand four hundred and ninety
(20,355,490) shares of the Company, with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each, representing the entire share
capital of the Company of an amount of two million thirty-five thousand five hundred and forty-nine euro (EUR 2,035,549)
are represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items
on the agenda hereinafter reproduced without the need of prior convening notices.
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. (i) redesignation of the existing shares of the Company into ordinary shares and (ii) creation of a new class of shares,
being the non-voting preferred shares having a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each (the Preferred Shares), will
have such rights and features as set out in the Articles as they are proposed to be amended in items 5., 6., 7., 8. and 9.
of this agenda, and creation of a share premium account in the books of the Company stapled to the Preferred Shares;
3. increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of six thousand six hundred and nine euro
(EUR 6,609) in order to bring the said share capital from its current amount of two million thirty-five thousand five
hundred and forty-nine euro (EUR 2,035,549), represented by twenty million three hundred fifty-five thousand four
hundred and ninety (20,355,490) ordinary shares with a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each, to an amount of
two million forty-two thousand one hundred and fifty-eight euro (EUR 2,042,158), by way of the issue of sixty-six thousand
and ninety (66,090) new Preferred Shares;
4. renunciation by the current shareholders' to their preferential subscription rights, subscription for the new Preferred
Shares and payment of the share capital increase specified under item 3. above;
5. amendment to article 5.1. of the Articles in order to reflect the creation and issuance of new Preferred Shares, as
proposed above;
6. amendment to article 6. of the Articles;
7. amendment to article 10. of the Articles;
8. amendment to article 14.2. of the Articles;
9. amendment to article 15.2. of the Articles;
10. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any director of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg, acting
6833
L
U X E M B O U R G
individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued Preferred Shares in the register
of shareholders of the Company; and
11. miscellaneous.
Now, therefore, the Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions which were
taken unanimously after deliberation:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting resolves to waive the convening
notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves (i) to redesignate the existing twenty million three hundred fifty-five thousand four hundred and
ninety (20,355,490) shares of the Company having a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each, into twenty million
three hundred fifty-five thousand four hundred and ninety (20,355,490) ordinary shares having a par value of ten euro
cents (EUR 0.10) each (the Ordinary Shares and individually, an Ordinary Share), and (ii) to create of a new class of shares,
being the non-voting preferred shares having a par value of ten euro cents (EUR 0.10) each (the Preferred Shares), which
will have such rights and features as set out in the Articles as they will be amended pursuant to the below resolutions,
and to create a share premium account in the books of the Company stapled to the Preferred Shares.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of six thousand six hundred
and nine euro (EUR 6,609) in order to bring the said share capital from its current amount of two million thirty-five
thousand five hundred and forty-nine euro (EUR 2,035,549), represented by twenty million three hundred fifty-five thou-
sand four hundred and ninety (20,355,490) Ordinary Shares, to an amount of two million forty-two thousand one hundred
and fifty-eight euro (EUR 2,042,158), by way of the issue of sixty-six thousand and ninety (66,090) new Preferred Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting acknowledges that the current shareholders unanimously waive their preferential subscription right and
resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase as follows:
<i>Subscription and paymenti>
1. Mr. Giovanni Pietro Cavalli, an Italian citizen, professionally residing at Vila-seca (Tarragona, Spain), avenida Alcalde
Pere Molas, autovia de Salou / Vila-seca, km. 2,
here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal, which power
of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration,
declares to subscribe to twenty-two thousand and thirty (22,030) newly issued Preferred Shares, having a par value
of ten euro cents (EUR 0.10) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash in an aggregate amount
of one hundred ninety-nine thousand eight hundred twelve euro and ten euro cents (EUR 199,812.10), of which (i) two
thousand two hundred and three euro (EUR 2,203) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company,
and (ii) the balance, i.e. one hundred ninety-seven thousand six hundred nine euro and ten euro cents (EUR 197,609.10)
to the share premium account of the Company stapled to the Preferred Shares.
2. Mr. Giovanni Modena, an Italian citizen, professionally residing at Vila-seca (Tarragona, Spain), avenida Alcalde Pere
Molas, autovia de Salou / Vila-seca, km. 2,
here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal, which power
of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration,
declares to subscribe to twenty-two thousand and thirty (22,030) newly issued Preferred Shares, having a par value
of ten euro cents (EUR 0.10) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash in an aggregate amount
of one hundred ninety-nine thousand eight hundred twelve euro and ten euro cents (EUR 199,812.10), of which (i) two
thousand two hundred and three euro (EUR 2,203) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company,
and (ii) the balance, i.e. one hundred ninety-seven thousand six hundred nine euro and ten euro cents (EUR 197,609.10)
to the share premium account of the Company stapled to the Preferred Shares.
3. Mr. Alfredo Bollini, an Italian citizen, professionally residing at Vila-seca (Tarragona, Spain), avenida Alcalde Pere
Molas, autovia de Salou / Vila-seca, km. 2,
here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal, which power
of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration,
6834
L
U X E M B O U R G
declares to subscribe to twenty-two thousand and thirty (22,030) newly issued Preferred Shares, having a par value
of ten euro cents (EUR 0.10) each and to have them fully paid up by way of a contribution in cash in an aggregate amount
of one hundred ninety-nine thousand eight hundred twelve euro and ten euro cents (EUR 199,812.10), of which (i) two
thousand two hundred and three euro (EUR 2,203) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company,
and (ii) the balance, i.e. one hundred ninety-seven thousand six hundred nine euro and ten euro cents (EUR 197,609.10)
to the share premium account of the Company stapled to the Preferred Shares.
The aggregate amount of five hundred ninety-nine thousand four hundred thirty-six euro and thirty euro cents (EUR
599,436.30) is forthwith at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles which shall be
reworded as follows:
" 5.1. The share capital is set at two million forty-two thousand one hundred and fifty-eight euro (EUR 2,042,158),
represented by twenty million three hundred fifty-five thousand four hundred and ninety (20,355,490) ordinary shares in
registered form, having a par value of ten cents (0.10) each (the Ordinary Shares and individually, an Ordinary Share),
and sixty-six thousand and ninety (66,090) non-voting preferred shares having a par value of ten euro cents (EUR 0.10)
each (the Preferred Shares and individually, a Preferred Share, and together with the Ordinary Shares, the Shares and
individually, a Share), all subscribed and fully paid."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting further resolves to amend article 6. of the Articles which shall be reworded as follows:
" Art. 6. Shares.
6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed
by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.
6.4. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.
6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law."
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting further resolves to amend article 10. of the Articles which shall be reworded as follows:
" Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting). The General
Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Each Ordinary Share entitles to one (1) vote.
(iii) The holders of the Preferred Shares shall not have any voting rights except in the circumstances described in article
46 of the Law (including but not limited to the matters listed below), in which case they will be entitled to one (1) vote
for each Preferred Share:
- the issuance of new shares carrying preferential rights;
- the determination of the preferential cumulative dividend attached to the Preferred Shares;
- the conversion of Preferred Shares into Ordinary Shares;
- the reduction of the capital of the company;
- any change to the corporate object of the company;
- the issuance of convertible bonds;
- the dissolution of the company before its term;
- the transformation of the company into a company of another legal form.
(iv) The holders of the Preferred Shares are entitled to receive the same information as the holders of the Ordinary
Shares in accordance with article 47 of the Law.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) Each holder of a Share is entitled to attend any meeting of the shareholders, but the holders of the Preferred Shares
are counted for the calculation of the quorum or of the majority required only for when they are entitled to vote in
accordance with article 10.1. (iii) above.
(ii) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.
6835
L
U X E M B O U R G
(iii) If all the shareholders (entitled to vote at the General Meeting) are present or represented and consider themselves
as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(iv) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order
to be represented at any General Meeting.
(v) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
(vi) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place
and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention are void.
(vii) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion
of the share capital represented.
(viii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-
sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Memorial and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate
the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the
proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be adopted by at least two-thirds of
the votes cast.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any). "
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting further resolves to amend article 14.2. of the Articles which shall be reworded as follows:
" 14.2.
(i) After the setting aside of part of the profits for the purpose of forming the legal reserve in the manner described
in the preceding paragraph, the holders of the Preferred Shares shall be entitled to receive, before any distribution is
made with respect to the Ordinary Shares, a fixed cumulative preferential dividend at the annual rate of 1% of the par
value of the Preferred Shares (the Preferred Dividend).
(ii) After the payments into the legal reserve and of the Preferred Dividend have been made in the manner described
in the preceding paragraphs, the General Meeting will have discretionary power to dispose of the surplus of the Company's
profits that are available for distribution. It may in particular allocate profits to the payment of a dividend, or transfer
them to the reserves or carry them forward. "
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting further resolves to amend article 15.2. of the Articles which shall be reworded as follows:
" 15.2. After payment of all debts and liabilities of the Company or the deposit of any funds as security to that effect,
the surplus assets of the Company will be distributed as follows to the shareholders:
(i) first, each holder of a Preferred Share shall be entitled to receive an amount per share corresponding to the total
of (i) the reimbursement of its contribution (apport) made at the time of its subscription; and (ii) the aggregate amount
of any accruals and/or unpaid amounts of Preferred Dividend (to be calculated down to and including the date of the
closing of any liquidation, and to include any unpaid Preferred Dividend entitlement carried forward from previous ac-
counting years in which such dividend was not or not fully paid);
(ii) thereafter, the balance of the surplus assets of the company will be distributed among the holders of the Ordinary
Shares in proportion to the number of such Ordinary Shares held by each such shareholder."
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorised any director of the Company and any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg,
acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued Preferred Shares in the
register of shareholders of the Company.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately two thousand one hundred Euros (EUR 2,100.-).
6836
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le huitième jour de novembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Leisure Park Holdings S.A., une
société anonyme constituée et organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
145.089 (la Société).
La Société a été constituée le 5 février 2009 suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven
(Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 663, page 31792,
du 26 mars 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 20 décembre
2012 du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 591, page 28340, du
11 mars 2013.
L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Pré-
sident).
Le Président nomme comme secrétaire (le Secrétaire) et l'Assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc
de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée par le(s) représentant(s) des Actionnaires, les membres
du Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant. Cette liste restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés seront paraphées ne varietur
par les membres du Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et resteront pareillement annexées au présent
acte.
II. Tel qu'il ressort de la liste de présence, les vingt millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-
dix (20.355.490) actions de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, représentant
la totalité du capital social de la Société d'un montant de deux millions trente-cinq mille cinq cent quarante-neuf euros
(EUR 2.035.549) sont représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut
statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après sans convocation préalable.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. (i) re-désignation des actions existantes de la Société en actions ordinaires et (ii) création d'une nouvelle classe
d'actions, soit les actions privilégiées sans droit de vote, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10)
chacune (les Actions Privilégiées), qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts qui font l'objet
d'une modification suivant les points 5., 6., 7., 8. et 9. du présent ordre du jour, et création d'un compte prime d'émission
dans les livres de la Société lié aux Actions Privilégiées;
3. augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de six mille six cent neuf euros (EUR 6.609) afin
de porter le capital social de son montant actuel de deux millions trente-cinq mille cinq cent quarante-neuf euros (EUR
2.035.549) représenté par vingt millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix (20.355.490) actions
ordinaires, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, à un montant de deux millions quarante-
deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 2.042.158), par l'émission de soixante-six mille quatre-vingt-dix (66.090)
nouvelles Actions Privilégiées;
4. renonciation par les actionnaires actuels à leurs droits préférentiels de souscription, souscription aux nouvelles
Actions Privilégiées et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 3. ci-dessus;
5. modification de l'article 5.1. des Statuts afin de refléter l'émission de nouvelles Actions Privilégiées telle que men-
tionnée ci-dessus;
6. modification de l'article 6. des Statuts;
7. modification de l'article 10. des Statuts;
8. modification de l'article 14.2. des Statuts;
6837
L
U X E M B O U R G
9. modification de l'article 15.2. des Statuts;
10. Modification du registre des actionnaires de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité donnés à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg,
agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des Actions Privilégiées nouvellement
émises dans le registre des actionnaires de la Société; et
11. divers.
Sur ce, l'Assemblée a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes, ayant été prises à l'unanimité
après délibération:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les
Actionnaires représentés à l'Assemblée se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée décide (i) de redésigner les vingt millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix
(20.355.490) actions existantes de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, en
vingt millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix (20.355.490) actions ordinaires (les Actions
Ordinaires, et individuellement, une Action Ordinaire) et (ii) de créer une nouvelle classe d'actions, soit les actions
privilégiées sans droit de vote, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune (les Actions Privi-
légiées), qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts, et de créer un compte prime d'émission
dans les livres de la Société lié aux Actions Privilégiées.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de six mille six cent neuf euros
(EUR 6.609) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux millions trente-cinq mille cinq cent quarante-
neuf euros (EUR 2.035.549) représenté par vingt millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix
(20.355.490) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, à un montant de
deux millions quarante-deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 2.042.158), par l'émission de soixante-six mille quatre-
vingt-dix (66.090) nouvelles Actions Privilégiées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la renonciation par les actionnaires actuels à leurs droits préférentiels de souscription et
décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l'augmentation du capital social:
<i>Souscription et libérationi>
1. Mr. Giovanni Pietro Cavalli, un citoyen italien, de résidence professionnelle à Vila-seca (Tarragona, Espagne), avenida
Alcalde Pere Molas, autovia de Salou / Vila-seca, km. 2,
ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ladite procuration,
après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,
déclare souscrire à vingt-deux mille trente (22.030) Actions Privilégiées nouvellement émises, ayant une valeur nomi-
nale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant
de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent douze euro et dix centimes d'euro (EUR 199.812,10), dont (i) deux mille
deux cent trois euros (EUR 2.203) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e.
cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent neuf euro et dix centimes d'euro (EUR 197.609,10) au compte prime d'émission
lié aux Actions Privilégiées.
2. Mr. Giovanni Modena, un citoyen italien, de résidence professionnelle à Vila-seca (Tarragona, Espagne), avenida
Alcalde Pere Molas, autovia de Salou / Vila-seca, km. 2,
ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ladite procuration,
après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,
déclare souscrire à vingt-deux mille trente (22.030) Actions Privilégiées nouvellement émises, ayant une valeur nomi-
nale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant
de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent douze euro et dix centimes d'euro (EUR 199.812,10), dont (i) deux mille
deux cent trois euros (EUR 2.203) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e.
cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent neuf euro et dix centimes d'euro (EUR 197.609,10) au compte prime d'émission
lié aux Actions Privilégiées.
3. Mr. Giovanni Modena, un citoyen italien, de résidence professionnelle à Vila-seca (Tarragona, Espagne), avenida
Alcalde Pere Molas, autovia de Salou / Vila-seca, km. 2,
6838
L
U X E M B O U R G
ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, ladite procuration,
après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement,
déclare souscrire à vingt-deux mille trente (22.030) Actions Privilégiées nouvellement émises, ayant une valeur nomi-
nale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant
de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent douze euro et dix centimes d'euro (EUR 199.812,10), dont (i) deux mille
deux cent trois euros (EUR 2.203) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e.
cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent neuf euro et dix centimes d'euro (EUR 197.609,10) au compte prime d'émission
lié aux Actions Privilégiées.
Le montant total de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente-six euro et trente centimes d'euro (EUR
599.436,30) est immédiatement à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura
désormais le libellé suivant:
" 5.1. Le capital social est fixé à deux millions quarante-deux mille cent cinquante-huit euros (EUR 2.042.158), repré-
senté par vingt millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix (20.355.490) actions ordinaires, ayant
une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune (les Actions Ordinaires, et individuellement, une Action
Ordinaire), et soixante-six mille quatre-vingt-dix (66.090) actions privilégiées sans droit de vote, ayant une valeur nominale
de dix centimes d'euro (EUR 0,10) chacune (les Actions Privilégiées, et individuellement, une Action Privilégiée, et en-
semble avec les Actions Ordinaires, les Actions, et individuellement, une Action), toutes souscrites et entièrement
libérées."
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide ensuite de modifier l'article 6. des Statuts, qui aura désormais le libellé suivant:
" Art. 6. Actions.
6.1. Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valable-
ment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une
acceptation par, la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme
preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.
6.4. Les Actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Action.
6.5. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi."
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide ensuite de modifier l'article 10. des Statuts, qui aura désormais le libellé suivant:
" Art. 10. Assemblées générales des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Géné-
rale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.
(ii) Chaque Action Ordinaire donne droit à un (1) vote.
(iii) Les porteurs d'Actions Privilégiées ne disposent pas de droits de vote, sauf dans les circonstances énumérées à
l'article 46 de la Loi (incluant, mais ne se limitant pas, aux décisions listées ci-dessous), auquel cas chaque Action Privilégiée
donne droit à un (1) vote:
- l'émission de nouvelles actions jouissant de droits privilégiés;
- la fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux Actions Privilégiées;
- la conversion d'Actions Privilégiées en Actions Ordinaires;
- la réduction du capital social de la Société;
- la modification de son objet social;
- l'émission d'obligations convertibles;
- sa dissolution anticipée;
- sa transformation en une société d'une autre forme juridique.
(iv) Les porteurs d'Actions Privilégiées ont le droit de recevoir les mêmes informations que les porteurs d'Actions
Ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Loi.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
6839
L
U X E M B O U R G
(i) Tout porteur d'Action a le droit de participer aux assemblée des actionnaires, mais les porteurs d'Actions Privilégiées
ne sont pris en compte pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer uniquement durant
les assemblées pour lesquelles ils disposent d'un droit de vote conformément aux dispositions de l'article 10.1 (iii) ci-
dessus.
(ii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(iv) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)
afin de le représenter à toute Assemblée Générale.
(v) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.
(vi) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote
indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
(viii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans
la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu)."
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée décide ensuite de modifier l'article 14.2. des Statuts, qui aura désormais le libellé suivant:
" 14.2.
(i) Après le prélèvement d'une partie des bénéfices affectés à la réserve légale conformément aux dispositions de
l'article précédent, les porteurs d'Actions Privilégiées bénéficieront, avant toute distribution aux porteurs d'Actions Or-
dinaires, d'un dividende privilégié cumulatif fixe à un taux annuel de 1% du prix d'émission de chacune des Actions
Privilégiées (le Dividende Privilégié).
(ii) Après les prélèvements affectés à la réserve légale et le paiement du Dividende Privilégié conformément aux
dispositions figurant aux paragraphes précédents, l'Assemblée Générale pourra décider souverainement de l'affectation
du solde restant des bénéfices disponibles en vue d'une distribution. L'assemblée pourra notamment décider de procéder
à la distribution de dividendes ou de transférer les profits dans des réserves ou de les reporter."
<i>Neuvième résolutioni>
L'Assemblée décide ensuite de modifier l'article 15.2. des Statuts, qui aura désormais le libellé suivant:
" 15.2. Après le paiement de toutes les dettes et passifs de la Société ou le dépôt de toutes sommes à titre de garantie
à cet effet, le surplus des actifs de la Société sera distribué entre les actionnaires de la façon suivante:
(i) en premier lieu, chaque porteur d'Action Privilégié aura droit à une somme par action s'élevant au total (i) du
remboursement de l'apport effectué lors de sa souscription; et (ii) de la somme totale de tout(s) produit(s) couru(s) et/
ou montant(s) impayé(s) de Dividende(s) Privilégié(s) (à calculer jusqu'au jour (inclus) de la clôture de la liquidation et
comprenant tout droit à des Dividendes Privilégiés impayés ayant fait l'objet d'un report à nouveau à partir des années
comptables antérieures pour lesquelles un tel dividende n'était pas -ou pas entièrement- payé);
(ii) en second lieu, le solde du surplus des actifs de la Société sera distribué entre les détenteurs des Actions Ordinaires
proportionnellement au nombre de ces Actions Ordinaires respectivement détenues par chacun desdits actionnaires."
<i>Dixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus et donnent pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats
6840
L
U X E M B O U R G
à Luxembourg, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des Actions Privilé-
giées nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, s'élèvent à environ deux mille cent Euros (EUR 2.100.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en Anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la
version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux membres du bureau, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2013. Relation: LAC/2013/51866. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2013.
Référence de publication: 2013170935/458.
(130208688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 112.881.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2013177751/14.
(130216632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Eurofinancial Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 163.194.
Il est porté à la connaissance des tiers que WINDSTORM - COMÉRCIO INTERNACIONAL, SOCIEDADE UNIPES-
SOAL LDA., associé de la société EUROFINANCIAL INVESTMENT S.à r.l, a changé de forme juridique et de dénomi-
nation sociale en date du 30 novembre 2011 et s'appelle, depuis cette date, EUROFINANCIAL GROUP S.à r.l., et dont
le siège social se situe au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUROFINANCIAL INVESTMENT S.à r.l.
Référence de publication: 2013177749/14.
(130216577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
6841
L
U X E M B O U R G
Noramco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7640 Christnach, 9, Fielserstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 104.039.
L'an deux mille treize, le trente novembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie:
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Noramco International S.à r.l.
(la «Société»), ayant son siège social à L-7640 Christnach, 9, Fielserstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 104.039, constituée suivant acte notarié en date du 23 janvier 1995, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 253 du 12 juin 1995 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1753 du 10 décembre 2002.
L'assemblée est ouverte à 19.11 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse
professionnelle à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, employé privé, avec adresse professionnelle à L-5612 Mon-
dorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Karola Böhm, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2134
Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l'assemblée générale décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation avec effet au 1
er
décembre 2013.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de nommer, avec effet au 1
er
décembre 2013, Monsieur
Paul Becker, né à Luxembourg, le 23 mars 1959, demeurant à L-7640 Christnach, 9, Fielserstrooss, comme liquidateur
de la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les
cas où elle est normalement requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevées, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
6842
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19.22 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, C. Oberhag, K. Bôhm, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 03 décembre 2013. REM/2013/2111. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 06 décembre 2013.
Référence de publication: 2013172486/65.
(130209701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2013.
Entreprise de Construction Erpelding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3233 Bettembourg, 26, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 24.570.
Les Comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen le 19/12/2013.
<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2013177719/12.
(130217488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Illinois Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 50.921.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2013177876/11.
(130216665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Fibart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 100.742.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013177789/10.
(130217561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Fu Dou Lou Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4480 Belvaux, 105, Chemin Rouge.
R.C.S. Luxembourg B 151.906.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013177808/10.
(130217063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
6843
L
U X E M B O U R G
Energylux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9690 Watrange, 17B, rue Abbé Welter.
R.C.S. Luxembourg B 159.745.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2012 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 20/12/2013.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2013178724/13.
(130218681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
DSV HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 32.882.776,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 93.010.
Les comptes annuels au 30 Avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DSV Holdco S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013178686/11.
(130218543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Minpark S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.647.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2013.
Référence de publication: 2013177028/10.
(130215344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Sibret Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 116.576.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013178257/10.
(130216890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Supercell S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 143.373.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178281/10.
(130217260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
6844
L
U X E M B O U R G
SL Lux Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 147.389.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg de manière extraordinaire en date du 29 novembrei>
<i>2013i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société Ernst & Young S.A., ayant
son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle,
qui se tiendra en 2014, approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.
Pour extrait conforme
SL Lux Investment S.C.A.
Représentée par SL Lux S.A.
Référence de publication: 2013178260/16.
(130217099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Société Immobilière de l'Arsenal, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 6.239.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26/11/2012.
Société Immobilière de l'Arsenal
Société à responsabilité limitée
Philippe GRUMBERG / Jean-Paul Rossignon
Référence de publication: 2013178222/13.
(130216615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Services Touristiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.949.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire du 13 septembre 2013 que le mandat des organes sociaux
venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) administrateursi>
- Dott. Gabrîeie BRAVI, gérant de sociétés, demeurant à Los Palos Grandes Caracas (Venezuela), 16F, Altamira Suites,
Apto 16F, YV
- Monsieur Filippo DOLLFUS DE VOLKERSBERG, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano,
1, Via Degli Amadio (Suisse)
- Monsieur Nicolas SCHAEFFER jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue
de la Porte-Neuve.
<i>b) commissaire aux comptesi>
- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2018.
Luxembourg, le 13 septembre 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2013178249/25.
(130216905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
6845
L
U X E M B O U R G
ATG Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 44.860,50.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 181.739.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of the month of November.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
- P6A S.à r.l, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg ("RCS") under number B171.590 represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, profes-
sionally residing in Luxembourg pursuant a proxy dated 26 November 2013 (such proxy to be registered together with
the present deed),
- ATGM S.à r.l, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg and registered with the RCS under number B 181.782
represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, professionally residing in Luxembourg pursuant a proxy
dated 26 November 2013 (such proxy to be registered together with the present deed),
P6A S.àr.l., prenamed, being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of ATG Luxco S.àr.l. (the "Company"), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, incorporated by deed
of the undersigned notary, on 7 November 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
and registered with the RCS under number B 181739.
The appearing parties declared and requested the notary to record that:
1. The Sole Shareholder holds all fifteen thousand (15,000) shares in issue in the Company so that decisions can validly
be taken on all items of the agenda.
2. The items on which resolutions were to be passed are as follows:
<i>Agendai>
1. To amend the nominal value of the shares to one Pound Sterling (GBP 1) to five pence Sterling (GBP 0.05) so that
the share capital is represented by three hundred thousand (300,000) shares with a nominal value of five pence Sterling
(GBP 0.05);
2. To create two (2) classes of shares namely class A1 shares and class A shares and reclassify the existing three
hundred thousand (300,000) shares into three hundred thousand (300,000) class A1 shares;
3. To increase the issued share capital of the Company from its current amount of fifteen thousand Pounds Sterling
(GBP 15,000) to forty-four thousand eight hundred sixty Pounds Sterling andfifty pence (GBP 44,860.50) by the issue of
five hundred ninety-seven thousand two hundred ten (597,210) class A shares of a nominal value of five pence Sterling
(GBP 0.05) (together the "New Shares"), for a total subscription price of eight hundred sixteen thousand one hundred
eighty-seven Pounds Sterling (GBP 816,187) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares and payment of
the Subscription Price by the subscribers by way of a contribution in cash; allocation of the nominal value of the New
Shares of an amount of twenty-nine thousand eight hundred sixty Pounds Sterling and fifty pence (GBP 29,860.50) so
issued to the share capital and an amount of seven hundred eighty-six thousand three hundred twenty-six Pounds Sterling
and fifty pence (GBP 786,326.50) to the freely distributable share premium account relating to the class A shares;
4. To amend and restate article 5 of the articles of association of the Company, to reflect the increase of the share
capital of the Company as set forth below:
" Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
The issued and fully paid up share capital of the Company is set at forty-four thousand eight hundred sixty Pounds
Sterling and fifty pence (GBP 44,860.50) represented by (i) three hundred thousand (300,000) class A1 shares and (ii) five
hundred ninety-seven thousand two hundred ten (597,210) class A shares each with a nominal value of five pence Sterling
(GBP 0.05) and such rights, obligations and terms as set forth in the articles." After consideration the Sole Shareholder
took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the nominal value of the shares to one Pound Sterling (GBP 1.-) to five pence
Sterling (GBP 0.05.-) so that the share capital is represented by three hundred thousand (300,000) shares with a nominal
value of five pence Sterling (GBP 0.05.-).
6846
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to two (2) classes of shares namely class A1 shares and class A shares and to reclassify
the existing three hundred thousand (300,000) shares into three hundred thousand (300,000) class A1 shares.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of fifteen
thousand Pounds Sterling (GBP 15,000.-) to forty-four thousand eight hundred sixty Pounds Sterling and fifty pence (GBP
44,860.50.-) by the issue of five hundred ninety-seven thousand two hundred ten (597,210) class A shares of a nominal
value of five pence Sterling (GBP 0.05.-) each (the "New Shares") for an aggregate subscription price of eight hundred
sixteen thousand one hundred eighty-seven Pounds Sterling (GBP 816,187) (the "Subscription Price") paid as follows:
Subscribers
Number of
class A
shares to
be
subscribed
Amount of the contribution in cash
in GBP
P6A S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
552,960
GBP 755,712.- of which GBP
728,064.- shall be allocated to the
share premium account relating to
class A shares
ATGM S.à r.l.,prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,250
GBP 60,475.- of which GBP
58,262.50.- shall be allocated to
the share premium account
relating to class A shares
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597,210
GBP 816,187.-
Evidence of the payment of the Subscription Price to the Company was shown to the undersigned notary.
It is resolved to allocate an amount of twenty-nine thousand eight hundred sixty Pounds Sterling and fifty pence (GBP
29,860.50.-) so issued to the share capital and an amount of seven hundred eighty-six thousand three hundred twenty-
six Pounds Sterling and fifty pence (GBP 786,326.50.-) to the freely distributable share premium account relating to the
class A shares.
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to amend and restate article 5 of the articles of association of the Company in order to provide for the
above resolution in the form set forth in item 4 of the agenda.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand three hundred Euro (€ 2,300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing party,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxyholder known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing party's proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-septième jour du mois de novembre.
Par-devant nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- P6A S.àr.l, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg, dont
le siège social est situé au 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg («RCS») sous le numéro B171.590 représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en
droit, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration datée du 26 novembre 2013 (cette procuration sera enregistrée
avec le présent acte),
- ATGM S.àr.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg,
dont le siège social est situé au 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg et enregistré auprès du RCS de Luxembourg sous
le numéro B 181.172 représentée par M
e
Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant à Luxembourg en vertu
d'une procuration datée du 26 novembre 2013 (cette procuration sera enregistrée avec le présent acte).
6847
L
U X E M B O U R G
P6A S.àr.l, précitée, étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de ATG Luxco S.à r.l. (la «Société»), une société à
responsabilité limitée dont le siège social est situé au 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, constituée par acte du notaire
soussigné, le 7 novembre 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et immatriculée
auprès du RCS sous le numéro B 181739.
Les parties comparantes ont déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. l'Associé Unique détient la totalité des quinze mille (15.000) parts sociales émises par la Société de sorte que des
décisions peuvent être prises valablement sur tous les points à l'ordre du jour.
2. Les points sur lesquels les décisions seront prises sont les suivants:
<i>Ordre du jouri>
1. Modifier la valeur nominale des parts sociales d'une Livre Sterling (1 GBP) à cinq pence (0,05 GBP) afin que le capital
social soit représenté par trois cent mille (300.000) parts sociales avec une valeur nominale de cinq pence (0,05 GBP);
2. Créer deux (2) classes de parts sociales à savoir les parts sociales de classe A1 et les parts sociales de classe A et
de reclassifier les trois cent mille (300.000)parts sociales existantes en trois cent mille (300.000)parts sociales de classe
A1.
3. Augmenter le capital social de la Société émis de son montant actuel de quinze mille Livres Sterling (15.000 GBP) à
quarante-quatre mille huit cent soixante Livres Sterling et cinquante pence (44.860,50 GBP) par l'émission de cinq cent
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent dix (597.210) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de cinq pence (0,05
GBP) (ensemble les «Nouvelles Parts Sociales»), pour un prix de souscription total de huit cent seize mille cent quatre-
vingt-dix-sept Livres Sterling (816.187 GBP) (le «Prix de Souscription»); souscription des Nouvelles Parts Sociales et
paiement du Prix de Souscription par l'Associé Unique par apport en numéraire; attribution de la valeur nominale des
Nouvelles Parts Sociales d'un montant de vingt-neuf mille huit cent soixante Livres Sterling et cinquante pence (29.860,50
GBP) émises au capital social et un montant de sept cent quatre-vingt-six mille trois cent vingt-six Livres Sterling et
cinquante pence (786.326,50 GBP) au compte de prime d'émission librement distribuable relative aux parts sociales de
classe A;
4. Modifier et reformuler l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social de la Société
comme indiqué ci-dessous:
« Art. 5. Capital social.
5.1 Capital social émis
Le capital social émis et intégralement libéré de la Société est fixé à quarante-quatre mille huit cent soixante Livres
Sterling et cinquante pence (44.860,50 GBP) représenté par (i) trois cent mille (300.000) parts sociales de classe A1 et
(ii) cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent dix (597.210) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de cinq
pence (0,05 GBP) chacune et assorties des droits et obligations énoncés dans les statuts.»
Après avoir dûment examiné les points portés à l'ordre du jour ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier la valeur nominale des parts sociales d'une Livre Sterling (1,- GBP) à cinq pence
(0,05 GBP) afin que le capital social soit représenté par trois cent mille (300.000) parts sociales avec une valeur nominale
de cinq pence (0,05 GBP).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de créer deux (2) classes de parts sociales à savoir les parts sociales de classe A1 et les
parts sociales de classe A et de reclassifier les trois cent mille (300.000) parts sociales existantes en trois cent mille
(300.000) parts sociales de classe A1.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société émis de son montant actuel de quinze mille Livres
Sterling (15.000,- GBP) à quarante-quatre mille huit cent soixante Livres Sterling et cinquante centimes (44.860.50,- GBP)
par l'émission de cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent dix (597.210) parts sociales de classe A d'une valeur
nominale de cinq pence (0,05 GBP) (ensemble les «Nouvelles Parts Sociales»), pour un prix de souscription total de huit
cent seize mille cent quatre-vingt-sept Livres Sterling (816.187,- GBP) (le «Prix de Souscription») payé comme suit:
6848
L
U X E M B O U R G
Souscripteurs
Nombre
de parts
sociales
de classe A
à souscrire
Montant de la contribution en
numéraire en GBP
P6A S.àr.l., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
552.960 755.712,- GBP desquels 728.064,-
GBP devront être alloués au
compte de prime d’émission relatif
aux parts sociales de classe A
ATGM S.àr.l., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.250
60.475,- GBP desquels 58.262,50
GBP devront être alloués au
compte de prime d’émission relatif
aux parts sociales de classe A
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597.210
816.187,- GBP
Preuve du paiement du Prix de Souscription à la Société a été montrée au notaire soussigné.
Il est décidé d'allouer un montant de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales d'un montant de vingt-neuf mille
huit cent soixante Livres Sterling et cinquante pence (29.860,50 GBP) émises au capital social et un montant de sept cent
quatre-vingt-six mille trois cent vingt-six Livres Sterling et cinquante pence (786.326,50 GBP) au compte de prime d'émis-
sion librement distribuable relatif aux parts sociales de classe A.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de modifier et reformuler l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la résolution ci-dessus dans
les formes indiquées au point 4 de l'ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société, sont
estimés à deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire
par nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Hermelinski-Ayache, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53998. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 4 décembre 2013.
Référence de publication: 2013172907/195.
(130211349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Gare Participations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 45.722.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013176759/11.
(130215764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
6849
L
U X E M B O U R G
Electricité SAND Jacques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7570 Mersch, 90, Rue Nic Welter.
R.C.S. Luxembourg B 99.258.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013178694/10.
(130218269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Real Estate Classifieds Asia Extra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 182.394.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies' Register, under number B 177.038,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 20 November 2013, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 21 No-
vember 2013; and
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Berlin, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 20 November 2013.
Said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Real Estate Classifieds Asia Extra S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
6850
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Duration.
3. 1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
6851
L
U X E M B O U R G
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14 Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
6852
L
U X E M B O U R G
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
6853
L
U X E M B O U R G
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2013.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed as follows:
- Twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) shares have been subscribed by Asia Internet Holding S.a r.l.,
aforementioned, for the price of twelve thousand four hundred ninety-nine euros (EUR 12,499);
- One (1) share has been subscribed by Bambino 53. V V UG (haftungsbeschrankt), aforementioned, for the price of
one euro (EUR 1).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
6854
L
U X E M B O U R G
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; and
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am achtundzwanzigsten November.
V uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.038,
hier vertreten durch Alix van der Wielen, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
ausgestellt in Berlin, Deutschland, vom 20. November 2013, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 21.
November 2013; und
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Berlin, unter der Nummer HRB 126893 B, mit
Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
hier vertreten durch Alix van der Wielen, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 20. November 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.
Besagte Vollmachten, welche von der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchten:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Real Estate Classifieds Asia Extra S.à r.l. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
6855
L
U X E M B O U R G
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten durch
Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
6856
L
U X E M B O U R G
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
6857
L
U X E M B O U R G
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-
schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Geschäftsführungsrats nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
6858
L
U X E M B O U R G
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungs-
rates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unter-
schrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und Andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
6859
L
U X E M B O U R G
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2013.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
- Zeichnung von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Anteilen durch Asia Internet Holding S.à r.l., vor-
benannt, zum Preis von zwölftausendvierhundertneunundneunzig Euro (EUR 12.499);
- Zeichnung von einem (1) Anteil durch Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), vorbenannt, zum Preis von einem
Euro (EUR 1).
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichten, haben daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; und
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
6860
L
U X E M B O U R G
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2013. Relation: LAC/2013/54487. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions. erteilt.
Luxemburg, den 9. Dezember 2013.
Référence de publication: 2013173529/603.
(130211129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Thea Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 178.900.
L'an deux mille treize.
Le vingt-cinq novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée THEA PARTICIPA-
TIONS S.à r.l. (ci-après "la Société"), avec siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue (Grand-Duché de
Luxembourg), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 178.900, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean SECKLER, préqualifié, en date du 26 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2221 du 11 septembre 2013.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Françoise HÜBSCH, employée, demeurant professionnellement
à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,
demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social d'un montant de 34.700,- EUR pour le porter de son montant actuel de 679.900,-
EUR à 714.600,- EUR, par la création et l'émission de 347 parts sociales nouvelles de 100,- EUR de valeur nominale
chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
2. - Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises.
3. - Modification afférente de l'article six, alinéa premier, des statuts.
II. - Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bureau
et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres
du bureau et le notaire instrumentant.
III. - Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors,
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les
associés ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.
IV. - Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente quatre mille sept cents euros
(34.700,- EUR) pour le porter de son montant actuel de six cent soixante dix neuf mille neuf cents euros (679.900,- EUR),
à sept cent quatorze mille six cents euros (714.600,-EUR), par la création et l'émission de trois cent quarante sept (347)
parts sociales nouvelles de cent euros (EUR 100,-) de valeur nominale chacune, jouissant des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.
Les parts sociales nouvellement émises sont souscrites et libérées entièrement par Monsieur Antoine WINCKLER,
dirigeant de société, né à Lyon (France), le 13 juillet 1974, demeurant à Sofitel Marrakech, rue Haroun Errachid Hivernage,
40000 Marrakech (Maroc), par un apport réalisé en nature de parts sociales d'une société ayant son siège social dans un
Etat membre de l'Union Européenne, tel que ci-après:
6861
L
U X E M B O U R G
<i>Description de l'apport en naturei>
Deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d'une valeur nominale d'environ quinze euros et vingt quatre cents (15,24
EUR) chacune, de la société à responsabilité limitée de droit français "COQ DE BRUYERE", établie et ayant son siège
social à F-73120 Courchevel 1850, Park City Saint-Bon-Tarentaise, R.C.S. Chambéry numéro 383 803 111, avec un capital
souscrit de sept cent quatre vingt cinq mille cent douze euros et quarante quatre cents (785.112,44 EUR), c'est à dire
environ quatre virgule quatre vingt cinq pour cent (4,85 %) de la totalité de ses parts sociales émises.
Cet apport a fait l'objet d'une évaluation établie préalablement aux présentes en date du 22 novembre 2013 par Madame
Sylvie JORIOZ, épouse MUGNIER, gérante de la société "COQ DE BRUYERE", de laquelle il ressort que ledit apport est
évalué à la somme de trente huit mille cent douze euros et vingt cinq cents (38.112,25 EUR).
Il est précisé que l'attribution des trois cent quarante sept (347) nouvelles parts sociales à Monsieur Antoine WINC-
KLER, en contrepartie de l'apport en nature décrit ci-dessus, sera assortie d'une soulte en espèces d'un montant de trois
mille quatre cent douze euros et vingt cinq cents (3.412,25 EUR).
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et des documents
sociaux de "COQ DE BRUYERE" attestant le nombre actuel de parts sociales et leur appartenance actuelle dans le chef
de l'apporteur.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Monsieur Antoine WINCKLER, apporteur, a déclaré que:
- toutes les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- ces parts sociales sont sous forme nominative;
- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possède le pouvoir d'en disposer;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en
acquérir une ou plusieurs;
- ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes formalités seront réalisées dans les Etats respectifs aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective
partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Rapport d'évaluationi>
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de gérante
de la société "COQ DE BRUYERE" à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, Madame Sylvie JORIOZ, épouse MU-
GNIER, marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de
la propriété desdites parts sociales et confirme la validité des souscription et libération.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre Monsieur Antoine WINCKLER, préqualifié, à la souscription des trois cent quarante
sept (347) parts sociales nouvelles.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite Monsieur Antoine WINCKLER, préqualifié, ici représenté par son mandataire en vertu d'une pro-
curation, pour la souscription des trois cent quarante sept (347) parts sociales nouvelles, lequel a déclaré souscrire lesdites
parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par l' apport en nature ci-avant détaillé.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura doré-
navant la teneur suivante:
" Art. 6. (Alinéa premier). Le capital social est fixé à 714.600,- EUR (sept cent quatorze mille six cents euros), représenté
par 7.146 (sept mille cent quarante six) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune."
<i>Estimation - Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués
approximativement à la somme de 1.200,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
6862
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2013. Relation GRE/2013/4799. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 12 décembre 2013.
Référence de publication: 2013173663/99.
(130211939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Marcuni S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 51.199.
<i>Extrait des résolutions prises par le liquidateur de la société en date du 17 décembre 2013i>
Le siège social de la société est transféré au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
MARCUNI S.A. en liquidation
FINANCIERE DE LATOUR S.à.r.l.
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2013177009/13.
(130215522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Mittelmeer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 132.507.
EXTRAIT
La société Mittelmeer SA communique la mise à jour des coordonnées des administrateurs de catégorie B et des
coordonnées du commissaire aux comptes:
1) Mise à jour de l'adresse de:
FREDERIC FRABETTI, administrateur de catégorie B, né le 26 février 1969 à Metz (France) est domicilié profession-
nellement à
L-2520 Luxembourg, 21-25 Allée Scheffer.
2) Mise à jour de l'adresse de:
CLAUDE KARP, administrateur de catégorie B, né le 11 octobre 1972 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) est domicilié
professionnellement à
L-8069 Strassen, 30 rue de l'Industrie.
3) Mise à jour de l'adresse de:
FEGON INTERNATIONAL SA, commissaire aux comptes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro RC B 72287, est sise à
L-8561 Schwebach, 1 Haaptstrooss.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
Sandra Cortinovis / Frédéric Frabetti / Claude Karp
<i>Administrateur, catégorie A / Administrateur, catégorie B / Administrateur, catégorie Bi>
Référence de publication: 2013176996/26.
(130215315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Cottonita Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 96.935.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la Société qui s’est tenue en date
du 16 décembre 2013 au siège social que:
6863
L
U X E M B O U R G
- L’Actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Fabrice Huberty de sa fonction d’administrateur en
date du 12 décembre 2013.
- L’Actionnaire unique a résolu de nommer Monsieur Michel De Groote, résidant 48 rue de Bragance L-1255 Luxem-
bourg en qualité d’Administrateur de la société, son mandat prenant effet rétroactivement le 12 décembre 2013 et se
terminant lors de l’Assemblée Générale Annuelle devant se tenir en 2014.
Référence de publication: 2013178644/15.
(130218040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Siola S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 46.799.
En date du 16 décembre 2013, le mandat de Maître Pierre Berna comme administrateur et président du conseil
d'administration a été renouvelé.
Son mandat prendra fin avec l'assemblée générale de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Siola SA
Référence de publication: 2013177284/12.
(130215733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Zimfi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 78.594.
Les Comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 17/12/2013.
<i>Pour ZIMFI SPF S.A.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2013177424/12.
(130215318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
C.P.S.L. (Concrete Project Services Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 115.964.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/12/2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013178575/12.
(130218701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Wistaria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 46.730.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WISTARIA SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2013179336/11.
(130218197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
6864
ATG Luxco S.à r.l.
Car Classifieds Bangladesh S.C.Sp.
Cottonita Investments S.A.
C.P.S.L. (Concrete Project Services Luxembourg) S.à r.l.
DAVIN Luxembourg SA
Decopress SA SPF
Delta Information Technologies S.A.
Deltservice S.à.r.l.
Directsearch (Luxembourg) Sàrl
Dojolux S.à r.l.
Double Benefit Bonds S.A.
DSV HoldCo S.à r.l.
Electricité SAND Jacques S.à r.l.
EMDP LUX S.à r.l.
Energylux
Entreprise de Construction Erpelding S.à r.l.
Eurofinancial Investment S.à r.l.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.
Fibart S.A.
Fu Dou Lou Sàrl
Gare Participations
Illinois Holding S.A.
Leisure Park Holdings S.A.
Marcuni S.A.
Minpark S.A.
Mittelmeer S.A.
Noble Offshore (Luxembourg) S.à r.l.
Noramco International S.à r.l.
Nord Lux Immo S.A.
Promotion Marechal Nico S.à r.l.
Real Estate Classifieds Asia Extra S.à r.l.
Sagis Gallica S.A.
Services Touristiques S.A.
Sibret Finance S.à r.l.
Simple Global Education S.A.
Siola S.A.
Skydeck S.à r.l.
SL Lux Investment S.C.A.
Société Immobilière de l'Arsenal
Spa Di Lantigos S.C.A.
Supercell S.A.
Thea Participations S.à r.l.
The Simpleshow Company S.A.
Wistaria S.A.
Zimfi SPF S.A.