This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 40
6 janvier 2014
SOMMAIRE
A.H.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1914
Albatros S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1918
Art Evolution Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
1879
Baek-Immo Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911
Bal Main International S.A. . . . . . . . . . . . . .
1914
Beyton Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
1912
BRE/Hamburg Reichshof Hotel S. à r.l. . . .
1908
Cabexco Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1912
Campwirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913
Canom Conseils s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1912
Cap Agro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1912
Capitalis Fund Management S.à r.l. . . . . . .
1910
Cardintel Investments Financiers S.A. . . .
1874
Carland s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911
Carricha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911
Casual S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911
C.B.R. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913
CDRD Investment (Luxembourg) III S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1912
CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1911
CDRD Investment (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913
COF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913
Compagnie Francilienne d'Investissements
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1913
Côte d'Emeraude S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910
CTR Machinery S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1887
Data-Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1887
Deep Blue Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909
Dennys Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1887
Dentsply EU Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
1874
Der Garten S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1897
Domani S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1887
Donjon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1907
East Side Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909
Edelweiss Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909
Edelweiss Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1909
Edelweiss Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1917
EF (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
1908
EHO Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1908
Empire 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910
FANSY Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
1881
Fashion2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1915
IF-Corporate Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1916
Lion/Visor Lux 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1915
PI Diffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1917
Prop Co. 15 A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1898
Prop Co. 15 C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1888
R-Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1917
Ship Atlantic Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1881
Société Luxembourgeoise d'Investisse-
ments Fonciers Internationaux (SLIFI)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1879
Socoproject Immobilière S.A. . . . . . . . . . . .
1880
Texas Instruments International Holding
Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1880
White House Luxembourg SA . . . . . . . . . .
1920
1873
L
U X E M B O U R G
Cardintel Investments Financiers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clémency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 50.800.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/11/2013.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2013163338/12.
(130199422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Dentsply EU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: USD 3.160.860.060,88.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 73.350.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of December.
In front of Maître Francis Kessler, notary public with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Dentsply EU Holding S.à r.l.", a Luxembourg "société
à responsabilité limitée", having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 73350 (the "Company"),
incorporated by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, on 17 December 1999, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 159 dated
21 February 2000 and amended for the last time by a deed enacted by Maître Henri Beck, public notary residing in
Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number
1361 dated 1 June 2012.
There appeared:
The shareholders of the Company, (i) Dentsply CE S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its
registered office at 560A, Rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 150469, holder of 1,000,001 (one million one) shares in the
Company ("DCE") and (ii) Dentsply Holdings S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered
office 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 153253, holder of 61,065 (sixty-one thousand sixty-five) shares in the Company
(together the "Shareholders"), duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional
address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal dated 7 December 2012.
The above-mentioned proxy, being initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Shareholders, represented as stated above, have requested the notary to record as follows:
I. - That the 1,061,066 (one million sixty-one thousand sixty-six) shares without nominal value of the Company, re-
presenting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda, of which the Shareholders state having been duly informed beforehand.
II. - The agenda of the meeting is the following:
<i>"Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,925,089,806.48 (two billion nine hundred
twenty-five millions eighty-nine thousand eight hundred six United States Dollars and forty-eight cents) by the issuance
of 13,164,143 (thirteen million one hundred sixty-four thousand one hundred forty-three) new shares of the Company,
without nominal value, to Dentsply CE S.à r.l. subject to the payment of a share premium amounting globally to USD
193.52 (one hundred ninety-three United States Dollars fifty-two cents), so as to raise it from its current amount of USD
235,770,254.40 (two hundred thirty-five million seven hundred seventy thousand two hundred fifty-four United States
Dollars and forty cents) to USD 3,160,857,060.88 (three billion one hundred sixty millions eight hundred fifty-seven
thousand sixty United States Dollars and eighty-eight cents);
1874
L
U X E M B O U R G
3. Subscription and payment by Dentsply CE S.a r.l. of all the 13,164,143 (thirteen million one hundred sixty-four
thousand one hundred forty-three) new shares to be fully paid-up by the contribution in kind of one share in Maillefer;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6. of the articles of association of the Company in order to
reflect the new share capital of the Company pursuant to the above resolutions; and
6. Miscellaneous."
After the foregoing was approved by the Shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders
acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to carefully examine each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount USD 2,925,089,806.48 (two billion nine
hundred twenty-five millions eighty-nine thousand eight hundred six United States Dollars and forty-eight cents) so as to
raise it from its current amount of USD 235,770,254.40 (two hundred thirty-five millions seven hundred seventy thousand
two hundred fifty-four United States Dollars and forty cents) to USD 3,160,857,060.88 (three billion one hundred sixty
millions eight hundred fifty-seven thousand sixty United States Dollars and eighty-eight cents) by the issuance of
13,164,143 (thirteen million one hundred sixty-four thousand one hundred forty-three) new shares of the Company (the
"New Shares"), subject to the payment of a share premium amounting to USD 193.52 (one hundred ninety-three United
States Dollars fifty-two cents), (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind by
DCE (the "Contributor") consisting of one share with a nominal value of CHF 360,000 (three hundred sixty thousand
Swiss Franc) in Maillefer Instruments Holding Sàrl, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its
registered office at Chemin du Verger 3 in Ballaigue, Switzerland ("Maillefer"), valuated at USD 2,925,090,000 (two billion
nine hundred twenty-five million ninety thousand United States Dollars) being the equivalent of CHF 2,716,000,000 (two
billion seven hundred sixteen million Swiss Franc) based on the CHF/USD exchange rate of 1.07698 as published on the
Oanda website on 7 December 2012 (the "Contribution").
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the full payment by DCE and of the Share Premium of the New Shares
by means of the Contribution.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon the Contributor, here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named, by virtue of a proxy
given under private seal, declares to subscribe to the New Shares having an aggregate value of USD 2,925,089,806.48
(two billion nine hundred twenty-five millions eighty-nine thousand eight hundred six United States Dollars forty-eight
cents), in the Company and to pay them up entirely together with the payment of the Share Premium through the
Contribution.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution made by the Contributor in exchange for the issuance of the New Shares is composed of one share
with a nominal value of CHF 360,000 (three hundred sixty thousand Swiss Franc), valuated at USD 2,925,090,000 (two
billion nine hundred twenty-five million ninety thousand United States Dollars) being the equivalent of CHF 2,716,000,000
(two billion seven hundred sixteen million Swiss Franc) based on the CHF/USD exchange rate of 1.07698 as published
on the Oanda website on 7 December 2012 that the Contributor holds in Maillefer.
<i>Valuationi>
The total net value of the Contribution amounts to USD 2,925,090,000 (two billion nine hundred twenty-five million
ninety thousand United States Dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 7 December 2012, which shall remain annexed to this deed and be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the contributions' existencei>
A proof of the Contribution has been given.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
1875
L
U X E M B O U R G
a) Mr. Daniel Mark Reed, with address at 221, West Philadelphia Street, York Pennsylvania 17405, United States of
America;
b) Mr. Robert J. Winters, with address at 221, West Philadelphia Street, York Pennsylvania 17405, United States of
America;
c) Mr. Brian M. Addison, with address at 221, West Philadelphia Street, York Pennsylvania 17405, United States of
America; and
d) Mr. John D. Buckley, with address at Hamm Moor Lane, Addleston, Weybridge, Surrey KT15 2SE, United Kingdom
all represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the state-
ment of contribution value;
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions described above having been fully
carried out, it is acknowledged that the shareholding of the Company is now composed of:
- Dentsply Holdings S.a r.l., holder of 61,065 (sixty-one thousand sixty-five) shares of the Company; and
- Denstply CE S.a r.l., holder of 14,164,144 (fourteen million one hundred sixty-four thousand one hundred forty-four)
shares of the Company.
The notary acts that the 14,225,209 (fourteen million two hundred twenty-five thousand two hundred nine) shares
representing the whole share capital of the Company, are duly represented so that the meeting can validly decide on the
resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend article 6 of the Company's articles of association to read as follows:
" Art. 6. The Company's capital is set at USD 3,160,857,060.88 (three billion one hundred sixty millions eight hundred
fifty-seven thousand sixty United States Dollars and eighty-eight cents) represented by 14,225,209 (fourteen million two
hundred twenty-five thousand two hundred nine) ordinary shares without nominal value, all subscribed and fully paid-
up."
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le septième jour de décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030, Esch-sur-
Alzette,, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «Dentsply EU Holding S.à r.l.», une société à res-
ponsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73350 (la
«Société»), constituée en société à responsabilité limitée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire établi à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 159 du 21 février 2000 et modifié pour la dernière fois par un acte passé par-devant Maître Henri
Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1361 le 1 juin 2012.
Sont apparus:
Les associés de la Société, (i) Dentsply CE S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège
social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
1876
L
U X E M B O U R G
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150469, détentrice de 1.000.001 (un million une) parts sociales
dans la Société ("DCE") et (ii) Dentsply Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son
siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73350, détentrice de 61.065 (soixante et un mille soixante-
cinq) parts sociales de la Société (ensemble les»Associés»), dûment représentés par Madame Sofia Afonso-Da Chao
Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030, Esch-sur-Alzette, Grand-duché
de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé en date du 7 décembre 2012.
Les procurations susmentionnées, après avoir été signée ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
Les Associés représentés comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire d'enregistrer comme suit:
I.- Que les 1.061.066 (un million soixante-et-un mille soixante-six) parts sociales de la Société représentant l'intégralité
du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous
les points de l'ordre du jour, dont les Associés ont été dument informés par avance.
II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 2.925.089.806,48 USD (deux milliards neuf cent vingt-
cinq millions quatre-vingt-neuf mille huit cent six Dollars Américains et quarante huit cents), par l'émission de 13.164.143
(treize millions cent soixante-quatre mille cent quarante-trois) nouvelles parts sociales de la Société soumis au paiement
d'une prime d'émission d'un montant total de 193,52 USD (cent quatre-vingt-treize Dollars Américains et cinquante-deux
cents) afin de le porter de son montant actuel de 235.770.254,40 USD (deux cent trente-cinq millions sept cent soixante-
dix mille deux cent cinquante-quatre Dollars Américains et quarante cents) à 3.160.857.060,88 USD (trois milliards cent
soixante millions huit cent cinquante-sept mille soixante Dollars Américains et quatre-vingt- huit cents) par le biais d'un
apport en nature;
3. Souscription et paiement par Dentsply CE S.à r.l. de 13.164.143 (treize millions cent soixante-quatre mille cent
quarante-trois) nouvelles parts sociales par l'apport d'une part sociale dans Maillefer;
4. Nouvelle composition du capital social de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau
capital social de la Société suivant l'augmentation de capital décrite dans la résolution ci-dessus; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;
les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement
convoqués et acceptent en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé
que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de
temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2.925.089.806,48 USD (deux milliards neuf
cent vingt-cinq millions quatre-vingt-neuf mille huit cent six Dollars Américains et quarante huit cents) afin de le porter
de son montant actuel de 235.770.254,40 USD (deux cent trente-cinq millions sept cent soixante-dix mille deux cent
cinquante-quatre Dollars Américains et quarante cents) à 3.160.857.060,88 USD (trois milliards cent soixante millions
huit cent cinquante-sept mille soixante Dollars Américains et quatre-vingt-huit cents) par l'émission de 13,164,143 (treize
millions cent soixante-quatre mille cent quarante-trois) nouvelles parts sociales de la Société (les «Nouvelles Parts So-
ciales»), soumises au paiement d'une prime d'émission d'un montant de 193,52 USD (cent quatre-vingt-treize Dollars
Américains et cinquante-deux cents) (la «Prime d'Emission»),, l'intégralité devant être libérée par un apport en nature
par DCE (l'«Apporteur») consistant en une part sociale d'une valeur nominale de 360.000 CHF (trois cent soixante mille
Francs Suisses) dans Maillefer Instruments Holding Sàrl, une société constituée selon les lois suisses, ayant son siège social
à Chemin du Verger 3 in Ballaigue, Suisse ("Maillefer"), évaluée à 2.925.090.000 USD (deux milliards neuf cent vingt-cinq
millions quatre-vingt-dix mille Dollars Américains), étant l'équivalent CHF de 2.716.000.000 (deux milliards sept cent
seize millions Francs Suisses), conformément au taux de change CHF/USD 1,07698 sur le site internet Oanda publié en
date du 7 décembre 2012 (l'«Apport»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par DCE des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission
par le biais de l'Apport.
1877
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Mme Sofia Da Chao, précitée en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société ayant une valeur totale de
2.925.089.806,48 USD (deux milliards neuf cent vingt-cinq millions quatre-vingt-neuf mille huit cent six Dollars Américains
et quarante huit cents) et les payer entièrement, ensemble avec le paiement de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.
<i>Description de l'apporti>
L'Apport réalisé par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales est composé d'une part sociale
d'une valeur nominale de 360.000 CHF (trois cent soixante mille Francs Suisses) dans Maillefer, évaluée à 2.925.090.000
USD (deux milliards neuf cent vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille Dollars Américains), étant l'équivalent CHF de
2.716.000.000 (deux milliards sept cent seize millions Francs Suisses), conformément au taux de change CHF/USD de
1,07698 publié sur le site internet Oanda en date du 7 décembre 2012 que l'Apporteur détient dans Maillefer.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l'Apport précédemment décrit s'élève à un montant global d'au moins 2.925.090.000 USD (deux
milliards neuf cent vingt-cinq millions quatre-vingt-dix mille Dollars Américains).
Une telle évaluation a reçu l'approbation de tous les gérants de la Société aux termes d'une déclaration de valeur de
l'Apport datant du 7 décembre 2012, qui est annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités d'enre-
gistrement.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée.
<i>Intervention des gérantsi>
Ensuite interviennent:
a) M. Daniel Mark Reed, résidant au 221, West Philadelphia Street, York Pennsylvania 17405, United States of America;
b) M. Robert J. Winters, résidant au 221, West Philadelphia Street, York Pennsylvania 17405, United States of America;
c) M. Brian M. Addison, résidant au 221, West Philadelphia Street, York Pennsylvania 17405, United States of America;
and
d) Mr. John D. Buckley, résidant à Hamm Moor Lane, Addleston, Weybridge, Surrey KT15 2SE, Royaume-Uni
Tous représentés ici par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu des dispositions de la déclaration de
valeur d'apport;
Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'augmentation de leur responsabilité, légalement liés en tant que
gérants de la Société en raison de l'Apport, confirment expressément la description de l'Apport, ainsi que son évaluation
et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est pris acte
que l'actionnariat de la Société est désormais composé de:
- Dentsply Holdings S.à r.l., détenteur de 61.065 (soixante-et-une mille soixante-cinq) parts sociales de la Société; et
- Dentsply CE S.à r.l., détenteur de 14.164.144 (quatorze millions cent soixante-quatre mille cent quarante-quatre)
parts sociales de la Société.
Le notaire établit que les 14.225.209 (quatorze millions deux cent vingt-cinq mille deux cent neuf) parts sociales
représentant l'intégralité du capital social de la Société étant dûment représentées, la présente assemblée peut valablement
décider de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de
modifier l'article 6, paragraphe 1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d'être lu comme suit:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 3.160.857.060,88 USD (trois milliards cent soixante millions huit cent
cinquante-sept mille soixante Dollars Américains et quatre-vingt-huit cents), représenté par 14.225.209 (quatorze millions
deux cent vingt-cinq mille deux cent neuf) parts sociales ordinaires sans valeur nominale entièrement souscrites et libé-
rées.».
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).
Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été levée.
Dont acte fait et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête de ce document.
1878
L
U X E M B O U R G
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16864.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013163378/269.
(130199353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Art Evolution Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'eau.
R.C.S. Luxembourg B 177.301.
EXTRAIT
L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 14 novembre 2013 à 11.00 heures, a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Inars GRINBERGS de son poste d'administrateur.
Et nomme en son remplacement:
- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg -Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte -France et domicilié professionnellement au 18
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Sébastian COYETTE, expert-comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
L'assemblée prend acte de la démission de la société SERVICES FIDUCIAIRES DU LUXEMBOURG S.A.R.L., ayant son
siège social au 38-40 avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105346, de son mandat de commissaire aux comptes et nomme en son
remplacement la société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79327, dont le mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013168048/27.
(130205421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Société Luxembourgeoise d'Investissements Fonciers Internationaux (SLIFI) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 122.357.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 29 novembre 2013i>
L'Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation de la société «Société Luxembourgeoise d'In-
vestissements Fonciers Internationaux (SLIFI) S.A.» (en liquidation) qui cessera d'exister.
L'Assemblée Générale décide que les documents sociaux seront conservés, au minimum pendant 5 années, au siège
social de HRT FIDALUX S.A., qui est actuellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 novembre 2013.
<i>Pour Société Luxembourgeoise d'Investissements Fonciers Internationaux (SLIFI) S.A.i>
Référence de publication: 2013174358/16.
(130212489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
1879
L
U X E M B O U R G
Texas Instruments International Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 170.340.795,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 137.048.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associée unique de la société en date du 25 novembre 2013:
1. Les personnes suivantes ont démissionné de leur mandat de gérant de catégorie A de la société, avec effet au 25
novembre 2013:
- Monsieur Christian Tordo;
- Monsieur Edgar Frank; et
- Monsieur Ian Spencer.
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérants de catégorie A de la société, avec effet au 25 novembre
2013, pour une durée illimitée:
- Madame Adrienne McGlynn, née le 25 mars 1964, à Glasgow, Ecosse, ayant son adresse professionnelle à Larkfield
Industrial Estate, Earnhill Road, Greenock, PA16 0EQ, Royaume-Uni;
- Monsieur Klaus Weisel, né le 15 avril 1965, à Kempten, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à Haggertystr.
1, 85356 Freising, Allemagne; et
- Monsieur Andreas Schwaiger, né le 21 mai 1974, à Straubing, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à Hag-
gertystr. 1, 85356, Freising, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 11 décembre 2013.
Référence de publication: 2013174401/26.
(130212142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
Socoproject Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4959 Bascharage, 30, Zone Industrielle Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 89.220.
<i>Extrait de résolutionsi>
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 décembre 2013
que:
Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2019:
- Monsieur Frédéric BEVER, gérant de société, demeurant à B-6760 Virton, 3, route d'Arlon
- Madame Marie-Ange LEMAIRE, employée privée, demeurant à B-6760 Virton, 3, route d'Arlon
- Monsieur Dominique RESIBOIS, employé privé, demeurant à B-6761 Chenois-Virton, 36, rue du Pierrard
Le mandat de Commissaire de la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue
de la Faïencerie, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25 797 est renouvelé
pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'administration en date du 12 décembre 2013 que:
- Monsieur Frédéric BEVER, prénommé, est nommé en tant que Président du Conseil d'administration pour toute la
durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
- Monsieur Frédéric BEVER, prénommé, est nommé en tant qu'Administrateur-délégué de la Société pour toute la
durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 12 décembre 2013.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013174387/28.
(130212466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
1880
L
U X E M B O U R G
Ship Atlantic Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 144.917.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 novembre 2013.i>
<i>Résolution:i>
L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, le mandat des administrateurs M. Giorgio Bianchi et Mme
Sandrine Durante.
L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Madame Ruijiao Liu, employée privée demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
administrateur, avec la signature de catégorie 'A';
- Madame Alessandra Bettati, employée privée demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg administrateur, avec la signature de catégorie 'B'.
Les mandats des nouveaux administrateurs auront échéance jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exer-
cice 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2013174381/20.
(130212550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
FANSY Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 54, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 181.768.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen on twenty-second October.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in ESCH-SUR-ALZETTE.
There appeared:
Yerli, Ömer Faruk, born 25 June 1971, passport No. U00868707, and having his residence at 60314, Frankfurt am
Main, Sonnemannstrasse 10, here represented by Me Alexander Zalivako, lawyer, having his professional address in
Luxembourg, by virtue of a power-of-attorney given under private seal dated 30 September 2013.
The said power-of-attorney shall be signed "ne varietur" by the representative of the appearing person and the un-
dersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée, which it declares to form:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of FANSY Ventures S.à r.l (hereinafter
the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form, in other Luxembourg or foreign
companies, and the management, control and development of such participating interests as well as the investment in,
and the holding and development of, real property.
The Company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds
and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.
The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary
thereto.
The Company may grant loans, advances, guarantees to the affiliated companies and to any other corporations in which
it takes some direct or indirect interest. The Company may grant any security in respect of its own obligations, the
obligations of its affiliated companies or any third parties. The Company may borrow in any form, including by issuing
bonds.
The Company may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations (including in respect of either
moveable or immoveable property) that it may deem of use in the accomplishment of its object.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
1881
L
U X E M B O U R G
Art. 4. The registered office of the Company is established in Bettembourg. It may be transferred to any other place
in the City of Luxembourg by means of a resolution of the board of managers. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each. Each share is entitled to one
vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
Art. 6. Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only
be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the share capital.
Otherwise reference is made to the provisions of articles 189 and 190 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended
Art. 7. The Company will recognise only one holder per share. Joint co-owners, if any, shall appoint a single repre-
sentative who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 9. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least two members, who need not be
shareholders of the Company.
The managers shall be elected by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders,
with or without limitation of the period of office. A manager may be removed with or without cause and replaced at any
time by a resolution adopted by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers
(or manager) may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the shareholders
ratifying such election.
Art. 10. The board of managers may choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman,
another manager may preside over the meeting.
The board of managers shall meet upon call by the chairman or any manager, as often as the interest of the Company
so requires. It shall meet at the registered office of the Company, unless otherwise indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
e-mail of each manager.
Notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have declared that
they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the
genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy. One manager can represent
more than one of his co-managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting (whether in person, or by proxy, or by means of
such communications device) to hear and be heard by one another. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly at a meeting of the board of managers only if at least a majority
of the managers is present or represented. If the board of managers consists of two managers, both managers shall be
present or represented. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at
such meeting. If the board of managers consists of two managers, the consent of both managers is required to pass a
decision at the meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by all of the managers present.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed jointly
by at least two managers.
1882
L
U X E M B O U R G
Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interest and in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the sole shareholder or, as
the case may be, the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board. It may also
confer the power to represent the Company to any other persons who need not be managers, who shall represent the
Company for specific transactions as determined by the board of managers.
Art. 13. The Company is bound either (i) by the joint signature of two managers or (ii) by the joint or single signature
of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.
D. General meeting of the shareholders
Art. 14. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section
XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Decisions, which exceed the powers of the managers, shall be taken by the sole shareholder, or as the case may be,
by the general meeting of the shareholders. Any such decision shall be in writing and shall be recorded in a special register.
In case there are less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders may be taken either in a general meeting
or by written consultation, at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly taken until it has been
adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy shall be permitted.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 15. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty first of December of the
same calendar year.
Art. 16. Each year as of the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities
of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must
be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has dropped
below one tenth of the share capital. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the shareholders by the majority defined in article
142 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Unless otherwise provided, the liquidators shall
have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 18. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as
follows:
Yerli, Ömer Faruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros
(EUR 12,500.-) is now available to the Company.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2014.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
1883
L
U X E M B O U R G
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed
capital passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 54, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:
- Yerli, Ömer Faruk, born born 25 June 1971, passeport No. U00868707, and having his residence at 60314, Frankfurt
am Main, Sonnemannstrasse 10; and
- Paul Lamberts, born on18 September 1965 in Tilburg (NL) and having his professional residence at 169 rue des
Romains, L-8041, Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the representative of whom is known to the notary by
surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Follows the french version
L'an deux mille treize, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Franics KESSELER, notaire de résidence à ESCH-SUR-ALZETTE.
A comparu:
Yerli, Ömer Faruk, né le 25 juin 1971 avec adresse au 60314, Frankfurt am Main, Sonnemannstrasse 10, passeport No.
U00868707, ici représenté par Me Alexander Zalivako, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration lui conférée sous seing privé le 30 septembre 2013.
Laquelle procuration sera signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire susnommé et restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer comme suit:
A. Nom - Objet - Durée - Siège - Social
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FANSY Ventures S.à r.l (ci-après
la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que l'investissement
et l'exploitation et le développement de biens immobiliers.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties. La Société peut accorder toute sécurité dans le
respect de ses propres obligations, les obligations de ses sociétés affiliées ou de tiers. La Société peut emprunter sous
toute forme, y compris en émettant des obligations.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières
qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Bettembourg. Il pourra être transféré à n'importe qu'elle autre place dans la ville de
Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être créé, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cent EUR (EUR 12.500,-,-) représenté par
douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un EUR (EUR 1,-). Chaque part sociale donne droit
à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
1884
L
U X E M B O U R G
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts existantes.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers
non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par chaque part sociale. Les copropriétaires sont les cas échéant
tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la
Société.
C. Gérance
Art. 9. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, lesquels ne seront pas
nécessairement associés de la Société.
Les gérants sont élus par résolution de l'associé unique ou, selon les cas, de l'assemblée générale des associés, pour
une durée limitée ou sans limitation de durée. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment
par une décision de l'associé unique ou, selon les cas, de l'assemblée générale des associés.
En cas de vacance d'un poste d'un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants
pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la
confirmation de cette élection par les associés.
Art. 10. Le conseil de gérance peut nommer un président; dans l'absence du président, un autre gérant peut présider
la réunion.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou tout autre gérant, aussi souvent que l'intérêt de la
Société l'exige. Il se réunit au siège social de l'entreprise, sauf indication contraire dans l'avis de convocation.
Un avis de convocation écrit sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour
une réunion du conseil de gérance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en
original, téléfax ou e-mail.
Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble des
gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la réunion
ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préalablement
par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter aux réunions de conseil de gérance en désignant par écrit soit en original, soit
par téléfax, soit par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant
comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses co-gérants.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion (soit en personne ou par
procuration, ou par le biais du dispositif de communication tels) peuvent s'entendre, et communiquer entre elles. La
participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement à une réunion du conseil de gérance que si la majorité
au moins des membres est présente ou représentée. Si le conseil de gérance est composé de deux gérants, deux gérants
sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à
une telle réunion. Si le conseil de gérance est composé de deux gérants, le consentement des deux gérants est nécessaire
pour adopter une décision lors de la réunion.
Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie
circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un
facsimile, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la
résolution prise.
Art. 11. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par tous les gérants qui sont présent.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés conjointement par au
moins deux gérants.
Art. 12. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour
la gestion journalière, à tout membre ou des membres du conseil de gérance. Il peut également conférer le pouvoir de
1885
L
U X E M B O U R G
représenter la Société à toutes autres personnes qui ne doivent pas être les gérants, qui représente la Société pour des
transactions spécifiques tel que déterminé par le conseil de gérance.
Art. 13. La Société sera engagée soit par (i) les signatures conjointes d'au deux gérants soit (ii) par les signatures
conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil
de gérance.
D. Assemblée générale des associés
Art. 14. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par
l'assemblée générale des associés. Les décisions seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.
S'il y a moins que vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consul-
tation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise à moins qu'elle n'ait été adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront à Luxembourg. Une participation en vertu d'une procuration sera
possible.
E. Exercice social - Bilan - Répartitions
Art. 15. L'exercice social commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de
la même année..
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et il est dressé un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction de tous amortissements, dépenses, charges et
provisions représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital social, étant entendu
que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il est inférieur de dix pour cent du capital social. Le surplus est distribué entre les associés.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, la comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
Yerli, Omer Faruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cent EUR (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).
<i>Assemblée générale des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 54, route de Mondorf, L-3260 Bettembourg, Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1886
L
U X E M B O U R G
- Yerli, Omer Faruk, né le 25 juin 1971 avec adresse au 60314, Frankfurt am Main, Sonnemannstrasse 10, passeport
No. U00868707; et
- Paul Lamberts, néle 18 septembre 1965 en Tilburg (NL), avec adresse professionnelle au 169 rue des Romains, L-8041,
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande dû comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande dû même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant dont le mandataire est connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Zalivako, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13966. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013163475/317.
(130199745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Data-Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5544 Remich, 9, Op der Kopp.
R.C.S. Luxembourg B 50.573.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La société
Signature
Référence de publication: 2013173973/11.
(130212959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
CTR Machinery S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 38, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 147.650.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013173963/10.
(130212251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
Domani S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 37.410.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2013173982/10.
(130212274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
Dennys Café, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 10, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 112.135.
Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
1887
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013173976/10.
(130212510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
Prop Co. 15 C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 182.240.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand DuchyP of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 158.363,
here represented by Christine Schaub, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 14 November 2013.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Prop Co. 15 C S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Contern, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
1888
L
U X E M B O U R G
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing
three-quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board
are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
1889
L
U X E M B O U R G
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement
such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners
S.a r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel
investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping
Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further
parties and such consent shall be documented in writing:
(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.
(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.
(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion
of the Company's ownership) real estate financings.
(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the
proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.
1890
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
1891
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Richard Neal Basire Goddard, Director, born on December 5, 1959 in Fareham, Great Britain, with professional
address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
b. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19,
rue des Lilas, L-8035 Strassen; and
c. José María Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern.
2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this
deed are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Contern, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party,, who is known to the undersigned notary by his
surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am neunundzwanzigsten Tag des Monats November im Jahre zweitausenddreizehn.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reu-
ter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 158.363,
hier vertreten durch Christine Schaub, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großher-
zogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 14. November 2013 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Prop Co. 15 C S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
1892
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der
Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Ge-
meinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in¬oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte
Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Gesellschafts-
anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
1893
L
U X E M B O U R G
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse
des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern un-
terzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-
bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.
1894
L
U X E M B O U R G
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-
plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:
(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.
(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.
(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.
(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
1895
L
U X E M B O U R G
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-
beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
1896
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.a r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert
(12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) betragen.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-
neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritanien,
geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
b. Ulrich Binninger, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland,
geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; und
c. José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem
Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. SCHAUB, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 3 décembre 2013. Relation: DIE/2013/14825. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 6. Dezember 2013.
Référence de publication: 2013171024/527.
(130208704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.
Der Garten S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5730 Aspelt, 1, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 141.992.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2013173977/13.
(130212817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
1897
L
U X E M B O U R G
Prop Co. 15 A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 182.245.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand DuchyP of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 158.361,
here represented by Christine Schaub, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 14 November 2013.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Prop Co. 15 A S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Contern, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
1898
L
U X E M B O U R G
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing
three-quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board
are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
1899
L
U X E M B O U R G
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s).
Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement
such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of ECE Real Estate Partners S.a
r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel investment
agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further parties and
such consent shall be documented in writing:
(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.
(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.
(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion
of the Company's ownership) real estate financings.
(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the
proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
1900
L
U X E M B O U R G
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2014.
1901
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and
b. Richard Neal Basire Goddard, Director, born on December 5, 1959 in Fareham, Great Britain, with professional
address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
c. José María Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond
Reuter, L- 5326 Contern.
2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this
deed are drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Contern, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party,, who is known to the undersigned notary by his
surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am neunundzwanzigsten Tag des Monats November im Jahre zweitausenddreizehn.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reu-
ter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 158.362,
hier vertreten durch Christine Schaub, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großher-
zogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 14. November 2013 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Prop Co. 15 A S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der
Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Ge-
1902
L
U X E M B O U R G
meinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in¬oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte
Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Gesellschafts-
anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
1903
L
U X E M B O U R G
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse
des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern un-
terzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-
bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
1904
L
U X E M B O U R G
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-
plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:
(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.
(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.
(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.
(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
1905
L
U X E M B O U R G
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-
beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
1906
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert
(12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) betragen.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-
neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxemburg; und
b. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritanien,
geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
c. José María Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
2. Sitz der Gesellschaft sind in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem
Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. SCHAUB, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 3 décembre 2013. Relation: DIE/2013/14819. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 6. Dezember 2013.
Référence de publication: 2013171022/527.
(130208702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.
Donjon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 43.003.
EXTRAIT
Le 22 Novembre 2013, les administrateurs de la Société ont consenti à prendre les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Mr Marcel Eggenkamp avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Wolter Brenninkmeijer, résidant professionnellement au 81 Fulham Road, 3
ème
étage, Michelin House, SW3 6RD Londres, Royaume-Uni, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet immédiat,
son mandat arrivant à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
Référence de publication: 2013173984/13.
(130212779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
1907
L
U X E M B O U R G
BRE/Hamburg Reichshof Hotel S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2432 Luxembourg, 18-24, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 119.897.
EXTRAIT
Par résolutions prises le 10 décembre 2013, les associés de la Société ont décidé:
- d'accepter la démission de BRE/Management 3 S.A. en tant que gérant unique de la Société avec effet immédiat;
- de nommer M. Ian Stuart MacLaughlin, né le 23 juillet 1956 à Malta, Malte et ayant son adresse professionnelle au
4C, Barentszplein, 1013 NJ, Amsterdam, Pays-Bas en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une
durée indéterminée;
- de nommer M. Matthieu Julien Hugues Vappiani, né le 1
er
mai 1979 à Thionville, France et ayant son adresse
professionnelle au 18-24, rue Michel Rodange, L-2432, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais constitué des personnes suivantes:
- M. Ian Stuart MacLaughlin;
- M. Matthieu Julien Hugues Vappiani.
Il convient également de noter le changement d'adresse de la Société. Le siège social de la Société a été transféré au
18-24 rue Michel Rodange, L-2432 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Référence de publication: 2013173897/24.
(130212366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
EHO Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 141.279.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'Associé Unique de la Société en date du 12 décembre 2013 que les
résolutions suivantes ont été prises:
- d'accepter la démission de Mr Fabrice Huberty avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Michel de Groote, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'Assemblée
statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
Référence de publication: 2013174003/15.
(130212895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
EF (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.300.000,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 130.974.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'Associé Unique de la Société en date du 12 décembre 2013 que les
résolutions suivantes ont été prises:
- d'accepter la démission de Mr Fabrice Huberty avec effet immédiat;
- de nommer en remplacement Mr Michel De Groote, résidant professionnellement au 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'Assemblée
statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
Référence de publication: 2013174716/15.
(130213025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1908
L
U X E M B O U R G
Deep Blue Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 73.623.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2013i>
- Monsieur Roger Caurla domicilié professionnellement au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg est nommé en tant
que nouveau liquidateur en remplacement de la société Financière de Latour S.à.r.l. avec siège social au 43, Boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg.
- l'adresse de la société est transférée du 43, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg à la nouvelle adresse suivante:
3, Place Dargent, L-1413 Luxembourg
Certifié sincère et conforme
DEEP BLUE HOLDING S.A.
Référence de publication: 2013174683/15.
(130213127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
East Side Global S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 143.259.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 DEC. 2013.
<i>Pour: EAST SIDE GLOBAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Cindy Szabo
Référence de publication: 2013174708/15.
(130213727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Edelweiss Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EDELWEISS GROUP S.A.
Geert DIRKX
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2013174695/12.
(130213411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Edelweiss Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EDELWEISS GROUP S.A.
Geert DIRKX
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2013174696/12.
(130213412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1909
L
U X E M B O U R G
Empire 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.746.572,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 174.328.
En date du 29 novembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Vincent Goy, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
2. Acceptation de la démission de Eric Biren, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
3. Acceptation de la démission de Maud Martin, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
4. Nomination de Peter Baxter, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
5. Nomination de Bronwyn Salvat-Winter, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Lu-
xembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
6. Transfert du siège social de la Société du 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2013.
Référence de publication: 2013174703/23.
(130213415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Côte d'Emeraude S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 180.724.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société à Luxembourg le 11 décembre 2013i>
Il a été décidé de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Amar MANSOURI avec effet au 21 novembre
2013.
Il a été décidé de nommer Monsieur Loïc STOURM, salarié, né le 8 février 1983 à Thionville, France, demeurant
professionnellement à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, administrateur de la Société avec effet au 21 no-
vembre 2013 et jusqu'à la fin de l' assemblée annuelle des actionnaires portant approbation des comptes annuels au 31
décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013174673/15.
(130213803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Capitalis Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 155.888.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
Il est décidé de transférer le siège social de la société du 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg au 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec effet au 28 novembre 2013.
Est nommé gérant, avec effet au 28 novembre 2013, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Tony PIGHINI, né le 16 janvier 1962 à Vernier (Suisse), employé privé, demeurant professionnellement au
15 Chemin de Claire Vue, CH-1213 Petit Lancy
Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2013174617/16.
(130213723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1910
L
U X E M B O U R G
Carricha S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 13/12/2013.
Référence de publication: 2013174636/10.
(130213158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Casual S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 31, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 22.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013174637/10.
(130213738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Carland s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9230 Diekirch, 18, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 92.023.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 13/12/2013.
Référence de publication: 2013174635/10.
(130213159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 77.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013174639/10.
(130213107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Baek-Immo Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.279.
Les administrateurs suivant:
- Enrico BALDAN, né le 04 juillet 1974 à Italie; et
- Natalie NAUGHTON, née le 17 decembre 1986, à Manchester
ont changé leurs adresses professionnelle du 15 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 Décembre 2013.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013174590/14.
(130213397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1911
L
U X E M B O U R G
Cabexco Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 139.876.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 13/12/2013.
Référence de publication: 2013174630/10.
(130213163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Canom Conseils s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 142.838.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 13/12/2013.
Référence de publication: 2013174632/10.
(130213162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Cap Agro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.708.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Référence de publication: 2013174633/10.
(130213852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
CDRD Investment (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 77.051.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013174640/10.
(130213112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Beyton Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.519.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2013.
Beyton Investments S.à r.l.
J. Mudde
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2013174583/14.
(130213197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1912
L
U X E M B O U R G
COF, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 101.788.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013174650/11.
(130213746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Compagnie Francilienne d'Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 71.411.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2013174653/13.
(130213203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
CDRD Investment (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 77.049.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013174641/10.
(130213082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Campwirt, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9353 Bettendorf, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.524.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013174616/10.
(130213225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
C.B.R. Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 17.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2013.
Référence de publication: 2013174614/10.
(130213116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1913
L
U X E M B O U R G
Bal Main International S.A., Société Anonyme,
(anc. A.H.P. S.A.).
Siège social: L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 158.346.
L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre.
Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.H.P S.A. (la «Société»),
société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
constituée suivant acte notarié en date du 17 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 808 du 23 avril 2011, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 158.346.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en derniers lieu suivant acte notarié en date du 28
février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1328 du 5 juin 2013.
L'assemblée est déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Maître Dorothée Ciolnio, avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Lorene Soulard, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Emilie Macchi, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de dénomination de la société;
2. Diminution du capital social de son montant actuel de cinquante quatre millions deux cent cinquante quatre mille
quatre cents euros (EUR 54.254.400) au montant de cinquante trois millions cinquante quatre mille quatre cents euros
(EUR 53.054.400) par l'annulation de douze mille (12.000) actions;
3. Augmentation du capital social de son montant actuel de cinquante trois millions cinquante quatre mille quatre cents
euros (EUR 53.054.400) au montant de cinquante trois millions deux cent soixante-trois mille huit cent euros (EUR
53.263.800), par l'émission de deux mille quatre-vingt-quatorze (2.094) actions nouvelles de valeur nominale égale à cent
euros (EUR 100) chacune; Souscription des actions nouvellement émises par apport en nature et en numéraire;
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;
5. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
III. Que la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires en date du
2 septembre 2013.
IV. Que sur un total de cinq cent quarante-deux mille cinq cent quarante-quatre (542.544) actions émises, quatre cent
quatre-vingt-treize mille deux cent quarante et une (493.241) actions sont dûment représentées à la présent assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points
portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société. A compter de ce jour, la dénomination
sociale de la Société sera «BALMAIN INTERNATIONAL S.A.».
En conséquence de ce qui précède, l'article 1
er
, alinéa 1 des statuts de la Société est modifié pour lui donner désormais
la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination BALMAIN INTERNATONAL S.A. (la «Société»).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide qu'il n'y a pas lieu de prendre de décisions quant aux points 2, 3 et 4 de l'ordre du jour
ci-dessus qui sont reportés à une assemblée ultérieure.
1914
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Ciolino, L. Soulard, E. Macchi, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 20 septembre 2013. REM/2013/1664. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): L. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 3 octobre 2013.
Référence de publication: 2013138346/65.
(130168951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.
Fashion2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 175.081.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique lors de l'assemblée général extraordinaire en date du 11 décembre 2013i>
Conformément aux résolutions prises par l'actionnaire unique lors de l'assemblée générale extraordinaire, en date du
11 décembre 2013, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Madame Isabelle Schul avec effet au 5 août 2013 au poste d'administrateur de la Société;
- D'accepter la démission de Monsieur Alain Renard avec effet au 26 août 2013 au poste d'administrateur de la Société;
- De créer deux catégories d'administrateurs, à savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de
catégorie B;
- De nommer Madame Maria Manuela DE MEDEIROS PEREIRA SOARES, demeurant à Rua D. Joao de Castro, 35,
P-4150, Porto, Portugal, administrateur de catégorie A, avec effet au 5 août 2013. Sa fonction prendra fin lors de l'as-
semblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2018.
- De nommer Madame Carla Alves Silva, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,
administrateur de catégorie B, avec effet au 5 août 2013. Sa fonction prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de
la Société qui se tiendra en 2018.
- De nommer Monsieur Vito Marinelli, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg,
administrateur de catégorie B, avec effet au 9 août 2013. Sa fonction prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de
la Société qui se tiendra en 2018.
- De ratifier la cooptation de Madame Chantal Mathu, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086
Luxembourg, administrateur de catégorie B, avec effet immédiat. Sa fonction prendra fin lors de l'assemblée générale
annuelle de la Société qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2013.
<i>Pour FASHION2 S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2013174745/30.
(130213228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Lion/Visor Lux 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.529.107,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 128.536.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013174887/13.
(130213357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1915
L
U X E M B O U R G
IF-Corporate Services, Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 143.346.
L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IF-Corporate Services", (la
"Société"), établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143.346, constituée suivant acte reçu par Maître
Léon Thomas dit Tom Metzler, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 novembre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3018 du 24 décembre 2008, dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 510 du 9 mars 2010.
L'assemblée est présidée par Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45
rue des Scillas.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Cécile PONCELET, employée, demeurant professionnel-
lement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michaël DUVAL, employé, demeurant professionnellement à L-2529
Howald, 45 rue des Scillas.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société de L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie à L-2529 Howald, 45 rue
des Scillas et modification corrélative du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la
teneur suivante:
« Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social de la Société est établi dans la commune de Hesperange. Il pourra être
transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.»
Le reste de l'article demeure inchangé.
2. Modification subséquente des adresses professionnelles des administrateurs, Président du Conseil d'Administration,
administrateur-délégué et commissaire aux comptes de la Société, qui seront à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.
3. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer l'adresse du siège social de la Société vers L-2529 Howald, 45 rue des Scillas,
et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. (Premier alinéa). Le siège social de la Société est établi dans la commune de Hesperange. Il pourra être
transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.»
Le reste de l'article demeure inchangé.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier en conséquence de ce qui précède les adresses professionnelles des admi-
nistrateurs, Président du Conseil d'Administration, administrateur-délégué et commissaire aux comptes de la Société, qui
seront à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
1916
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Laure SINESI, Cécile PONCELET, Michaël DUVAL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 novembre 2013. Relation GRE/2013/4417. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. PIERRET.
Référence de publication: 2013163559/66.
(130199192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Edelweiss Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EDELWEISS GROUP S.A.
Geert DIRKX
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2013174697/12.
(130213413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
PI Diffusion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 139.061.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier daté du 20 septembre 2013 adressé à l'actionnaire de la société PI DIFFUSION SA. que Monsieur
Jean-Marie SCHUL a démissionné de sont poste d'administrateur unique avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013176387/13.
(130214440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
R-Solution, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 124.412.
<i>Beschluss des Einzelaktionäres gefasst am 10. Dezember 2013i>
Der Einzelaktionär hat am 10. Dezember 2013 beschlossen, den aktuellen Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes)
Frau Josiane Jennes abzuberufen und Herrn Dr. Christoph Becker, geboren in Hermeskeil (Deutschland) am 2. September
1973, professionell wohnhaft in 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Rechnungsprüfer (commissaire aux
comptes) zu ernennen.
Sein Mandat ist bis zur regelmäßigen Haupversammlung der Gesellschaft 2014 erteilt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 16. Dezember 2013.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
Référence de publication: 2013176388/17.
(130214339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.
1917
L
U X E M B O U R G
Albatros S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 181.418.
IN THE YEAR TWO THOUSAND and THIRTEEN,
ON THE TWENTIETH DAY of NOVEMBER.
Before Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
REPSOL, S.A., (sociedad anónima), a company duly incorporated under the laws of the Kingdom of Spain, having its
registered office at Calle Méndez Álvaro, 44, 28045, Madrid (Spain) registered with the Commercial Register of Madrid
under page number M-65289,
here represented by:
Maître Rina Breininger, residing professionally in Luxemburg, by virtue of a proxy given under private seal on 7 No-
vember 2013.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows:
I. The appearing party is the sole and only shareholder of the company Albatros S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), with registered office at L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies under number B 181418, incorporated by deed of the undersigned
notary on 29 October 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").
II. The corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12.500 EUR), represented by
one hundred and twenty-five (125) shares with a nominal value of one hundred Euro (100 EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.
III. The appearing party, duly represented, then passes the following resolutions:
<i>Agendai>
1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of one hundred Euro (100 EUR) in order to raise
it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) to twelve thousand six hundred Euro
(12,600 EUR) by the creation and issue of one (1) new share with a nominal value of one hundred Euro (100 EUR).
2. Subscription and payment of the new share by the sole shareholder in cash.
3. Subsequent amendment of article 6, first paragraph, of the articles of association of the Company.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred Euro
(100 EUR) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) to twelve
thousand six hundred Euro (12,600 EUR) by the creation and issue of one (1) new share with a nominal value of one
hundred Euro (100 EUR).
<i>Subscription - Paymenti>
The one (1) new share with a nominal value of one hundred Euro (100 EUR) together with a share premium of
135,167,648.20 EUR has been entirely subscribed by the sole shareholder, prenamed, who declares to have fully paid-up
this one (1) new share thereon by contribution in cash.
The aggregate amount of the subscription (share capital and share premium) of 135,167,748.20 EUR is at the disposal
of the Company, as has been proved by a bank certificate to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The aggregate amount of 135,167,748.20 EUR is allotted for (i) one hundred Euro (100 EUR) to the corporate capital
of the Company and (ii) for an amount of 135,167,648.20 EUR to the share premium allocated to a free share premium
account.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, article 6, first paragraph, of the articles of association of the Company
is amended and shall henceforth have the following wording:
" Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred Euro (12,600 EUR), repre-
sented by one hundred and twenty-six (126) shares with a nominal value of one hundred Euro (100 EUR) each, all
subscribed and fully paid-up."
1918
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 6.800.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE VINGTIEME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE.
Pardevant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
REPSOL, S.A. (sociedad anonima), une société dûment constitutée sous les lois du Royaume d'Espagne, ayant son siège
social à Calle Méndez Âlvaro, 44, 28045, Madrid (Espagne), immatriculée auprès du registre de commerce de Madrid sous
le numéro de page M-65289, ici représentée par:
Maître Rina Breininger, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé en date du 7 novembre 2013.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La comparante est la seule et unique associée de la société Albatros S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social à L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 29 octobre 2013, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cent vingt-cinq
(125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
III. La comparante, dûment représentée, prend ensuite les résolutions concernant l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent euros (100 EUR) pour le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à douze mille six cents euros (12.600 EUR) par la
création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale, d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR).
2. Souscription et paiement de la nouvelle part sociale par l'associée unique moyennant versement en espèces.
3. Modification subséquente de l'article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société.
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent euros (100
EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à douze mille six cents euros
(12.600 EUR) par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR).
<i>Souscription - Payementi>
La nouvelle part sociale d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) ensemble avec une prime d'émission de
135,167,648.20 EUR a été entièrement souscrite par l'associée unique, prénommée, qui déclare qu'elle a été entièrement
libérée par versement en espèces.
Le montant total de la souscription (capital et prime d'émission) à hauteur de 135,167,748.20 EUR est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé moyennant certificat bancaire au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
Le montant total de 135,167,748.20 EUR est alloué pour (i) cent euros (100 EUR) au capital social de la Société et (ii)
pour un montant de 135,167,648.20 EUR à la prime d'émission qui sera allouée à un compte libre de prime d'émission.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
1919
L
U X E M B O U R G
« Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600 EUR), représenté par cent vingt-
six (126) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées
approximativement à EUR 6.800.-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête
de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant ainsi qu'il a été dit, il a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: R. BREININGER, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 21 novembre 2013. Relation: RED/2013/1986. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 25 novembre 2013.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013163878/123.
(130200733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
White House Luxembourg SA, Société Anonyme.
Capital social: EUR 131.000,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 118.927.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue à Luxembourg le 4 décembre
2013 que:
(i) Monsieur Jacques Engel a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 18 novembre
2013;
(ii) Monsieur Jonathan Engel a démissionné de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société
avec effet au 18 novembre 2013;
(iii) Monsieur Philippe Quanson, né le 27 août 1953 à Alger (Algérie), demeurant à F-78112 Fourqueux, 9, rue des
Boulettes, a été coopté, avec effet au 4 décembre 2013 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014,
comme administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jacques Engel;
(iv) Monsieur Julien Giry, né le 30 juin 1989 à Evry (France), demeurant à F-91210 Draveil, 6, allée des Marronniers, a
été coopté, avec effet au 4 décembre 2013 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014, comme
administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jonathan Engel;
(v) Monsieur Patrick Giry, né le 4 juillet 1969 à Zweibrücken (République Fédérale Allemande), demeurant à L-2630
Luxembourg, 132, rue de Trèves, a été nommé comme délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 4
décembre 2013 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013174448/26.
(130212605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1920
A.H.P. S.A.
Albatros S.à r.l.
Art Evolution Group S.A.
Baek-Immo Sicav
Bal Main International S.A.
Beyton Investments S.à r.l.
BRE/Hamburg Reichshof Hotel S. à r.l.
Cabexco Group S.A.
Campwirt
Canom Conseils s.àr.l.
Cap Agro S.A.
Capitalis Fund Management S.à r.l.
Cardintel Investments Financiers S.A.
Carland s.à r.l.
Carricha S.A.
Casual S.àr.l.
C.B.R. Finance S.A.
CDRD Investment (Luxembourg) III S.à r.l.
CDRD Investment (Luxembourg) II S.à r.l.
CDRD Investment (Luxembourg) S.à r.l.
COF
Compagnie Francilienne d'Investissements S.A.
Côte d'Emeraude S.A.
CTR Machinery S. à r. l.
Data-Immo S.à r.l.
Deep Blue Holding S.A.
Dennys Café
Dentsply EU Holding S.à r.l.
Der Garten S. à r.l.
Domani S.A. SPF
Donjon S.A.
East Side Global S.A.
Edelweiss Group S.A.
Edelweiss Group S.A.
Edelweiss Group S.A.
EF (Luxembourg) S.à r.l.
EHO Holdings S.à r.l.
Empire 1 S.à r.l.
FANSY Ventures S.à r.l.
Fashion2 S.A.
IF-Corporate Services
Lion/Visor Lux 2
PI Diffusion S.A.
Prop Co. 15 A S.à r.l.
Prop Co. 15 C S.à r.l.
R-Solution
Ship Atlantic Holding S.A.
Société Luxembourgeoise d'Investissements Fonciers Internationaux (SLIFI) S.A.
Socoproject Immobilière S.A.
Texas Instruments International Holding Company S.à r.l.
White House Luxembourg SA