This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3278
24 décembre 2013
SOMMAIRE
Autopolis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157307
Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157307
Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157307
Batavia Lugduno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157308
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157306
BlueBay Global Unconstrained High Yield
Investments (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
157343
Blue Sky Care Home Holding 1 S.à r.l. . . .
157336
Blue Sky Holding 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
157338
Cambenes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157308
CBC AcquiCo1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157307
Centre de Télécommunications et Téléin-
formatiques Luxembourgeois . . . . . . . . . .
157308
Cervin Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157308
Corpag Services (Luxembourg) S.A. . . . . .
157338
Dagobah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157301
Dakhla SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157301
Dakhla SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157300
Dana Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157301
Data Circuits S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157302
De Grisogono Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
157305
Directional Communications S.à r.l. . . . . .
157302
DIVALARUS Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
157305
ERT Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
157314
Eurofood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157304
Events & Business Catering S.A. . . . . . . . . .
157300
Garage Auto Prestige S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
157340
GRB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157303
Holborn S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157335
Inzag II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157305
Ishti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157306
James Finance & Co. S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
157303
Karibou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157303
Kemaba Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157304
KH Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
157302
Kuznetski Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157304
Lerner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157309
LFPartners Investment Funds . . . . . . . . . . .
157314
Lune Holdings SPF SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157306
Lux 29 Starlight EUR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
157306
Luxbauhaus Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157311
Rubus International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
157330
Schreinerei Wilmes Patrick S. à r.l. . . . . . .
157298
SECMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157298
SOVALIM S.àr.l. (Société de Valorisation
Immobilière) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157298
SR Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157298
Stare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157299
Stylesconcept s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157299
Thesaly S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157299
Vamas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157300
Vaseq Holdings S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157300
Vitol Holding II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157299
White Star Publishers S.A. . . . . . . . . . . . . . .
157299
WP Roaming IV S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
157298
157297
L
U X E M B O U R G
SOVALIM S.àr.l. (Société de Valorisation Immobilière), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 10, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 35.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOVALIM S.àr.l. (Société de Valorisation Immobilière)
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013167827/11.
(130203618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
SR Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 64.122.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167833/10.
(130203937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
SECMI, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 450.800,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 163.872.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2013167815/10.
(130204404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Schreinerei Wilmes Patrick S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 82, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 113.962.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167810/10.
(130204554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
WP Roaming IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.868.200,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 109.441.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013167926/13.
(130204130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157298
L
U X E M B O U R G
Stare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3271 Bettembourg, 101, route de Peppange.
R.C.S. Luxembourg B 117.868.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013167836/11.
(130204272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Stylesconcept s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, Pierre Risch Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 166.541.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jorge Manuel SIMOES / Jean-Claude AUGÉ
<i>Le gérant administratif / Le gérant techniquei>
Référence de publication: 2013167840/11.
(130203600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Thesaly S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6437 Echternach, 8, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 106.073.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167876/10.
(130204351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Vitol Holding II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 43.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 28 novembre 2013.
Référence de publication: 2013167910/11.
(130204077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
White Star Publishers S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 59.922.
Le 19 novembre 2013, la société Administration Technique et Travaux Comptables S.A., en abrégé ATTC S.A., RCS
numéro B16441, a décidé de dénoncer le siège social avec effet immédiat, de la société WHITE STAR PUBLISHERS SA,
RCS numéro B 59.922 établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3a, boulevard du Prince Henri.
ATTC S.A.
Jean Bernard Zeimet
Référence de publication: 2013167922/11.
(130204609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157299
L
U X E M B O U R G
Vamas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-8085 Bertrange, 46, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 101.198.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167898/10.
(130204311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Vaseq Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013167902/10.
(130204082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Events & Business Catering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 26, rue d'Audun.
R.C.S. Luxembourg B 54.096.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siègeant en
matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions,
qu'ont été déclarées closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme EVENTS & BU-
SINESS CATERING SA, préqualifiée;
Le 14 novembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société en liquidation
i>Maître Edouard BUBENICEK
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013167986/19.
(130204754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Dakhla SA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 48.771.
EXTRAIT
M. Clive GODFREY, né le 6 août 1954 à Courtrai (Belgique), demeurant professionnellement L-2330 Luxembourg,
Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date
du 2 décembre 2013 de son mandat d'administrateur de la société DAKHLA S.A., société anonyme de droit luxembour-
geois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48 771 et dont le siège
est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clive GODFREY.
Référence de publication: 2013168152/15.
(130205263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157300
L
U X E M B O U R G
Dakhla SA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 48.771.
EXTRAIT
M. Jean-Pierre HIGUET, né le 23 novembre 1960 à Couvin (Belgique), demeurant professionnellement L-2330 Lu-
xembourg, Boulevard de la Pétrusse, 128, informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa
démission en date du 2 décembre 2013 de son mandat d'administrateur de la société DAKHLA S.A., société anonyme
de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48
771 et dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Pierre HIGUET.
Référence de publication: 2013168153/15.
(130205263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Dagobah S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, 182, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 169.364.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2013i>
<i>«Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel Patricia BENERE, deumeurant professionnellement
2, rue Gabriel Lippmann L-5365 MUNSBACH
L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, pour une période de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire à tenir en 2019:
FOP Conseil & Expertise S.A., ayant son siège social à L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 176.877.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
POUR EXTRAIT CONFORME
182, rue Principale
L-5366 MUNSBACH
Référence de publication: 2013168143/19.
(130205045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Dana Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 134.876.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2013i>
1- L'assemblée générale décide de renouveler jusqu'en 2019 le mandat des administrateurs suivants:
- Madame Albina BOECKLI
- Madame Liudmila ENILINA
- Monsieur Jean DONNET
Par ailleurs, l'assemblée prend acte que l'adresse de Madame Liudmila ENILINA est désormais la suivante:
- 5, route du Lac, CH-1246 Corsier (GE).
2- L'assemblée générale décide également de renouveler jusqu'en 2019 le mandat du commissaire aux comptes CHES-
TER & JONES Sàrl, RCS Luxembourg B 120,602.
Il est pris note de son changement d'adresse au:
- 14 rue Bernard Haal, L -1711 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2013168155/20.
(130204528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157301
L
U X E M B O U R G
Directional Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 45.371.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 30 mai 2013 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, a prononcé et ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée
DIRECTIONAL COMMUNICATIONS s.à.r.l. dont le siège social à L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I
er
a
été dénoncé en date du 11 mai 2001.
Le prédit jugement a nommé juge commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Anne DEVINKESSLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du tribunal de commerce avant le 21
juin 2013.
Pour extrait conforme
Anne DEVIN-KESSLER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013168162/20.
(130205112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Data Circuits S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1856 Luxembourg, 1, rue Evrard Ketten.
R.C.S. Luxembourg B 58.384.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 30 mai 2013 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, a prononcé et ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société à responsabilité limitée DATA
CIRCUIT s.à.r.l. Luxembourg avec siège social à L-1856 Luxembourg, 1 rue Evrard Ketten, de fait inconnue à cette adresse.
Le prédit jugement a nommé juge commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Anne DEVINKESSLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du tribunal de commerce avant le 21
juin 2013.
Pour extrait conforme
Anne DEVIN-KESSLER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013168156/19.
(130205113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
KH Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.048.750,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 76.006.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
<i>Pour: KH INVESTMENTS S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Christine Racot
Référence de publication: 2013167541/15.
(130203986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157302
L
U X E M B O U R G
GRB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.458.
Référence est faite à l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 3 juin 2013, déposé le
3 juin 2013 sous la référence L 130088157 et publié le 17 juillet 2013 au Mémorial C n° 1713 sous la référence
2013071219/33)
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 novembre 2013i>
- La cooptation de Monsieur Pierre PARACHE, employé privé, né le 9 décembre 1977 à Libramont, Belgique, demeu-
rant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de
Mademoiselle Noëlle PICCIONE, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.
Certifié sincère et conforme
Suit la traduction en anglais de ce qui précède:
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on November 22 i>
<i>ndi>
<i> , 2013i>
- The co-option of Mr Pierre PARACHE, private employee, born on December 9
th
, 1977 in Libramont, Belgium,
professionally residing at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, as Director in replacement of Ms Noëlle PICCIONE,
resigning Director, is ratified.
Luxembourg, November 22
nd
, 2013.
For true copy
GRB S.A.
Signatures
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2013167437/25.
(130203194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Karibou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 128.443.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2013.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Jean-Marie LEGENDRE et les sociétés FMS SERVICES S.A. et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Adminis-
trateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric HERREMANS, est réélu Commissaire aux Comptes pour
une nouvelle période de 6 ans
<i>Pour la société
i>KARIBOU S.A.
Référence de publication: 2013168325/14.
(130204866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
James Finance & Co. S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 127.598.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 4 avril 2013 par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
de renouveler le Conseil d'Administration comme suit:
- Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont Saint Martin (France) et demeurant professionnellement au 38
Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
- La société Compagnie d'Etude et de Conseil Luxembourg S.A. ayant son siège social au 38 avenue du X Septembre,
L-2550 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-59942, dont
157303
L
U X E M B O U R G
le représentant permanent est Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont Saint Martin (France) et demeurant
professionnellement au 38 Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
- La société Decia Invest S.A., ayant son siège social au 38 Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-99624, dont le représentant permanent est
Monsieur Guy FEITE, né le 22 juillet 1944 à Mont Saint Martin (France) et demeurant professionnellement au 38 Avenue
du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs viendront à échéance le 4 avril 2019.
de renouveler à son poste de commissaire aux comptes:
- la société M.P.M. International S.A., ayant son siège social au 30 Route de Luxembourg, L-6916 Roodt-Sur-Syre et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 69702.
Son mandat viendra à échéance le 4 avril 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2013.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013168307/29.
(130205336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Kemaba Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 111.418.
RECTIFICATIF
Suite à l'extrait enregistré et déposé le 15 avril 2013 N° L130058600, il y a lieu de lire que Madame Magali Fetique a
un pouvoir de signature de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2013.
KEMABA FINANCE S.A.
Référence de publication: 2013168327/13.
(130204893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Kuznetski Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 102.041.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 novembrei>
<i>2013i>
L'assemblée générale extraordinaire a accepté la démission de Monsieur Georges GUDENBURG de ses fonctions
d'administrateur de la Société avec date d'effet au 3 octobre 2013.
L'assemblée générale extraordinaire a nommé Madame Mevlüde-Aysun TOKBAG, née le 30 janvier 1979 à Krefeld,
Allemagne, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, aux fonctions d'admi-
nistrateur de la Société avec effet au 3 octobre 2013 et pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale
ordinaire en relation avec l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013168322/16.
(130204938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Eurofood, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 71, montée du Krakelshaff.
R.C.S. Luxembourg B 67.132.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 décembre 2013.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2013168197/11.
(130205509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157304
L
U X E M B O U R G
DIVALARUS Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 170.512.
<i>Résolutions de l'actionnaire unique de la société en date du 26 novembre 2013i>
En date du 26 novembre 2013, l'actionnaire unique de la Société a pris les trois (3) décisions suivantes:
1. Démission de l'administrateur unique de la Société
La démission de Monsieur Michaël ZERBIB, avocat, situé 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en qualité d'admi-
nistrateur unique de la Société, intervenue le 20.11.2013 est acceptée.
2. Nomination du nouvel administrateur unique
Monsieur Jean DE BEAUMONT, né le 17 août 1959 à Bourgoin (38), France, résidant 5 avenue des Gobelins, F-75005
Paris, France, est nommé administrateur unique de la Société pour une durée indéterminée.
3. Commissaire aux Comptes
Monsieur Fabien VLASSOF, sis Tour des Bureaux Rosny 2, F-93118 Rosny-sous-Bois, France, est démis de son mandat
de commissaire aux comptes de la Société.
Est nommée commissaire aux comptes de la Société Madame Anne-Ingrid ATTIAS, expert-comptable née le 5 mars
1975, à Fès, Maroc, sise 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, à compter de ce jour jusqu'à l'Assemblée Générale
de la Société qui se tiendra en 2015.
Référence de publication: 2013168163/21.
(130205560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
De Grisogono Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 69.573.
Par résolutions circulaires, le conseil d'administration a décidé en date du 2 décembre 2013 de transférer le siège
social de la Société du 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 19, rue Eugène Ruppert L-2453
Luxembourg et ce avec effet au 14 novembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour De Grisogono Holding S.A.
i>Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013168160/14.
(130205174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Inzag II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 151.604.
<i>Extrait rectificatif du dépôt L130163021 en date du 24.09.2013i>
1) Proroger le mandat de gérant de Monsieur Miguel Alexandre Martins CARDOSO DOS SANTOS BARREIROS, né
le 29 octobre 1973 à Lisbonne (Portugal), demeurant à 1700 Lisbonne (Portugal), 54, av. Frei Miguel Contreiras
2) Proroger le mandat de gérant de Monsieur Rui Manuel FERNANDES ANDRADE, né le 17 octobre 1970 à Angola,
demeurant à 2740-244 Porto Salvo, Lagoas Park, Edificio 6, Piso 1 (Portugal)
3) Nomination de Monsieur Leandro DE AGUIAR, né le 1
er
avril 1950 à Archa Minas Gérais (Brésil), demeurant à
22250 040 Rio de Janeiro (Brésil), 300, Praia de Botafogo aux fonctions de gérant, avec effet immédiat.
4) Divers
Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013168283/19.
(130205471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157305
L
U X E M B O U R G
Lux 29 Starlight EUR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 181.439.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales prenant effet en date du 29 novembre 2013 que la société Starwood
Capital Operations LLC dont le siège social se situe Corporation trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, State of Delaware, USA, a cédé toutes les parts sociales qu'elle détenait dans la Société, soit:
- 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq EUR) chacune à la société
Brookstar JVCo Lux S.à r.l. dont le siège social se situe 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 180 201.
Les détenteurs de parts sociales sont désormais les suivants:
- Brookstar JVCo Lux S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Thierry Drinka
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013168341/19.
(130205510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Lune Holdings SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.964.
Les administrateurs de la Société ont décidé, par résolution écrite du 28 novembre 2013, de transférer le siège social
du 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013168340/12.
(130205087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Ishti, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.628.
Le gérant unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 28 novembre 2013, de transférer le siège social du
7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013168286/12.
(130204663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 173.602.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 12 août 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 septembre 2013.
Référence de publication: 2013168059/11.
(130205473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157306
L
U X E M B O U R G
Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 111.817.
Les statuts coordonnés de la prédite société au 19 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 décembre 2013.
Maître Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013168056/13.
(130205301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 110.187.
Les statuts coordonnés de la prédite société au 19 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 3 décembre 2013.
Maître Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013168055/13.
(130205353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Autopolis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 30.604.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 17 juin 2013i>
L'Assemblée constate et accepte la démission de Monsieur Dominique MOORKENS aux fonctions d'administrateur
et d'administrateur-délégué avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS ATO
Référence de publication: 2013168052/12.
(130205252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
CBC AcquiCo1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 178.996.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Sociétéi>
Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 27 novembre 2013, qu'a été acceptée:
- la nomination de Mme Pamela Valasuo, née le 26 mai 1975 à Borga Ik, Finlande, résidant professionnellement à 2a,
rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 17 novembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 décembre 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013168109/16.
(130205556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157307
L
U X E M B O U R G
Cervin Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 168.858.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 novembre 2013, le Conseil a pris les
résolutions suivantes:
1. Le Conseil d'Administration accepte avec effet immédiat les démissions de Monsieur Jean-Pierre DE WOLF et de
Monsieur Vincent MULDER, en leur qualité d'administrateur de la Société.
2. Le Conseil accepte avec effet immédiat la démission de Monsieur Vincent MULDER, en sa qualité d'administrateur-
délégué de la Société.
3. Les Résolutions précitées seront ratifiés lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013168113/16.
(130204747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Centre de Télécommunications et Téléinformatiques Luxembourgeois, Société Anonyme.
Siège social: L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël.
R.C.S. Luxembourg B 33.061.
Monsieur Vincent Lekens a présenté sa démission comme administrateur de la société avec effet au 27 novembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2013.
G.T. Experts Comtpables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2013168112/12.
(130205205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Cambenes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 106.241.
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 7 novembre 2011 que:
Le mandat de Monsieur Rudi Puwels et Madame Carine Claeys a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour une
durée de six ans.
L'adresse de Madame Carine Claeys se trouve désormais Victor Jacobslei, 15, B-2600 Berchem et celle de Monsieur
Alberto Morandini au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Référence de publication: 2013168105/14.
(130205060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Batavia Lugduno, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.629.
Le gérant unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 28 novembre 2013, de transférer le siège social du
7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013168057/12.
(130204664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157308
L
U X E M B O U R G
Lerner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 181.996.
STATUTS
L'an deux mille treize, le treize novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Madame Catherine ZOLLER, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique) le 08 avril 1967, demeurant profes-
sionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'elle constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de LERNER S.à r.l. (ci-après la «Société»).
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut:
- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou
indirectement à son objet;
- détenir des marques et brevets;
- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-
ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales, sans désignation de la valeur nominale.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
157309
L
U X E M B O U R G
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la Loi de 1915.
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, Madame
Catherine ZOLLER, pré-qualifiée, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numé-
raire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales se trouvent remplies.
157310
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 950,- EUR.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1. - L'adresse du siège social est établie à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
2. - Madame Catherine ZOLLER, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique) le 08 avril 1967, demeurant
professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, est nommée gérante unique de la Société pour une durée
indéterminée.
3. - La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Catherine ZOLLER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2013. Relation GRE/2013/4572. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013167581/118.
(130203911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Luxbauhaus Invest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 36, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 181.994.
STATUTS
L'an deux mille treize, le treize novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1. La société anonyme «DEPALOM S.A.» ayant son siège social au 34-36, rue du Dernier Sol, L-2543 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 132.178,
représentée par son administrateur unique, à savoir Monsieur Robert ZUPANOSKI, gérant de société né le 30 juillet
1968 à Struga (Macédoine), demeurant au 9, rue du 31 août 1942, L- 5809 Hesperange.
2. La société à responsabilité limitée «VITRUVE S.à r.l.» ayant son siège social au 36, rue du Dernier Sol, L-2543
Luxembourg, en cours d'immatriculation, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné,
représentée par son gérant, à savoir Monsieur Stéphane BESADOUX, demeurant au 95 Boulevard Pasteur, F- 93320
Les Pavillons Sous Bois.
Lesquels représentants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Forme. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il
est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
La société comporte initialement plusieurs associés. Elle peut cependant à toute époque, comporter un seul associé,
par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts, sans que cela n'entraîne la dissolution de la Société.
Art. 2. Objet. La société a pour objet la prise de participations financières, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres
sociétés Luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apports, de souscriptions, d'options, d'achat et de toute autre manière, de valeurs
immobilières et mobilières de toute nature et de les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société pourra également acquérir et mettre en valeur tout brevet et droits attachés, emprunter ou accorder à
d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêt, avance ou garantie de quelque nature.
A ce titre et dans le cadre de son activité, la société pourra se porter caution en faveur de tiers, personnes physique
ou morale.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «LUXBAUHAUS INVEST».
Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.
157311
L
U X E M B O U R G
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé
unique ou des associés.
La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et Obligations attachées aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenues de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. Les parts sociales sont librement cessibles et transmissibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. L'agrément doit être
donné dans un délai de trois mois de la notification. Passé ce délai, à défaut de réponse, l'agrément est réputé donné. En
cas de refus d'agrément, le gérant doit proposer la reprise des parts soit par un autre associé, soit par un tiers qu'il aura
fait agréer. A défaut, passé un délai de trois mois supplémentaires, la cession initialement prévue peut être réalisée.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évé-
nement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Les gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée par l'Associé unique ou l'Assemblée Générale
des Associés, selon le cas.
Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l'Associé unique ou l'Assemblée Générale des Associés, selon le cas,
détermine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.
Les Gérants sont rééligilbles.
L'Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L'Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.
Art. 14. Pouvoirs des gérants. Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'adminis-
tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à
condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société
en justice soit en demandant soit en défendant.
Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou
temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).
Art. 15. Evénements atteignant les gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
157312
L
U X E M B O U R G
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 16. Responsabilité des gérants. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 17. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la seule
signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants ou encore
par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été
délégués par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Cependant pour toute activité soumise à autorisation de la part
du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne sur laquelle repose l'autorisation sera toujours requise.
Art. 18. Assemblée générale des associés. Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par
vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 19. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, seront établies
par écrit et consignée dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés,
ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 20. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre
de la même année.
Art. 21. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la
société et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication
desdits inventaire et bilan.
Art. 22. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des
frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale. Toutes les matières qui seraient pas régies par les présents statuts seraient régies
conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Ensuite les comparants ont déclaré souscrire et libérer intégralement en numéraire les parts sociales émises en cette
qualité comme suit:
Associés
Nombre
de parts
sociales
1) «DEPALOM S.A.», prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) «VITRUVE S.à r.l.», prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Preuve de cette libération en numéraire, soit la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) a
été donnée au notaire soussigné qui la constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.
<i>Coût, Évaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille euros.
157313
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés prénommés se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ils
ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre de gérants est fixé à UN (1), et le gérant suivant est nommé pour une durée illimitée, avec les pouvoirs
prévus à l'article QUATORZE (14) des statuts de la Société:
Monsieur Robert ZUPANOSKI, gérant de société né le 30 juillet 1968 à Struga (Macédoine), demeurant au 9, rue du
31 août 1942, L- 5809 Hesperange.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement
par sa seule signature en conformité avec l'article DIX-SEPT (17) des statuts.
2.- L'adresse du siège social est fixée au 36 rue du Dernier Sol, L-2543 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux représentants des parties comparantes, connus du notaire
instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les mêmes représentants ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: S. BESADOUX, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14863.
Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2013167601/160.
(130203826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
ERT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.640,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.256.
<i>Extrait d'une résolution prise à Luxembourg par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 14 novembre 2013.i>
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Alain Vauthier né le 29 juillet 1951 à Rambervilliers (88), France, résidant
professionnellement au 12, Rue de Notre Dame des Victoires, 75002 Paris, France, aux fonctions de gérant de la Société
pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013168192/13.
(130205219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
LFPartners Investment Funds, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 182.010.
STATUTES
In the year two thousand thirteen, on the fourteenth day of November.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Luxembourg Fund Partners S.A., having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscribed
in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 150332
duly represented by Me Jonathan BURGER, avocat a la Cour, professionally residing at 12, rue Jean Engling, L-1466
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 8
th
November 2013.
The proxy given, signed ne varietur by proxyholder of the the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to this deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which she act has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which he declares to constitute as sole shareholder.
Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose - Definitions
Art. 1. Name. There is hereby established by the sole subscriber and all those who may become owners of shares
hereafter issued (the "Shares"), a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with
157314
L
U X E M B O U R G
variable share capital (société d'investissement à capital variable) which can be composed of one or several portfolios of
assets under the name of "LFPartNERS INVESTMENT FUNDS" (the "Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad (but
in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a resolution of the Board of Directors of
the Company (the "Board of Directors"). The registered office of the Company may be transferred within the same
municipality by decision of the Board of Directors. It may be transferred to any other municipality within the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of holders of Shares ("Shareholder(s)"), adopted in the
manner required for an amendment of these articles of incorporation (the "Articles") or by a resolution of the sole
Shareholder.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military events
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in (i) shares in companies
and other securities equivalent to shares in companies, (ii) bonds and other forms of securitised debt, and/or (iii) any
other negotiable securities which carry the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchange
("Transferable Securities") and (iv) other assets permitted by applicable law, with the purpose of spreading investment
risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted by Part I of the law of 17
th
December 2010 on undertakings
for collective investment as may be amended from time to time (the "Law of 2010").
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of
no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof (the "Net
Asset Value"). The minimum capital as provided by the Law of 2010 shall be one million two hundred and fifty thousand
euro (EUR 1,250,000). Such minimum capital must be reached within a period of six (6) months after the date on which
the Company has been authorised as a collective investment undertaking under Luxembourg law. The initial capital is of
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty one (31) Shares of no par value.
The Company may have one or several Shareholders.
The Board of Directors may establish several portfolios of assets, each constituting a compartment of the Company
(each a "Compartment" or "Compartments") within the meaning of Articles 181 of the Law of 2010.
Within each Compartment, the Shares to be issued pursuant to Articles 6 and 7 hereof may, as the Board of Directors
shall determine, be of different classes (each a "Class" or "Class of Shares"). The proceeds of the issue of each Class of
Shares shall be invested pursuant to the investment policy determined by the Board of Directors for the Compartment
established in respect of the relevant Class or Classes of Shares, subject to the investment restrictions and eligibility of
assets provided by the Law of 2010 and Luxembourg applicable Grand-Ducal Decree and regulations and as determined
by the Board of Directors.
The Company constitutes one single legal entity. However, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive
benefit of the relevant Compartment. In addition, each Compartment shall only be responsible for the liabilities which
are attributable to it.
The Board of Directors may create each Compartment or Class of Shares for an unlimited or limited period of time;
in the latter case at the expiry of the initial period of time, the Board of Directors may extend the duration of the relevant
Compartment or Class of Shares once or several times. At expiry of the duration of the Compartment, the Company
shall redeem all the Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with Article 8.
At each prorogation of a Compartment or Class(es) of Shares, the registered Shareholders shall be duly notified in
writing, by a notice sent to the registered address as recorded in the register of Shares of the Company. The Company
shall inform the bearer Shareholders by a notice published in newspapers to be approved by the Board of Directors,
unless these Shareholders and their addresses are known to the Company. The sales documents of the Company (the
"Sales Documents") shall indicate the duration of each Compartment and if appropriate, its prorogation. The Board of
Directors, acting in the best interest of the Company, may decide that all or part of the assets of two or more Com-
partment be co-managed, as described in the Sales Documents.
157315
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Form of Shares.
(1) The Board of Directors shall determine whether the Company shall issue Shares in bearer and/or in registered
form. If bearer Share certificates are to be issued upon request of a Shareholder, they will be issued in such denominations
as the Board of Directors shall prescribe and shall provide on their face that they may not be transferred to any prohibited
person as defined hereinafter in Article 10 ("Prohibited Person") or entity organized by or for a Prohibited Person
All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by
the Company or by one or more persons or by other duly authorized agent designated by the Company, and such register
shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company
and the number of registered Shares held by him.
The inscription of the Shareholder's name in the register of Shareholders evidences his right of ownership on such
registered Shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the Share-
holder or whether the Shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
If bearer Shares are issued, registered Shares may be converted into bearer Shares and bearer Shares may be converted
into registered Shares at the request of the holder of such Shares. A conversion of registered Shares into bearer Shares
will be effected by cancellation of the registered Share certificate, if any, representation that the transferee is not a
Prohibited Person and issuance of one or more bearer Share certificates in lieu thereof; and an entry shall be made in
the register of Shareholders to evidence such cancellation. A conversion of bearer Shares into registered Shares will be
effected by cancellation of the bearer Share certificate, and, if applicable, by issuance of a registered Share certificate in
lieu thereof, and an entry shall be made in the register of Shareholders to evidence such issuance. At the option of the
Board of Directors, the costs of any such exchange may be charged to the Shareholder requesting it.
Before Shares are issued in bearer form and before registered Shares shall be converted into bearer Shares, the
Company may require assurances satisfactory to the Board of Directors that such issuance or exchange shall not result
in such Shares being held by a Prohibited Person.
The Share certificates shall be signed by two members of the Board of Directors ("Directors") or the share registrar
agent acting on behalf of the Company. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. The certificates
will remain valid even if the list of authorized signatures of the Company is modified. However, one of such signatures
may be made by a person duly authorized thereto by the Board of Directors; in the latter case, it shall be manual. The
Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board of Directors may determine.
(2) If bearer Shares are issued, transfer of bearer Shares shall be effected by the delivery of the relevant Share certi-
ficates. Transfer of registered Shares shall be effected (i) if Share certificates have been issued, upon delivering the
certificate or certificates representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory
to the Company and (ii) if no Share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in
the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers
of attorney to act therefore. Any transfer of registered Shares shall be entered into the register of Shareholders; such
inscription shall be signed by one or more Directors or officers of the Company or by one or more other persons or
agent duly authorized thereto by the Board of Directors.
(3) Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(4) If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance
of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in replacement
of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated Share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the Shareholder the costs of a duplicate or of a new Share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original Share certificate.
(5) The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the
ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney
to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such Share(s).
(6) The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall
be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis. If the sum of
157316
L
U X E M B O U R G
the fractional Shares so held by the same Shareholder represents one or more entire Share(s), such Shareholder has the
correspondent voting right. In the case of bearer Shares, only certificates evidencing full Shares will be issued.
Art. 7. Issue of Shares. The Board of Directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully
paid up Shares at any time without reserving the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to
be issued.
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class or
Compartment; the Board of Directors may, in particular, decide that Shares of any Compartment shall only be issued
during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the Sales Documents.
The Board of Directors may impose restrictions in relation to the minimum amount of initial subscription, the minimum
amount of any additional investments and the minimum amount of any holding of Shares.
After the initial offer of Shares for subscription, whenever the Company offers Shares for subscription, the price per
Share at which such Shares are offered shall be the Net Asset Value per Share of the relevant Class within the relevant
Compartment as determined in compliance with Article 11 hereof as of such day ("Valuation Day", as further described
in Article 12 hereinafter) as is determined in accordance with such policy as the Board of Directors may from time to
time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the
Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time to time
by the Board of Directors. The price so determined shall be payable within a maximum period as provided for in the
Sales Documents and determined by the Board of Directors and which shall not exceed ten (10) business days as defined
in the Sales Documents ("Business Day") after the relevant Valuation Day.
The Board of Directors may delegate to any Director, manager, officer or other duly authorized agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.
If subscribed Shares are not paid for, the Company may redeem the Shares issued, whilst retaining the right to claim
the issue fees and commission and any difference. In this case the applicant may be required to indemnify the Company
against any and all losses, costs or expenses incurred directly or indirectly as a result of the applicant's failure to make
timely settlement, as conclusively determined by the Board of Directors in its discretion. In computing such losses, costs
or expenses account shall be taken where appropriate of any movement in the price of the Shares between allotment
and cancellation or redemption and the costs incurred by the Company in taking proceedings against the applicant.
The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with
the conditions set forth by applicable Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the
independent auditor of the Company (réviseur d'entreprises agréé) and provided that such securities delivered by way
of contribution in kind comply with the investment objectives and investment policies and restrictions of the Compart-
ment to which they are contributed. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of securities shall be
borne by the relevant Shareholders.
Art. 8. Redemption of Shares. Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the Board of Directors in the Sales Documents and within the limits provided
by the Law of 2010 and these Articles.
The redemption price per Share shall be paid within a maximum period of time as provided by the Sales Documents.
Such a period shall not exceed ten (10) business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance
with such policy as the Board of Directors may from time to time determine, provided that the Share certificates, if any,
and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 11 hereof.
The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Class within the relevant
Compartment, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such expenses and commissions
(if any) at the rate provided by the Sales Documents, in compliance with the Law of 2010 and any applicable regulation.
The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest one thousandth of the currency in which the
Net Asset Value per Share is expressed and calculated as further detailed in the Sales Documents (the "Pricing Currency")
as the Board of Directors shall determine.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate Net Asset Value of the Shares held by any
Shareholder in any Class of Shares of the relevant Compartment would fall below such number or such value as deter-
mined by the Board of Directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption
for the full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class.
Further, if on any given Valuation Day redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant
to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the Board of Directors and disclosed in the Sales Documents
in relation to the number of Shares in issue of a Class or in case of a strong volatility of the market or markets on which
a Class is investing, or in the interest of the Company and the Shareholders, the Board of Directors may decide that part
or all of such requests for redemption or conversion will be deferred as long as it is needed to sell the assets and only if
it is in a manner that the Board of Directors considers to be in the best interests of the Company. On the next Valuation
Day, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests if necessary on a pro-rata basis
among involved Shareholders.
157317
L
U X E M B O U R G
If on any given Valuation Day redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article
9 hereof amount to the total number of Shares in issue in any or all Class of Shares or Compartments, the calculation of
the Net Asset Value per Share of the relevant Class(es) of Shares may be deferred to take into consideration the fees
incurred in closing of said Class(es) and or Compartment.
The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any Shareholder who agrees in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in
connection with such Class(es) equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the Valuation Day
on which the redemption price is calculated to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to
be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the
other holders of Shares of the relevant Class or Classes of Shares and the valuation used shall be confirmed by a special
report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.
All redeemed Shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares. Unless otherwise determined by the Board of Directors for certain Classes of Shares
or Compartments, any Shareholder is entitled to request the conversion of whole or part of his Shares of one Class into
Shares of the same or another Class, within the same or another Compartment subject to such restrictions as to the
terms, conditions and payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine.
The price for the conversion of Shares from one Class or Compartment into another Class or Compartment shall be
computed by reference to the respective Net Asset Value of the two Classes of Shares, calculated on the same Valuation
Day.
If as a result of any request for conversion the number or the aggregate Net Asset Value of the Shares held by any
Shareholder in any Class of Shares would fall below such minimum holding as determined by the Board of Directors, then
the Board of Directors may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such
Shareholder's holding of Shares in such Class.
The Shares which have been converted into Shares of another Class shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to
the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof
the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise
incurred (such person, firm or corporate body to be determined by the Board of Directors being herein referred to as
"Prohibited Person").
For such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a Prohibited
Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of Shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares, direct such Shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the
sale within thirty (30) days of the notice. If such Shareholder fails to comply with the direction, the Company may
compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the
following manner:
(1) The Company shall serve a second notice (the "Purchase Notice") upon the Shareholder holding such Shares or
appearing in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased
as aforesaid the manner in which the Purchase Price as defined hereinafter will be calculated and the name of the purchaser.
Any such Purchase Notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said Share-
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates representing
the Shares specified in the Purchase Notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Shareholder shall cease to
be the owner of the Shares specified in such Purchase Notice and, in the case of registered Shares, his name shall be
removed from the register of Shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing
such Shares shall be cancelled.
(2) The price at which each such Share is to be purchased (the "Purchase Price") shall be an amount based on the net
asset value per Share of the relevant class as at the Valuation Day specified by the Board of Directors for the redemption
of shares in the Company next preceding the date of the Purchase Notice or next succeeding the surrender of the Share
157318
L
U X E M B O U R G
certificate or certificates representing the Shares specified in such Purchase Notice, whichever is lower, all as determined
in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.
(3) Payment of the Purchase Price will be made available to the former owner of such Shares normally in the currency
fixed by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the Shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
purchase notice) upon final determination of the Purchase Price following surrender of the Share certificate or certificates
specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the Purchase Notice as
aforesaid such former owner shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Purchase Price (without interest) from such
bank following effective surrender of the Share certificate or certificates as aforesaid. Any funds receivable by a Share-
holder under this paragraph, but not collected within a period of six months from the date specified in the Purchase
Notice, may not thereafter be claimed and shall be deposit with the "Caisse de Consignations". The Board of Directors
shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on
behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to Shares of the Company issued in connection
with the incorporation of the Company while such subscriber holds such Shares nor any securities dealer who acquires
Shares with a view to their distribution in connection with an issue of Shares by the Company.
Prohibited Person does include without limitation:
- Any person subject to the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended ("ERISA"),
and to other benefit plan, as defined in ERISA so as to avoid that the aggregate holding of shares by such persons may
reach 25 per cent of the value of any class (as determined in accordance with ERISA).
- "U.S. person" which means a person as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933 and thus
shall include but not limited to, (i) any natural person resident in the United States; (ii) any partnership or corporation
organised or incorporated under the laws of the United States; (iii) any estate of which any executor or administrator is
a U.S. Person; (iv) any trust of which any trustee is a U.S. Person; (v) any agency or branch of a foreign entity located in
the United States; (vi) any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer,
or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. Person; (vii) any discretionary account or similar account (other
than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the
United States; and (viii) any partnership or corporation if: (A) organised or incorporated under the laws of any foreign
jurisdiction; and (B) formed by a U.S. Person principally for the purpose of investing in securities not registered under
the Securities Act, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors (as defined in Rule 501(a)
under the Securities Act) who are not natural persons, estates or trusts; but shall not include (i) any discretionary account
or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non U.S. Person by a dealer or
other professional fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States or (ii) any estate
of which any professional fiduciary acting as executor or administrator is a U.S. Person if an executor or administrator
of the estate who is not a U.S. Person has sole or shared investment discretion with respect to the assets of the estate
and the estate is governed by foreign law.
U.S. person as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with
the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares
with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.
Art. 11. Calculation of the Net Asset Value. The Net Asset Value per Share of each Class of Shares within each
Compartment shall be expressed in the Pricing Currency (as defined in the Sales Document) of the relevant Class or
Compartment and shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to
each Class of Shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class, on
any such Valuation Day by the total number of Shares in the relevant Class then outstanding, in accordance with the
valuation rules set forth below. The Net Asset Value per Share may be rounded up or down to the nearest one thousandth
of the relevant Pricing Currency as the Board of Directors shall determine.
If after the time of determination of the Net Asset Value per Share, but before its publication, there has been a material
change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to a Compartment
are dealt in or quoted on, the Company may cancel the first valuation and carry out a second valuation, in order to
safeguard the interests of the Shareholders and the Company. In such a case, instructions for subscription, redemption
or conversion of Shares shall be executed on the basis of the second Net Asset Value calculation.
The valuation of the Net Asset Value of the different Classes of Shares shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued
157319
L
U X E M B O U R G
thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all debt securities, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription
rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the
Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below
with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset;
6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing Shares, insofar as the same
have not been written off;
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of the assets of each Compartment shall be determined as follows:
(a) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes payable and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full
amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is
arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true
value thereof.
(b) The value of any asset admitted to official listing on any stock exchange or dealt on any regulated market shall be
based on the last available closing or settlement price in the relevant market prior to the time of valuation, or any other
price deemed appropriate by the Board of Directors.
(c) The value of assets that are not listed or dealt in on a stock exchange or on any regulated market or if, with respect
to assets listed or dealt in on any stock exchange or any regulated market, the price as determined pursuant to sub-
paragraph (b) is, in the opinion of the directors, not representative of the value of the relevant assets, such assets are
stated at fair market value or otherwise at the fair value at which it is expected they may be resold, as determined in
good faith by or under the direction of the Board of Directors.
(d) The liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on a stock exchange of another state or
regulated markets, or on other regulated market or dealt on any regulated market shall mean their net liquidating value
determined, pursuant to the policies established prudently and in good faith by the Board of Directors, on a basis con-
sistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward and options contracts
traded on a stock exchange of another state or regulated markets, or on other regulated markets or dealt on any regulated
market shall be based upon the last available closing or settlement prices of these contracts on stock exchanges and
regulated market or on other regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
on behalf of the Company; provided that if a future, forward or options contract could not be liquidated on the day with
respect to which assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be
such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.
(e) Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortized cost method,
which approximates market value. Under this valuation method, the relevant Compartment's investments are valued at
their acquisition cost as adjusted for amortization of premium or accretion of discount rather than at market value.
(f) Units or shares of an open-ended undertaking for collective investment ("UCI") will be valued at their last determined
and available official net asset value, as reported or provided by such UCI or its agents, or at their last unofficial net asset
values (i.e. estimates of net asset values) if more recent than their last official net asset values, provided that due diligence
has been carried out by the investment manager, in accordance with instructions and under the overall control and
responsibility of the Board of Directors, as to the reliability of such unofficial net asset values. The Net Asset Value
calculated on the basis of unofficial net asset values of the target UCI may differ from the Net Asset Value which would
have been calculated, on the relevant Valuation Day, on the basis of the official net asset values determined by the
administrative agents of the target UCI. The Net Asset Value is final and binding notwithstanding any different later
determination. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued in accordance with the valuation rules set out in
items (b) and (c) above.
(g) Interest rate swaps will be valued on the basis of their market value established by reference to the applicable
interest rate curve.
Total return swaps will be valued at fair value under procedures approved by the Board of Directors. As these swaps
are not exchange-traded, but are private contracts into which the Company and a swap counterparty enter as principals,
the data inputs for valuation models are usually established by reference to active markets. However it is possible that
such market data will not be available for total return swaps near the Valuation Day. Where such markets inputs are not
available, quoted market data for similar instruments (e.g. a different underlying instrument for the same or a similar
reference entity) will be used provided that appropriate adjustments are made to reflect any differences between the
157320
L
U X E M B O U R G
total return swaps being valued and the similar financial instrument for which a price is available. Market input data and
prices may be sourced from exchanges, a broker, an external pricing agency or a counterparty.
If no such market input data are available, total return swaps will be valued at their fair value pursuant to a valuation
method adopted by the Board of Directors which shall be a valuation method widely accepted as good market practice
(i.e. used by active participants on setting prices in the market place or which has demonstrated to provide reliable
estimate of market prices) provided that adjustments that the Board of Directors may deem fair and reasonable be made.
The Company's auditor will review the appropriateness of the valuation methodology used in valuing total return swaps.
In any way the Company will always value total return swaps on an arm-length basis.
All other swaps, will be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the
Board of Directors.
(h) Assets or liabilities denominated in a currency other than that in which the relevant Net Asset Value per Share
will be expressed, will be converted at the relevant foreign currency spot rate on the relevant Valuation Day. If such
quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established
by the Board of Directors. In that context account shall be taken of hedging instruments used to cover foreign exchange
risks.
(i) All other securities instruments and other assets are valued at fair market value as determined in good faith pursuant
to procedures established by the Board of Directors.
For the purpose of determining the value of the Company's assets, the administrative agent, having due regards to the
standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the Net Asset Value, completely and exclusively
rely, unless there is manifest error or negligence on its part, upon the valuations provided (i) by various pricing sources
available on the market such as pricing agencies (e.g. Bloomberg, Reuters) or fund administrators, (ii) by prime brokers
and brokers, or (iii) by (a) specialist(s) duly authorized to that effect by the Board of Directors. Finally, in the case no
prices are found or when the valuation may not correctly be assessed, the administrative agent may rely upon the valuation
provided by the Board of Directors.
In circumstances where (i) one or more pricing sources fails to provide valuations to the administrative agent, which
could have a significant impact on the Net Asset Value, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as
rapidly and accurately as required, the administrative agent is authorized to postpone the Net Asset Value calculation
and as a result may be unable to determine subscription and redemption prices. The Board of Directors shall be informed
immediately by the administrative agent should this situation arise. The Board of Directors may then decide to suspend
the calculation of the Net Asset Value in accordance with the procedures described in Article 12 below.
Adequate provisions will be made, Compartment by Compartment, for expenses to be borne by each of the Company's
Compartment's and off-balance-sheet commitments may possibly be taken into account on the basis of fair and prudent
criteria.
The value of all assets and liabilities not expressed in the base currency of a Compartment will be converted into the
base currency of such Compartment at the rate of exchange on the relevant Valuation Day. If such quotations are not
available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the Board of
Directors.
The Board of Directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses, including but not limited to administrative expenses, investment advisor fees,
management fees, including incentive fees, fees of the depositary bank as defined in article 29 (the "Depositary Bank"),
and administrative agents' fees;
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature including set-up expenses of the Company or any
of its Compartments reflected in accordance with generally accepted accounting principles. In determining the amount
of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation
expenses, fees payable to its investment manager and adviser, including performance fees, fees and expenses payable to
its auditors and accountants, Depositary Bank and its correspondents, domiciliary and corporate agent, registrar and
transfer agent, listing agent, any paying agent, any permanent representatives in places of registration, as well as any other
agent employed by the Company, the remuneration of the Directors (if any) and their reasonable out-of-pocket expenses,
insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal and
157321
L
U X E M B O U R G
auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any
governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and
publishing expenses, including the cost of preparing, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory me-
moranda, periodical reports or registration statements, and the costs of any reports to Shareholders, all taxes, duties,
governmental and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest,
bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may accrue administrative and other expenses
of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably for yearly or other periods.
III. The assets shall be allocated as follows:
The Board of Directors shall establish a Compartment in respect of each Class of Shares and may establish a Com-
partment in respect of two or more Classes of Shares in the following manner:
a) If two or more Classes of Shares relate to one Compartment, the assets attributable to such Classes shall be
commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Compartment concerned. Within a Compartment,
Classes of Shares may be defined from time to time by the board so as to correspond to (i) a specific distribution policy,
such as entitling to distributions ("Distribution Shares") or not entitling to distributions ("Capitalization Shares") and/or
(ii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iii) a specific management or advisory fee structure, and/or
(iv) a specific distribution fee structure, and/or (v) a specific currency, and/or (vi) different minimum investment requi-
rements, and/or (vii) the use of different hedging techniques in order to protect in the base currency of the relevant
Compartment the assets and returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements
of their currency of quotation; and/or (viii) any other specific features applicable to one Class.
b) The proceeds to be received from the issue of Shares of a Class shall be applied in the books of the Company to
the Compartment established for that Class of Shares, and the relevant amount shall increase the proportion of the net
assets of such Compartment attributable to the Class of Shares to be issued, and the assets and liabilities and income and
expenditure attributable to such Class or Classes shall be applied to the corresponding Compartment subject to the
provisions of this Article.
c) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Compartment as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or
decrease in value shall be applied to the relevant Compartment.
d) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Compartment or to any action taken
in connection with an asset of a particular Compartment, such liability shall be allocated to the relevant Compartment.
e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Class of Shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of Shares pro rata to the Net Asset Values of
the relevant Classes of Shares or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith.
Each Compartment shall only be responsible for the liabilities which are attributable to such Compartment.
f) Upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the Net Asset Value of such Class of Shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken
by the Board of Directors or by any bank, company or other organization which the Board of Directors may appoint for
the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
Shareholders.
IV. For the purpose of this Article:
1) Shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board of Directors on the Valuation Day on which such redemption is
made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the
Company;
2) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of
Directors on the Valuation Day on which such issue is made and from such time and until received by the Company the
price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the base currency of the relevant
Compartment shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force on the relevant
Valuation Day; and
4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
157322
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Conversion of Shares. With respect to each Class of Shares, the Net Asset Value per Share and the subscription, re-
demption and conversion price of Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the Board of Directors, such date or time
of calculation being the Valuation Day.
The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any particular Com-
partment and the issue and redemption of its Shares from its Shareholders as well as the conversion from and to Shares
of each Compartment:
a) during any period when any of the principal stock exchanges, regulated market or other regulated markets on which
a substantial portion of the investments of the Company attributable to a Compartment from time to time is quoted or
when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the assets of the Com-
partment is denominated are closed otherwise than for ordinary holidays or during which dealings are substantially
restricted or suspended;
b) political, economic, military, monetary or other emergency beyond the control, liability and influence of the Com-
pany makes the disposal of the assets of any Compartment impossible under normal conditions or such disposal would
be detrimental to the interests of the Shareholders;
c) during any breakdown in the means of communication network normally employed in determining the price or value
of any of the investments of such Compartment or the current price or value on any stock exchange or market in respect
of the assets attributable to such Compartment;
d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Shares of such Compartment or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected
at normal rates of exchange;
e) during any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to
such Compartment cannot promptly or accurately be ascertained;
f) during any period when the Board of Directors so decides, provided all Shareholders are treated on an equal footing
and all relevant laws and regulations are applied (i) as soon as an extraordinary general meeting of Shareholders of the
Company or a Compartment has been convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the
Company or a Compartment and (ii) when the Board of Directors is empowered to decide on this matter, upon its
decision to liquidate or dissolve a Compartment;
g) following a decision of merging, liquidate or dissolve the Company or any of its Compartments or upon the order
of the regulatory authority;
h) following the suspension of the calculation of the net asset value, issue, redemptions or conversions of shares or
units of the master fund in which the Company invests as its feeder fund.
When exceptional circumstances might adversely affect Shareholders' interests or in the case that significant requests
for subscription, redemption or conversion are received, the Board of Directors reserves the right to set the value of
Shares in one or more Compartments only after having sold the necessary securities, as soon as possible, on behalf of
the Compartment(s) concerned. In this case, subscriptions, redemptions and conversions that are simultaneously in the
process of execution will be treated on the basis of a single Net Asset Value per Share in order to ensure that all
Shareholders having presented requests for subscription, redemption or conversion are treated equally.
Any such suspension of the calculation of the Net Asset Value shall be notified to the subscribers and Shareholders
requesting redemption, subscription or conversion of their Shares on receipt of their request for subscription, redemption
or conversion.
Suspended subscriptions, redemptions and conversions will be taken into account on the first Valuation Day after the
suspension ends.
Such suspension as to any Class of Shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share, the
issue, redemption and conversion of Shares of any other Class of Shares.
Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of
the calculation of the Net Asset Value.
Title III. Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members,
who need not be Shareholders of the Company. However, if it is noted at a Shareholders' meeting that all the Shares
issued by the Company are held by one single Shareholder, the Company may be managed by one single Director until
the first annual Shareholders' meeting following the moment where the Company has noted that its Shares are held by
more than one Shareholder. They shall be elected for a term not exceeding six years. They may be re-elected. The
Directors shall be elected by the Shareholders at a general meeting of Shareholders; in particular by the Shareholders at
their annual general meeting for a period of three years or until their successors are elected and qualify, provided,
however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by
157323
L
U X E M B O U R G
the Shareholders. The Shareholders shall further determine the number of Directors, their remuneration and the term
of their office.
In the event in which an elected Director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be
designated as member of the Board of Directors. Such individual is submitted to the same obligations than the other
Directors.
Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
Directors shall be elected by the majority of the votes validly cast and shall be subject to the approval of the Luxembourg
regulatory authorities.
In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders which shall
take a final decision regarding such nomination.
Art. 14. Board Meetings. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who
shall write and keep the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. The Board of Directors
shall meet upon call by the chairman or any two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. In his absence, the
Shareholders or the board members shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a Shareholders'
meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings.
The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers deemed necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may
be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be Directors or Shareholders of the Company.
Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the
Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telefax or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means
of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-
nications equipment which enables his/her identification whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors.
The Directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by
resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the number of the majority of the Directors,
or any other number of Directors that the board may determine, are present or represented.
Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the person who will chair the meeting.
Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two Directors or by the secretary or any other authorized person.
Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented and voting at such meeting.
In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution is equal, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the Board
of Directors' meetings; each Director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other
similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that
proves that such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 17 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders are in the
competence of the Board of Directors.
157324
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
Directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of
Directors.
Art. 17. Delegation of Power. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out
acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which
need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and
who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The Company may enter with any Luxembourg or foreign company into (an) investment management agreement(s),
according to which such company will supply the Company with recommendations and advice with respect to the Com-
pany's investment policy. Furthermore, such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and
ultimate responsibility of the Board of Directors, purchase and sell securities and otherwise manage the Company's
portfolio. The investment management agreement shall contain the rules governing the modification or expiration of such
contract(s) which are otherwise concluded for an unlimited period.
The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notary or private proxy.
Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has
the power to determine (i) the investment policies and strategies to be applied in respect of each Compartment, (ii) the
hedging strategy, if any, to be applied to specific Classes of Shares within particular Compartments and (iii) the course of
conduct of the management and business affairs of the Company.
In compliance with the requirements set forth by the Law of 2010 and detailed in the Sales Documents, in particular
as to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each
Compartment may invest in:
(i) Transferable Securities or Money Market Instruments;
(ii) shares or units of other UCIs, including shares of a master fund and Shares of other Compartments to the extent
permitted and at the conditions stipulated by the Law of 2010;
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
(iv) financial derivative instruments.
The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities
recognized by the Luxembourg supervisory authority.
The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market of a State of Europe,
being or not a member of the European Union ("EU"), of America, Africa, Asia, Australia or Oceania as such notions are
defined in the Sales Documentation.
The Company may also invest in recently issued Transferable Securities and Money Market Instruments provided that
the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated
Market, stock exchange or other regulated market and that such admission be secured within one year of issue.
In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorized to invest up to 100% of the net assets
attributable to each Compartment in transferable securities or instruments normally dealt in on a money market which
are liquid and have a value which can be accurately determined at any time ("Money Market Instruments") issued or
guaranteed by an European Union ("EU") member States, its local authorities, another member State of the OECD or
public international bodies of which one or more member States of the EU are members being provided that if the
Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Compartment, securities belonging
to six different issues at least. The securities belonging to one issue cannot exceed 30% of the total net assets attributable
to that Compartment.
The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the Sales
Documents, that: (i) all or part of the assets of the Company or of any Compartment be co-managed on a segregated
basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their com-
partments; or that (ii) all or part of the assets of two or more Compartments of the Company be co-managed amongst
themselves on a segregated or on a pooled basis.
Investments of each Compartment of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned
subsidiaries, as the Board of Directors may from time to time decide and as described in the Sales Documents. Reference
in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially
held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.
The Company is authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market
instruments.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a Director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the Company
157325
L
U X E M B O U R G
who serves as a Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, except for day-to-day transactions concluded in normal terms such Director
or officer shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding
general meeting of Shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving the investment manager, the management company, the Depo-
sitary Bank or such other person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors
in its discretion.
The Board of Directors is responsible for the implementation of the conflict of interest policy of the Company.
Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 21. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor
(réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2010.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of Shareholders of the Company
shall represent the entire body of Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders
regardless of the Class of Shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.
The general meeting of Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.
It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one fifth of the Share capital.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law in Luxembourg City at a place specified
in the notice of meeting, on the second Thursday of the month of May at 2 p.m.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least
eight days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders.
The giving of such notice to registered Shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared
by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the Shareholders
in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.
If bearer Shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the
Board of Directors may decide.
If all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to Shareholders may be mailed by registered
mail only.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The holders of bearer Shares are obliged, in order to be admitted to the general meetings, to deposit their Share
certificates with an institution specified in the convening notice at least five days prior to the date of the meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend
any meeting of Shareholders.
The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
157326
L
U X E M B O U R G
Each Share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A
Shareholder may act at any meeting of Shareholders by giving a written proxy or by cable, telegram or facsimile trans-
actions to another person, who need not be a Shareholder and who may be a Director of the Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
validly cast votes.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Compartment or in a Class of Shares. The Shareholders of the Class
or Classes issued in respect of any Compartment may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which
relate exclusively to such Compartment.
In addition, the Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters
which relate exclusively to such Class.
The provisions of Article 22, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 shall apply to such general meetings.
Each Share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either
in person or by giving a proxy in writing or by cable, telegram or facsimile transmission to another person who needs
not be a Shareholder and may be a Director of the Company.
Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders of a Compartment
or of a Class of Shares are passed by a simple majority vote of the validly cast votes.
Any resolution of the general meeting of Shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of Shares
of any Class vis-à-vis the rights of the holders of Shares of any other Class or Classes, shall be subject to a resolution of
the general meeting of Shareholders of such Class or Classes in compliance with Article 68 of the law of 10 August, 1915
on commercial companies, as amended.
Art. 24. Dissolution and Merger of Compartments or Classes of Shares. In the event that for any reason the value of
the net assets in any Compartment or the value of the net assets of any Class within a Compartment has decreased to
an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Compartment or such Class to be
operated in an economically efficient manner, or if a change in the economical or political situation relating to the Com-
partment or Class concerned would have material adverse consequences on the investments of that Compartment, or
in order to proceed to an rationalization of the Classes and/or the Compartments offered, the Board of Directors may
decide to compulsorily redeem all the Shares of the relevant Class or Classes issued in such Compartment at the Net
Asset Value per Share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated
on the Valuation Day at which such decision shall take effect and therefore close such Class or Compartment. The decision
of the Board of Directors will be published (either in newspapers to be determined by the Board of Directors or by way
of a notice sent to the Shareholders at their addresses indicated in the register of Shareholders) prior to the effective
date of the compulsory redemption and the publication and will indicate the reasons for, and the procedures of the
compulsory redemption operations. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between
the Shareholders, the Shareholders of the Compartment or Class concerned may continue to request redemption or
conversion of their Shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization
expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the Shareholders of
any one or all Classes of Shares issued in any Compartment may at a general meeting of such Shareholders, upon proposal
from the Board of Directors, redeem all the Shares of the relevant Class or Classes and refund to the Shareholders the
Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses)
calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such
general meeting of Shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the validly cast votes.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed Shares shall be cancelled.
The dissolution of the last Compartment of the Company will result in the liquidation of the Company.
Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the Board of Directors may decide
to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the assets of the Company, any Compartment with
those of (i) another existing Compartment within the Company or another compartment within such other Luxembourg
or foreign UCITS (the "new sub-fund"), or of (ii) another Luxembourg or foreign UCITS (the "new UCITS"), and to
designate the Shares of the Company or the Compartment concerned as Shares of the new UCITS or the new com-
partment, as applicable. The Board of Directors of the Fund is competent to decide on or approve the effective date of
the merger. Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 2010, in particular
concerning the merger project to be established by the Board of Directors and the information to be provided to the
Shareholders.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding section, a merger (within the
meaning of the Law of 2010) of the assets and of the liabilities attributable to any Compartment with another Compart-
ment within the Company may be decided upon by a general meeting of the Shareholders of the Compartment concerned
for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such a merger by resolutions taken by
157327
L
U X E M B O U R G
simple majority vote of the Shareholders validly cast. The general meeting of the Shareholders of the Fund concerned
will decide on the effective date of such a merger it has initiated within the Company, by resolution taken with no quorum
requirement and adopted at a simple majority of the Shares validly cast.
The Shareholders may also decide a merger (within the meaning of the Law of 2010) of the assets and of the liabilities
attributable to the Company or any Compartment with the assets of any new UCITS or new compartment within another
UCITS. Such a merger and the decision on the effective date of such a merger shall require resolutions of the Shareholders
of the Company or Compartment concerned subject to the quorum and majority requirements provided for the amend-
ment of these Articles, except when such a merger is to be implemented with a Luxembourg UCITS of the contractual
type ("fonds commun de placement"), in which case resolutions shall be binding only on such Shareholders who have
voted in favour of such merger. If the merger is to be implemented with a Luxembourg fonds commun de placement,
Shareholders not having voted in favour of such merger will be considered as having requested the redemption of their
Shares, except if they have given written instructions to the contrary to the Company. The assets which may not or are
unable to be distributed to such Shareholders for whatever reasons will be deposited with the "Caisse de Consignation"
on behalf of the persons entitled thereto.
Where the Company or any of its Compartments is the absorbed entity which, thus, ceases to exist and irrespective
of whether the merger is initiated by the Board of Directors or by the Shareholders, the general meeting of Shareholders
of the Company or of the relevant Compartment must decide the effective date of the merger. Such general meeting is
subject to the quorum and majority requirements provided for the amendment of these Articles.
Art. 25. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.
Art. 26. Distributions. The general meeting of Shareholders of the Class or Classes issued in respect of any Com-
partment shall, upon proposal from the Board of Directors and within the limits provided by law, determine how the
results of such Compartment shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors
to declare, distributions.
For any Class of Shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in
compliance with the conditions set forth by law.
Payments of distributions to holders of registered Shares shall be made to such Shareholders at their addresses in the
register of Shareholders. Payments of distributions to holders of bearer Shares shall be made upon presentation of the
dividend coupon to the agent or agents therefore designated by the Company.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall determine
from time to time.
For each Compartment or Class of Shares, the Board of Directors may decide on the payment of interim dividends
in compliance with legal requirements.
The Board of Directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and con-
ditions as may be set forth by the Board of Directors.
Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the
Compartment relating to the relevant Class or Classes of Shares.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final provisions
Art. 27. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of Shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.
Whenever the Share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 6 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of Shareholders by the Board of Directors.
The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by a simple majority of the validly cast votes.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the Share
capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by Shareholders holding one-fourth of the
votes of the Shares represented and validly cast at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 28. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
Art. 29. Depositary Bank. To the extent required by law, the Company shall enter into a depositary bank agreement
with a banking or credit institution as defined by the law of 5 April, 1993 on the financial sector, as amended.
The Depositary Bank shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.
157328
L
U X E M B O U R G
If the Depositary Bank desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor
depositary bank within two months of the effectiveness of such retirement. The Board of Directors may terminate the
appointment of the Depositary Bank but shall not remove the Depositary Bank unless and until a successor depositary
bank shall have been appointed to act in the place thereof.
Art. 30. Amendments to the Articles of Incorporation. The Articles may be amended by a general meeting of Share-
holders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 10 August 1915. For the avoidance of
doubt, such quorum and majority requirements shall be as follows: fifty percent of the Shares issued must be present or
represented at the general meeting and a super-majority of two thirds of the Shareholders present or represented and
validly voting is required to adopt a resolution. In the event that the quorum is not reached, the general meeting must
be adjourned and re-convened. There is no quorum requirement for the second meeting but the majority requirement
remains unchanged.
Art. 31. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or Shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law of
10 August 1915 and the Law of 2010 as such laws have been or may be amended from time to time.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first accounting year will begin on the date of the formation of the Company and will end on 31
st
December
2014.
2) The first annual general meeting will be held in 2015.
<i>Subscription and Paymenti>
The Share capital of the Company is subscribed as follows:
Luxembourg Fund Partners S.A., predesignated, subscribes for thirty-one (31) Shares, resulting in a total payment of
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000).
Evidence of the above payments, totalling thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) was given to the undersigned notary.
The subscriber declared that upon determination by the Board of Directors, pursuant to the Articles, of the various
Classes of Shares which the Company shall have, he will elect the Class or Classes of Shares to which the Shares subscribed
to shall appertain.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the Law of 10 August 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The formation and preliminary expenses of the Company, amount to approximately two thousand five hundred (EUR
2,500.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person representing the entire subscribed capital and considering herself as validly convened, has
immediately proceeded to resolve as follows:
I. The following are elected as Directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31
st
December 2014:
<i>Chairman of the Board:i>
Mr. Luc LELEUX, born on 26 January 1967 at Aumetz (France), director of companies.
<i>Members:i>
Mr Yves MAHE, born on 25 January 1953 at Versailles (France), director of companies;
Mr Antony BARNETT, born on 9 November 1964 at Leeds (England), Director of Companies;
Mr Quentin RUTSAERT, born on 7 September 1973 at Tienen (Belgium), Attorney-at-law.
II. The following is elected as auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders
which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at 31
st
December 2014:
PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
III. The address of the Company is set at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
party, this deed is worded in English only.
157329
L
U X E M B O U R G
WHEREOF this notary deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.
This deed having been given for reading to the proxyholder of the appearing party, he signed together with us, the
notary this original deed.
Signé: J. BURGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52298. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 27 novembre 2013.
Référence de publication: 2013167584/887.
(130204184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Rubus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 117.513.
In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of the month of November,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
(1) KKR Millennium Fund (Overseas), Limited Partnership, a limited partnership governed by the laws of Alberta,
Canada, with registered office at 603, 7
th
Avenue S.W., CDN-T2P 2T5 Calgary, Alberta, Canada, registered with the
Alberta Corporate Registry under the registration number LP 101917716,
hereby represented by Maître Philip Basler-Gretic, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on November 2, 2013;
(2) KKR European Fund II, Limited Partnership, a limited partnership governed by the laws of Alberta, Canada, with
registered office at 603, 7
th
Avenue S.W., CDN-T2P 2T5 Calgary, Alberta, Canada, registered with the Alberta Corporate
Registry under the registration number LP 11768199,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 2, 2013;
(3) KKR Partners (International) Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of Alberta, Canada,
having its registered office at 603, 7
th
Avenue S.W., CDN-T2P 2T5 Calgary, Alberta, Canada, registered with the Alberta
Corporate Registry under the registration number LP 7762867,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 2, 2013;
(4) KFN Co-Invest Holdings, L.P., a Delaware limited partnership, with registered office at c/o The Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, United States of America,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 2, 2013;
(5) The Northwestern Mutual Life Insurance Company, a company incorporated in Wisconsin, United States of Ame-
rica, with registered office at 720 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, WI 53202-4797, United States of America,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on October 6, 2013;
(6) TCW/Crescent Mezzanine Partners IV, L.P., a limited partnership governed by the laws of the United States of
America, with registered office at 160, Greentree Drive, USA - DE 19904 Dover, County of Kent, and registered with
the State of Delaware under number SRV 060072005 4099833,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on October 29, 2013;
(7) TCW/Crescent Mezzanine Partners IVB, L.P., a limited partnership governed by the laws of the United States of
America, with registered office at 160, Greentree Drive, USA - DE 19904 Dover, County of Kent, and registered with
the State of Delaware under number SRV 060240404 4124912,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on October 29, 2013;
(8) RBC cees Trustee Limited, a Jersey corporate entity, having its registered office at 19-21, Broad Street, St Helier,
Jersey JE1 3PB, Channel Islands and registered with the Jersey Company Register under number 68138, acting as trustee
of KKR International Employee Pension Plan, a trust formed under the laws of Jersey and having its registered address at
19-21 Broad Street, St Helier, Jersey JE1 3PB, Channel Islands,
157330
L
U X E M B O U R G
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on October 31, 2013;
(9) Mr Robert Lewin, residing professionally at 9 West 57 Street, 10019 New York, USA,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 1, 2013;
(10) BIS MPP Limited, a public company incorporated in Australia having its registered office at Level 18, 109 St Georges
Terrace, Perth WA 6000, Australia and registered under Australian Company Number 120 480 444 ("BIS MPP Limited"),
acting as trustee of the BIS Senior MPP Trust,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 1, 2013;
(11) BIS MPP Limited, acting as trustee of the BIS Senior MPP Trust (No. 2),
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November1, 2013;
(12) BIS MPP Limited, acting as trustee of the BIS Senior MPP Trust (No. 3),
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November1, 2013;
(13) BIS MPP Limited, acting as trustee of the BIS Senior MPP Trust (No. 4),
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 1, 2013;
(14) BIS MPP Limited, acting as trustee of the BIS Senior MPP Trust (No. 5),
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 1, 2013;
(15) BIS MPP Limited, acting as trustee of the BIS Senior MPP Trust (No. 6),
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November1, 2013;
(16) The Trust Company (RE Services) Limited, a limited corporation incorporated in Australia, having its registered
office at Level 15, 20 Bond Street, Sydney, NSW, 2000 and registered under Australian Company Number 003 278 831,
acting as trustee of the BIS Management Trust,
hereby represented by Me Philip Basler-Gretic, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on November 1, 2013;
being hereafter collectively referred to as the "Shareholders".
I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The Shareholders declare that they are the sole shareholders of Rubus International S.á r.l., a société á responsabilité
limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rol-
lingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), having a share capital of three hundred sixty-seven
thousand four hundred fifty euro (EUR 367,450.-), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 117.513, and incorporated by a notarial deed of June 22, 2006, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, of September 1, 2006 under number 1656 (the "Company"). The articles of incorporation have
lastly been amended by a notarial deed of 20 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
of May 8, 2012, under number 1151.
III. The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To approve the transfer to the Company of eleven (11) of its own shares from The Trust Company (RE Services)
Limited acting as trustee of the BIS Management Trust in view of their immediate cancellation and confirm that such
transfer should be effective immediately.
2 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of two hundred seventy-five euro (EUR 275.-) so as
to reduce it from its current amount of three hundred sixty-seven thousand four hundred fifty euro (EUR 367,450.-) to
three hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-five euro (EUR 367,175.-) by cancellation of eleven (11) shares
the ownership of which has been transferred to the Company on the date of this meeting.
3 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, in order to reflect the
resolutions to be adopted under the above items.
4 To confer all and any powers to the Company's managers to implement the resolutions to be adopted under the
above items.
157331
L
U X E M B O U R G
The Shareholders have requested the undersigned notary to document the following resolutions, each time unani-
mously adopted:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to approve the transfer to the Company from The Trust Company (RE Services) Limited
acting as trustee of the BIS Management Trust of eleven (11) of its own shares in view of their immediate cancellation
and confirm that such transfer should be effective immediately.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to reduce, with immediate effect, the corporate capital of the Company by an amount of
two hundred seventy-five euro (EUR 275.-) so as to reduce it from its current amount of three hundred sixty-seven
thousand four hundred fifty euro (EUR 367,450.-) to three hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-five euro
(EUR 367,175.-) by cancellation of eleven (11) shares the ownership of which has been transferred to the Company on
the date of this meeting.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend the 1
st
paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in
order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
« Art. 5. Capital. The share capital of the Company is set at three hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-
five euro (EUR 367,175.-) divided into fourteen thousand six hundred eighty-seven (14,687.-) shares, with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.".
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolved to confer all and any powers to the Company's managers to implement the above reso-
lutions and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid
capital increase are estimated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing parties, who is known to the undersigned
notary by its surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned
notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le quatrième jour du mois de novembre,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
(1) KKR Millennium Fund (Overseas), Limited Partnership, une limited partnership régie par le droit d'Alberta, Canada,
dont le siège social se situe au 603, 7
th
Avenue S.W. CDN-T2P 2T5 Calgary, Alberta, Canada et immatriculée auprès du
Alberta Corporate Registry sous le numéro LP 101917716,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 2 novembre 2013;
(2) KKR European Fund II, Limited Partnership, une limited partnership régie par le droit d'Alberta, Canada, dont le
siège social se situe au 603, 7
th
Avenue S.W. CDN-T2P 2T5 Calgary, Alberta, Canada, et immatriculée auprès du Alberta
Corporate Registry sous le numéro LP 11768199,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 2 novembre 2013;
(3) KKR Partners (International) Limited Partnership, une limited partnership régie par le droit d'Alberta, Canada, dont
le siège social se situe au 603, 7
th
Avenue S.W. CDN-T2P 2T5 Calgary, Alberta, Canada, et immatriculée auprés du
Alberta Corporate Registry sous le numéro LP 7762867,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 2 novembre 2013;
157332
L
U X E M B O U R G
(4) KFN Co-Invest Holdings, L.P., une limited partnership régie par le droit de Delaware, Etats-Unis d'Amérique dont
le siège social se situe au c/o The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,
Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(5) The Northwestern Mutual Life Insurance Company, une société constituée à Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique,
dont le siège social se situe au 720 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, WI 53202-4797, Etats-Unis d'Amérique,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 31 octobre 2013;
(6) TCW/Crescent Mezzanine Partners IV, L.P., une limited partnership régie par le droit des Etats-Unis d'Amérique
dont le siège social se situe au 160, Greentree Drive, USA - DE 19904 Dover, County of Kent, et immatriculée auprés
de l'Etat de Delaware sous le numéro SRV 060072005 4099833,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Balser-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 29 octobre 2013;
(7) TCW/Crescent Mezzanine Partners IVB, L.P., une limited partnership régie par le droit des Etats-Unis d'Amérique
dont le siège social se situe au 160, Greentree Drive, USA - DE 19904 Dover, County of Kent, et immatriculée auprés
de l'Etat de Delaware sous le numéro SRV 060240404 4124912,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 29 octobre 2013;
(8) RBC cees Trustee Limited, une personne morale régie par le droit de Jersey, dont le siège social se situe au 19-21,
Broad Street, St Helier, Jersey JE1 3PB, Channel Islands, et immatriculée auprés du Jersey Company Register sous le
numéro 68138, agissant en qualité de mandataire de KKR International Employee Pension Plan, un trust régi par le droit
de Jersey, dont le siège social se situe au 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey JE1 3PB, Channel Islands,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 31 octobre 2013;
(9) Mr Robert Lewin, résidant professionnellement 9 West 57 Street, 10019 New York, Etats-Unis d'Amérique,
représenté aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(10) BIS MPP Limited, une société publique constituée en Australie, dont le siège social se situe au Level 18, 109 St
Georges Terrace, Perth, WA 6000 Australie, et immatriculée sous le Australian Company Number 120 480 444, ("BIS
MPP Limited"), agissant en qualité de mandataire de BIS Senior MPP Trust,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembtre 2013;
(11) BIS MPP Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Senior MPP Trust (No. 2),
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(12) BIS MPP Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Senior MPP Trust (No. 3),
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(13) BIS MPP Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Senior MPP Trust (No. 4),
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(14) BIS MPP Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Senior MPP Trust (No. 5),
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(15) BIS MPP Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Senior MPP Trust (No. 6),
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
(16) The Trust Company (RE Services) Limited, une société à responsabilité limitée constituée en Australie, dont le
siège social se situe au Level 15, 20 Bond Street, Sydney, NSW, 2000, et immatriculée sous le Australiern Company
Number 003 278 831, agissant en qualité de mandataire de BIS Management Trust,
représentée aux fins des présentes par Maître Philip Basler-Gretic, prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
novembre 2013;
désignés ci-après ensemble, les «Associés».
157333
L
U X E M B O U R G
I. Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
II. Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les seuls et uniques associés de Rubus
International S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social se situe
59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de trois cent
soixante-sept mille quatre cent cinquante euros (EUR 367.450,-), constituée suivant acte notarié en date du 22 juin 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1656 du 1 septembre 2006 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.513 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois par un acte notarié en date du 20 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 1151, en date du 8 mai 2012.
III. Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des
décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Approbation du transfert à la Société de onze (11) de ses propres parts sociales par Trust Company (RE Services)
Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Management Trust en vue de leur annulation immédiate, et confirmation
de l'effet immédiat de ce transfert.
2 Réduction du capital social de la Société à concurrence de deux cent soixante-quinze euros (EUR 275,-) pour le
porter de son montant actuel de trois cent soixante-sept mille quatre cent cinquante euros (EUR 367.450,-) à trois cent
soixante-sept mille cent soixante-quinze euros (EUR 367.175,-) par l'annulation de onze (11) parts sociales dont la pro-
priété a été transférée à la Société à la date de cette assemblée.
3 Modification de l'alinéa premier de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être
adoptées sous les articles ci-dessus.
4 Délégation de tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société afin d'implémenter les résolutions ci-dessus.
IV. Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes, chacune prise à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d'approuver le transfert à la Société de onze (11) de ses propres parts sociales par Trust
Company (RE Services) Limited, agissant en qualité de mandataire de BIS Management Trust en vue de leur annulation
immédiate, et de confirmer l'effet immédiat de ce transfert.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé de réduire le capital social de la Société, avec effet immédiat, à concurrence de deux cent
soixante-quinze euros (EUR 275,-) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante-sept mille quatre cent
cinquante euros (EUR 367.450,-) à trois cent soixante-sept mille cent soixante-quinze euros (EUR 367.175,-) par l'annu-
lation de onze (11) parts sociales dont la propriété a été transférée à la Société à la date de cette assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier l'alinéa 1
er
de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-
dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à trois cent soixante-sept mille cent soixante-quinze
euros (EUR 367.175,-) divisé en quatorze mille six cent quatre-vingt-sept (14.687) parts sociales ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés ont décidé de déléguer au conseil de gérance tous pouvoirs pour mettre en œuvre les résolutions ci-
dessus et pour faire tout le nécessaire et utile en relation avec les résolutions ci-dessus.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants ci-avant, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: P. Basler-Gretic, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 6 novembre 2013. REM/2013/1935. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
157334
L
U X E M B O U R G
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 11 novembre 2013.
Référence de publication: 2013159585/261.
(130195354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Holborn S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 178.924.
L'an deux mille treize, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOLBORN S.A.", établie et
ayant son siège social à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche
MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 juillet 2013, publié au Mémorial C numéro 2241 du
12 septembre 2013, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 178924.
La séance est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de Monsieur Freddy BRACKE, Economiste, demeurant à
L-1744 Luxembourg, 9, rue de St Hubert.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine BERNARD, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel JADOT, ingénieur commercial et de gestion, demeurant pro-
fessionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les QUATRE MILLE
(4.000) actions, sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de QUATRE MILLIONS
D'EUROS (€ 4.000.000.-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social d'un montant de UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 1.200.000,00) par
renonciation à l'appel du capital non libéré de façon à réduire le capital de son montant actuel de QUATRE MILLIONS
D'EUROS (EUR 4.000.000,00 ) à la somme de DEUX MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 2.800.000,00).
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
3. Divers
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant de UN MILLION
DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 1.200.000,00) par renonciation à l'appel du capital non libéré de façon à réduire le
capital de son montant actuel de QUATRE MILLIONS D'EUROS (EUR 4.000.000,00 ) à la somme de DEUX MILLIONS
HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 2.800.000,00).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 2.800.000.- (deux millions huit cent mille Euros),
représenté par 4.000.- (quatre mille) actions, sans désignation de valeur nominale.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: BRACKE, BERNARD, JADOT, MOUTRIER.
157335
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19/11/2013. Relation: EAC/2013/15074. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2013.
Référence de publication: 2013161427/56.
(130197888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Blue Sky Care Home Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 160.150.
In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of November.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Blue Sky Care Home Holding 1 S.à r.l.", (R.C.S
Luxembourg, section B number 160.150), having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20 rue de la Poste, incor-
porated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on the 31st
th
of March 2011 and published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C number 1392 of the 27
th
of June 2011,
The Meeting is presided over by Tony Whiteman, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as Secretary Susanne Merz, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Vincenzo Viceconte, with professional address in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The sole represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list which, signed by
the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.
II. - As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been
beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Deliberation on the dissolution of the company.
2.- Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve
the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator, Mr. Tony Whiteman,
with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders
in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period he will fix.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
157336
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le huit novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée " Blue Sky
Care Home Holding 1 S.à r.l. " (R.C.S. Luxembourg numéro B 160.150), ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20
rue de la Poste, constituée suivant acte reçu par maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 mars
2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1392 du 27 juin 2011.
L'Assemblée est présidée par Tony Whiteman, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Susanne Merz, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Vincenzo Viceconte, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée
par le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur, Monsieur Tony Whiteman,
demeurant professionnellement à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des associés dans les cas où
elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: T. WHITEMAN, S. MERZ, V. VICECONTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2013. Relation: LAC/2013/51705. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Référence de publication: 2013161235/100.
(130198384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
157337
L
U X E M B O U R G
Corpag Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.579.
EXTRAIT
La société PREMIER TAX SA présente sa démission en qualité de commissaire aux comptes de la société Corpag
Services (Luxembourg) S.A. (B 151579) et ce, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2013.
PREMIER TAX S.A.
Référence de publication: 2013168097/13.
(130205153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Blue Sky Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 146.572.
In the year two thousand and thirteen,
on the eighth day of November.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Blue Sky Holding 1 S.à r.l.", (R.C.S Luxembourg,
section B number 146.572), having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20 rue de la Poste, incorporated by deed
of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on the 8
th
of June 2009 and published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations C number 1275 of the 2
nd
of July 2009,
The Meeting is presided over by Tony Whiteman, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as Secretary Susanne Merz, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Vincenzo Viceconte, with professional address in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The sole represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list which, signed by
the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.
The proxy forms of the sole represented shareholder after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons
will also remain annexed to the present deed.
II. - As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been
beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Deliberation on the dissolution of the company.
2.- Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve
the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator, Mr. Tony Whiteman,
with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders
in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
157338
L
U X E M B O U R G
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period he will fix.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le huit novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée " Blue Sky
Holding 1 S.à r.l. " (R.C.S. Luxembourg numéro B 146.572), ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 20 rue de la
Poste, constituée suivant acte reçu par maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 juin 2009 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1275 du 2 juillet 2009.
L'Assemblée est présidée par Tony Whiteman, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Susanne Merz, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Vincenzo Viceconte, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée
par le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée
décide de dissoudre la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur, Monsieur Tony Whiteman,
demeurant professionnellement à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des associés dans les cas où
elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
157339
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
signé: T. WHITEMAN, S. MERZ, V. VICECONTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2013. Relation: LAC/2013/51704. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Référence de publication: 2013161236/103.
(130198377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Garage Auto Prestige S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5886 Alzingen, 502, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 181.707.
STATUTS
L'an deux mille treize,
Le onze novembre,
Pardevant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, soussigné,
Ont comparu:
1) Monsieur Cesar Luis SOUSA DA CRUZ, salarié, né à Pero Moniz (Portugal) le 25 mai 1965 (matricule n° 1965 05
25 895), divorcé, demeurant à L-5886 Alzingen, 502, route de Thionville;
2) Monsieur Antonio Luis GOMES FRADE, salarié, né à Carvalhal / Bombarral (Portugal) le 20 novembre 1985 (ma-
tricule n° 1985 11 20 338), célibataire, demeurant à L-3725 Rumelange, 4, rue Dr Flesch;
3) Monsieur César Tiago GOMES DA CRUZ, salarié, né à Carvalhal/Bombarral (Portugal) le 20 juin 1986 (matricule
n° 1986 06 20 270), célibataire, demeurant à L-4140 Esch-sur-Alzette, 35, rue Victor Hugo,
ci-après dénommés «les comparants» ou «les associés»,
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux
qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts.
La société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la
réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de cession
ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.
Art. 2. Objet. La société a pour objet l'exploitation d'un garage automobile, comprenant la vente de voitures auto-
mobiles, l'exploitation d'un atelier mécanique y compris la vente des articles de la branche et l'exploitation d'une station
de lavage d'autos.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination de "GARAGE AUTO PRESTIGE S.à r.l.".
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Alzingen.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé ou des associés,
selon les modalités requises pour la modification des statuts. Des succursales ou agences pourront être établies partout,
au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- €), représenté par
cent (100) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié, suivant le cas, moyennant
décision de l'associé unique ou une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification
des statuts.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.
157340
L
U X E M B O U R G
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas
de pluralité d'associés, toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
Art. 10. Cession et Transmission des parts.
1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont
libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des
non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts
sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-
dants soit au conjoint survivant.
Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont
un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix
de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la
société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 11. Décès, Incapacité, Faillite ou Déconfiture de l'associé ou de l'un des associés. Le décès, l'incapacité, la mise
en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution
de la société.
Art. 12. Gérance. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet
de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par
l'assemblée générale des associés.
Dans ce dernier cas l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre,
la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans
qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent
pas la dissolution de la société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la société.
Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés. Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en
disposent autrement.
157341
L
U X E M B O U R G
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède
Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication
de l'inventaire et des comptes annuels.
Art. 18. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,
amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.
Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés,
selon le cas, se référent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre deux mille treize.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Cesar Luis SOUSA DA CRUZ, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 parts
2) Monsieur César Tiago GOMES DA CRUZ, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts
3) Monsieur Antonio Luis GOMES FRADE, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des apports en numéraire, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500.-€) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné
qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille (1.000.- €) Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les comparants, représentant comme seuls associés l'intégralité du capital social se considérant dûment
convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-5886 Alzingen, 502, route de Thionville
2.- L'adresse du local d'activité est fixée à L-3895 Foetz, 9, rue du Commerce.
3.- La gérance de la société est fixée comme suit:
Monsieur Cesar Luis SOUSA DA CRUZ, prénommé, est nommé gérant unique de la société à responsabilité limitée
«GARAGE AUTO PRESTIGE S.à r.l.», pour une durée indéterminée.
La société est engagée en toute circonstance, et pour un montant illimité, par la signature de son gérant unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête,
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire
par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. SOUSA DA CRUZ, A. GOMES FRADE, C. GOMES DA CRUZ, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14784.
Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
157342
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 novembre 2013.
C. GOEDERT..
Référence de publication: 2013161397/156.
(130198365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
BlueBay Global Unconstrained High Yield Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité
limitée.
Capital social: USD 3.500.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 172.932.
In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of October.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
BlueBay Specialised Funds, a common fund set up under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, represented by
its management company BlueBay Funds Management Company S.A., incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having their registered office at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (RCS Luxembourg B 88445),
duly represented by Arlette Siebenaler, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
established on October 25, 2013.
The said proxy, "initialled ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
I. Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of BlueBay Global Unconstrained High Yield Invest-
ments (Luxembourg) S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at 24, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 172 932) (the "Company"), incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 20 November 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 3079 of December 22
nd
, 2012 has required the
undersigned notary to state its resolutions as follows:
II. The Company's share capital is fixed at two million five hundred thousand United States dollars (USD 2,500,000.)
represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of hundred United States dollars (USD 100.) each.
III. The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million United
States dollars (USD 1,000,000.-) so as to raise it from its current amount of two million five hundred thousand United
States dollars (USD 2,500,000.-) up to three million five hundred thousand United States dollars (USD 3,500,000.-) by
issuing ten thousand (10,000) new shares, having a par value of one hundred United States dollar (USD 100.-) each.
IV. The ten thousand (10,000) new shares are subscribed by BlueBay Specialised Funds, a common fund set up under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, represented by its management company BlueBay Funds Management
Company S.A., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having their registered office at 24, rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg (RCS Luxembourg B 88445), here represented by Arlette Siebenaler, prenamed, by virtue
of the aforementioned proxy.
V. The ten thousand (10,000) new shares have been fully paid up in cash by the subscriber so that the total sum of one
million United States dollars (USD 1,000,000.-) is at the free disposal of the Company, as has been proved to the under-
signed notary.
VI. Pursuant to the above resolutions, Article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The share capital of the Company is fixed at three million five hundred thousand United States dollars (USD
3,500,000.-), represented by thirty five thousand (35,000) ordinary shares with a nominal value of one hundred United
States dollars (USD 100.-) each.»
There being no further business on the agenda, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR 2,500.-
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
157343
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation
L'an deux mille treize, le trente-et-un octobre.
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
BlueBay Specialised Funds, un fonds commun de placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, agissant
par sa société de gestion BlueBay Funds Management Company S.A., soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg
et ayant établi son siège social au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, (RCS Luxembourg B 88445), dûment repré-
sentée par Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé donnée le 25 octobre 2013.
La procuration signée "ne varietur" par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
I. Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de BlueBay Global Unconstrained High Yield
Investments (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 24, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 172 932) (la "Société"), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant
acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 novembre 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3079 du 22 décembre 2012, a requis le notaire instrumentant
de constater les résolutions suivantes:
II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinq cent mille Dollars US (USD 2.500.000.-) divisé en vingt-
cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100.-) chacune.
III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un million de Dollars US (USD
1.000.000.-), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille Dollars US (USD 2.500.000.-) à trois
millions cinq cent mille Dollars US (USD 3.500.000.-) par l'émission de dix mille (10.000) nouvelles parts sociales, d'une
valeur nominale de cent Dollars US (USD 100.-) chacune.
IV. Les dix mille (10.000) nouvelles parts sociales sont souscrites par BlueBay Specialised Funds, un fonds commun de
placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, agissant par sa société de gestion BlueBay Funds Management
Company S.A., soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant établi son siège social au 24, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, (RCS Luxembourg B 88445), ici représenté par Arlette Siebenaler, prénommée, en vertu de la
procuration dont mention a été faite ci-avant.
V. Les dix mille (10.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées en espèces par le souscripteur, de sorte
que la somme de un million de Dollars US (USD 1.000.000.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en
est justifié au notaire instrumentant.
VI. Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions cinq cent mille Dollars US (USD 3.500.000.-) représenté par trente-
cinq mille (35.000) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100.-) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 2.500.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50833. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 novembre 2013.
Référence de publication: 2013161237/105.
(130197808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
157344
Autopolis S.A.
Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.
Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l.
Batavia Lugduno
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) VI S.à r.l.
BlueBay Global Unconstrained High Yield Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Blue Sky Care Home Holding 1 S.à r.l.
Blue Sky Holding 1 S.à r.l.
Cambenes S.A.
CBC AcquiCo1 S.à r.l.
Centre de Télécommunications et Téléinformatiques Luxembourgeois
Cervin Shipping S.A.
Corpag Services (Luxembourg) S.A.
Dagobah S.A.
Dakhla SA
Dakhla SA
Dana Real Estate S.A.
Data Circuits S.à r.l.
De Grisogono Holding S.A.
Directional Communications S.à r.l.
DIVALARUS Luxembourg S.A.
ERT Luxembourg S.à r.l.
Eurofood
Events & Business Catering S.A.
Garage Auto Prestige S.à r.l.
GRB S.A.
Holborn S.A.
Inzag II S.à r.l.
Ishti
James Finance & Co. S.A.
Karibou S.A.
Kemaba Finance S.A.
KH Investments S.à r.l.
Kuznetski Capital S.A.
Lerner S.à r.l.
LFPartners Investment Funds
Lune Holdings SPF SA
Lux 29 Starlight EUR S.à r.l.
Luxbauhaus Invest
Rubus International S.à r.l.
Schreinerei Wilmes Patrick S. à r.l.
SECMI
SOVALIM S.àr.l. (Société de Valorisation Immobilière)
SR Finance S.A.
Stare S.à r.l.
Stylesconcept s.à r.l.
Thesaly S.A.
Vamas S.à r.l.
Vaseq Holdings S.C.A.
Vitol Holding II S.A.
White Star Publishers S.A.
WP Roaming IV S. à r.l.