This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3276
24 décembre 2013
SOMMAIRE
Antin Infrastructure Luxembourg IX . . . .
157221
Burger King (Luxembourg) 2 S.à r.l. . . . . .
157237
Catalyst Alpha 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
157247
Finprotec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157209
FRII S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157248
Golfing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157202
Golfing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157202
Golfing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157203
Golfing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157202
Grandia International Investments S.A. . .
157203
Gruppo Mobili e Salotti S.A. . . . . . . . . . . . .
157204
GS Construction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157203
HET BESTE BROOD HOLDING S.A. so-
ciété de gestion de patrimoine familial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157204
HET BESTE BROOD HOLDING S.A. so-
ciété de gestion de patrimoine familial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157204
Hills Place S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157204
IBTD International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
157206
ICTUniverse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157202
IHC Immobilien A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157205
Immobilière 2F S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157206
Immobilière C.JANS & Associés S.A. . . . .
157205
Immobilière du GRÄFGEN . . . . . . . . . . . . .
157205
Immogar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157205
Imohtech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157206
Indunet S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157207
Instal-Fit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157207
I-Space S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157204
IT Advanced Consulting Holding S.A. . . . .
157203
J.L. Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157207
J.L. Freeze Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157207
JPMorgan European Property Holding Lu-
xembourg 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157202
Kingfisher International Holdings Limited -
Luxembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157203
Madrax Properties Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
157208
Mama Forte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157209
MCM Import-Export Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
157209
MEGG Invest S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157205
Misys Manco S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157209
Misys Manco S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157208
Moor Park Fortuny Luxembourg S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157208
Net's Bar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157208
OUTOX International S.A. . . . . . . . . . . . . .
157207
Prophac Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .
157248
Rubysam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157206
Skye Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
157213
St. Georges Investment S.A. - SPF . . . . . . .
157212
Storebrand Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
157206
TIAA Lux 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157210
TIAA Lux 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157211
Tinsel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157210
Toba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157212
Tommy Sports S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157211
Tortoise US Energy Infrastructure S.A. . .
157212
Transports Carlier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
157211
Tubosider International S.A. . . . . . . . . . . . .
157210
Velosi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157210
Virlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157211
Wahaca International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
157212
157201
L
U X E M B O U R G
Golfing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167431/10.
(130203700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Golfing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167432/10.
(130203724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Golfing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167433/10.
(130203778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
ICTUniverse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4979 Fingig, 48, rue Nicolas Margue.
R.C.S. Luxembourg B 137.078.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2013167482/11.
(130203538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 106.902.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2013.
JP Morgan European Property Holding Luxembourg 6 S.à r.l.
Mr. Richard Crombie / Mr. Mark Doherty
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013167521/13.
(130204588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157202
L
U X E M B O U R G
Kingfisher International Holdings Limited - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étran-
ger.
Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 147.359.
Le bilan au 31 janvier 2013 de la société de droit étranger Kingfisher International Holdings Limited, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2013.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013167529/13.
(130203302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
IT Advanced Consulting Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.390.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IT Advauced Consulting Holding S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013167504/11.
(130203682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Golfing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 46.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167434/10.
(130203843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Grandia International Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 91.951.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2013.
Référence de publication: 2013167436/10.
(130203974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
GS Construction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 15, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 29/11/2013.
Référence de publication: 2013167443/10.
(130203955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157203
L
U X E M B O U R G
Hills Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 135.680.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
Référence de publication: 2013167449/10.
(130204447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Gruppo Mobili e Salotti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4980 Reckange-sur-Mess, 71, rue Jean-Pierre Hilger.
R.C.S. Luxembourg B 60.914.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GRUPPO MOBILI E SALOTTI S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013167442/11.
(130203964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
HET BESTE BROOD HOLDING S.A. société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - So-
ciété de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 29.544.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167456/11.
(130203822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
HET BESTE BROOD HOLDING S.A. société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - So-
ciété de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 29.544.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167457/11.
(130203823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
I-Space S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 165.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour I-SPACE S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013167466/11.
(130203972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157204
L
U X E M B O U R G
Immobilière du GRÄFGEN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 106.165.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167468/10.
(130204482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Immobilière C.JANS & Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
R.C.S. Luxembourg B 102.762.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167469/10.
(130204106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Immogar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 93.404.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167490/10.
(130203962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
IHC Immobilien A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 59.184.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IHC IMMOBILIEN A.G.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013167486/11.
(130203642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
MEGG Invest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 136.284.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Agent administratif
i>Signature
Référence de publication: 2013167639/13.
(130204538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157205
L
U X E M B O U R G
IBTD International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 162.876.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
<i>Pour: IBTD INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Mireille Wagner
Référence de publication: 2013167481/15.
(130203809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Immobilière 2F S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 68.776.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
IMMOBILIÈRE 2F S.A.
Référence de publication: 2013167489/11.
(130204138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Imohtech S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 110.812.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167491/10.
(130203664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Rubysam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 59, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 173.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167775/9.
(130203891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Storebrand Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 54.439.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167792/9.
(130204025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157206
L
U X E M B O U R G
Indunet S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 10, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 42.496.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INDUNET S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013167494/11.
(130203547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Instal-Fit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 98.432.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167495/10.
(130203905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
J.L. Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R.C.S. Luxembourg B 139.070.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167508/10.
(130204409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
J.L. Freeze Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9554 Wiltz, 29, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 160.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2013167509/10.
(130203795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
OUTOX International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 135.262.
DCL Avocats, cabinet d'avocats, 9 avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, ici représenté par Madame
Dorothée Ciolino, dénonce le siège de la société OUTOX International S.A., 9 avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B135262.
Avec date d'effet au 29/11/2013
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DCL Avocats
i>Dorothée Ciolino
Référence de publication: 2013167698/13.
(130203565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157207
L
U X E M B O U R G
Moor Park Fortuny Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.353.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
Anna D'Alimonte
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013167626/12.
(130204549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Misys Manco S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.514.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 20 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
777 du 23 mars 2012.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Misys Manco S.C.A.
Signature
Référence de publication: 2013167624/15.
(130204258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Madrax Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 117.269.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167628/10.
(130203903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Net's Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9268 Diekirch, 1, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 165.406.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 02/12/2013.
<i>Pour la société
i>C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013167659/17.
(130203914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157208
L
U X E M B O U R G
Mama Forte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9806 Hosingen, 16, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 153.819.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167629/10.
(130204346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Misys Manco S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.514.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 20 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
777 du 23 mars 2012.
Les comptes annuels de la Société au 31 mai 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Misys Manco S.C.A.
Signature
Référence de publication: 2013167623/15.
(130204257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
MCM Import-Export Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3432 Dudelange, 22, rue Dr Orphée Bernard.
R.C.S. Luxembourg B 63.791.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2013167637/12.
(130203902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Finprotec S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 128.230.
Par leurs courriers adressés à la société FINPROTEC S.A., il résulte que:
- Monsieur Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 45-47, route d'Arlon,
L-1140 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration et Administrateur,
- Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, avec adresse professionnelle au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Ad-
ministrateur,
- Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4547 route d'Arlon, L-1140 Lu-
xembourg, Administrateur,
ont démissionné de leur fonction d'Administrateur de ladite société et ce, avec effet au 22 novembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINPROTEC S.A.
Référence de publication: 2013168221/17.
(130204757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
157209
L
U X E M B O U R G
TIAA Lux 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.233.800,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 167.150.
En date du 19 novembre 2013, l'associé unique de la Société, ND Europe S.à r.l., a transféré 59.945 parts sociales qu'il
détenait dans la Société à:
- SAS PIAL 34, une société par actions simplifiée, constituée et régie selon les lois de France, ayant son siège social à
l'adresse suivante: 8-12, rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris, France et immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris, sous le numéro 795 395 706.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
SAS PIAL 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.945 parts sociales
ND Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.393 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
TIAA Lux 11 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013167877/20.
(130203638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Tinsel Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.180.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 établis conformément aux normes comptables internationales telles qu’ad-
optées au sein de l’Union Européenne, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 28 novembre 2013.
Référence de publication: 2013167879/12.
(130204149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Tubosider International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 113.476.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167885/9.
(130204171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Velosi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 967.690,96.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 174.012.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013167894/13.
(130204039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157210
L
U X E M B O U R G
TIAA Lux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.654.700,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 115.160.
En date du 19 novembre 2013, l'associé unique de la Société, ND Properties, Inc., a transféré 110.832 parts sociales
qu'il détenait dans la Société à:
- SAS PIAL 34, une société par actions simplifiée, constituée et régie selon les lois de France, ayant son siège social à
l'adresse suivante: 8-12, rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris, France et immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris, sous le numéro 795 395 706.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
SAS PIAL 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.832 parts sociales
ND Properties, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.356 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2013.
TIAA Lux 5 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013167878/20.
(130203639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Tommy Sports S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, 11A, allée John W. Léonard.
R.C.S. Luxembourg B 138.277.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167881/9.
(130203649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Transports Carlier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 61.248.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167883/9.
(130203657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Virlux, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 174.316.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 novembre 2013i>
Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique du 15.11.2013 de la société Virlux
S.A., SPF il à été décidé:
Révocation de Madame Sandrine Stourm comme commissaire aux comptes à partir du 20.12.2012.
Nomination de Madame Olga Jerohina, comptable, née à Riga, Lettonie, le 17 Novembre 1976 demeurant profession-
nellement à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling comme commissaire aux comptes de la Société avec effet du
20.12.2012 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2018.
Revocation de la Société EZD S.à r.l., comme administrateur unique de la Société avec effet à partir du 16.10.2013.
Luxembourg, le 29.11.2013.
Référence de publication: 2013167908/16.
(130203508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157211
L
U X E M B O U R G
Toba S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.512.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2013i>
- Les démissions des Administrateurs de la société, à savoir la société LANNAGE S.A., représentée par Madame
Nathalie LETT, la société VALON S.A., représentée par Monsieur Cédric JAUQUET et la société KOFFOUR S.A., re-
présentée par Monsieur Guy BAUMANN sont acceptées;
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg, Monsieur Vito MARINELLI, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg et Monsieur Olivier OUDIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg sont nommés Administrateurs avec effet immédiat. Leurs mandats d'Administrateurs viendront à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019;
- La démission du Commissaire aux Comptes, la société AUDIT TRUST S.A. est acceptée;
- la société FIN Contrôle, Société Anonyme, 12 rue Guillaume J. Kroll, L-1882 Luxembourg est nommée Commissaire
aux Comptes avec effet immédiat. Son mandat de Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2019;
- Le siège social est transféré au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg avec effet immédiat.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Certifié sincère et conforme
TOBA S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013167880/26.
(130203707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Tortoise US Energy Infrastructure S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 150.246.
Les comptes annuels au 30 novembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013167882/10.
(130204207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Wahaca International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.767.
Le bilan au 30 Juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167916/9.
(130203555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
St. Georges Investment S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.251.
Les comptes annuels au 30-06-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167834/9.
(130203866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
157212
L
U X E M B O U R G
Skye Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.559.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,
ON THE SIXTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BREDS Europe 1 NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 176.328,
represented by Maître Thierry Kauffman, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 31
October 2013, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Skye Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Skye Investment
S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
157213
L
U X E M B O U R G
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
157214
L
U X E M B O U R G
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2013.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
157215
L
U X E M B O U R G
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
BREDS Europe 1 NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1.300.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BREDS Management S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.408.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDDREIZEHN,
AM SECHSTEN TAG DES MONATS NOVEMBER,
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum
Luxemburg,
ist erschienen,
BREDS Europe 1 NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxembur-
gischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhun-
dert Euro (EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg unter der
Nummer B 176.328,
157216
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Herrn Thierry Kauffman, Rechtsanwalt, beruflich Wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer pri-
vatschriftlichen Vollmacht vom 31. Oktober 2013, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Skye Investment S.à r.l." wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Skye Investment S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebe-
nenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, Lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes vom 5. April 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
157217
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
157218
L
U X E M B O U R G
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder
„Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit" und
„Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das
erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2013 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
157219
L
U X E M B O U R G
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BREDS Europe 1 NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.300.-.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BREDS Management S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.408.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: T. KAUFFMAN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 08 novembre 2013. Relation: RED/2013/1888. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
157220
L
U X E M B O U R G
Redange-sur-Attert, den 14. November 2013.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013158876/453.
(130194492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Antin Infrastructure Luxembourg IX, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.441.
In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Antin Infrastructure Partners FCPR, a joint ownership of securities (fonds commun de placement á risques) as defined
in article L 214-20 of the French Monetary and Financial Code, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré,
F-75001 Paris,
represented by Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue
Saint-Honoré, F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 487 530 677, repre-
sented by Mr Alain Rauscher, President of Antin Infrastructure Partners SAS, having his professional address at 374, rue
Saint-Honoré, F-75001 Paris, (the Sole Shareholder),
here represented by Mr Franz Kerger, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Paris (France) on October 30
th
, 2013.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed.
The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents
the entire share capital of the Company, denominated Antin Infrastructure Luxembourg IX, a public limited company
(société anonyme) established under the laws of Luxembourg, the registered office of which is at 44, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 172.441. The Com-
pany has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 26
th
, 2012, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2901 of November 29
th
, 2012 (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated
April 25
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1502 of June 25
th
, 2013.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting (the Meeting) is regularly consti-
tuted and that it may validly deliberate on the following agenda (the Agenda):
<i>Agendai>
1. Creation of two classes of shares denominated "class A" and "class B";
2. Amendment of article 6 of the Articles;
3. Amendment of article 20 of the Articles;
4. Amendment of article 21 of the Articles;
5. Amendment of article 23 of the Articles;
6. Adjunction of a new article 24 to the Articles;
7. Adjunction of a new article 25 to the Articles;
8. Adjunction of a new article 26 to the Articles;
9. Conversion of the existing shares into class A shares;
10. Decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 1,136,030 (one million one
hundred thirty-six thousand thirty euro) by an amount of EUR 2,490 (two thousand four hundred ninety euro) to an
amount of EUR 1,138,520 (one million one hundred thirty-eight thousand five hundred twenty euro), and (ii) to issue 249
(two hundred and forty-nine) new B shares, having a par value of EUR 10 (ten euro) each;
Offer of the new B shares for subscription to Mr Frédéric Zimer, Mr Didier Quillot, DQ Conseil, Mr Cédric Lépolard,
Mr Bruno Quennesson and Mr Pierre Cassier, for a subscription price per share of EUR 5,000 (five thousand euro);
11. Waiver by the Sole Shareholder of its pre-emptive rights in connection with the increase of the share capital as
referred to in item (10) above in favour of Mr Frédéric Zimer, Mr Didier Quillot, DQ Conseil, Mr Cédric Lépolard, Mr
Bruno Quennesson and Mr Pierre Cassier;
12. Subscription to the new B shares referred to in item (10) above in cash by Mr Frédéric Zimer, Mr Didier Quillot,
DQ Conseil, Mr Cédric Lépolard, Mr Bruno Quennesson and Mr Pierre Cassier and payment in full of the subscription
price per share of EUR 5,000 (five thousand euro);
13. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the creation of the class A and class B shares
under item (1) above, the conversion of the existing shares into class A shares under item (9) above and the share capital
157221
L
U X E M B O U R G
increase under item (10) above, with grant of a power of attorney to proceed in the name and on behalf of the Company
to the registration of the newly created and issued shares in the share register of the Company;
14. Subsequent amendment of article 5 of the Articles in order to reflect the creation of the class A and class B shares
under item (1) above, the conversion of the existing shares into class A shares under item (9) above and the share capital
increase under item (10) above;
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder of the Company resolves to create two different classes of shares denominated "A shares" and
"B shares".
All the shares will remain ordinary shares.
The class A shares will entitle their holders to the portion of the distributable profits of the Company that is not
attributable to the class B shares pursuant to article 20 of the Articles.
The class B shares will entitle their holders by priority to the portion of the distributable profits of the Company that
is attributable to them pursuant to article 20 of the Articles.
Losses of the Company shall be allocated by priority to the class A shares. All costs suffered by the Company will be
allocated to the class A shares.
Upon the liquidation of the Company, the class A shares and the class B shares will entitle their holders to the proceeds
resulting from the liquidation of the Company, allocated among the two classes of shares in accordance with article 20
of the Articles.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 6 of
the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will
be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
The Board is authorised, for a period starting on 26 October 2012 and ceasing on the fifth anniversary of such date,
to redeem shares of the Company pursuant to the terms and conditions set out below. This authorisation is granted to
the Board pursuant to article 49-2 of the Companies Act.
The Board is authorised to redeem shares of the Company by any means, including without limitation under share
redemption agreements, option agreements, and exchange agreements, against a cash consideration or a consideration
in kind, on the terms and conditions to be set out by the Board, provided that:
(i) the maximum number of shares of the Company that can be redeemed from time to time under this authorisation
shall be equal to the number of shares of the Company outstanding from time to time less the number of shares of the
Company representing the minimum share capital required by the Companies Act for a public limited liability company
(société anonyme);
(ii) the redemption price of the A Shares, whether it is paid in cash or in kind, shall be set at EUR 10 (ten euro) per
share redeemed; and
(iii) the redemption price of the B Shares, whether it is paid in cash or in kind, shall be set by application of the principles
exposed under article 23 below.
Share redemptions shall be made out of the distributable reserves (including share premium and capital surplus) and
profits available to that effect in accordance with article 49-2 of the Companies Act.
Redeemed shares of the Company may (or may not) be cancelled by a resolution made by a General Meeting in
accordance with the requirements set out in the Companies Act.
Once redeemed and for so long as the shares of the Company are kept in treasury by the Company, the shares of the
Company shall bear no voting rights and the rights to receive dividends or liquidation proceeds shall be suspended.
The Board shall take or authorise any person to take any necessary steps resulting from the redemption of the shares
of the Company, including but not limited to the recording of such redemption in the share register of the Company.
The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person,
the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company."
157222
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 20 of
the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to
the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten
per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5
above.
The annual net profits of the Company that are not allocated to the reserve required by law shall be allocated between
the A Shares and the B Shares in accordance with the following principles:
(i) to the B Shares, it shall be allocated a right to a preferential dividend determined in accordance with the provisions
of article 23 of these Articles; and
(ii) to the A Shares, it shall be allocated the annual net profits of the Company that are not attributed to the B Shares.
The annual net losses of the Company shall be allocated by priority to the A Shares.
The General Meeting shall determine how the annual net profits allocated to the A Shares shall be disposed of and it
may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and
policy. The General Meeting shall be bound to automatically distribute the annual net profits of the Company that are
allocated to the B Shares, provided that such distributions shall in all cases be mentioned in the convening notice to the
General Meeting established in accordance with article 10, except (i) if such distributions would be contrary to the
corporate interest of the Company or (ii) in the case where holders of B Shares have made, at least 2 (two days) prior
to the holding of the General Meeting (but after having received the convening notice to the General Meeting), a request
to the holders of the A Shares to retain the net profits of the Company that are attributable to them, for such portion
of the net profits of the Company that is attributable to said holders of B Shares.
The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places
and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915."
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 21 of
the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 21. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 22 below. In the event
of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also
determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).
The distribution of a liquidation profit, if any, shall be made in accordance with article 20 above, it being specified that
the entirety of the paid-in share premiums and other informal contributions shall be allocated to the A Shares."
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend article 23 of
the Articles, which shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 23. Financial rights of the B Shares. In addition to the political rights conferred on them by law and the bylaws
of the Company, the financial rights of the ADP AIL IX (the Rights to ADP AIL IX's Proceeds) are described below.
For the purposes of this article23 and of article 24, words and phrases starting with a capital letter shall have the
meaning assigned to them in article 25.
The ADP AIL IX will be entitled, as a whole, upon the occurrence of the following events, to financial rights calculated
as follows (it being understood that apart from the following cases, the ADP AIL IX will not receive any financial rights):
(a) upon the occurrence of an ADP AIL X Trigger: the ADP AIL IX will give right in the form of a dividend or in the
form of a share in the liquidation proceeds when the ADP AIL X Trigger is followed by an AIL IX Liquidation, to an
amount equal to the Rights to ADP AIL X's Proceeds;
(b) upon the occurrence of an ADP AIL IX Trigger: the ADP AIL IX will give right to an amount calculated by applying
the following formula and which will be due in the form of (a) a share of the sale price attributable to the ADP AIL IX
when the ADP AIL IX Trigger is a Change in Control or (b) a dividend when the ADP AIL IX Trigger is a distribution of
dividend by AIL IX or lastly (c) in the form of a share of the liquidation proceeds when the ADP AIL IX Trigger is a
Liquidation:
Rights to ADP AIL IX's Proceeds = Total ADP Proceeds - ADP Intermediary Collections
Where:
157223
L
U X E M B O U R G
- Total ADP Proceeds means an amount in euro calculated by multiplying (a) the aggregate subscription amount of the
B Shares held by the Managers by (b) a ADP Multiple determined according to the table below based on the Gross Antin
Multiple calculated in the event of the ADP AIL IX Trigger.
Gross Antin Multiple . . . . . . . <0.5x 0.5x–1x 1x–1.6x 1.6x 1.81x 2.05x 2.25x 2.46x 2.62x >2.62x
ADP Multiple . . . . . . . . . . . . . 0x
0.5x–1x 1x
1x
1.80x 3x
5x
8x
10x
Increases
proportionally
to the Gross
Antin Multiple
In the case of a Gross Antin Multiple strictly included in between the figures indicated in the table above, the ADP
Multiple is calculated by linear interpolation.
As an exception to the above, in the event that the ADP AIL IX Trigger would be a Change in Control which occurred:
- before December 31, 2014 in favor of a Related Entity (as defined under the term "Entité Liée" in the Sharesholders'
Agreement): the ADP Multiple will be equal to whichever is greater between (i) the Gross Antin Multiple, (ii) the ADP
Multiple according to the table above and (iii) 1,5x;
- before December 31, 2014 in favor of an entity other than the Related Entity: the ADP Multiple will be equal to
whichever is greater between (i) the Gross Antin Multiple and (ii) the ADP Multiple according to the table above.
And where:
- ADP Intermediary Collections means the sum of all Collection perceived, if any, by the ADP AIL IX holders from
the date of issuance of the ADP AIL IX and until the date of the ADP AIL IX Trigger (or their predecessors from the
date of issuance of the ADP AIL IX) plus the amount of preferred dividends to which the ADP AIL IX would have been
entitled under previous ADP AIL IX Triggers.
In the event where the ADP AIL IX Trigger is a Collection by the Financial Investor that would not occur in the context
of an Exit, the Managers, as ADP AIL IX holders may decide (at a majority in voting rights attached to their ADP AIL IX)
that (i) the ADP AIL IX will receive a dividend of an equal amount to the Rights to ADP AIL IX's Proceeds calculated in
the context of the relevant ADP AIL IX Trigger or that (ii) the ADP AIL IX will benefit from a right to receive a preferred
dividend in an amount equivalent until the Exit (the latter not bearing any interest).
It is specified for the avoidance of doubt, that regardless of the circumstances under which the ADP AIL IX will give
access to financial rights, the sum of all Collections that the ADP AIL IX holders shall be entitled to receive from the date
of issuance of the ADP AIL IX until the sale or repurchase of the ADP AIL IX shall not exceed the amount of the Total
ADP Proceeds."
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to adjoin a new article
24 to the Articles, which shall be worded as follows:
" Art. 24. Automatic conversion. In the event where the ADP AIL IX Trigger is an Initial Public Offering or a Change
in Control under which the Managers do not exercise their Total Tag Along Right (as defined under the term "Droit de
Cession Conjointe Totale" in the Shareholders' Agreement) and where the Financial Investor does not exercise his Drag
Along Right, the ADP AIL IX will automatically convert into common shares as follows.
All the ADP AIL IX will be converted into a total number of common shares equal to the result of the following formula:
NAO = VADP / Price of the Transaction
Where:
NAO means the number of common shares issued by the conversion of all ADP AIL IX; and
VADP means the Rights to ADP AIL IX's Proceeds in the context of the relevant ADP AIL IX Trigger (excluding, for
the avoidance of doubt, the ADP Intermediary Collections);
Price of the Transaction means the value of an AIL IX common share as part of the relevant transaction (either the
Initial Price in the case of an Initial Public Offering, or the unit price of an AIL IX common share under the Change in
Control)."
<i>Seventh resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to adjoin a new article
25 to the Articles, which shall be worded as follows:
" Art. 25. Definitions. ADP AIL IX means the preference shares issued by AIL IX and subscribed by the Managers;
ADP AIL X means the preference shares issued by AIL X and subscribed by AIL IX;
ADP Multiple means, on the date of the ADP AIL IX Trigger, the sum of all Collections related to the ADP AIL IX
divided by the sum of all Disbursement related to the ADP AIL IX;
AIL IX means the Company;
157224
L
U X E M B O U R G
AIL X means Antin Infrastructure Luxembourg X S.A., a public limited company (société anonyme) established under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered under
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 172.547;
Associate means any shareholders or holders of other securities of a Group Company as well as any entity or person
that consented to a loan or an advance for a Group Company;
ADP AIL IX Trigger means the occurrence of a Collection by the Financial Investor, provided that the sum of the
Financial Investor's Collections up to such date (including, the Collection relating to the relevant ADP AIL IX Trigger)
allows it to make a Gross Antin Multiple equal to at least 0.5x;
ADP AIL IX's Proceeds has the meaning ascribed to such term, and is calculated in accordance with the rules set out,
in the articles of association of AIL X;
Change in Control means any transaction (particularly a transfer of shares) after which the Financial Investor ceases
to own directly or indirectly at least 50.1% of the share capital or voting rights of AIL IX;
Collection means, relatively to an Associate, all amounts received by the Associate (i) from a Group Company for the
payment of dividends, a reduction of capital, a redemption, a buyback, interests, a bonus or the repayment of a loan or
advance and (ii) those resulting from the transfer by the Associate of shares, securities or loans held in one of the Group
Companies until the date of completion of an Exit;
Disbursement means, relatively to an Associate, all amounts paid by the Associate to acquire or subscribe for shares
or other securities of a Group Company or to make an advance or a loan to a Group Company, and generally, all payments
made to a Group Company by the Associate until the date of completion of an Exit;
Exit means indifferently a Change in Control, an Initial Public Offering or a Liquidation.
Financial Investor means Antin Infrastructure Partners FCPR, a joint ownership of securities (fonds commun de pla-
cement ä risques), represented by its management company, Antin Infrastructure SAS, with a share capital of
EUR1,380,000, having its registered office at 374, rue Saint Honoré, 75001 Paris (France), registered under 487 530 677
RCS Paris;
FPS Towers means FPS Towers, a simplified stock company (société par actions simplifiée) established under the laws
of France, with a share capital of EUR34,576,270, having its registered office at 60, rue Etienne Dolet, 92240 Malakoff
(France), registered under 538 419 052 RCS Nanterre;
Gross Antin Multiple means, at the date of a given ADP AIL IX Trigger, the sum of all the Financial Investor's Collections
divided by the sum of all the Financial Investor's Disbursements.
It is specified, to calculate the Gross Antin Multiple, that:
(i) the Gross Antin Multiple will be calculated before any allocation of the proceeds to the ADP AIL IX (therefore the
Financial Investor's Collections will be calculated based on the assumption that the Rights to ADP AIL IX's Proceeds are
equal to zero, any flow that may be received by the holders of ADP AIL IX before the relevant ADP AIL IX Trigger shall
be restated as if it had not been received);
(ii) in the event of an Initial Public Offering, if the Financial Investor retains some of its shares or other securities, they
will be deemed to have assigned all these shares or other securities at a price per share equal to the Initial Price;
(iii) in the event of a Change in Control in which the Financial Investor retains a portion of its shares or other securities,
the Financial Investor will be deemed to have assigned, at the date of the Change in Control, all these shares or other
securities at a price per share equal to the price per share emerging from the transaction of the Change in Control;
(iv) the commissions or management fees paid to the Financial Investor (if any) will be included in the Financial Investor's
Collections (for their amount net of taxes);
(v) will be deducted from the Financial Investor's Collection the amount of all expenses, fees and other outgoings for
external advice related to the acquisition, holding and management, or the transfer of AIL IX, AIL X and FPS Towers'
shares or securities, payable immediately or in the future, which will reduce the net amount received by the Financial
Investor;
(vi) in the event that the ADP AIL IX Trigger is an Exit and where the Financial Investor would have made a Disbur-
sement less than 12 months before the completion date of an Exit (a Short Term Disbursement), then (a) the amount of
this Short Term Disbursement will not be taken into account in the sum of the Financial Investor's Disbursements and
(b) will be deducted from the Financial Investor's Collections an amount equal to the Short Term Disbursement increased
by an 8% interest per annum calculated prorata temporis between the date of the Short Term Disbursement and the
date of completion of the Exit; and
(vii) in the event where the Financial Investor has received, after the date of issuance of ADP AIL IX, a Disbursement
followed by a Collection (of a kind referred to in (i) the definition of "Collection" above) less than 12 months after the
date of this Disbursement, then (a) the Disbursement in question will be reduced by an amount (the Reduction Amount)
equal to the share of the relevant Disbursement which exceeds 5% of the all Disbursements and (b) will be deducted
from the Financial Investor's Collections an amount equal to the Reduction Amount increased by a 8% interest per annum
calculated prorata temporis between the date of the relevant Disbursement and the date of the relevant Collection.
Group Company means AIL IX, AIL X, FPS Towers or any other company controlled, directly or indirectly by FPS
Towers and Group Companies means all of these companies;
157225
L
U X E M B O U R G
Indirect Loss of Control means any event for which AIL IX ceases to hold at least 50.1% of the share capital or voting
rights of AIL X;
Initial Price means the fixed price for the issuance of new shares to the public or the transfer of all or part of its existing
shares as part of an Initial Public Offering;
Initial Public Offering means the admission of all or part of AIL IX on a regulated or organized market, in France or an
equivalent foreign market;
Liquidation means the liquidation of AIL IX following an Indirect Loss of Control; and
Managers means (i) Mr Frédéric Zimer, born on 8 September 1957 in Neuilly-sur-Seine (France), residing in France at
8 bis, Impasse Césaire, 92240 Malakoff, (ii) Mr Didier Quillot, born on 18 May 1959 in Mas Grenier (France), residing in
France at 15, rue Ernest Cognacq, 92300 Levallois-Perret, (iii) Mr Cédric Lépolard, born on 24 March 1979 in Château
Thierry (France), residing in France at 62, rue Marjolin, 92300 Levallois Perret, (iv) Mr Bruno Quennesson, born on 9
March 1962 in Puteaux (France), residing in France at 18 bis, rue du Bois, 92000 Nanterre, (v) Mr Pierre Cassier, born
on 27 October 1972 in Paris (France), residing in France at 95, avenue de Paris, 92320 Châtillon and (vi) DQ Conseil (a
simplified stock company (société par actions simplifiée) established under the laws of France, having its registered office
at 5, avenue de Messine, 75008 Paris (France), registered under 537 673 972 R.C.S. Paris); and
Shareholders' Agreement means the agreement entered into by the holders of the A Shares and the holders of the B
Shares to govern their relationships."
<i>Eighth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder of the Company resolves to adjoin a new article
26 to the Articles, which shall be worded as follows:
" Art. 26. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act 1915."
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert the existing shares of the Company into class A shares. The share capital
of the Company will henceforth be composed as follows:
113,603 shares are converted into 113,603 class A shares.
Currently, all shares of all classes are held by the Sole Shareholder.
<i>Tenth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves:
(i) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,490 (two thousand four hundred ninety euro)
in order to raise it from its previous amount of EUR 1,136,030 (one million one hundred thirty-six thousand thirty euro),
represented by 113,603 (one hundred thirteen thousand six hundred three) class A shares, having a par value of EUR 10
(ten euro) each, to an amount of EUR 1,138,520 (one million one hundred thirty-eight thousand five hundred twenty
euro), represented by 113,852 (one hundred thirteen thousand eight hundred fifty-two) ordinary shares, having a par
value of EUR 10 (ten euro) each, divided into 2 (two) classes; and
(ii) to issue 249 (two hundred forty-nine) new class B shares, each share having a par value of EUR 10 (ten euro) (the
New B Shares).
The Sole Shareholder resolves that the New B Shares shall be offered for subscription at this Meeting to (i) Mr Frédéric
Zimer, born on 8 September 1957 in Neuilly-sur-Seine (France), residing in France at 8 bis, Impasse Césaire, 92240
Malakoff, (ii) Mr Didier Quillot, born on 18 May 1959 in Mas Grenier (France), residing in France at 15, rue Ernest Cognacq,
92300 Levallois-Perret, (iii) Mr Cédric Lépolard, born on 24 March 1979 in Château Thierry (France), residing in France
at 62, rue Marjolin, 92300 Levallois Perret, (iv) Mr Bruno Quennesson, born on 9 March 1962 in Puteaux (France), residing
in France at 18 bis, rue du Bois, 92000 Nanterre, (v) Mr Pierre Cassier, born on 27 October 1972 in Paris (France),
residing in France at 95, avenue de Paris, 92320 Châtillon and (vi) DQ Conseil, a simplified stock company (société par
actions simplifiée) established under the laws of France, having its registered office at 5, avenue de Messine, 75008 Paris
(France), registered under 537 673 972 R.C.S. Paris), as follows,
subject to the waiver of its pre-emptive rights, to the extent required, by the Sole Shareholder of the Company:
Mr Frédéric Zimer, 140 (one hundred forty) New B Shares;
Mr Didier Quillot, 30 (thirty) New B Shares;
Mr Cédric Lépolard, 15 (fifteen) New B Shares;
Mr Bruno Quennesson, 24 (twenty-four) New B Shares;
Mr Pierre Cassier, 10 (ten) New B Shares; and
DQ Conseil, 30 (thirty) New B Shares.
157226
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder further resolves that the New B Shares shall be subscribed and fully paid in cash for a subscription
price per New B Share of EUR 5,000 (five thousand euro) and that the issuance of the New B Shares shall be effective
immediately before the amendment of the Articles to reflect the issuance of the New B Shares.
<i>Eleventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to waive its pre-emptive rights in favour of Mr Frédéric Zimer, Mr Didier Quillot, Mr
Cédric Lépolard, Mr Bruno Quennesson, Mr Pierre Cassier and DQ Conseil to the extent required for the purpose of
the issuance of the New B Shares, as set out under the tenth resolution.
<i>Twelfth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following interventions for the subscription to the New B
Shares and the full payment of the subscription price of the New B Shares, as follows:
<i>Interventions - Subscription - Paymenti>
1) Mr Frédéric Zimer declares to subscribe in cash to 140 (one hundred forty) New B Shares having a nominal value
of EUR 10 (ten euro) each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of
EUR 700,000 (seven hundred thousand euro);
2) Mr Didier Quillot declares to subscribe in cash to 30 (thirty) New B Shares having a nominal value of EUR 10 (ten
euro) each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of EUR 150,000
(one hundred fifty thousand euro);
3) Mr Cédric Lépolard declares to subscribe in cash to 15 (fifteen) New B Shares having a nominal value of EUR 10
(ten euro) each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of EUR 75,000
(seventy-five thousand euro);
4) Mr Bruno Quennesson declares to subscribe in cash to 24 (twenty-four) New B Shares having a nominal value of
EUR 10 (ten euro) each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of
EUR 120,000 (one hundred twenty thousand euro);
5) Mr Pierre Cassier declares to subscribe in cash to 10 (ten) New B Shares having a nominal value of EUR 10 (ten
euro) each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of EUR 50,000
(fifty thousand euro), and
6) DQ Conseil declares to subscribe in cash to 30 (thirty) New B Shares having a nominal value of EUR 10 (ten euro)
each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of EUR 150,000 (one
hundred fifty thousand euro),
each being represented by Mr Franz Kerger, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of powers of
attorney given under private seal, signed and attached to this deed.
The Meeting acknowledges that the cash payments in consideration for the issuance of the New B Shares in the
aggregate amount of EUR 1,245,000 (one million two hundred forty-five thousand euro) are allocated as follows:
(i) an amount of EUR 2,490 (two thousand four hundred ninety euro) to the share capital account; and
(ii) an amount of EUR 1,242,510 (one million two hundred forty-two thousand five hundred ten euro) to the share
premium account.
The aggregate amount of EUR 1,245,000 (one million two hundred forty-five thousand euro) is at the free disposal of
the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate issued by
BGL BNP Paribas on October 31
st
, 2013 confirming the availability of the subscription amounts on the Company's bank
account and the notary expressly bears witness to it.
<i>Thirteenth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby
empowers and authorises any director of the Company and any lawyer of Allen & Overy Luxembourg, to proceed on
behalf of the Company to the registration of the newly created shares classes in the share register of the Company and
to see to any formalities in connection therewith.
<i>Fourteenth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 5 of the Articles, which shall be
henceforth reworded as follows:
" Art. 5. Share capital. The share capital is set at EUR 1,138,520 (one million one hundred f thirty-eight thousand five
hundred twenty euro) consisting of 113,852 (one hundred thirteen thousand eight hundred fifty-two) ordinary shares in
registered form with a par value of EUR 10 (ten euro) each, which are fully paid-up and divided into classes as follows:
1. 113,603 class A shares (the A Shares); and
2. 249 class B shares (the B Shares).
157227
L
U X E M B O U R G
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.
In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment
in cash of those instruments covered in article 32-4 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for
or to be allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance
in accordance with the Companies Act.
The Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in
cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the Board, within the limit prescribed by
Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account
in accordance with Luxembourg law.
In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares
by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting,
within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the "capital surplus" account referred to in
the above paragraph.
The authorised capital of the Company is set at EUR 200,000,000 (two hundred million euro) represented by maximum
of 20,000,000 (twenty million) shares, each with a nominal value of EUR 10 (ten euro).
The Board is authorised, during a period starting on 26 October 2012, and expiring on the fifth anniversary of such
date (the Period), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part
from time to time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares
in consideration for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share
premium and capital surplus, with or without an issuance of new shares.
The Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares
pursuant to the authority granted under this Article 5, including by setting the time and place of the issue or the successive
issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment for the shares
under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option
plans.
The Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments,
bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with
shares, including convertible bonds (the Instruments), and (b) issue shares subject to and effective as of the exercise of
the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital
that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised
share capital, and (ii) issue shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of
increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether
or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The shares to be issued following
the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a
capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.
The Board is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price, the interest
rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.
The Board is authorised to (i) cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act,
as reflected in this Article 5, in connection with an issue of new shares and Instruments and (ii) cancel or limit the rights
of the shareholders to be treated equally for the allocation of (a) shares to be issued by way of capitalisation of distributable
profits and distributable reserves, including share premium and capital surplus, under any documents and agreements
including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans and pursuant to the exercise of
the rights attached to the Instruments, within the limit set forth under Luxembourg law.
Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the
authorisation granted to the Board under this Article 5 and the Board shall take or authorise any person to take any
necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles
before a notary."
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares that, in accordance with article 32-1 of the law dated August 10
th
, 1915 on com-
mercial companies, as amended, (the Companies Act) the conditions prescribed by articles 26, 26-3 and 26-5 (with the
terms of article 26-1 paragraph (2) being not applicable as no contribution for assets other than cash was made at this
Meeting) of the Companies Act, have been fulfilled, and expressly bears witness to their fulfilment.
There being no further business on the Agenda of the Meeting, the Meeting is closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,900 (two thousand nine hundred euro).
157228
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The deed having been read to the Meeting and the appearing party, the appearing party signed together with us, the
notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trente et un octobre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.
A comparu:
Antin Infrastructure Partners FCPR, un fonds commun de placement à risques, tel que défini à l'article L 214-20 du
code monétaire et financier, ayant son siege au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris,
représenté par Antin Infrastructure Partners SAS, sa société de gestion, ayant son siège social au 374, rue Saint-Honoré,
F-75001 Paris, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 487 530 677, représentée par Mr
Alain Rauscher, Président de Antin Infrastructure Partners SAS, ayant son adresse professionnelle au 374, rue Saint-
Honoré, F-75001 Paris, (l'Actionnaire Unique),
ici représentée par Me Franz Kerger, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée à Paris (France) le 30 octobre 2013.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et le notaire instrumentaire, restera également annexée au présent acte.
L'Actionnaire Unique, en la capacité en vertu de laquelle il agit, a demandé au notaire instrumentant de prendre acte
de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société anonyme dénommée Antin Infrastructure Luxembourg IX,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.441, organisée sous le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (la Société). La Société a été
constituée selon acte du notaire instrumentant du 26 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association, N° 2901 du 29 novembre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour
la dernière fois par un acte du notaire instrumentant daté du 25 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N° 1502 du 25 juin 2013.
L'Actionnaire Unique reconnaît que la présente assemblée (l'Assemblée) est régulièrement constituée et peut vala-
blement décider sur son ordre du jour (l'Agenda):
<i>Agendai>
1. Création de deux classes d'actions dénommées «classe A» et «classe B»;
2. Modification de l'article 6 des Statuts;
3. Modification de l'article 20 des Statuts;
4. Modification de l'article 21 des Statuts;
5. Modification de l'article 23 des Statuts;
6. Adjonction d'un nouvel article 24 aux Statuts;
7. Adjonction d'un nouvel article 25 aux Statuts;
8. Adjonction d'un nouvel article 26 aux Statuts;
9. Conversion des actions existantes en actions de classe A;
10. Décision (i) d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 2.490 (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix
euros), pour le faire passer de son montant actuel de EUR 1.136.030 (un million cent trente-six mille trente euros) à un
montant de 1,138,520 (un million cent trente-huit mille cinq cent vingt euros) et (ii) d'émettre 249 (deux cent quarante-
neuf) nouvelles actions de classe B, d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune;
Offre des nouvelles actions de classe B à la souscription par Monsieur Frédéric Zimer, Monsieur Didier Quillot,
Monsieur Cédric Lépolard, Monsieur Bruno Quennesson, Monsieur Pierre Cassier et DQ Conseil, pour un prix de
souscription par action de EUR 5.000 (cinq mille euros);
11. Renonciation par l'Actionnaire Unique à son droit préférentiel de souscription relatif à l'augmentation de capital
social mentionnée au point (10) ci-dessus en faveur de Monsieur Frédéric Zimer, Monsieur Didier Quillot, Monsieur
Cédric Lépolard, Monsieur Bruno Quennesson, Monsieur Pierre Cassier et DQ Conseil;
12. Souscription en numéraire aux nouvelles actions de classe B mentionnées au point (10) ci-dessus par Monsieur
Frédéric Zimer, Monsieur Didier Quillot, Monsieur Cédric Lépolard, Monsieur Bruno Quennesson, Monsieur Pierre
Cassier et DQ Conseil et libération intégrale du prix de souscription par action de EUR 5.000 (cinq mille euros);
13. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou salarié d'Allen & Overy Luxembourg, afin
157229
L
U X E M B O U R G
d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales
nouvellement émises dans le registre de parts sociales de la Société; et
14. Modification consécutive de l'article 5 des Statuts afin d'y refléter la création des actions de classe A et de classe
B mentionnée au point (1) ci-dessus, la conversion des actions existantes en actions de classe A mentionnée au point (9)
ci-dessus et l'augmentation de capital social de la Société mentionnée au point (10) ci-dessus.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de créer deux différentes classes d'actions dénommées «actions de classe A» et «actions de
classe B».
Toutes les actions resteront des actions ordinaires.
Les actions de classe A donneront droit à leurs détenteurs à la portion des bénéfices distribuables de la Société qui
n'est pas attribuée aux actions de classe B par application de l'article 20 des Statuts.
Les actions de classe B donneront droit à leurs détenteurs en priorité à une portion des bénéfices distribuables de la
Société qui leur est attribuable par application des articles 20 des Statuts.
Les pertes de la Société seront attribuée en priorité aux actions de classe A. Tous les coûts supportés par la Société
seront alloués aux actions de classe A.
Lors de la liquidation de la Société, les actions de classe A et les actions de classe B donneront droit à leurs détenteurs
aux produits résultant de la liquidation de la Société, attribués entre les deux classes d'actions en accord avec l'article 20
des Statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la première résolution, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de lui
donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce
registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant
libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La
propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Le Conseil d'Administration est autorisé, pour une période commençant le 26 octobre 2012 et se terminant au cin-
quième anniversaire de cette date, à racheter des actions de la Société selon les modalités stipulées ci-dessous. Cette
autorisation est accordée au Conseil d'Administration en vertu de l'article 49-2 de la Loi de 1915.
Le Conseil d'Administration est autorisé à racheter les actions de la Société par tout moyen, y compris et sans res-
triction en concluant des contrats de rachat d'actions, des contrats d'option et des contrats d'échange, contre un paiement
en numéraire ou un paiement en nature, suivant les conditions devant être définies par le Conseil d'Administration, à la
condition que:
(i) le nombre maximum d'actions de la Société pouvant être rachetées en vertu de la présente autorisation soit égal
au nombre d'actions de la Société restantes moins le nombre d'actions de la Société représentant le capital social minimum
exigé par la Loi de 1915 pour les sociétés anonymes;
(ii) le prix de rachat des Actions A, qu'il soit payé en numéraire ou en nature, soit de EUR 10 (dix euros) par action
rachetée; et
(iii) le prix de rachat des Actions B, qu'il soit payé en numéraire ou en nature, soit déterminé par application des
principes exposés à l'article 23 ci-dessous.
Les rachats d'actions seront effectués au moyen des réserves distribuables (y inclus la prime d'émission et le capital
surplus) ainsi que sur les bénéfices disponibles à cet effet, conformément à l'article 49-2 de la Loi de 1915.
Les actions de la Société rachetées peuvent ou non être annulées par une résolution de l'Assemblée Générale prise
conformément aux dispositions de la Loi de 1915.
Une fois rachetées et tant que les actions de la Société sont détenues en portefeuille par la Société, les actions n'auront
aucun droit de vote et les droits aux dividendes ou au boni de liquidation seront suspendus.
Le Conseil d'Administration prendra toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre les me-
sures nécessaires en conséquence du rachat des actions de la Société, y compris, entre autres, l'inscription dudit rachat
dans le registres des actionnaires de la Société.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes,
la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été
désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.»
157230
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique de la Société décide de modifier l'article 20 des
Statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 20. Affectation des Bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
Le bénéfice net annuel de la Société non affecté à la réserve légale est alloué entre les Actions A et les Actions B en
accord avec les principes suivants:
(i) aux Actions B, il est attribué un droit à un dividende préférentiel déterminé en accord avec ce qui est prévu à l'article
23 des présents Statuts; et
(ii) aux Actions A, il est attribué le bénéfice net annuel de la Société qui n'est pas attribué aux Actions B. Les pertes
nettes annuelles subies par la Société seront attribuées en priorité aux Actions A.
L'Assemblée Générale décide de l'affectation du bénéfice net annuel alloué au Actions A et décidera seule de payer
des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société. L'Assemblée Générale sera tenue de faire distribuer automatiquement le bénéfice net annuel de la Société qui
est alloué aux Actions B, une telle distribution devant dans tous les cas être mentionnées dans la convocation à l'Assemblée
Générale faite en accord avec l'article 10, excepté (i) dans la mesure où une telle distribution serait contraire à l'intérêt
social de la Société ou (ii) dans le cas où des détenteurs d'Actions B ont fait aux détenteurs des Actions A une demande
de mise en réserve de la portion du bénéfice net de la Société qui leur est attribuable au moins 2 (deux) jours avant la
tenue de l'Assemblée Générale (mais après réception de la convocation à l'Assemblée Générale), pour la portion du
bénéfice net de la Société attribuable auxdits détenteurs d'Actions B.
Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent
être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer
des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.»
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique de la Société décide de modifier l'article 21 des
Statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
La distribution d'un éventuel boni de liquidation sera faite en accord avec l'article 20, étant précisé que l'intégralité
des primes d'émissions et autres contributions informelles sera attribuée aux Actions A.»
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique de la Société décide de modifier l'article 23 des
Statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 23. Droits financiers des Actions B. Outre les droits politiques qui leur sont attribués par la loi et les statuts de
la Société, les droits financiers des ADP AIL IX (les Droits aux Produits des ADP AIL IX) sont décrits ci-après.
Pour les besoins du présent article et de l'article 24, les mots et expressions commençant par une majuscule ont le
sens qui leur est attribué à l'article 25.
Les ADP AIL X donneront droit, dans leur ensemble, dans les cas suivants, à des montants calculés comme suit (étant
précisé qu'en dehors des cas visés ci-après, les ADP AIL IX ne bénéficieront d'aucun droit financier):
a) lors de la survenance d'un Cas de Déclenchement ADP AIL X: les ADP AIL IX donneront droit, sous forme de
dividende ou sous forme de quote-part dans le boni de liquidation lorsque le Cas de Déclenchement ADP AIL X est suivi
d'une Liquidation d'AIL IX, à un montant égal aux Droits aux Produits des ADP AIL X;
b) lors de la survenance d'un Cas de Déclenchement ADP AIL IX: les ADP AIL IX donneront droit à un montant qui
sera calculé par application de la formule suivante et qui sera dû sous forme (a) de quote-part du prix de cession revenant
aux ADP AIL IX lorsque le Cas de Déclenchement ADP AIL IX est un Changement de Contrôle ou (b) de dividende
lorsque le Cas de Déclenchement ADP AIL IX est une distribution de dividende par AIL IX ou enfin (c) sous forme de
quote¬part dans le boni de liquidation lorsque le Cas de Déclenchement ADP AIL IX est une Liquidation:
Droits aux Produits des ADP AIL IX = Produits Totaux ADP -Encaissements ADP Intermédiaires
Où:
157231
L
U X E M B O U R G
- Produits Totaux ADP désigne un montant en euros calculé en multipliant (a) le montant total de souscription des
Actions B détenues par les Cadres, par (b) un Multiple ADP déterminé conformément au tableau ci-dessous selon le
Multiple Antin Brut calculé à l'occasion du Cas de Déclenchement ADP AIL IX.
Multiple Antin Brut . . . . . . . <0.5x 0.5x–1x 1x–1.6x 1.6x 1.81x 2.05x 2.25x 2.46x 2.62x >2.62x
Multiple ADP . . . . . . . . . . . . 0x
0.5x–1x 1x
1x
1.80x 3x
5x
8x
10x
Augmentation
proportionnelle
à celle du
Multiple Antin
Brut
En cas de Multiple Antin Brut strictement compris entre les bornes indiquées dans le tableau ci-dessus, le Multiple
ADP sera calculé par interpolation linéaire.
Par exception à ce qui précède, dans l'hypothèse où le Cas de Déclenchement ADP AIL IX serait un Changement de
Contrôle qui interviendrait:
- avant le 31 décembre 2014 au profit d'une Entité Liée (tel que ce terme est défini dans le Pacte): le Multiple ADP
sera égal au plus élevé entre (i) le Multiple Antin Brut, (ii) le Multiple ADP conformément au tableau qui précède et (iii)
1,5x;
- avant le 31 décembre 2014 au profit d'une entité autre qu'une Entité Liée: le Multiple ADP sera égal au plus élevé
entre (i) le Multiple Antin Brut et (ii) le Multiple ADP conformément au tableau qui précède.
Et où:
- Encaissements ADP Intermédiaires désigne la somme de tous les Encaissements perçus, le cas échéant, par les por-
teurs d'ADP AIL IX depuis la date d'émission des ADP AIL IX et jusqu'à la date du Cas de Déclenchement ADP AIL IX
(ou leurs prédécesseurs depuis la date d'émission des ADP AIL IX) augmentée du montant du dividende prioritaire auquel
donneraient droit les ADP AIL IX au titre de Cas de Déclenchement ADP AIL IX antérieurs.
Dans l'hypothèse où le Cas de Déclenchement ADP AIL IX serait un Encaissement par l'Investisseur Financier qui
n'interviendrait pas à l'occasion d'une Sortie, les Cadres, en tant que porteurs d'ADP AIL IX pourront décider, à la
majorité du nombre de voix attachées à leurs ADP AIL IX, que (i) les ADP AIL IX percevront un dividende d'un montant
égal aux Droits aux Produits des ADP AIL IX tels que calculés à l'occasion du Cas de Déclenchement ADP AIL IX concerné
ou que (ii) les ADP AIL IX bénéficieront d'un droit à percevoir un dividende prioritaire d'un montant équivalent jusqu'à
la Sortie (ce dernier ne portant pas intérêt).
Il est précisé afin d'éviter toute ambiguïté, que quelles que soient les circonstances dans lesquelles les ADP AIL IX
donneront accès à des droits financiers, la somme de l'ensemble des Encaissements que les porteurs d'ADP AIL IX
pourront recevoir entre la date d'émission des ADP AIL IX et la cession ou le rachat des ADP AIL IX, ne pourra excéder
un montant total supérieur aux Produits Totaux ADP.»
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique de la Société décide d'adjoindre un nouvel article
24 aux Statuts, et de lui donner la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 24. Conversion Automatique des ADP AIL IX. Dans l'hypothèse où le Cas de Déclenchement ADP AIL IX serait
une Introduction en Bourse ou un Changement de Contrôle dans le cadre duquel les Cadres n'exerceraient pas leur
Droit de Cession Conjointe Totale (tel que ce terme est défini dans le Pacte) et où l'Investisseur Financier n'exercerait
pas son Droit de Cession Forcée, les ADP AIL IX seront automatiquement converties en actions ordinaires selon les
modalités suivantes.
Toutes les ADP AIL IX seront converties en un nombre total d'actions ordinaires égal au résultat de la formule suivante:
NAO = VADP / Prix de l'Opération
Où:
NAO désigne le nombre d'actions ordinaires émises par conversion de toutes les ADP AIL IX; et
VADP désigne les Droits aux Produits des ADP AIL IX à l'occasion du Cas de Déclenchement ADP AIL IX concerné
(en excluant, afin d'éviter toute ambiguïté, les Encaissement ADP Intermédiaires); et
Prix de l'Opération désigne la valeur d'une action ordinaire d'AIL X dans le cadre de l'opération concernée (soit le
Prix d'Introduction en cas d'Introduction en Bourse, ou le prix unitaire d'une action ordinaire d'AIL IX dans le cadre du
Changement de Contrôle).»
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique de la Société décide d'adjoindre un nouvel article
25 aux Statuts, et de lui donner la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 25. Définitions. ADP AIL IX désigne les Actions B émises par AIL IX et souscrites par les Cadres;
ADP AIL X désigne les Actions B émises par AIL X et souscrites par AIL IX;
AIL IX désigne la Société;
157232
L
U X E M B O U R G
AIL X désigne Antin Infrastructure Luxembourg X S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège
social est situé 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B172.547;
Associé signifie tout titulaire d'actions ou autres valeurs mobilières d'une Société du Groupe ainsi que toute entité ou
personne ayant consenti à une Société du Groupe un prêt ou une avance;
Cadres désigne (i) Monsieur Frédéric Zimer, né le 8 septembre 1957 à Neuilly-sur-Seine (France), résidant en France
au 8 bis, Impasse Césaire, 92240 Malakoff, (ii) Monsieur Didier Quillot, né le 18 mai 1959 à Mas Grenier (France), résidant
en France au 15, rue Ernest Cognacq, 92300 Levallois-Perret, (iii) Monsieur Cédric Lépolard, né le 24 mars 1979 à Château
Thierry (France), résidant en France au 62, rue Marjolin, 92300 Levallois Perret, (iv) Monsieur Bruno Quennesson, né le
9 mars 1962 à Puteaux (France), résidant en France au 18 bis, rue du Bois, 92000 Nanterre, (v) Monsieur Pierre Cassier,
né le 27 octobre 1972 à Paris (France), résidant en France au 95, avenue de Paris, 92320 Châtillon et (vi) DQ Conseil
(une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège au 5, avenue de Messine, 75008 Paris (France),
enregistrée sous le numéro 537 673 972 R.C.S. Paris);
Cas de Déclenchement ADP AIL IX désigne la survenance d'un Encaissement par l'Investisseur Financier dès lors que
la somme des Encaissements de l'Investisseur Financier jusqu'à cette date (incluant l'Encaissement relatif aux Cas de
Déclenchement des ADP AIL IX) lui permet de réaliser un Multiple Antin Brut au moins égal à 0,5x;
Changement de Contrôle désigne toute opération (en particulier un transfert de titres) à l'issue de laquelle l'Investis-
seur Financier cesserait de détenir directement ou indirectement au moins 50,1% du capital social ou des droits de vote
d'AIL IX;
Décaissements signifie, relativement à un Associé, toutes les sommes en numéraire versées par ledit Associé pour
acquérir ou souscrire à des actions ou autres valeurs mobilières d'une Société du Groupe ou pour consentir des avances
ou prêts à une Société du Groupe, et plus généralement, tout paiement fait aux Sociétés du Groupe par ledit Associé
jusqu'à la date de réalisation d'une Sortie;
Droits aux Produits des ADP AIL X a le sens qui lui est attribué, et est calculé conformément aux règles fixées, dans
les statuts d'AIL X;
Encaissements signifie, relativement à un Associé, toutes les sommes en numéraire reçues par ledit Associé (i) en
provenance d'une Société du Groupe au titre du paiement de dividendes, réduction de capital, amortissement, rachat
d'actions, intérêts, prime ou remboursement de prêt et (ii) celles résultant de la cession par ledit Associé des actions,
valeurs mobilières ou prêts détenus dans une Société du Groupe jusqu'à la date de réalisation d'une Sortie;
FPS Towers désigne FPS Towers, société par actions simplifiée de droit français au capital de 34.576.270 €, dont le
siège social est situé 60 Rue Etienne Dolet, 92240 Malakoff (Luxembourg), identifiée sous le numéro 538 419 052 RCS
Nanterre;
Investisseur Financier désigne Antin Infrastructure Partners FCPR, fonds commun de placement à risques, représenté
par sa société de gestion, Antin Infrastructure SAS, au capital de 1.380.000 €, dont le siège social est situé 374, Rue Saint
Honoré, 75001 Paris, identifiée sous le numéro 487 530 677 RCS Paris;
Introduction en Bourse signifie l'admission de tout ou partie des actions d'AIL IX sur un marché réglementé ou organisé,
français ou un marché équivalent à l'étranger;
Liquidation désigne la liquidation d'AIL IX faisant suite à une Perte de Contrôle Indirecte;
Multiple Antin Brut signifie, à la date d'un Cas de Déclenchement ADP AIL IX, la totalité des Encaissements de l'In-
vestisseur Financier rapportée à la totalité des Décaissements de l'Investisseur Financier. Il est précisé, pour le calcul du
Multiple Antin Brut, que:
(i) le Multiple Antin Brut sera calculé avant toute allocation de produits aux ADP AIL IX (les Encaissements de l'In-
vestisseur financier seront donc calculés en supposant que les Droits aux Produits des ADP AIL IX sont égaux à zéro,
tout flux éventuellement reçus par les porteurs d'ADP AIL IX avant le Cas de Déclenchement ADP AIL IX devant donc
être retraité comme s'il n'avait pas été reçu);
(ii) en cas d'Introduction en Bourse, si l'Investisseur Financier conserve une partie de ses actions ou autres valeurs
mobilières, ils seront réputés avoir cédé la totalité desdites actions ou autres valeurs mobilières à un prix par action égal
au Prix d'Introduction;
(iii) en cas de Changement de Contrôle dans le cadre duquel l'Investisseur Financier conserverait une partie de ses
actions ou autres valeurs mobilières, l'Investisseur Financier sera réputé avoir cédé à la date du Changement de Contrôle
la totalité desdites actions ou autres valeurs mobilières à un prix par action égal au prix par action ressortant de l'opération
de Changement de Contrôle;
(iv) les commissions ou management fees versés à l'Investisseur Financier (le cas échéant) seront compris dans les
Encaissements de l'Investisseur Financier (pour leur montant hors taxe);
(v) sera déduit des Encaissements de l'Investisseur Financier le montant de toutes les dépenses, frais et autres débours
de conseils externes liés à l'acquisition, la détention et la gestion, ou la cession de titres d'AIL IX, AIL X et FPS Towers,
payables immédiatement ou à terme, qui viendront réduire le montant net reçu par l'Investisseur Financier;
(vi) dans l'hypothèse où le Cas de Déclenchement ADP AIL IX est une Sortie et où l'Investisseur Financier aurait réalisé
un Décaissement moins de 12 mois avant la date de réalisation d'une Sortie (un Décaissement Court Terme), alors (a)
157233
L
U X E M B O U R G
le montant de ce Décaissement Court Terme ne sera pas pris en compte dans la somme des Décaissements de l'Inves-
tisseur Financier et (b) il sera également déduit des Encaissements de l'Investisseur Financier un montant égal à ce
Décaissement Court Terme augmenté d'un intérêt de 8% par an calculé prorata temporis entre la date du Décaissement
Court Terme et la date de réalisation de la Sortie; et
(vii) dans l'hypothèse où l'Investisseur Financier aurait réalisé, après la date d'émission des ADP AIL IX, un Décaisse-
ment suivi d'un Encaissement (d'une nature visée au (i) de la définition d'«Encaissement» ci-dessus) moins de 12 mois
après la date de ce Décaissement, alors (a) le Décaissement concerné sera réduit d'un montant (le Montant de la Ré-
duction) égal à la quote-part de l'Encaissement concerné qui excède 5% de la totalité des Décaissements et (b) il sera
également déduit des Encaissements de l'Investisseur Financier un montant égal au Montant de la Réduction augmenté
d'un intérêt de 8% par an calculé prorata temporis entre la date du Décaissement concerné et la date de l'Encaissement
concerné.
Multiple ADP signifie, à la date d'un Cas de Déclenchement ADP AIL IX, la totalité des Encaissements liés aux ADP
AIL IX rapportée à la totalité des Décaissements liés aux ADP AIL IX;
Pacte désigne le contrat conclu entre les détenteurs des Actions A et les détenteurs des Actions B pour gouverner
leurs rapports.
Perte de Contrôle Indirecte désigne tout événement à raison duquel AIL IX cesserait de détenir au moins 50,1% du
capital ou des droits de vote d'AIL X;
Prix d'Introduction signifie le prix fixé pour l'émission d'actions nouvelles auprès du public ou la cession de tout ou
partie de ses actions existantes dans le cadre d'une Introduction en Bourse;
Société de Groupe signifie AIL IX, AIL X, FPS Towers ou tout autre société contrôlée, directement ou indirectement
par FPS Towers et Sociétés de Groupe désigne l'ensemble de ces sociétés; et
Sortie désigne indifféremment un Changement de Contrôle, une Introduction en Bourse ou une Liquidation.»
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Actionnaire Unique de la Société décide d'adjoindre un nouvel article
26 aux Statuts, et de lui donner la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 26. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915.»
<i>Neuvième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de convertir les actions existantes de la Société en actions de classe A. Le capital de la
société sera donc composé comme suit:
113.603 actions sont converties en 113.603 actions de classe A.
Actuellement, toutes les actions de toutes les classes sont détenues par l'Actionnaire Unique.
<i>Dixième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide:
(i) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2.490 (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix euros)
afin de le porter de son montant précédent de EUR 1.136.030 (un million cent trente-six mille trente euros), représenté
par 113.603 (cent treize mille six cent trois) actions de classe A, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune,
à un montant de EUR 1.138.520 (un million cent trente-huit mille cinq cent vingt euros), représenté par 113.852 (cent
treize mille huit cent cinquante-deux) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, divisée
en 2 (deux) classes; et
(ii) d'émettre 249 (deux cent quarante-neuf) nouvelles actions de classe B, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix
euros) chacune (les Nouvelles Actions B).
L'Actionnaire Unique décide que les Nouvelles Actions B seront offertes à la souscription lors de cette Assemblée à
(i) Monsieur Frédéric Zimer, né le 8 septembre 1957 à Neuilly-sur-Seine (France), résidant en France au 8 bis, Impasse
Césaire, 92240 Malakoff, (ii) Monsieur Didier Quillot, né le 18 mai 1959 à Mas Grenier (France), résidant en France au
15, rue Ernest Cognacq, 92300 Levallois-Perret, (iii) Monsieur Cédric Lépolard, né le 24 mars 1979 à Château Thierry
(France), résidant en France au 62, rue Marjolin, 92300 Levallois Perret, (iv) Monsieur Bruno Quennesson, né le 9 mars
1962 à Puteaux (France), résidant en France au 18 bis, rue du Bois, 92000 Nanterre, (v) Monsieur Pierre Cassier, né le
27 octobre 1972 à Paris (France), résidant en France au 95, avenue de Paris, 92320 Châtillon et (vi) DQ Conseil, une
société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège au 5, avenue de Messine, 75008 Paris (France), enregistrée
sous le numéro 537 673 972 R.C.S. Paris), de la manière suivante, sous réserve de la renonciation par l'Actionnaire Unique
de la Société à son droit préférentiel de souscription dans la mesure requise:
Monsieur Frédéric Zimer, 140 (cent quarante) Nouvelles Actions B;
Monsieur Didier Quillot, 30 (trente) Nouvelles Actions B;
Monsieur Cédric Lépolard, 15 (quinze) Nouvelles Actions B;
Monsieur Bruno Quennesson, 24 (vingt-quatre) Nouvelles Actions
157234
L
U X E M B O U R G
Monsieur Pierre Cassier, 10 (dix) Nouvelles Actions B; et
DQ Conseil, 30 (trente) Nouvelles Actions B.
L'Actionnaire Unique décide en outre que les Nouvelles Actions B seront souscrites et intégralement libérées en
numéraire pour un prix de souscription par Nouvelle Action B de EUR 5.000 (cinq mille euros) et que l'émission des
Nouvelles Actions B sera effective immédiatement avant la modification des Statuts reflétant l'émission des Nouvelles
Actions B.
<i>Onzième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription en faveur de Monsieur Frédéric
Zimer, Monsieur Didier Quillot, Monsieur Cédric Lépolard, Monsieur Bruno Quennesson, Monsieur Pierre Cassier et
DQ Conseil dans la mesure requise aux fins de l'émission des Nouvelles Actions B, tel que décrite dans la dixième
résolution.
<i>Douzième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'accepter et d'enregistrer les interventions suivantes concernant la souscription aux
Nouvelles Actions B et la libération intégrale du prix de souscription des Nouvelles Actions B, de la manière suivante:
<i>Interventions - Souscription - Paiementi>
1) Monsieur Frédéric Zimer déclare souscrire en numéraire à 140 (cent quarante) Nouvelles Actions B, ayant une
valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement
en numéraire d'un montant total de EUR 700.000 (sept cent mille euros);
2) Monsieur Didier Quillot déclare souscrire en numéraire à 30 (trente) Nouvelles Actions B, ayant une valeur nominale
de EUR 10 (dix euros) chacune, et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement en numéraire
d'un montant total de EUR 150.000 (cent cinquante mille euros);
3) Monsieur Cédric Lépolard déclare souscrire en numéraire à 15 (quinze) Nouvelles Actions B, ayant une valeur
nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement en
numéraire d'un montant total de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros);
4) Monsieur Bruno Quennesson déclare souscrire en numéraire à 24 (vingt-quatre) Nouvelles Actions B, ayant une
valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement
en numéraire d'un montant total de EUR 120.000 (cent vingt mille euros);
5) Monsieur Pierre Cassier déclare souscrire en numéraire à 10 (dix) Nouvelles Actions B, ayant une valeur nominale
de EUR 10 (dix euros) chacune, et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement en numéraire
d'un montant total de EUR 50.000 (cinquante mille euros); et
6) DQ Coneil déclare souscrire en numéraire à 30 (trente) Nouvelles Actions B, ayant une valeur nominale de EUR
10 (dix euros) chacune, et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement en numéraire d'un
montant total de EUR 150.000 (cent cinquante mille euros).
L'Assemblée constate que les paiements en numéraire relatifs à l'émission des Nouvelles Actions B pour un montant
total de EUR 1.245.000 (un million deux cent quarante-cinq mille euros) sont alloués comme suit:
(i) un montant de EUR 2.490 (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) est affecté au compte de capital social
de la Société; et
(ii) un montant de EUR 1.242.510 (un million deux cent quarante-deux mille cinq cent dix euros) est affecté au compte
de prime d'émission.
Le montant total de EUR 1.245.000 (un million deux cent quarante-cinq mille euros) est à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été attesté auprès du notaire instrumentant par le certificat de blocage émis par BGL BNP Paribas,
le 31 octobre 2013, confirmant la disponibilité du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société, et le
notaire le constate expressément.
<i>Treizième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat de Allen & Overy Luxembourg,
afin d'effectuer pour le compte de la Société l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre de
parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.
<i>Quatorzième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts, afin de lui donner
désormais la teneur suivante dans sa version française:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à EUR 1.138.520 (un million cent trente-huit mille cinq cent vingt euros)
représenté par 113.852 (cent treize mille huit cent cinquante-deux) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros)
chacune, lesquelles ont été intégralement libérées et sont divisées en différentes classes d'actions de la façon suivante:
157235
L
U X E M B O U R G
1. 113.603 actions de classe A (les Actions A); et
2. 249 actions de classe B (les Actions B).
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale
statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ
d'application de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915)
et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur
détenteur de souscrire à des actions ou de s'en voir attribuer, les actionnaires disposent de droits préférentiels de
souscription au prorata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions de
la Loi de 1915.
Le Conseil d'Administration est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions
au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les con-
ditions définies par le Conseil d'Administration et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds
propres sans émission de nouvelles actions doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi
luxembourgeoise.
De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles
actions, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les
conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise; de tels apports seront
enregistrés dans le compte de capital surplus mentionné au paragraphe ci-dessus.
La capital autorisé de la Société est fixé à un montant de EUR 200.000.000 (deux-cent millions d'euros) représenté
par un maximum de 20.000.000 (vingt millions) d'actions, ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.
Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu'au montant de capital autorisé, en
une ou plusieurs fois, au cours d'une période débutant le 26 octobre 2012 et se terminant au cinquième anniversaire de
cette date (la Période) au moyen de (i) l'émission d'actions en raison d'apports en numéraire, (ii) l'émission d'actions en
raison d'apports en nature, et (iii) l'incorporation des bénéfices et réserves distribuables, y inclus la prime d'émission et
le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions.
Le Conseil d'Administration est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d'actions
conformément au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet Article 5, et notamment de déterminer le lieu et la date
de l'émission ou des émissions successives d'actions, le prix d'émission, l'existence ou non d'une prime d'émission, ainsi
que les modalités de paiement des actions en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non-exhaustive
un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions.
Le Conseil d'Administration est autorisé (i) durant la Période, (a) à émettre des obligations convertibles ou tous autres
instruments de dettes convertible, des obligations assorties d'un droit de souscription et autres instruments permettant
à leur détenteur de souscrire à des actions ou de se voir attribuer des actions, y compris des obligations convertibles (les
Instruments), et (b) à émettre des actions sous la condition de l'exercice des droits attachés aux Instruments et dont
l'émission est effective à compter de cet exercice jusqu'à ce que, en ce qui concerne chacun des points (a) et (b), le
montant du capital social augmenté atteint en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments soit égal au
capital autorisé, et (ii) à émettre des actions en raison de l'exercice des droits attachés aux Instruments jusqu'à ce que
le montant du capital social augmenté atteint en conséquence d'une telle émission d'actions soit égal au capital autorisé,
à tout moment, que ce soit pendant la Période ou en dehors de la Période, à la condition que les Instruments soient émis
pendant la Période. Les actions devant être émises en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments
peuvent être payées par un apport en numéraire, un apport en nature, ou au moyen de l'incorporation de bénéfice et de
réserves distribuables, en ce compris la prime d'émission et le capital surplus.
Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions applicables aux Instruments, y compris le prix, le
taux d'intérêt, le prix d'exercice, le taux de conversion ou le taux de change, ainsi que les modalités de remboursement,
et il est autorisé à émettre lesdits Instruments.
Le Conseil d'Administration est autorisé (i) à supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des action-
naires prévus par la Loi de 1915, tels que reflétés dans cet Article 5, portant sur l'émission de nouvelles actions et
d'Instruments et (ii) à supprimer ou limiter les droits des actionnaires à être traités de manière égalitaire pour ce qui
concerne l'attribution des actions devant être émises par voie d'incorporation de bénéfices et de réserves distribuables,
y compris la prime d'émission et le capital surplus, en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non
exhaustive un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions et conformément à l'exercice des
droits attachés aux Instruments, dans les limites fixées par la loi luxembourgeoise.
L'Article 5 des présents Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de
l'autorisation accordée au Conseil d'Administration conformément à l'Article 5, et le Conseil d'Administration prendra
lui-même ou autorisera toute personne à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire
l'augmentation de capital social et les modifications consécutives des Statuts.»
157236
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare que, conformément à l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (la Loi sur les sociétés), les conditions prescrites aux articles 26, 26-3 et 26-5 (les dispositions
du paragraphe (2) de l'article 26-1 n'étant pas applicables, aucun apport autres qu'en numéraire n'ayant été effectué au
cours de l'Assemblée) de la Loi sur les Sociétés ont été satisfaites, ce qu'il constate expressément.
Aucun autre point ne figurant à l'Ordre du Jour, l'Assemblée décide de clore la réunion.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.900 (deux mille neuf cents euros).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties, et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite à l'Assemblée et aux parties comparantes, lesdites parties comparantes ont signé ensemble avec
le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant le signer.
Signé: F. Kerger et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50522. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Référence de publication: 2013159043/906.
(130194969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Burger King (Luxembourg) 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 181.592.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of October.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS, a limited partnership established under the law of Luxembourg,
having its registered office at 9A, rue Robert Stümper, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174.834,
here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is “Burger King (Luxembourg) 2 S.à r.l.” (the “Com-
pany”). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the
“Law”), and these articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
157237
L
U X E M B O U R G
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the
Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets.
3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their
efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several members.
II. Capital - Corporate units
Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand
five hundred (12,500) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.
5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
5.3. In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. Any share premium paid on the subscription of given shares shall always
remain attached to the shares on which it has been paid and shall be reimbursed exclusively to the owners of such shares.
The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may
repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the
form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case
of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.
6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject
to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.
The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing
at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.
A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance
by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
157238
L
U X E M B O U R G
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves
for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the
term of their office. The managers need not be members.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.
Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the
“Board”). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the “Category A Ma-
nagers”) and category B managers (the “Category B Managers”).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who
need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting
of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the
member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken
by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A
Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as
Category A Managers and Category B Managers.
(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are
signed by all the managers present.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The
meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes
will be signed later by the manager participating to the Board by such means.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers Circular Resolutions”), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint
signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has
(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of
any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of
these Articles.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
157239
L
U X E M B O U R G
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Member(s)
Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the “General Meeting”) or by way of
circular resolutions (the “Members Circular Resolutions”) in case the number of members of the Company is less or
equal to twenty-five.
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed,
Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear
the date of the last signature.
(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members
representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the
date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members
owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters
(3/4) of the corporate capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company
require the unanimous consent of the members.
Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is
to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1
st
) of January of each year and ends on the thirty-first (31
st
) of December
of the same year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.
13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members
Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be
held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
157240
L
U X E M B O U R G
is not a day on which banks are opened for general business in the City of Luxembourg (i.e. a “Business Day”), on the
next following Business Day at the same time and place.
Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall
be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.
14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-
prises), when so required by law.
14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur
d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be
reappointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.
15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are
available for distribution; and
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the
members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities
of the Company.
16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in
proportion to the corporate units held by each of them.
VII. General provisions
Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members
Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communica-
tion.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolu-
tions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to
any non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS, pre-named, declares to subscribe for all the twelve thousand
five hundred (12,500) corporate units and to fully pay them up at nominal value together with a share premium of twenty
five thousand Euro (EUR 25,000.-).
To fully pay up the subscription price of the above corporate units and of the share premium by a contribution in kind
(the “Contribution”) for a total amount of thirty seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-).
157241
L
U X E M B O U R G
<i>Description of the contributioni>
The Contribution is legally owned by Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS, pre-named. The con-
tribution to the Company is composed of a financial asset of thirty seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-).
<i>Evaluationi>
The aggregate value of the Contribution is thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-). Such evaluation
has been approved by Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS pursuant to a statement of contribution
value dated October 16, 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of
registration.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the Contribution has been given.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Mr. Jose Cil, born in Florida, United States of America, on July 6, 1969, residing in 10, Zählerweg, CH-6300 Zug,
Switzerland, as category A manager of the Company,
b. Mr. Paulo Arcoverde Barbosa, born in Rio de Janeiro, Brazil, on December 19, 1975, residing in 10, Zählerweg,
CH-6300 Zug, Switzerland, as category A manager of the Company,
c. Mr. Erik Adam, born in Coventry, United Kingdom, on May 28, 1975, residing professionally at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as category B manager of the Company,
d. Mr. René Beltjens, born in Etterbeek, Belgium, on September 17, 1961, residing professionally at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as category B manager of the Company.
2. The registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le seizième jour d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS, une Société en Commandite Simple constituée sous les lois
de Luxembourg, ayant son siège social à 9A, rue Robert Stümper, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.834,
ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société à responsabilité limitée est «Burger King (Luxembourg) 2 S.à r.l.» (la
«Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en
157242
L
U X E M B O U R G
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents
statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intel-
lectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait
partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés
au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.
3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion
efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change,
de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui
lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euro (12.500,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.
5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
5.3 En plus du capital émis il peut être établi un compte prime d'émission auquel toute prime payée sur toute action
en plus de sa valeur nominale est transférée. Toute prime payée lors de la souscription des dites actions doit restée
attachée aux actions avec lesquelles elle a été payée et doit être remboursée exclusivement aux détenteurs de telles
actions. Le compte prime d'émission peut être utilisé pour le paiement d'actions que la Société peut racheter de ses
actionnaires, pour compenser des pertes, faire des distributions aux actionnaires sous forme de dividende ou allouer des
fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas
d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
157243
L
U X E M B O U R G
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les
associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad
hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).
8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au
Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que
Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un
Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.
(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal
est signé par tous les gérants présents.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au
jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables
et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures
conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
157244
L
U X E M B O U R G
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») ou par
voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal
ou moindre que vingt-cinq (25).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par
écrit. Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles
avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts (3/4) du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à
l'Assemblée Générale.
12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même
année.
157245
L
U X E M B O U R G
13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit
se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.
Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont
contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.
14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus
par la loi.
14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseurs d'entreprise et déterminer leur nom-
bre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux
comptes / réviseur d'entreprise pourront être réélus.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des
associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Réso-
lutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2013.
157246
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS, prénommée, souscrit toutes les douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales intégralement avec une prime d'émission globale d'un montant de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-) par
un apport en nature.
Libérer intégralement le prix de souscription des parts sociales ci-dessus par un apport en nature (la «Contribution»)
d'une valeur totale de trente-sept mille cinq cents Euro (37.500,- EUR).
<i>Description de la contributioni>
La Contribution est légalement la propriété de Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS. La Contribution
à la Société est constituée d'un actif financier de trente-sept mille cinq cents Euro (EUR 37.500,-). Cette évaluation a été
approuvée par Burger King Interamerica LLC EuroAsian Holdings SCS conformément à la déclaration de la valeur de
l'apport datée du 16 octobre 2013, qui sera annexée à cet acte et qui sera soumise aux formalités d'enregistrement.
<i>Preuve d'existence de la contributioni>
Preuve de la Contribution a été donnée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a. M. Jose Cil, né à Florida, Etats-Unis d'Amerique, le 6 juillet 1969, demeurant à 10, Zählerweg, CH-6300 Zug, Swi-
tzerland, comme gérant de catégorie A de la Société,
b. M. Paulo Arcoverde Barbosa, né à Rio de Janeiro, Brésil, le 19 décembre 1975, demeurant à 10, Zählerweg, CH-6300
Zug, Switzerland, comme gérant de catégorie A de la Société,
c. M. Erik Adam, né à Coventry, Royaume-Uni, le 28 mai 1975, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société,
d. M. René Beltjens, né à Etterbeek, Belgique, le 17 septembre 1961, ayant son adresse professionnelle au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société.
2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
FAIT ET PASSÉ à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé, avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 23 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13778. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013159111/562.
(130195463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Catalyst Alpha 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.647.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 novembre 2013i>
- La démission de Monsieur Michel van Krimpen de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé
unique avec effet rétroactif au 9 septembre 2013.
157247
L
U X E M B O U R G
- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 9 septembre 2013
* Monsieur Onno Bouwmeister, né le 26 janvier 1977 à Maarssen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
- La démission de Monsieur Peter Kasch de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec
effet rétroactif au 28 août 2013.
- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 28 août 2013
* Monsieur Jonathan Petit, né le 24 avril 1955 à Worcester Park, United Kingdom, avec adresse professionnelle au 33
Cavendish Square, W1G 0PW London, United Kingdom;
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013167191/23.
(130204572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
FRII S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 146.620.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 18 octobre 2013 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2015:
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a nommé
comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Madame Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxem-
bourg:
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2013168226/18.
(130205032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Prophac Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Howald, 5, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 122.112.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2013 a:
- reconduit Monsieur Philippe Zirnheld, gérant, né à Luxembourg le 7 décembre 1967, demeurant à L-6943 Niede-
ranven, 23 rue du Bois, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2019;
- reconduit Monsieur Olivier Zirnheld, ingénieur civil, né à Luxembourg le 22 juin 1974, demeurant à L-7430 Fischbach,
8 am Batz, en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019;
- reconduit Madame Armelle Pinot épouse Zirnheld, née le 5 mars 1972 à LE MANS (France), demeurant à L-6943
Niederanven, 23 rue du Bois, en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2019;
- reconduit Madame Danielle Zirnheld, employée privé, née à Luxembourg le 30 avril 1964, demeurant à L-4965
Clemency, 21 rue de Sélange, en qualité de commissaire de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013167716/22.
(130203493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
157248
Antin Infrastructure Luxembourg IX
Burger King (Luxembourg) 2 S.à r.l.
Catalyst Alpha 3 S.à r.l.
Finprotec S.A.
FRII S.A.
Golfing S.A.
Golfing S.A.
Golfing S.A.
Golfing S.A.
Grandia International Investments S.A.
Gruppo Mobili e Salotti S.A.
GS Construction S.A.
HET BESTE BROOD HOLDING S.A. société de gestion de patrimoine familial
HET BESTE BROOD HOLDING S.A. société de gestion de patrimoine familial
Hills Place S.à r.l.
IBTD International S.A.
ICTUniverse S.à r.l.
IHC Immobilien A.G.
Immobilière 2F S.A.
Immobilière C.JANS & Associés S.A.
Immobilière du GRÄFGEN
Immogar S.A.
Imohtech S.A.
Indunet S.àr.l.
Instal-Fit S.à r.l.
I-Space S.à r.l.
IT Advanced Consulting Holding S.A.
J.L. Development S.A.
J.L. Freeze Sàrl
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 6 S.à r.l.
Kingfisher International Holdings Limited - Luxembourg Branch
Madrax Properties Sàrl
Mama Forte S.à r.l.
MCM Import-Export Sàrl
MEGG Invest S.àr.l.
Misys Manco S.C.A.
Misys Manco S.C.A.
Moor Park Fortuny Luxembourg S. à r.l.
Net's Bar S.à r.l.
OUTOX International S.A.
Prophac Immobilière S.A.
Rubysam S.à r.l.
Skye Investment S.à r.l.
St. Georges Investment S.A. - SPF
Storebrand Luxembourg S.A.
TIAA Lux 11 S.à r.l.
TIAA Lux 5 S.à r.l.
Tinsel Group S.A.
Toba S.A.
Tommy Sports S.àr.l.
Tortoise US Energy Infrastructure S.A.
Transports Carlier S.A.
Tubosider International S.A.
Velosi S.à r.l.
Virlux
Wahaca International S.à r.l.