This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3154
12 décembre 2013
SOMMAIRE
Akeance Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151375
Alpine Administrative Services S.à r.l. . . .
151362
Amboyna Cay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151347
BBV-Dachfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151370
BBV-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151370
BTMU Unit Management S.A. . . . . . . . . . . .
151369
Build Group Co. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151348
CIGL - Differdange a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . .
151374
Cominsider S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151346
Cortem International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
151392
Empark Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151352
Finadis S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151347
Hauck & Aufhäuser Investment Gesell-
schaft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151351
Hauck & Aufhäuser Investment Gesell-
schaft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151351
International Financing Partners S.A. - SPF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151346
Island Fund S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151365
Kneerise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151377
La Commedia Dell'Arte Sàrl . . . . . . . . . . . .
151383
Land and Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
151383
La Parunia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151383
L'Arche S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151391
La-ser Alpha Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
151362
Latimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151383
LC Sales Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
151383
Leger S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151382
Ligiol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151385
Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l. . . . . .
151386
LIST Société Anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . .
151384
Lou Paradou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151384
Lou Paradou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151384
LTH (Logistik, Transport, Handel) S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151385
Luxambulance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151385
Macor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151385
Mareuil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151385
Marienfeld Leasing (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . .
151390
Martin Currie Global Funds . . . . . . . . . . . . .
151348
Medea Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
151390
Medea Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
151349
Medina Financial Markets S.à r.l. . . . . . . . .
151384
Microfinance Enhancement Facility SA, SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151386
Microfinance Enhancement Facility SA, SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151390
Myway Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151346
Ocean Race S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151349
Pfizer Holdings International Luxembourg
(PHIL) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151370
Private Investment Fund Management S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151365
Ruta Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151363
Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l. . . .
151375
Sapient Operations Luxembourg S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151375
Sico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151376
SI.TO. Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151363
Société Anonyme de Participations et de
Placements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151380
Sodiphar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151380
Software Development & Support S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151379
SOF-VII Asian Hotel Holdings, S.à r.l. . . . .
151379
SOL S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151391
Studio 206 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151347
Thumbria Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
151376
Tontarelli Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151376
Touchstone Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
151348
Twelve Magnolia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151379
VB Hamm Spezialfonds Nr. 3 . . . . . . . . . . .
151369
151345
L
U X E M B O U R G
Myway Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.046.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>30 décembre 2013i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2013172001/1023/16.
International Financing Partners S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fami-
lial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 48.973.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A.-SPF sont priés
d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>27 décembre 2013i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013172245/750/19.
Cominsider S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 61.138.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le <i>02 janvier 2014i> à 10h00 au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décharge au Conseil d'Administration pour la convocation de l'assemblée générale annuelle à une autre date que
la date statutaire;
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012;
3. Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre
2012, affectation des résultats;
4. Délibération quant aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013171208/1017/19.
151346
L
U X E M B O U R G
Finadis S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 30.186.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une
ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu le lundi <i>30 décembre 2013i> à 16.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013171953/504/16.
Amboyna Cay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.842.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 décembre 2013i> à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013172318/795/15.
Studio 206 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 114.842.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>8 janvier 2014i> à 14.30 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et liquidation volontaire de la société;
2. Nomination du liquidateur de la société;
3. Détermination des pouvoirs à conférer au liquidateur et de la procédure de liquidation;
4. Décision de charger le liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la société,
et de payer toutes les dettes de la société;
5. Pouvoir de signature; et
6. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2013171207/20.
151347
L
U X E M B O U R G
Touchstone Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 46.174.
The shareholders of the Company are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, on <i> December 20 i>
<i>thi>
<i> , 2013 i> at
10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the Balance Sheet as of (i) December 31
st
, 2008, (ii) December 31
st
, 2009 and (iii) December 31
st
, 2010 and the related statements of profit and loss for the periods then ended;
3. Special vote on the discharge to the directors and the statutory auditor;
4. Decision concerning the eventual dissolution of the Company in accordance with article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies;
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2013165842/317/19.
Build Group Co. S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 122.985.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>23 décembre 2013i> à 11.45 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
Référence de publication: 2013167976/755/16.
Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 65.796.
Shareholders are hereby invited to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of Martin Currie Global Funds (the "Meeting") , which will be held on <i>December 23, 2013i> at 11.00
a.m. at the offices of State Street Bank Luxembourg S.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Semi-annual report including the report of the Managers as at September 30, 2013.
2. Discharge to be granted to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties until
the semi- financial year ended September 30, 2013.
3. Acknowledgement of the resignation of Mr. Zvi Hoffman as director of the Company and appointment of Mr. Henry
Cannell Kelly as director of the Company until the next annual general meeting to be held in 2014 in replacement
of Mr. Zvi Hoffman.
4. Acknowledgement of the resignation of Mr. Jan Ankarcrona as director of the Company and appointment of Mr.
Toby Hogbin as director of the Company until the next annual general meeting to be held in 2014 in replacement
of Mr. Jan Ankarcrona.
151348
L
U X E M B O U R G
5. Acknowledgement of the resignation of Mr. Michael Hoare as director of the Company and appointment of Mr.
Darren Cannon as director of the Company until the next annual general meeting to be held in 2014 in replacement
of Mr. Michael Hoare.
6. Acknowledgement of the resignation of Mr. Aly El Tahry as director of the Company and appointment of Ms. Sheena
Mary Kelman as director of the Company until the next annual general meeting to be held in 2014 in replacement
of Mr. Aly El Tahry.
7. Appointment of Mr. Paul Hughes as director of the Company until the next annual general meeting.
8. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any Meeting by proxy.
A proxy form may be obtained at the Company's registered office and has to be returned by fax no later than 48 hours
before the meeting to the attention of Ms. Louise Chiappalone at number (+352) 464 010 413 and by mail to the registered
office.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2013166408/755/36.
Ocean Race S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial (en liquidation).
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 147.514.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>23 décembre 2013i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
Référence de publication: 2013167980/755/16.
Medea Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 169.778.
In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of the month of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 6NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company), governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B 166.230
(the “Sole Shareholder”),
represented by Sophie Liberatore, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 30 Oc-
tober 2013 which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and
the undersigned notary,
being the Sole Shareholder of Medea Holding II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company),
having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Registre de Commerce et des
Sociétés (Trade and Companies Register) of Luxembourg under number B 169.778 (the “Company”), incorporated on
26 June 2012 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the “Mémorial”) on 27 July 2012, number 1869.
151349
L
U X E M B O U R G
The articles of association of the Company have been amended on 30 October 2013 by deed of the undersigned notary
not yet published in the Mémorial.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital is
represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
A. Decision to close the current financial period of the Company on 31 December 2013.
B. Amendment of the Article 20 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
“The accounting year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same year.”
Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved that the accounting year shall begin on 1 January of each year and ends on 31 December
of the same year.
The current financial period of the Company which has begun on 31 October 2013 shall close on 31 December 2013.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend Article 20 of the articles of incorporation of the Company so that it reads
as follows:
“The accounting year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of the same year.”
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and German version, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden englischen Textes:
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am einunddreißigsten Tage des Monats Oktober.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
BRE/Europe 6NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) unter luxem-
burgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg,
mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingetragen im Registre de Commerce
et des Sociétés (Gesellschafts- und Handelsregister) zu Luxemburg, unter der Nummer B 166.230 (der „Alleinige Ge-
sellschafter“),
Hier vertreten durch Frau Sophie Liberatore, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
ausgestellt am 30. Oktober 2013, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den
Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde.
Der Alleinige Gesellschafter der Medea Holding II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung), mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,
mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) im Registre de Commerce et des
Sociétés (Gesellschafts- und Handelsregister) zu Luxemburg unter Nummer B 169.778 eingetragen, (die „Gesellschaft“),
gegründet am 26. Juni 2012 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, vorbenannt, am 27. Juli 2012
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 1869, veröffentlicht.
Die Satzung der Gesellschaft wurde am 30. Oktober 2013 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx,
vorbenannt, abgeändert, welcher noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.
Der Erschienene gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft besitzt alle fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile welche von der
Gesellschaft ausgegeben wurden, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der
Tagesordnung entschieden werden konnte.
2. Der Punkt für welche einen Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
A. Beschluss, dass die laufende Geschäftsperiode der Gesellschaft am 31. December 2013 endet.
B. Abänderung von Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft so dass Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft folgenden
Wortlaut hat:
„Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
desselben Jahres.“
151350
L
U X E M B O U R G
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, dass das Geschäftsjahr am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember des-
selben Jahres enden wird.
Das laufende Geschäftsjahr welches am 31. Oktober 2013 begonnen hat endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass Artikel 20
der Satzung wie folgt lautet:
„Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
desselben Jahres.“
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S. LIBERATORE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 octobre 2013. Relation: LAC/2013/49762. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 19. November 2013.
Référence de publication: 2013160887/99.
(130197074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2013.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 31.093.
Für den Fonds gilt das Allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 28. Oktober 2013 in Kraft trat. Das Verwal-
tungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Oktober 2013.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2013157307/13.
(130192517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 31.093.
Für den Fonds gilt das Sonderreglement, welches am 28. Oktober 2013 in Kraft trat. Das Sonderreglement wurde
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Oktober 2013.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2013157308/13.
(130192518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.
151351
L
U X E M B O U R G
Empark Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 182.119.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of November,
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., a public limited liability company incorporated under the laws of Spain, having
its registered office at Plaza Manuel Gómez Moreno no. 2, 28020 Madrid, Spain, registered with the Companies' Registry
of Madrid, Volume 14090, Folio 86,
here represented by Flora Gibert, notary's employee, whose professional address is in Luxembourg by virtue of a
power of attorney given in Madrid, Spain, on November 27, 2013.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Empark Funding S.A." (the Company). The Company is a public limited
liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred
to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the
General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It
may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
151352
L
U X E M B O U R G
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty-one thousand (31,000)
registered shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives), and are freely transferable.
6.3. A register of shares shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any shareholder
on request.
6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed
and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Company,
following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil
Code.
6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members with at least one
(1) class A director and one (1) class B director. The directors need not be shareholders.
(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of
their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re- appoint-
ment at the expiry of their term of office.
(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The
permanent representative shall be a natural person and is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he
had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.
(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint
another permanent representative.
(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on
a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.
7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents (who need not be directors or share-
holders) for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this
respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.
7.3. Procedure
(i) The Board shall appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a
director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.
(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any director, at the place indicated in the notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
151353
L
U X E M B O U R G
(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members is present or represented and at least
one (1) class A director and at least one (1) class B director are present or represented. Board resolutions shall be validly
taken by a majority of the votes of the directors present or represented provided that any resolution shall not validly be
passed unless it is approved by at least one (1) class A director and at least one (1) class B director. Board resolutions
shall be recorded in minutes signed by the chairperson and by all the directors present or represented at the meeting.
(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held
Board meeting, and shall bear the date of the last signature thereto.
(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which
conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the
minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A
special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any
vote on any other resolution.
7.4. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A director and
any class B director.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom
special signatory powers have been delegated by the Board.
Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an
additional shareholder; and
(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a
reference to that sole director, as appropriate.
8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded
in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.
Art. 9. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and
the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a General Meeting. The General Meeting has full powers to
adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.
(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders
must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10)
of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
151354
L
U X E M B O U R G
(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.
(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must
contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form
must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return
the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be
taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor
an abstention shall be considered void.
(viii) Subject to section (ix) and section (x) below, resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by
a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.
(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented
and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to
the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of
notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results
of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of
capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.
(x) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).
Art. 11. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole
shareholder, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by the officers, directors and statutory auditors to the Company.
12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on,
and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditors shall then prepare a report setting out
their proposals.
12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of
the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not
a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 13. Auditors.
13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés).
13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) and (if applicable) the external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term
of office of the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
14.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
151355
L
U X E M B O U R G
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as ap-
plicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets
and pay its liabilities.
15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provision
16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by
fax, email or any other means of electronic communication.
16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall
constitute one and the same document.
16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law and other
applicable laws and, subject to any non-waivable provisions of the Law, any other applicable law and/or with any agreement
entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and end on the thirty-first (31) of December
two thousand and fourteen (2014).
<i>Subscription and Paymenti>
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., represented as stated above, subscribes for thirty-one thousand (31,000)
shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-).
The amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is at the Company's disposal and evidence of such amount
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed share capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as A directors of the Company for a period of six (6) years:
- Pedro Maria Povoas Mendes Leal, economist, born on January 28, 1958 in Madrid, Spain, having its professional
address at Rua Joaquim Antonio de Aguiar, 19-1°, Lisboa (1070-149), Portugal; and
- Gonzalo Gómez Navarro, business administration, born on September 4, 1969 in Madrid, Spain, having its professional
address at Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Madrid (28020), Spain.
2. The following are appointed as B directors of the Company for a period of six (6) years:
- Harald Thul, director, born on March 13, 1972 in Bonn, Germany, having its professional address at 13-15 Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Vladimir Mornard, senior account manager, born on May 18, 1979 in Verviers, Belgium, having its professional address
at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg; and
- Hille-Paul Schut, director born on September 29, 1977 in 's-Gravenhage, the Netherlands, having its professional
address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
151356
L
U X E M B O U R G
3. Ernst & Young S.A. is appointed as approved external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for a
period of three (3) years.
4. The registered office of the Company is located at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour de novembre,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., une société anonyme de droit Espagnol, ayant son siège social à Plaza Manuel
Gómez Moreno no. 2, 28020 Madrid, Espagne, enregistrée auprès du registre des sociétés de Madrid sous le volume
14090, Folio 86, représentée par Flora Gibert, clerc de notaire avec adresse professionnelle à Luxembourg en vertu d'une
procuration donnée à Madrid (Espagne), le 27 novembre 2013.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon sui-
vante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Empark Funding S.A.» (la Société). La Société est une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré dans cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des action-
naires (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
des personnes situées à l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation com-
plète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le
transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
des titres de dettes assortis avec des sûretés (debenture), certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus
généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'obligations et de
titres de dettes ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à
ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
151357
L
U X E M B O U R G
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II. Capital - Actions
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31.000)
actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée
Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.2. Les actions sont et resteront sous forme nominative et sont librement transférables.
6.3. Un registre des actions est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque
actionnaire.
6.4. Une cession d'action s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valablement
datée et signée:
(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou
(ii) par un quelconque mandataire de la Société, suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.5. Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut
également être accepté par la Société comme preuve d'un transfert d'action.
6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par le Conseil composé d'au moins trois (3) membres dont au moins un (1) administrateur de
classe A et au moins un (1) administrateur de classe B. Les administrateurs ne doivent pas nécessairement être action-
naires.
(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de
leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur
mandat.
(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent doit être une per-
sonne physique et est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions
en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente.
(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer
immédiatement un autre représentant permanent.
(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-
rement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.
7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux actionnaires sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents (qui ne doivent pas
nécessairement être administrateurs ou actionnaires) pour des tâches spécifiques.
(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.
151358
L
U X E M B O U R G
7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président, et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,
et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.
(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'un administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation,
qui en principe, est au Luxembourg.
(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans l'avis de convocation.
(iv) Aucun avis de convocation n'est requis si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun
d'eux déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également
renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées
ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement
adopté par le Conseil.
(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion
du Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés
pourvu qu'au moins un (1) administrateur de classe A et un (1) administrateur de classe B soient présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés
pourvu qu'au moins un (1) administrateur de classe A et un (1) administrateur de classe B votent en faveur de la décision.
Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs
présents ou représentés à la réunion.
(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout
autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si
elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.
(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des
opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.
7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes d'un administrateur
de classe A et d'un administrateur de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à
qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction
d'un actionnaire supplémentaire; et
(ii) toute référence dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à quelques administrateurs ou à un quelconque
administrateur doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.
8.2. Les transactions conclues par la Société doivent être mentionnées dans des procès-verbaux si elles sont interve-
nues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues
dans des conditions normales.
Art. 9. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune ob-
ligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces
engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Actionnaire(s)
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors d'Assemblées Générales. L'Assemblée Générale a les pouvoirs
les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
151359
L
U X E M B O U R G
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire
(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant plus de un dixième (1/10e) du
capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires au moins huit (8) jours
avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent
être précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas nécessairement être
un actionnaire) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.
(vi) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.
(vii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires
de vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque
résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou
de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le
calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée
Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions
proposées) ni une abstention, sont nuls.
(viii) Sous réserve du paragraphe (ix) et du paragraphe (x) ci-dessous, les décisions de l'Assemblée Générale sont
adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.
(ix) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.
(x) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans
la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).
Art. 11. Actionnaire unique. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant,
comme une référence à cet actionnaire unique; et
(iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès- verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.
12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de
la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.
12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce
jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le
requiert.
151360
L
U X E M B O U R G
13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires et (le cas échéant) les réviseurs d'entreprises agréés et détermine
leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six
(6) ans mais peut être renouvelé.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice
au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales appli-
cables.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et
(iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui
doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a un, est distribué
aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circu-
laires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être appo-
sées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et aux autres lois
applicables et, sous réserve des dispositions légale d'ordre public de la Loi et de toute autre loi applicable et/ou à tout
accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le trente et un (31) décembre deux mille
quatorze (2014).
<i>Souscription et Libérationi>
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente et un mille
(31.000) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Le montant de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).
151361
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions de l’actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, a adopté les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs A de la Société pour une durée de six (6) ans:
- Pedro Maria Povoas Mendes Leal, économiste, né le 28 janvier 1958 à Madrid, Espagne, ayant son adresse profes-
sionnelle à Rua Joaquim Antonio de Aguiar, 19-1°, Lisboa (1070-149), Portugal; et
- Gonzalo Gómez Navarro, chargé d'administration d'affaires, né le 4 septembre 1969 à à Madrid, Espagne, ayant son
adresse professionnelle à Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Madrid (28020), Espagne.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs B de la Société pour une durée de six (6) ans:
- Harald Thul, administrateur, né le 13 mars 1972 à Bonn, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 13-15
Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- Vladimir Mornard, responsable de comptes senior, né le 18 mai 1979 à Verviers, Belgique, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et
- Hille-Paul Schut, administrateur, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle
au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
3. Ernst & Young S.A. est nommée en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée de trois
(3) années.
4. Le siège social de la Société est établi au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54174. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 3 décembre 2013.
Référence de publication: 2013168883/578.
(130206292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.
La-ser Alpha Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.663.
Alpine Administrative Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 106.488.
PROJET DE FUSION
Par décision de leur conseil de gérance respectif en date du 20 novembre 2013, LA-SER ALPHA GROUP S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, ayant son siège social 43 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 147.663, au capital social de
25.000.000,00 EUR (vingt-cinq millions euros) représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale
de 100,00 EUR (cent euros), chacune entièrement libérées,
(ci-après la «Société Absorbante»),
et
ALPINE ADMINISTRATIVE SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 17 rue Michel
Rodange L-2430 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 106.488 au capital social de 13.000,00 EUR (treize mille euros) représenté par 130 (cent trente) parts sociales
d'une valeur nominale de 100.- EUR (cent euros), chacune entièrement libérées.
(ci-après la «Société Absorbée»),
(la Société Absorbante et la Société Absorbée étant ensemble collectivement désignées les «Sociétés Fusionnantes»)
151362
L
U X E M B O U R G
ont décidé de procéder à leur fusion et ont convenu du projet de fusion qui va suivre (le «Projet de Fusion»), étant
préalablement souligné que:
- la Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée et la fusion est donc
soumise aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»);
- le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes a décidé que la Société Absorbée sera absorbée par la Société
Absorbante et, pour ce faire; la Société Absorbée fera apport de tout son actif et de tout son passif Actif et le Passif») à
la Société Absorbante.
1. A la date déterminée par le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes, en l'occurrence à la date d'expiration du
délai d'un mois à compter de la publication du Projet de Fusion dans le au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») (la "Date d'Effet"), et sous réserve de l'approbation de la Fusion par les assemblées générales extraor-
dinaires des actionnaires des Sociétés Fusionnantes, l'Actif et le Passif de la Société Absorbée seront transférés à la Société
Absorbante,
2. La fusion est basée sur les comptes annuels et les rapports annuels relatifs aux 3 derniers exercices sociaux ainsi
que les états financiers arrêtés à la date du 15 octobre 2013 pour chacune des Sociétés Fusionnantes.
3. A l'issue du processus de fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et ses actions seront annulées.
4. La fusion sera en outre soumise aux conditions suivantes:
a) La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs de la Société Absorbée dans leur état actuel à la Date d'Effet.
b) La Société Absorbante réglera, à compter de la Date d'Effet, tous les impôts et taxes, y inclus, sans que cette
énumération soit limitative, les droits d'apport, droits de timbre, assurances et toutes autres annuités et redevances,
qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, qui seraient dus ou pourraient être dus, en rapport avec les actifs apportés.
Au besoin, la Société Absorbante réglera les impôts sur le capital et les bénéfices, pour les exercices non encore imposés.
c) La Société Absorbante continuera tous les contrats et obligations de la Société Absorbée en cours à la Date d'Effet;
d) La Société Absorbante continuera en particulier tous les contrats de travail en cours à la Date d'Effet ainsi que les
contrats avec la clientèle, les fournisseurs, les créanciers et les débiteurs de la Société Absorbée et sera subrogée dans
tous ses droits et obligations à cet égard, à ses propres risques.
5. Pour les besoins comptables, la fusion sera effective à compter du 15 octobre 2013 (la «Date d'Effet Comptable»).
6. Les documents mentionnés à l'article 267, par.1 a), b) et c) de la Loi (à savoir, le projet de fusion, les comptes annuels
et les rapports annuels relatifs aux 3 derniers exercices sociaux ainsi que les états financiers arrêtés à la date du 15 octobre
2013) seront à la disposition des associés pour inspection au siège social des Sociétés Fusionnantes.
7. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.
8. Sile Projet de Fusion n'est pas refusé par les assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fu-
sionnantes, la Fusion deviendra définitive comme prévu au point 1. ci-dessus et engendrera tous les effets prévus par
l'article 274 de la Loi, en particulier en son paragraphe a), à la date prévue au point 1. ci-dessus.
9. Le mandat des gérants prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière leur sera accordée pour l'exercice
de leur mandat.
10. Tous les documents sociaux, les dossiers et les registres de la Société Absorbée seront conservés pendant la durée
légale au siège de la Société Absorbante.
Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2013.
LA-SER ALPHA GROUP S.à r.l. / ALPINE ADMINISTRATIVE SERVICES S.à r.l.
Référence de publication: 2013163626/64.
(130199338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
SI.TO. Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 44.390.
Ruta Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 139.844.
L'an deux mille treize, le vingt-neuf novembre.
Par-devant, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) «SI. TO. FINANCIERE S.A.», société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 44390, constituée
suivant acte notarié en date du 06 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 436
151363
L
U X E M B O U R G
du 18 septembre 1993, dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, suivant acte notarié en date du 23 décembre
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 394 du 29 avril 2005,
ici représentée par Madame Christine RACOT, employée privée, résidant professionnellement au Luxembourg, agis-
sant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'administration de «SI. TO. FINANCIERE S.A.», en
vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 21 novembre
2013 et
2) «RUTA FINANCIERE S.A.», société anonyme, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 139844, constituée
suivant acte notarié en date du 20 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1827 du
24 juillet 2008,
ici représentée par Madame Christine RACOT, prénommée, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte
du conseil d'administration de «RUTA FINANCIERE S.A.», en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution
prise par le Conseil d'Administration en date du 21 novembre 2013.
Lesdites Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
PROJET DE FUSION
1) Parties à la fusion:
«SI. TO. FINANCIERE S.A.», société anonyme dont le siège social est au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-44390 (ci-après appelée
"société absorbante"),
«RUTA FINANCIERE S.A.», société anonyme dont le siège social est au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-139844 (ci-après appelée
"société absorbée").
2) La société absorbante est titulaire de la totalité des actions représentant l'intégralité du capital et détient la totalité
des droits de vote de la société absorbée.
3) Les sociétés fusionnantes n'ont émis ni actions conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des actions.
4) La société absorbante absorbera la société absorbée aux termes d'une fusion conformément aux articles 278 à 280
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.
5) A partir du 1
er
janvier 2013, toutes les opérations de la société absorbée, la société RUTA FINANCIERE S.A., sont
considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante SI.TO. FINANCIERE
S.A..
6) Aucun avantage particulier n'est conféré aux membres des conseils d'administration ni aux commissaires aux comp-
tes des sociétés qui fusionnent.
7) La fusion entraînera de plein droit, à partir de sa prise d'effet, la transmission universelle tant entre les sociétés
fusionnantes qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante.
8) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, durant un mois suivant la publication du présent projet
de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance des documents indiqués à l'article 267 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ils auront le droit d'obtenir copie desdits documents, sans frais
et sur simple demande.
9) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent des actions du capital
souscrit a/ont le droit de requérir pendant un délai d'un mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial
C, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.
10) Sous réserve du droit des actionnaires de la société absorbante prévu au paragraphe ci-avant, la fusion deviendra
effective après expiration du délai d'un mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C et entraînera
de plein droit et simultanément les effets prévus à l'article 274 [exception faite du point b) du paragraphe (1)] de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
11) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prendront fin à la date
de la fusion et décharge leur sera accordée.
12) Les livres et documents de la société absorbée seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la
société absorbante.
Le notaire soussigné déclare attester de l'existante et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et
formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom,
prénom usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. RACOT, J.J. WAGNER.
151364
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15795.
Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2013170480/76.
(130207721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.
Island Fund S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 79.111.
Island Fund S.A., agissant en tant que Société de Gestion de Glitnir Mutual Fund (le Fonds), un fonds commun de
placement, certifie que le Fonds a été liquidé le 5 mai 2011 et qu'aucun résidu de liquidation n'a été constaté.
Référence de publication: 2013171206/8.
Private Investment Fund Management S.à r.l., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2180 ;Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 182.289.
STATUTEN
IM JAHR ZWEITAUSEND UND DREIZEHN,
AM FUENFTEN DEZEMBER.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum
Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1) BayernInvest BALE Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
2) BayernInvest BERA Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft
mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
3) BayernInvest Kammerfonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsak-
tiengesellschaft mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
4) BayernInvest LRP Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft mit
Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
5) BayernInvest STL 1 Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Union Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Peter-Zimmer-Straße 2, 66123 Saarbrücken, Deutschland, ist
6) BayernInvest VKB-RV Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversi-
cherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
7) BayernInvest VKKV Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des
Öffentlichen Rechts mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
8) BayernInvest SALE Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Saarland Feuerversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Mainzer Straße 32-34, 66111 Saarbrücken, Deutschland, ist
9) BayernInvest BSFS Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktien-
gesellschaft mit Sitz in Am Karlsbad 4-5, 10785 Berlin, Deutschland, ist
10) BayernInvest ÖLB Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg
Aktiengesellschaft mit Sitz in Am Karlsbad 4-5, 10785 Berlin, Deutschland, ist
11) BayernInvest IGEL Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Saarland Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Mainzer Straße 32-34, 66111 Saarbrücken, Deutschland, ist
vertreten durch Frau Sabine EBERT, Privatangestellte, beruflich ansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
aufgrund einer privatrechtlichen apostillierten Vollmacht, ausgestellt in München am 2ten Dezember 2013.
Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte der erschienenen Person und durch
die Notarin, bleibt dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die erschienenen Parteien, wie erwähnt vertreten, ersuchen die unterzeichnende Notarin, die Satzung einer ge-
schäftsführenderen Komplementärin der Private Investment Fund OP SCSi SICAV SIF, die geschäftsführende Komple-
mentärin in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit
gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
151365
L
U X E M B O U R G
Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form und Name der Gesellschaft. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société ä respon-
sabilité limitée) mit dem Namen Private Investment Fund Management S.à r.l. (die „Gesellschaft") gegründet, auf der
Grundlage der auf eine solche Gesellschaft anwendbaren Gesetze, und insbesondere des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung sowie dieser Satzung (die „Satzung").
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft wird in der Stadt Luxemburg errichtet. Die Geschäftsführer sind
ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des satzungsgemäßen Sitzes zu verlegen.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter
gemäß den Bestimmungen dieser Satzung über Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche militärische, politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Umstände eintreten oder un-
mittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten am Sitz der Gesellschaft verhindern, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis sich die Situation wieder normalisiert. Solche vorübergehenden
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlage-
rung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt. Die Entscheidung einer Sitzverlegung
ins Ausland wird von den Geschäftsführern getroffen.
Die Gesellschaft darf Büros und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland einrichten.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist es, als geschäftsführende Komplementärin der
Private Investment Fund OP SCSi SICAV SIF (die „SICAV" oder der „Fonds") tätig zu sein. In dieser Eigenschaft kann sie
die SICAV und ihr Vermögen verwalten und insbesondere die Anlagepolitik, die Anlageziele und die Anlagebeschränkun-
gen festlegen, und zwar entsprechend dem abgeänderten luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 betreffend
spezialisierte Investmentfonds, der Satzung und dem Emissionsdokument der SICAV.
Die geschäftsführende Komplementärin kann entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen Dritte mit dem
Fondsmanagement, dem Risikomanagement und/oder Aufgaben der Hauptverwaltung beauftragen.
Sie wird Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., eine Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société ä responsabilité limitée), als Verwalter alternativer Investmentfonds für die SICAV ernennen.
Sofern in Zukunft eine Änderung der Fondsstruktur insbesondere aus (aufsichts-)rechtlichen oder steuerrechtlichen
Gründen erforderlich oder beabsichtigt wird, wird die geschäftsführende Komplementärin die Kommanditisten hierbei
unterstützen.
Die geschäftsführende Komplementärin kann ein Anlegerkomitee einrichten. Dieses Anlegerkomitee soll mit Vertre-
tern der Kommanditisten besetzt werden. Das Anlegerkomitee soll seitens der geschäftsführenden Komplementärin in
regelmäßigen Abständen einberufen werden und den Anlegern als Informations¬und Kommunikationsgremium dienen,
insbesondere bezüglich der Anlagen der SICAV.
Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen sowie generell alle
Tätigkeiten durchführen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, sowie Maßnahmen ergreifen, welche
direkt oder indirekt der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausend sechshundert fünfzig Euro
(EUR 12.650,-), eingeteilt in elf Anteile mit einem Nennwert von je eintausend einhundert fünfzig Euro (EUR 1.150,-).
Art. 6. Änderung des Kapitals. Das Kapital der Gesellschaft darf jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung
der Gesellschafter, welcher den an eine Satzungsänderung der Gesellschaft zu stellenden Anforderungen genügt, abgeän-
dert werden.
Art. 7. Ausschüttungsrecht der Anteile. Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zu einem Anteil am Vermögen und Gewinn
der Gesellschaft im direkten Verhältnis zu der Anzahl an im Umlauf befindlichen Anteilen.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile unteilbar und pro Anteil ist nur ein
Inhaber zugelassen.
Art. 9. Übertragung von Anteilen. Die Anteile sind übertragbar.
Art. 10. Rücknahme von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Kapital zu erwerben,
solange dabei die gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.
Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 11. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt mindestens drei Geschäftsführern. Die Ge-
schäftsführer werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt. Die Geschäftsführer können jederzeit
151366
L
U X E M B O U R G
und ohne Angabe eines Grundes durch einen Mehrheitsbeschluss der Generalversammlung der Gesellschafter abberufen
werden.
Jeder Geschäftsführer darf sich bei einer Versammlung durch einen anderen Geschäftsführer aufgrund einer schriftlich
oder per Fax oder auf andere geeignete Art erteilten Vollmacht vertreten lassen.
Jeder Geschäftsführer darf an jeder Versammlung per Telefon, Videokonferenz oder vergleichbarer Kommunikations-
mittel teilnehmen, solange gewährleistet ist, dass alle Teilnehmer der Sitzung einander hören und miteinander sprechen
können. Die Teilnahme an einer Versammlung auf diese Weise steht der persönlichen Teilnahme an einer solchen Ver-
sammlung gleich.
Schriftliche Beschlüsse der Versammlung sind wirksam, wenn alle Mitglieder der Versammlung schriftlich zustimmen
und die Beschlüsse unterschreiben. Eine solche Zustimmung kann in einem einzigen oder in mehreren Dokumenten erteilt
werden, welche per Post, Fax, E-Mail, Telegramm oder Fernschreiben versandt werden. Solche Beschlüsse stehen Bes-
chlüssen gleich, die auf physisch abgehaltenen Versammlungen zustande gekommen sind.
Stimmen dürfen auch per Fax, E-Mail, Telegramm, Fernschreiben oder Telefon abgegeben werden. In letzterem Fall
muss die Stimmabgabe schriftlich bestätigt werden.
Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Gegenüber Dritten besitzen die Geschäftsführer die Befugnis, jegliche Hand-
lungen unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft auszuführen, und jegliche Handlungen und Geschäfte auszu-
führen und zu genehmigen, die dem Gesellschaftszweck entsprechen, solange die Bestimmungen dieser Satzung
eingehalten werden.
Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten
sind, fallen in die Kompetenz der Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer dürfen insbesondere Verwaltungsverträge und Anlageberaterverträge abschließen.
Art. 13. Vertretung der geschäftsführenden Komplementärin. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift
von zwei beliebigen Geschäftsführern verpflichtet.
Art. 14. Unterbevollmächtigung und Vertreter des Geschäftsführers. Ein Geschäftsführer darf seine Befugnisse für
spezifische Aufgaben auf einen oder mehrere Unterbevollmächtigte übertragen. Er legt die Verantwortlichkeiten und
gegebenenfalls die Vergütung, die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen der Bevollmäch-
tigung seines Unterbevollmächtigten fest.
Art. 15. Haftung des Geschäftsführers. Die Geschäftsführer übernehmen aufgrund ihrer jeweiligen Position keine per-
sönliche Haftung in Bezug auf jegliche Verbindlichkeiten, die sie wirksam im Namen der Gesellschaft eingehen, voraus-
gesetzt, diese Verbindlichkeit wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Satzung und den anwendbaren
gesetzlichen Vorschriften eingegangen.
Kapitel IV. - Generalversammlung der Gesellschafter
Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter. Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter
findet am zweiten Dienstag des Monats Mai eines Jahres um vierzehn Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in
der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalver-
sammlung der Gesellschafter am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.
Generalversammlungen der Gesellschafter einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland
abgehalten werden, wenn die Geschäftsführer dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließen; eine solche Entschei-
dung ist unanfechtbar.
Jeder Gesellschafter hat ein Stimmrecht entsprechend der von ihm gehaltenen Anteile.
Ein Gesellschafter darf bei Generalversammlungen der Gesellschafter durch einen Stellvertreter, der nicht selbst Ge-
sellschafter zu sein braucht, teilnehmen, welchen er schriftlich oder per Telefax, Telegramm, Fernschreiben oder E-Mail
ernannt hat. Wenn der Gesellschafter eine juristische Person ist, handelt er auf Generalversammlungen der Gesellschafter
durch seinen gesetzlichen Vertreter.
Gemeinschaftliche Beschlüsse sind nur wirksam, wenn sie von Gesellschaftern getroffen werden, die mehr als die Hälfte
des Kapitals der Gesellschaft vertreten. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur Auflösung und Liquidierung der
Gesellschaft dürfen nur von Gesellschaftern getroffen werden, welche mindestens drei Viertel des Kapitals der Gesell-
schaft vertreten, und unter den gesetzlichen Voraussetzungen.
Solange die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, brauchen Beschlüsse der
Gesellschafter nicht auf einer Generalversammlung der Gesellschafter gefasst werden, sondern können schriftlich von
allen Gesellschaftern gefasst werden. In einem solchen Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf der zu fassenden Bes-
chlüsse ausgehändigt, welcher von ihm unterschrieben werden soll. Ein solcher schriftlicher Beschluss, der in einer oder
mehreren Ausfertigungen gefasst worden ist, anstatt eine Generalversammlung abzuhalten, steht einem auf einer Gene-
ralversammlung der Gesellschafter gefassten Beschluss gleich.
Jede Bezugnahme in dieser Satzung auf Beschlüsse der Generalversammlung der Gesellschafter ist so auszulegen, dass
sie sich auch auf schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter bezieht, vorausgesetzt dass die Anzahl der Gesellschafter
fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt.
151367
L
U X E M B O U R G
Der alleinige Gesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Generalversammlung der Gesellschafter zugewiesen
sind.
Kapitel V. - Geschäftsjahr - Gesetzliche reserve und Gewinnverteilung
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.
Am Ende jeden Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft erstellt, und die Geschäftsführer stellen das
Inventar auf, welches Angaben über den Wert des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält, sowie
eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft, das genannte Inventar, die Bilanz
und die Gewinn- und Verlustrechnung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.
Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher unterliegen der Aufsicht eines Wirt-
schaftsprüfers oder mehrerer Wirtschaftsprüfer, die berechtigt sind, die Bezeichnung réviseur d'entreprises agréé zu
führen. Der/Die Wirtschaftsprüfer wird/werden von den Gesellschaftern entweder auf bestimmte oder auf unbestimmte
Zeit ernannt.
Art. 18. Gesetzliche Reserve und Gewinnverteilung. Der Bruttogewinn der Gesellschaft, wie er im Jahresabschluss
beziffert ist, bildet nach Abzug der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Geschäftskosten den Nettogewinn. Ein
Betrag, der fünf (5) Prozent des Nettogewinns der Gesellschaft entspricht, wird für die Bildung einer gesetzlichen Reserve
zurückgelegt, bis diese Reserve sich auf einen Betrag von zehn (10) Prozent des Kapitals der Gesellschaft beläuft.
Der Überschuss des Nettogewinns darf an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der von ihm/ihnen
gehaltenen Anteile der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
Kapitel IV. - Auflosung - Liquidation
Art. 19. Gründe der Auflösung. Die Gesellschaft wird durch den Tod, den Entzug der bürgerlichen Rechte, oder die
Insolvenz des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter nicht aufgelöst. Die Gesellschaft kann jederzeit
durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschaft aufgelöst werden, der den an eine Satzungsänderung zu
stellenden Anforderungen genügt.
Art. 20. Liquidation. Nach der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren
ausgeführt, welche keine Gesellschafter zu sein brauchen, und welche durch die Gesellschafter ernannt werden, welche
ihre Befugnisse und ihre Vergütung festlegen.
Ein alleiniger Gesellschafter, welcher alles Vermögen und alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernimmt, ob sie
der Gesellschaft bekannt sind oder nicht, kann die Auflösung der Gesellschaft beschließen und zu ihrer Liquidation forts-
chreiten.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
Art. 21. Anwendbares Recht. Alle Angelegenheiten, welche nicht ausdrücklich in dieser Satzung geregelt sind, unter-
liegen den Bestimmungen der anwendbaren Gesetze.
<i>1. Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2014.
<i>2. Zeichnung - Einzahlungi>
Die gesamten elf Anteile, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellen, wurden durch die Gründungsgesell-
schafter
a) BayernInvest BALE Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
b) BayernInvest BERA Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayerische Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft
mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
c) BayernInvest Kammerfonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsak-
tiengesellschaft mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
d) BayernInvest LRP Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft mit
Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
e) BayernInvest STL 1 Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Union Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Peter-Zimmer-Straße 2, 66123 Saarbrücken, Deutschland, ist
f) BayernInvest VKB-RV Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversi-
cherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
g) BayernInvest VKKV Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des
Öffentlichen Rechts mit Sitz in Maximilianstraße 53, 80530 München, Deutschland, ist
h) BayernInvest SALE Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Saarland Feuerversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Mainzer Straße 32-34, 66111 Saarbrücken, Deutschland, ist
151368
L
U X E M B O U R G
i) BayernInvest BSFS Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktien-
gesellschaft mit Sitz in Am Karlsbad 4-5, 10785 Berlin, Deutschland, ist
j) BayernInvest ÖLB Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Ak-
tiengesellschaft mit Sitz in Am Karlsbad 4-5, 10785 Berlin, Deutschland, ist
k) BayernInvest IGEL Fonds, dessen Anteilsscheininhaber die Saarland Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Mainzer Straße 32¬34, 66111 Saarbrücken, Deutschland, ist
im selben Verhältnis von je 1 gezeichnet und vollständig auf das ihnen angegebene Konto der Gesellschaft überwiesen,
so dass der Betrag von zwölftausend sechshundert fünfzig Euro (EUR 12.650,-) ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft zur
Verfügung steht, so wie es der unterzeichnenden Notarin nachgewiesen wurde.
<i>3. Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Aufwendungen, in welcher Form auch immer, welche von der Gesellschaft zu
tragen sind, oder die ihr im Zusammenhang mit der Gründung in Rechnung gestellt werden, werden geschätzt auf einen
Betrag von EUR 1.200,-.
<i>4. Generalversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft haben die Gründungsgesellschafter, die das gesamte Kapital der Gesell-
schaft vertreten und die gesamten Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter ausüben, die folgende Bes-
chlüsse gefasst:
1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft werden auf unbestimmte Zeit ernannt:
- Herr Max von Frantzius, geb. am 15.08.1968 in Oldenburg, Deutschland.
- Herr Tobias Woll, geb. am 02.08.1975 in Saarlouis, Deutschland.
- Herr Dominik Thienel, geb. am 02.10.1978 in Cloppenburg, Deutschland.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.
3) KPMG Luxembourg, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg wird für unbestimmte Zeit als Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft ernannt, R.C.S. Luxembourg B 149133.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, welche der unterzeichnenden Notarin durch
ihren Nachnamen, Vornamen und durch ihre Geschäftsanschrift bekannt ist, hat dieselbe mit der Notarin diese Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: S. EBERT, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 06 décembre 2013. Relation: RED/2013/2125. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. ELS.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 06. Dezember 2013.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013171721/241.
(130209480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.
BTMU Unit Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.510.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la dénomination de la société figurant à la première ligne de l'en-tête de la publication
de sa clôture de liquidation, dans le Mémorial C n° 3124 du 10 décembre 2013, page 149916:
au lieu de: «BTMU Premier Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialsé»,
lire: «BTMU Unit Management S.A., Société Anonyme.»
Il y a lieu de corriger pareillement le nom de la société dans le sommaire dudit Mémorial, à la page 149905.
Référence de publication: 2013171898/12.
VB Hamm Spezialfonds Nr. 3, Fonds Commun de Placement.
Hiermit informieren wir, dass der Investmentfonds VB Hamm Spezialfonds Nr. 3 (WKN: A1C10S, ISIN:
LU0525963947) mit Wirkung zum 16. Dezember 2010 liquidiert und der Liquidationserlös ausgezahlt wurde. Alle An-
teilinhaber wurden erreicht, infolge dessen erfolgte keine Zahlung an die Caisse de Consignation.
151369
L
U X E M B O U R G
Das Liquidationsverfahren ist somit abgeschlossen und der geprüfte Schlussbericht kann kostenlos bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingesehen werden.
Luxembourg, im Dezember 2013.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Référence de publication: 2013172190/755/10.
BBV-Fonds, Fonds Commun de Placement.
Hiermit werden die Anteilinhaber darüber informiert, dass die Liquidation abgeschlossen ist und sämtliche Liquida-
tionserlöse an die Anteilinhaber ausgezahlt wurden. Ein Übertrag an die Caisse de Consignation ist nicht erfolgt, da
sämtliche Fondsanteile in Globalurkunden verbrieft waren.
Luxemburg, im Dezember 2013.
Pioneer Asset Management S.A.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2013172388/250/10.
BBV-Dachfonds, Fonds Commun de Placement.
Hiermit werden die Anteilinhaber darüber informiert, dass die Liquidation abgeschlossen ist und sämtliche Liquida-
tionserlöse an die Anteilinhaber ausgezahlt wurden. Ein Übertrag an die Caisse de Consignation ist nicht erfolgt, da
sämtliche Fondsanteile in Globalurkunden verbrieft waren.
Luxemburg, im Dezember 2013.
Pioneer Asset Management S.A.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2013172427/250/10.
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 93.646.
In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of October.
Before the undersigned, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL, organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered
office at 51, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg
Trade Register under number B 98684,
here represented by Cécile JAGER, Avocat à la Cour, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 October 2013.
Pfizer Pharmaceuticals B.V., a private company with limited liability organized under the laws of the Netherlands, with
corporate seat in Rotterdam, the Netherlands, having its address at Rivium Westlaan 142, 2909LD, Capelle a/d IJssel,
The Netherlands, registered at the Trade register under number 24243225,
here represented by Cécile JAGER, previously named, by virtue of a proxy given on 16 October 2013.
PHIVCO Holdco S.à r.l., organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 51,
avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register
under number B 162507,
here represented by Cécile JAGER, previously named, by virtue of a proxy given on 16 October 2013.
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties are the shareholders of PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) SARL,
a limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 93646 (the "Company"), incorporated pursuant
to a notarial deed dated 15 May 2003, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on 16 June 2003 (number 652) (the "Mémorial C"). The articles of incorporation have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 24 February 2012, published in the Mémorial
C number 950 on 12 April 2012.
The appearing parties representing the whole corporate capital and organised as a meeting, require the notary to enact
the following resolutions taken by unanimous vote:
151370
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of FIFTY US Dollars (USD 50.-), so as to
raise it from its present amount of THREE BILLION TWO HUNDRED AND FIFTY-ONE MILLION FOUR HUNDRED
AND FIFTY-EIGHT THOUSAND ONE HUNDRED AND FIFTY US Dollars (USD 3,251,458,150.-) up to THREE BIL-
LION TWO HUNDRED AND FIFTY-ONE MILLION FOUR HUNDRED AND FIFTY-EIGHT THOUSAND TWO
HUNDRED US Dollars (USD 3,251,458,200.-), by the issue of ONE (1) new class A share (referred as the "New Share"),
such New Share having a par value of FIFTY US Dollar (USD 50.-) and having the same rights and obligations as set out
in the Company's articles of incorporation, paid up by a contribution in kind consisting into the contribution of one claim
held by PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL, prenamed, for a global amount of TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND
ONE HUNDRED AND SIXTY-TWO US Dollars (USD 280,162.-).
The aggregate contribution of TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND ONE HUNDRED AND SIXTY-TWO US
Dollars (USD 280,162.-) in relation to the New Share is allocated as follows: (i) FIFTY US Dollars (USD 50.-) is allocated
to the share capital of the Company and (ii) TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND ONE HUNDRED AND TWELVE
US Dollars (USD 280,112.-) is allocated to the share premium account of the Company.
<i>Subscriptioni>
PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL, prenamed and represented as mentioned hereabove, has declared to subscribe
for ONE (1) New Share, and to pay them a total price of FIFTY US Dollars (USD 50.-) together with total issue premium
of TWO HUNDRED EIGHTY THOUSAND ONE HUNDRED AND TWELVE US Dollars (USD 280,112.-) by a contri-
bution in kind consisting in the contribution of a claim.
The above contribution in kind has been dealt with in a statement issued by the management of the Company and the
management of Pfizer Luxco Holdings SARL, based on accounts of Pfizer Luxco Holdings SARL dated October 16, 2013
which certifies the existence and the total value of the claim.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the first sentence of Section 1 (General) of article 7 of the Articles in order to reflect
the above resolutions so that it shall henceforth read as follows:
Art. 7. Section 1-General. The Company's share capital is set at THREE BILLION TWO HUNDRED AND FIFTY-
ONE MILLION FOUR HUNDRED AND FIFTY-EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED US Dollars (USD
3,251,458,200.-) divided into:
- SIXTY TWO MILLION TWO HUNDRED AND THIRTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED AND SEVENTY-
ONE (62,234,371) Class A shares having a par value of fifty US Dollars (USD 50.-);
- NINE HUNDRED AND FIFTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED AND NINETY-TWO (956,792) Class B shares
having a par value of fifty US Dollars (USD 50.-);
- ONE MILLION EIGHT HUNDRED AND THIRTY-EIGHT THOUSAND (1,838,000) Class C shares having a par
value of fifty US Dollars (USD 50.-) (...) and
- ONE (1) Class D share having a par value of fifty US Dollars (USD 50.-) (.).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to enact that the Company's shares are currently hold as follows:
Shareholders
Shares
PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,114,159 Class A parts
956,792 Class B parts
1 Class D part
Pfizer Pharmaceuticals B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,120,212 Class A parts
PHIVCO Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,838,000 Class C parts
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,234,371 Class A parts
956,792 Class B parts
1,838,000 Class C parts
1 Class D part
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand six hundred euros (EUR 1,600).
<i>Powersi>
The appearing person, acting in the above stated capacity does hereby grant power to any clerc and / or employee of
the firm of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing
error(s)) to the present deed.
151371
L
U X E M B O U R G
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille treize, le seize octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven, Grand-duché de Luxembourg.
ONT COMPARU
PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98 684,
ici représentée par Maître Cécile JAGER, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Peternelchen,
L-2370 Howald, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 16 octobre 2013.
Pfizer Pharmaceuticals B.V., une société privée régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Rotterdam, Pays-
Bas, avec son adresse au Rivium Westlaan 142, 2909LD, Capelle a/d Ussel, Pays-Bas, immatriculé auprès du registre local
sous le numéro 24243225,
ici représentée par Maître Cécile JAGER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date
du 16 octobre 2013.
PHIVCO Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social
au 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 162507,
ici représentée par Maître Cécile JAGER, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date
du 16 octobre 2013.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes sont les associés de PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL)
SARL, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93646 (la «Société»), constituée suivant un acte notarié en date
du 15 mai 2003, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 16 juin
2003 (numéro 652) (le «Mémorial C»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte du notaire soussigné
en date du 24 février 2012, publié au Mémorial C du 12 avril 2012 numéro 950.
Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social et constituées en assemblée ont requis le
notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de CINQUANTE Dollars Américains
(USD 50.-), de façon à l'accroître de son montant actuel de TROIS MILLIARDS DEUX CENT CINQUANTE ET UN
MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT MILLE CENT CINQUANTE Dollars Américains (USD 3.251.458.150,-)
à TROIS MILLIARDS DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT MILLE DEUX
CENTS Dollars Américains (USD 3.251.458.200,-) par l'émission de UNE (1) nouvelle part sociale de classe A (désignée
comme la «Nouvelle Part Sociale»), cette Nouvelle Part Sociale ayant une valeur nominale de CINQUANTE Dollars
Américains (USD 50.-) et ayant les mêmes droits et obligations que ceux déterminés dans les statuts de la Société, payées
par un apport en nature consistant dans la conversion d'une créance détenue par PFIZER LUXCO HOLDINGS, S.à r.l.,
prénommé pour un montant total de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS AME-
RICAINS (USD 280.162).
L'apport total de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS AMERICAINS (USD
280.162) relativement à la Nouvelle Part Sociale est alloué comme suit: (i) CINQUANTE DOLLARS AMERICAINS (USD
50.-) au capital social de la Société et (ii) DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CENT DOUZE DOLLARS AMERICAINS
(USD 280.112). au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Souscriptioni>
PFIZER LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., prénommée et représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire UNE (1)
Nouvelle Part Sociale et de la payer un montant de CINQUANTE DOLLARS AMERICAINS (USD 50.-) avec une prime
151372
L
U X E M B O U R G
d'émission de DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE CENT DOUZE DOLLARS AMERICAINS (USD 280.112) par un
apport en nature consistant en l'apport d'une créance.
L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'une confirmation de l'existence et de la valeur de la créance apportée émise
par les gérants de la Société et les gérants de PFIZER LUXCO HOLDINGS SARL et sur base d'un bilan de PFIZER LUXCO
HOLDINGS SARL daté du 16 octobre 2013, qui certifient la valeur totale de l'apport en nature.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la première phrase de la Section 1 (Général) de l'article 7 des Statuts de la Société,
afin d'y refléter les modifications ci-dessus de sorte à ce qu'il aura désormais la teneur suivante:
Art. 7. Section 1. Général. Le capital social de la société est fixé à TROIS MILLIARDS DEUX CENT CINQUANTE ET
UN MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT MILLE DEUX CENTS Dollars Américains (USD 3.251.458.200),
représenté par:
- SOIXANTE DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE
(62.234.371) parts de Classe A ayant une valeur nominale de CINQUANTE Dollars Américains (USD 50,-) chacune;
- NEUF CENT CINQUANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (956.792) parts ordinaires de classe
B d'une valeur nominale de CINQUANTE Dollars Américains (USD 50,-) chacune;
- UN MILLION HUIT CENT TRENTE-HUIT MILLE (1.838.000) parts privilégiés de classe C d'une valeur nominale de
CINQUANTE Dollars Américains (USD 50,-) chacune; et
- UNE (1) part de classe D d'une valeur nominale de CINQUANTE Dollars Américains (USD 50,-).»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société est le suivant:
Associés
Nombre de parts sociales
Pfizer Luxco Holdings SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.114.159 parts sociales de classe A
956.792 parts sociales de classe B
1 part sociale de classe D
Pfizer Pharmaceuticals B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.120.212 parts sociales de classe A
PHIVCO Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.838.000 parts sociales de classe C
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.234.371 parts sociales de classe A
956.792 parts sociales de classe B
1.838.000 parts sociales de classe C
1 part sociale de classe D
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600).
<i>Pouvoirsi>
La personne comparante es qualité qu'elle agit donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
DONT ACTE, passé à Senningerberg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-
mentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: Cécile Jager, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 octobre 2013. LAC / 2013 / 48144. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 4 novembre 2013.
Référence de publication: 2013152967/194.
(130187115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.
151373
L
U X E M B O U R G
CIGL - Differdange a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-4530 Differdange, 40, avenue Charlotte.
R.C.S. Luxembourg F 2.866.
<i>Modification des status 2013i>
Assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2013 à 18.30 heures, dans le bureau de CIGL Differdange.
Présences
DADARIO Michel, GINEPRI Norbert, MEISCH Marcel, MOUSEL Jean-Marie, NICKELS Alain, PETERHÄNSEL Elke,
SCHEUER Roland, TRAVERSINI Roberto
Absent
BERG Robert, LEBLOND Marie-Jeanne, REUTER Jean-Paul
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts du CIGL Differdange comme suit:
Art. 2. Son siège est à Differdange, 4, rue Emile Mark
Remplacer par: «Son siège est à L-4530 Differdange 40, Avenue Charlotte
Art. 12. Les organes de l'association sont:
a) L'assemblé général
b) Le Conseil d'Administration
Remplacer par: Les organes de l'association sont:
a) L'assemblé général
b) Le Conseil d'Administration
c) Le Bureau exécutif
Art. 14. Alinéa 2.
Doit obligatoirement figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:
a) La nomination et la révocation des administrateurs
b) L'approbation des comptes et bilan
c) l'admission de nouveaux membres
Remplacer par: Alinéa 2
Doit obligatoirement figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:
a) La nomination et la révocation des administrateurs
b) L'approbation des comptes et bilans
c) L'admission de nouveaux membres
d) La nomination des réviseurs aux comptes
Art. 18. Le Conseil d'Administration choisit en son sein, parmi les membres élus un bureau composé au moins d'un
président, d'un vice-président. D'un secrétaire, d'un trésorier et d'un membre suppléant. La répartition des charges devra
être effectuée dans un mois suivant la date d'assemblée générale.
Remplacer par: Le Conseil d'Administration choisit en son sein, parmi les membres élus un Bureau exécutif composée
au moins d'un président, d'un vice-président. D'un secrétaire, d'un trésorier et d'un membre suppléant. La répartition
des charges devra être effectuée dans un mois suivant la date d'assemblée générale.
Le Bureau exécutif se réunit sur simple demande d'un membre du conseil d'administration et autant de fois qu'il est
jugé nécessaire. Le Bureau exécutif prend des décisions sur la gestion des affaires courantes. Les décisions sont à ratifier
lors d'une prochaine réunion du Conseil d'Administration
TRAVERSINI Roberto / LEBLOND Marie-Jeanne / MEISCH Marcel / SCHEUER Roland
<i>Président / Vice-Présidente / Trésorier / Secrétairei>
Référence de publication: 2013159007/46.
(130195202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
151374
L
U X E M B O U R G
Sapient Operations Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 145.139.
<i>Extrait sincère et conforme de la résolution du conseil de gérance de Sapient Opérations Luxembourg S.à.r.l. (la société") adoptéei>
<i>le 13 novembre 2013i>
<i>Résolutioni>
Il est résolu de nommer Mme. Sabine PERRIER comme présidente du conseil de gérance de la Société en remplacement
de M. Markus RUHL
Le conseil de gérance est donc composé comme suit:
M. Markus RUHL, gérant et délégué à la gestion journalière;
M. Joseph S. TIBBETTS Jr., gérant
Mme. Elizabeth CONDER, gérante; et
Mme. Sabine PERRIER, gérante et présidente du conseil de gérance.
<i>Pour et au nom de SAPIENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.R.L.
i>Sabine Perrier
Référence de publication: 2013158894/20.
(130194713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 77.640.622,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 145.246.
<i>Extrait sincère et conforme de la résolution du conseil de gérance de Sapient Holdings Luxembourg S.à.r.l. (la société") adoptée lei>
<i>13 novembre 2013i>
<i>Résolutioni>
Il est résolu de nommer Mme. Sabine PERRIER comme présidente du conseil de gérance de la Société en remplacement
de M. Markus RUHL
Le conseil de gérance est donc composé comme suit:
M. Markus RUHL, gérant et délégué à la gestion journalière;
M. Joseph S. TIBBETTS Jr., gérant
Mme. Elizabeth CONDER, gérante; et
Mme. Sabine PERRIER, gérante et présidente du conseil de gérance.
<i>Pour et au nom de SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.R.L.
i>Sabine Perrier
Référence de publication: 2013158893/20.
(130194712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Akeance Group, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 173.523.
EXTRAIT
Il résulte de la lettre datée du 11 novembre 2013 que Monsieur Eddy DÔME a démissionné avec effet immédiat de sa
fonction de gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
151375
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 14 Novembre 2013.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013159033/14.
(130195273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Tontarelli Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Hautcharage, 3, rue Bommel.
R.C.S. Luxembourg B 107.009.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 12 juillet 2013i>
Suivant extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale qui s'est tenue en date du 12 juillet 2013, il a
été constaté que le mandat du Réviseur d'Entreprise a été renouvelé:
- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du Réviseur de l'Entreprise - la société BDO Audit, dont le
siège social est sis à Le Dôme -Espace Pétrusse - 2, avenue Charles de Gaulle - 2013 Luxembourg - pour la durée de
l'exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sergio TONTARELLI
<i>Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013158944/17.
(130194131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Thumbria Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 134.237.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 23
novembre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 49 du 9 janvier 2008.
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 novembre 2013, que les mandats
des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une durée de 6 ans, à
savoir:
<i>- aux postes d'administrateurs:i>
* Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEM-
BOURG, 15, boulevard Roosevelt.
* Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boule-
vard Roosevelt.
* Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard
Roosevelt.
<i>- au poste de commissaire aux comptes:i>
* REVILUX S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-25.549.
Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
<i>Pour la société THUMBRIA INVESTMENTS S.A.i>
Référence de publication: 2013158940/24.
(130194554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Sico S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 53.786.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
151376
L
U X E M B O U R G
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2013159658/13.
(130195044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Kneerise, Association sans but lucratif.
Siège social: L-5775 Weiler-la-tour, 13, rue Emil Marx.
R.C.S. Luxembourg F 9.749.
STATUTEN
Am 13. Oktober 2013 wird zwischen den Unterzeichneten
M. Sørensen Yannik, Selbstständig, 56a, rue pricipale, L-7595 Reckange-Mersch
M. Wohl Christophe, Angestellter Gemeinde Hesperange, 13 rue Emil Marx, L-5775 Weiler-la-tour
Mme. Wohl Chiara-Alexandra, 8, rue Michel Rodange, L-8085 Bertrange
und allen später eintretenden Personen eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, die dem Gesetz vom
21. April 1928 sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt.
§1. Name, Sitz und Zweck der Vereinigung
Art. 1. Die Vereinigung führt den Namen: Kneerise.
Art. 2. Sitz der Vereinigung: 13, rue Emil Marx, L-5775 Weiler-la-tour.
Art. 3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Vereinigung wurde gegründet, um mit der von ihr erworbenen Anlage, für Musik und Unterhaltung auf
Veranstaltungen zu sorgen. Des weiteren kann die Anlage vermietet werden. Ebenfalls soll die Vereinigung als Anlaufstelle
für Leute gelten, welche sich für Veranstalltungstechnik interessieren.
Art. 5. Der Verein ist politisch neutral. Er darf keiner politischen oder religiösen Vereinigung beitreten.
Art. 6. Kneerise ist gerne zur Zusammenarbeit mit anderen Vereinen bereit.
§ 2. Die Mitglieder
Art. 7. Der Verein besteht nur aus aktiven Mitgliedern.
Art. 8. Jedes Mitglied muss einen Jahresbeitrag leisten. Dieser Beitrag wird in der Generalversammlung festgesetzt.
Art. 9. Jedes Mitglied ist verpflichtet zum Wohle der Vereinigung beizutragen.
Art. 10. Um in der Vereinigung aufgenommen zu werden, muss man einen schriftlichen Antrag beim Vorstand stellen.
Der Vorstand muss nun einstimmig entscheiden, ob die Person aufgenommen wird.
Art. 11. Aus der Vereinigung ausgewiesen werden kann ein Mitglied nur, unter triftigem Grund und mit Einverständnis
aller Mitglieder des Vorstandes.
Art. 12. Jedes Mitglied hat das Recht, sich zu jeder Zeit aus der Vereinigung zurück zu ziehen, dies durch schriftliche
Einreichung der Kündigung an den Vorstand.
Art. 13. Als aus der Vereinigung ausgeschlossen gilt ebenfalls jedes Mitglied, welches bis zu zwei (2) Monaten
nach abgelaufener Mitgliedschaft, nicht den festgelegten Jahresbeitrag gezahlt hat.
Art. 14. Aus der Vereinigung ausgeschlossene oder ausgetretene Personen können kein Recht auf Finanzielle oder
Materielle Güter geltend machen.
Art. 15. Falls ein Mitglied durch eigenes Verschulden, Eigentum der Vereinigung beschädigt, kann es dafür haftbar
gemacht werden, und muss für den Schaden aufkommen.
§ 3. Der Vorstand
Art. 16. Die Leitung der Vereinigung geschieht durch den Vorstand.
Art. 17. Die Vorstandsmitglieder sind folgende Personen:
- Sørensen Yannik
- Wohl Chiara-Alexandra
- Wohl Christophe
151377
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Ein neues Mitglied kann nur in den Vorstand aufgenommen werden, wenn ein anderes Mitglied zurücktritt,
oder aus dem Vorstand ausgewiesen wird (Art. 25). Das neue Mitglied wird von der Generalversammlung gewählt. Die
Kandidatur muss vor Beginn der Generalversammlung, schriftlich eingereicht werden.
Art. 19. Die Aufgaben des Vorstandes sind:
- die Geschäftsführung der Vereinigung
- die Aufnahme resp. der Ausschluss von Mitgliedern
- die Vorbereitung und die Einberufung der Generalversammlung sowie die Festlegung der Tagesordnung.
Art. 20. Im Vorstand sind folgende Ämter zu besetzen: Präsident, Schriftführer und Kassierer.
Art. 21. Die Ämter werden jedes Jahr neu innerhalb des Vorstandes verteilt.
Art. 22. Der Präsident führt die Versammlungen und wacht über die Vollziehung der Statuten.
Art. 23. In Abwesenheit des Präsidenten vertritt ihn der Schriftführer.
Art. 24. Der Schriftführer führt Protokoll über die Verhandlungen des Vereins und des Vorstandes. Er schreibt
sämtliche Sitzungsberichte und bewahrt sie auf.
Art. 25. Der Kassierer verwaltet die Kasse, führt Buch über das Vereinsvermögen und ist dem Vorstand sowie
dem Verein für die gute Verwaltung persönlich verantwortlich. Ausgaben dürfen nur mit Einverständnis des Vorstandes
erfolgen.
Art. 26. Der ganze Vorstand kann nicht verantwortlich gemacht werden für das Handeln eines einzigen Vorstands-
mitgliedes. Jedes Vorstandsmitglied haftet voll und ganz für den Ihm anvertrauten Posten.
Art. 27. Jedes Mitglied des Vorstandes, egal welches Amt es ausführt hat das gleiche Stimmrecht. Bei einer Abstimmung
entscheidet immer die Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
Art. 28. Aus dem Vorstand ausgewiesen werden, kann ein Mitglied nur, unter triftigem Grund und mit Einverständnis
aller Mitglieder des Vorstandes. In der Zeit zwischen dem Ausweisungsantrag, und dem Beschluss des Vorstandes ist die
betreffende Person von seinen Funktionen im Vorstand entbunden.
§ 4. Kassenwesen und Geschäftsjahr
Art. 29. Der Kassierer ist verantwortlich für die Finanzen. Er führt ordnungsgemäss Buch über Einnahmen und Aus-
gaben und hat dem Vorstand regelmässig über die Finanzen zu berichten.
Art. 30. Alle Vorstandsmitglieder sind gleichzeitig Kassenrevisoren. Sie müssen den Jahresbericht des Kassierers in
einer Vorstandsversammlung überprüfen und bestätigen.
Art. 31. In der obligatorischen Generalversammlung muss der Kassierer den Mitgliedern den Bericht des vergangenen
Jahres präsentieren. Der Kassierer enthält Entlastung durch die Generalversammlung.
Art. 32. Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
§ 5. Versammlungen
Art. 33. Der Vorstand tritt periodisch, den Bedürfnissen entsprechend zusammen.
Art. 34. Periodisch werden auch Mitgliederversammlungen einberufen. Hier werden die Beschlüsse des Vorstands den
Mitgliedern mitgeteilt.
Art. 35. Eine obligatorische Generalversammlung muss zum Jahresanfang stattfinden.
Art. 36. Falls notwendig, kann der Vorstand jederzeit eine Generalversammlung einberufen.
Art. 37. Generalversammlungen müssen mindestens 5 Tage im voraus mit Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen
werden.
Art. 38. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter
geführt.
Art. 39. Die Generalversammlung ist nicht öffentlich.
Art. 40. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Aussergewöhnliche Generalversammlungen sind in jedem Fall beschlussfähig.
Art. 41. Jedes Mitglied verfügt über nur eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit erfasst.
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
Art. 42. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
- die Genehmigung des Tätigkeits- und des Kassenberichts.
151378
L
U X E M B O U R G
- die Entlastung des Kassierers
- die Änderung der Statuten
- die Auflösung der Vereinigung.
Art. 43. Alle in der Vereinigung ausgeführten Arbeiten und Funktionen sind ehrenamtlich, und werden unentgeltlich
ausgeführt.
Art. 44. Zur Umänderung der Statuten ist eine 2/3 Stimmenmehrheit erfordert.
§ 6. Auflösung der Vereinigung
Art. 45. Solange sich 2 Mitglieder der Vereinigung gegen eine Auflösung aussprechen, kann diese nicht erfolgen.
Art. 46. Wenn die Auflösung der Vereinigung erfolgt, werden alle Schulden beglichen, und das Barvermögen
wird für einen guten Zweck übergeben.
§ 7. Verschiedenes
Art. 47. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fällen gelten die allgemeinen Bestim-
mungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzwecke.
Weiler-la-tour, den 13. Oktober 2013.
Sørensen Yannik / Wohl Chiara-Alexandra /
Wohl Christophe.
Référence de publication: 2013159761/108.
(130195152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Twelve Magnolia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 171.334.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 novembre 2013, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
1. Acceptation de la démission de Marie-Catherine Brunner, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.
2. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.
3. Nomination de Jérôme Demimuid, avec adresse au 62, rue Reckenthal, L-2410 Luxembourg, au mandat d'adminis-
trateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018.
4. Nomination d'Olivier Revol, avec adresse professionnelle au 480, avenue Louise, 1000 Bruxelles, Belgique, au mandat
d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Référence de publication: 2013159689/21.
(130195227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Software Development & Support S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3985 Pissange, 31, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 73.443.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 novembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013159674/10.
(130195493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
SOF-VII Asian Hotel Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 106.771.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
151379
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2013.
Référence de publication: 2013159672/10.
(130195136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Société Anonyme de Participations et de Placements, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 56.550.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 novembre 2013, les actionnaires ont pris la décision
de nommer Clélia Benenati, avec adresse professionnelle au 2, Rue Beni Bouayach Souissi, Rabat, Maroc, au mandat
d'administrateur pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Référence de publication: 2013159666/13.
(130195039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Sodiphar, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.789,35.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 55.822.
In the year two thousand and thirteen, on the fourth of November.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole Partner of "SODIPHAR" (hereafter referred to as the "Company"),
a "Société à responsabilité limitée", established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section
B number 55.822, incorporated by deed of Maître Frank Baden, then notary residing in Luxembourg, on July 31, 1996,
published in the Luxembourg Memorial C number 545, page 26138, on October 24, 1996 and whose Articles of Incor-
poration were for the last time modified by deed enacted by Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg,
on November 28
th
, 2003, published in Memorial C, number 80, page 3839, on January 21, 2004.
There appeared:
"SOBEDIP, S.A.", a "Société Anonyme" incorporated and existing under the law of Belgium with registered office at
55, boulevard de l'Humanité, B-1070 Anderlecht (the "Sole Partner"), hereby represented by Mister Erwin VANDE
CRUYS, private employee, with professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Luxembourg on October 28
th
, 2013.
Which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The Sole Partner has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of SOBEDIP,S.A., a Belgian company with registered office at 55, boulevard de l'Humanité, B-1070
Anderlecht as liquidator (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Approval of the financial statements of the Company for the period from January 1, 2013 to November 4, 2013;
5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
6. Miscellaneous.
III. The Sole Partner passes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Partner resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary
liquidation).
<i>Second resolution:i>
The Sole Partner resolves to appoint SOBEDIP, S.A., prenamed, as liquidator (the "Liquidator").
151380
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolution:i>
The Sole Partner resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended
Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").
The Sole Partner further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,
including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Partner. The Liquidator
may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons
or entities.
The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature
on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is
required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds to the Sole Partner of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolution:i>
The Sole Partner resolves to approve the financial accounts of the Company for the period from January 1, 2013 to
November 4, 2013.
<i>Fifth resolution:i>
The Sole Partner decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their
respective mandates until today.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le quatre novembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé unique de la société à responsabilité limitée
"SODIPHAR" (la "Société"), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 55.822, constituée suivant acte reçu par le notaire
Maître Franck Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro
545, page 26138, du 24 octobre 1996 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 28
novembre 2003, publié au Mémorial C, N°80, page 3839 du 21 janvier 2004.
A comparu:
"SOBEDIP, S.A.", (société anonyme) constituée sous le droit belge, ayant son siège social au 55, boulevard de l'Hu-
manité, B-1070 Anderlecht (l'"Actionnaire Unique"),
Ici représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, demeurant professionnellement au 74, Avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 28 octobre 2013.
Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les actions du capital de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de SOBEDIP, S.A., une société anonyme belge ayant son siège social au 55, boulevard de l'Humanité à
B-1070 Anderlecht, en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1 janvier 2013 au 4 novembre
2013;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
6. Divers.
151381
L
U X E M B O U R G
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décide de nommer SOBEDIP, S.A., précitée, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du
10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").
L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations,
en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule
signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.
L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des
avances sur le solde de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant
du 1 janvier 2013 au 4 novembre 2013.
<i>Cinquième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce
jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec
Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en
langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2013. LAC/2013/51271. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Référence de publication: 2013159668/130.
(130195058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Leger S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4880 Lamadelaine, 53, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 39.277.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013160155/10.
(130196057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
151382
L
U X E M B O U R G
LC Sales Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.840.
Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8/10/2013.
Signature.
Référence de publication: 2013160154/10.
(130196803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Latimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 37.129.
Le Conseil d'Administration a pris note du changement d'adresse de l'Administrateur A:
- Monsieur Carlo D'AMARIO, 44, Conduit Street, UK- LONDON WIS 2YL.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>J. WINANDY
<i>Administrateur Bi>
Référence de publication: 2013160153/12.
(130196645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Land and Business S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 114.483.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2013 que la société CLERC (RCS
Luxembourg B 111 831), ayant son siège social au 1, rue Pletzer L-8080 Bertrange, Luxembourg, a été nommée réviseur
en remplacement de Ser.Com Sàrl, commissaire démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013160152/13.
(130196562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
La Parunia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 98.179.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2013160151/13.
(130196589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
La Commedia Dell'Arte Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
151383
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013160150/10.
(130196063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Medina Financial Markets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 177.251.
<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 15 novembre 2013 effectif au 18 novembre 2013i>
En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 15 novembre 2013 effectif au 18 novembre 2013, Darby Converging
Europe Fund III (SCS) SICAR, a transféré 6,250 de ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:
- 6,250 parts sociales ordinaires d'une valeur de 1,- Euro chacune, à la société ARX CEE III L.P., une société en
commandite de droit de Jersey, immatriculée au Jersey Financial Services Commission, Companies Registry sous le nu-
méro 1086, et ayant comme siège social Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE23RT11
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013160183/18.
(130196291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Lou Paradou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 114.244.
Le Bilan au 30.06.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013160167/10.
(130196549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Lou Paradou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 114.244.
Le Bilan au 30.06.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013160166/10.
(130196545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
LIST Société Anonyme, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 20.764.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2013160163/14.
(130196073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
151384
L
U X E M B O U R G
Macor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 177.688.
<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 16 septembre 2013i>
1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
3. Monsieur Franck BETH, administrateur de sociétés, né à Roubaix (France), le 6 mai 1974, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B
pour une durée indéterminée.
4. Madame Stéphanie MEYER, administrateur de sociétés, née à Saint-Mard (Belgique), le 14 août 1987, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
de classe B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Macor S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013160174/20.
(130195976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Mareuil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 158.582.
Les comptes annuels au 31/12/2011 de la société Mareuil S.àr.l., Société à responsabilité limitée, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013160175/10.
(130196813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Luxambulance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 21, rue Benjamin Franklin.
R.C.S. Luxembourg B 105.564.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUXAMBULANCE SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013160172/11.
(130196721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
LTH (Logistik, Transport, Handel) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 32, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 88.536.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013160170/9.
(130196447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Ligiol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.250,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 135.634.
Le bilan de la société au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
151385
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Le Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2013160161/12.
(130196571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 100.755.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Halsey S.à r.l.
Représenté par M. Christophe Gammal
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2013160142/12.
(130196339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 144.746.
In the year two thousand thirteen, on the twenty-fifth day of October;
Before us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the corporation established in Luxembourg under the
denomination of Microfinance Enhancement Facility S.A., SICAV-SIF, a "société anonyme", having its registered office at
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
enacted on February 5, 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations'", number 391 of February
23, 2009, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 144746 (the "Fund"),
and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary, on October 26, 2012, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number
2918 of December 1, 2012.
The Meeting is presided by Mr. Georges BECKENE, Vice President, CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEM-
BOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The chairman appoints as secretary Mrs. Jacqueline SIEBENALLER, Director, CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LU-
XEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet and the Meeting elects as scrutineer Mrs.
Elizabete MACHADO, Assistant Vice President, CREDIT SUISSE FUND Management S.A., residing professionally in Lu-
xembourg, 5, rue Jean Monnet.
The chairman requests the notary to act that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. With effect as from 25 October 2013 or any date thereafter, change the definition of Prohibited Person in Article
11 "Restrictions on Ownership of Shares".
2. With effect as from 25 October 2013 or any date thereafter, change to Article 27 "Payment waterfall".
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed ne varietur by the proxyholders of the represented
shareholders, by the bureau of the Meeting and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
III. The present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on September 23, 2013
to the registered shareholders.
IV. The resolutions on the agenda require a quorum of 70% of the share capital of the Fund and may only be validly
take if approved by at least 3/4 of the votes cast.
V. It appears from the attendance list that, out of the 4,084.537 shares in issue as at 25 October 2013, 3,487 shares
are present or represented and that they represent 85.37% of the share capital of the Fund.
VI. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of
the agenda.
151386
L
U X E M B O U R G
After approval of the statements of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting
passed, after deliberation, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously approved the changes to the definition of "Prohibited Person" in article 11 "Restrictions on
Ownership of Shares" in order to have the following wording:
" Art. 11. Restrictions on Ownership of Shares. The Fund may restrict or prevent the ownership of shares in the Fund
by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Fund such holding may be detrimental to the Fund, if it
may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Fund may
become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such
persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited
Persons").
For such purposes the Fund may:
A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
B.- at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares
on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited
Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and
C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Fund; and
D.- where it appears to the Fund that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is
a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Fund evidence of the sale
within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Fund may compulsorily
redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
(1) The Fund shall serve a second notice (the "purchase notice") upon the shareholder holding such shares or appearing
in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Fund.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice; his name shall be removed from the register of shareholders.
(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net
asset value per share of the relevant class as at the Valuation Date specified by the board of directors for the redemption
of shares in the Fund preceding the date of the purchase notice as determined in accordance with Article 9 hereof, less
any service charge provided therein.
(3) The redemption price will be equal to the net asset value of the shares to be so redeemed as of the redemption
date (as specified in the purchase notice). Payment of the redemption price will be made by the Fund or its agents no
later than 30 business days after the redemption date depending on the available cash in the Fund. If no cash is available
within thirty days, such payment shall be made to such shareholder as a priority as soon as there is sufficient cash available.
Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any
of them, nor any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price
(without interest) from such bank. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not
collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and
shall revert to the relevant class or classes of shares. The board of directors shall have power from time to time to take
all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Fund.
(4) The exercise by the Fund of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,
on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of
any shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any purchase notice, provided in such case the said
powers were exercised by the Fund in good faith.
"Prohibited Person" as used herein does neither include any subscriber to shares of the Fund issued in connection
with the incorporation of the Fund while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares
with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Fund.
"Prohibited Person" include any investor who is not an eligible investor within the meaning of article 2 of the 2007
Law.
An eligible investor within the meaning of Article 2 of the 2007 Law is defined as any institutional investor, professional
investor as well as any other investor who fulfills the following conditions:
a) he has confirmed in writing that he adheres to the status of well-informed investor, and
b) (i) he invests a minimum of 125,000 Euros in the Fund, or
151387
L
U X E M B O U R G
(ii) he has been the subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC,
by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of
Directive 2001/107/EC certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment
in the Fund.
Prohibited Person also includes prohibited parties, which are any of the persons or entities named on (i) the lists of
sanctioned persons promulgated by the European Union relating to any economic, financial and trade restrictive measures
and arms embargoes issued by the European Union pursuant to Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Union
as well as Article 215 of the Treaty on functioning of the European Union, as available in the official EU websites (see
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm and http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf,
as amended and supplemented from time to time or on any successor page;) (ii) the lists of sanctioned persons promul-
gated by the United Nations Security Council or its committees relating to economic, financial, trade and restrictive
measures and arms embargoes issued by the United Nations Security Council pursuant to Chapter VII of the United
Nations Charter as well as in connection with money laundering or anti-terrorism matters (as currently set forth at
www.un.org/terrorism and http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, as amended and supplemented from ti-
me to time or on any successor page) and/or (iii) the World Bank Listing of Ineligible Firms (see www.worldbank.org/
debarr).
The conditions set forth above are not applicable to the directors and other persons who intervene in the management
of the Fund.
U.S. Persons as defined in this Article may constitute a specific category of Prohibited Persons.
Where it appears to the Fund that any Prohibited Person is a U.S. Person, who either alone or in conjunction with
any other person is a beneficial owner of shares, the Fund may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any
shareholder all shares held by such shareholder without delay. In such event, Clause D (1) here above shall not apply.
Whenever used in these Articles, the terms "U.S. Person" mean with respect to individuals, any U.S. citizen (and certain
former U.S. citizens as set out in relevant U.S. Income Tax laws) or "resident alien" within the meaning of U.S. income
tax laws and in effect from time to time.
With respect to persons other than individuals, the term "U.S. Person" means (i) a corporation or partnership or other
entity created or organised in the United States or under the laws of the United States or any state thereof; (ii) a trust
where (a) a U.S. court is able to exercise primary jurisdiction over the trust and (b) one or more U.S. fiduciaries have
the authority to control all substantial decisions of the trust and (iii) an estate (a) which is subject to U.S. tax on this
worldwide income from all sources; or (b) for which any U.S. Person acting as executor or administrator has sole in-
vestment discretion with respect to the assets of the estate and which is not governed by foreign law. The term "U.S.
person" also means any entity organised principally for passive investment such as a commodity pool, investment company
or other similar entity (other than a pension plan for the employees, officers or principals of any entity organised and
with its principal place of business outside the United States) which has as a principal purpose the facilitating of investment
by a United States person in a commodity pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements
of part 4 of the United States Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants being non United
States persons. "United States" means the United States of America (including the States and the District of Columbia),
its territories, its possessions and any other areas subject to its jurisdiction."
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously resolved to change article 27 "Payment waterfall" as follows:
" Art. 27. Payment waterfall. Income waterfall
For each valuation date, after paying the direct operating expenses, the investment management fees, the interest and
fees on Debt Instruments, and after accruing for the incentive bonus (actual payment(s) made upon decision of the board
of directors) and without taking into account the losses and/or the gains attributable to the Shares as described under
Article 6 "Share Capital - Classes of Shares and Debt Instruments", the year-to-date net investment income of the Fund
will be allocated in the following order of priority:
1. Allocation of the year-to-date target dividends for the A Shares, pro-rata to the dividends for each tranche of A
Shares;
2. Allocation of the year-to-date target dividends for the B Shares, pro-rata to the dividends for each tranche of B
Shares;
3. Allocation of the fixed target return or the floating rate target return, capitalised, for the C Shares;
4. The incentive bonuses of the Investment Managers subject to pre-defined parameters;
5. Complementary dividends for the A Shares and B Shares, pro-rata to each respective tranche issued multiplied by
a weighting factor (A Shares weighting factor = 1; B Shares weighting factor = 1).
The losses and/or gains attributable to the Shares as described under Article 6 "Share Capital and Debt Instruments"
are allocated after the above income waterfall.
In case the year-to-date net investment income of the Fund is negative, such negative income will be allocated in the
following order of priority:
151388
L
U X E M B O U R G
1. Allocation of the negative income to the C Shares up to the total net asset value of the C Shares;
2. Allocation of the remaining negative income to the B Shares up to the total net asset value of the B Shares;
3. Allocation of the remaining negative income to the A Shares up to the total net asset value of the A Shares;
The net gains in case of a write-back of provisions previously borne by specific tranches of shares are allocated to
them in addition to their dividends or capitalised return calculated as per this sub-section (a).
<i>Cash waterfalli>
Initial use of available cash
The Fund's available cash will be initially used to pay the direct operating expenses, the investment management fees
and the amounts drawn under the revolving credit facility.
Satisfaction of the entitlements under the Debt Instruments
Cash remaining available after paying the direct operating expenses, the investment management fees and the amounts
drawn under the revolving credit facility shall be applied to satisfy interest, fees and principal repayments in relation to
the Debt Instruments.
Satisfaction of shareholders' and other entitlements
Remaining available cash will be applied in the following order and priority, following any compulsory redemptions:
1. Payment of target annual dividends for the A Shares as of December 31;
2. Payment of redemption amounts for the A Shares;
3. Payment of target annual dividends for the B Shares as of December 31;
4. Payment of redemption amounts for the B Shares;
5. Payment of the incentive bonuses of the Investment Managers as of December 31 if applicable;
6. Payment of complementary dividends for A Shares and B Shares as of December 31.
The payment of the annual target and complementary dividends as of December 31 is approved by the General Meeting
of Shareholders.
<i>Liquidation of the Fundi>
Upon the liquidation of the Fund, the moneys will be distributed in the following order of priority to the extent of
available cash:
1. Payment of all liabilities related to taxes, Direct Operating Expenses, Investment Management Fees and amounts
drawn under the revolving credit facility;
2. Payment of the interest and the fees due on the Notes and on the Loans, pro-rata to the interest and the fees due
on each tranche of Notes and on each Loan;
3. Payment of the outstanding principal of the Notes and of the Loans;
4. Payment of target dividends for the A Shares, pro-rata to the dividends for each tranche of A Shares;
5. A Shares at their respective Net Asset Value on dissolution (which will include the complementary dividend if any);
6. Payment of target dividends for the B Shares, pro-rata to the dividends for each tranche of B Shares;
7. B Shares at their respective Net Asset Value on dissolution (which will include the complementary dividend, if any);
8. The incentive bonuses of the Investment Managers subject to pre-defined parameters;
9. C Shares at their Net Asset Value on dissolution.
For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from
time to time.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the relevant
class or classes of shares.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Fund and kept by it at the disposal of its beneficiary."
The changes approved by the present Meeting will enter into force on 25 October 2013.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English.
WHEREUPON, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this
document.
151389
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Signé: G. BECKENE, J.SIEBENALLER, E. MACHADO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2013. LAC/2013/49228. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Référence de publication: 2013160187/216.
(130196207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 144.746.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013160188/15.
(130196249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Marienfeld Leasing (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.935.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 2 octobre 2013 que:
- Madame Nina Kleinbongartz, née le 24 décembre 1969 à Krefeld, Allemagne, avec adresse professionnelle au 51
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée gérante de la Société avec effet au 2 octobre 2013, pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013160176/17.
(130196274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
Medea Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 169.778.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Référence de publication: 2013160182/11.
(130196560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
151390
L
U X E M B O U R G
L'Arche S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 50.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2013.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013160138/11.
(130196845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2013.
SOL S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2319 Howald, 72, rue Dr J. Peffer.
R.C.S. Luxembourg B 151.982.
L'an deux mille treize, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOL S.A., SPF, ayant son
siège social à L-2319 Howald, 72, rue Dr. J. Peffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 151892, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 mars 2010, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 884 du 28 avril 2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Carlo SCHLESSER, administrateur, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Serge KRANCENBLUM, administrateur, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions représentant l'intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Création de deux classe d'actions A et B («les actions traçantes) et détermination de leurs droits.
2.- Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de créer deux classes d'actions, les actions de classe A et les actions de classe B, dénommées aussi
les «actions traçantes».
Les actions de classe A (numérotées de 1 à 160) donneront droit aux revenus et capitaux de la société Solace S.A.,
SPF et les actions de classe B (numérotées de 161 à 320) donneront droit aux revenus et capitaux de la société Solsk
S.A., SPF.
Capitaux et intérêts d'éventuels prêts que la Société pourrait accorder à ses deux filiales Solace S.A. SPF et Solsk S.A.
SPF seront également tracés par les actions A ou les actions B.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier les statuts comme suit:
L'article 5 des statuts est modifié comme suit:
5.1. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000) représenté par cent soixante (160) actions
de classe A et cent soixante (160) actions de classe B ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
151391
L
U X E M B O U R G
5.2. Chacune des actions de classe A et de classe B tracera la performance et le rendement des actifs et passifs sous-
jacents qu'elle suit.
Les actions de classe A (numérotées de 1 à 160) donneront droit aux revenus et capitaux de la société Solace S.A.,
SPF et les actions de classe B (numérotées de 161 à 320) donneront droit aux revenus et capitaux de la société Solsk
S.A., SPF. Capitaux et intérêts d'éventuels prêts que la Société pourrait accorder à ses deux filiales Solace S.A. SPF et
Solsk S.A. SPF seront également tracés par les actions A ou les actions B.
5.3. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
5.4. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. SCHLESSER, S. KRANCENBLUM et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50315. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158249/66.
(130193857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Cortem International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 114.366.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée généralei>
<i>ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 septembre 2013i>
<i>Résolution:i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit.
<i>Conseil d'administrationi>
M. Giovanni Spasiano, employé privé, demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-
xembourg, président et administrateur;
M. Riccardo Gratton, demeurant Via Della Vitalba No 4, I-34121 Trieste (Italie), administrateur;
M. Alessandro Rossi, demeurant Viale Argonne No 8, I-20120 Milan (Italie), administrateur;
M. Alberto Mossini, demeurant Via Cocconcelli Antonio No 11, I-43100 Parme (Italie), administrateur;
M. Emmanuel Briganti, empoyé privé, demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
ComCo S.A., 68, rue de Koerich, L-8437 Steinfort
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2013159206/27.
(130195175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
151392
Akeance Group
Alpine Administrative Services S.à r.l.
Amboyna Cay S.A.
BBV-Dachfonds
BBV-Fonds
BTMU Unit Management S.A.
Build Group Co. S.A.
CIGL - Differdange a.s.b.l.
Cominsider S.A.
Cortem International S.A.
Empark Funding S.A.
Finadis S.A. SPF
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
International Financing Partners S.A. - SPF
Island Fund S.A.
Kneerise
La Commedia Dell'Arte Sàrl
Land and Business S.A.
La Parunia S.A.
L'Arche S.A. - SPF
La-ser Alpha Group S.à r.l.
Latimo S.A.
LC Sales Holding S.à r.l.
Leger S.àr.l.
Ligiol S.à r.l.
Lincoln Electric Luxembourg S.à r.l.
LIST Société Anonyme
Lou Paradou S.A.
Lou Paradou S.A.
LTH (Logistik, Transport, Handel) S.àr.l.
Luxambulance Sàrl
Macor S.à r.l.
Mareuil S.à r.l.
Marienfeld Leasing (Lux) S.à r.l.
Martin Currie Global Funds
Medea Holding II S.à r.l.
Medea Holding II S.à r.l.
Medina Financial Markets S.à r.l.
Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF
Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF
Myway Invest S.A.
Ocean Race S.A., SPF
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sàrl
Private Investment Fund Management S.à r.l.
Ruta Financière S.A.
Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l.
Sapient Operations Luxembourg S. à r.l.
Sico S.A.
SI.TO. Financière S.A.
Société Anonyme de Participations et de Placements
Sodiphar
Software Development & Support S.à r.l.
SOF-VII Asian Hotel Holdings, S.à r.l.
SOL S.A., SPF
Studio 206 S.A.
Thumbria Investments S.A.
Tontarelli Lux S.A.
Touchstone Holding S.A.
Twelve Magnolia S.A.
VB Hamm Spezialfonds Nr. 3