logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3105

6 décembre 2013

SOMMAIRE

Credit Suisse Specialised Capital (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149006

Essential Trust Holding S.A. SPF  . . . . . . . .

149029

Flying Bird S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149040

GBS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148994

Georges Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148994

Georges Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148994

Get Real Estate International S.A.  . . . . . . .

148995

Global Telephone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148995

GP-2 Office A LBC Luxco S.à r.l.  . . . . . . . .

148994

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l.  . . . . . . . .

148995

GP-4 Inner City A LBC Luxco S.à r.l.  . . . .

148994

GP-5 Inner City B LBC Luxco S.à r.l. . . . . .

148995

GP-6 Development LBC Luxco S.à r.l.  . . .

148996

GP-7 Opportunity LBC Luxco S.à r.l.  . . . .

148996

Grand Large Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

148996

Hésione S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148996

Hilger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148995

Hitech Futur Car Center SA  . . . . . . . . . . . .

149040

Immopartner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148997

Innisfree ISF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148997

Integrated BioBank of Luxembourg  . . . . .

148997

Laguna Verde S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148998

Land Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148998

LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l.  . . . . . . . .

149001

LBP Luxco GP 2-Resi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

149001

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l.  . . . . . . . . . .

149001

LBP Luxco GP 4-North S.à r.l. . . . . . . . . . . .

149000

LBP Luxco GP 5-South S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

149000

LBP Luxco GP 6-Hessen S.à r.l. . . . . . . . . . .

149000

LBP Luxco GP 7-Office S.à r.l. . . . . . . . . . . .

148999

LBP Luxco GP 8-West S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

148998

Levanna Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148997

Leyla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148996

LGT Fund Management (Lux) S.A.  . . . . . .

148999

Lusol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148998

Lux Gare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148999

Lux Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148999

Lux Publicité Immobilière S.à r.l.  . . . . . . . .

148998

Lux Technicom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149000

Lux Trade Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

149001

MAF Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149002

Matterhorn Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

149001

Mercurio Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149003

Michelangelo Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149004

Milux International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149002

Mochis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149002

Morgan Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

149003

MP Trans Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149002

Naga 1 (BC) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149000

Naja Investment S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .

149003

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149005

OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERA-

TIONS Europäische Gesellschaft für die
Leistungs- und Kostenoptimierung ge-
bäudetechnischer Anlagen  . . . . . . . . . . . . .

149005

Optolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149004

Orbis Invest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149004

Pacific Santa Ana S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

149003

Pacific Sharav S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149004

Pacific Specialised Finance Capital S.A.  . .

149006

Replay Associate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149005

Spanish Residential (REIT) Holdco I S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149040

Topfashionesch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149036

Zitro S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149038

148993

L

U X E M B O U R G

GBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 110.165.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2013155329/12.
(130190105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Georges Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 95, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 96.563.

Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Peiffer
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2013155334/11.
(130190151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Georges Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 95, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 96.563.

Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Christophe Peiffer
<i>Le Gérant

Référence de publication: 2013155335/11.
(130190152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

GP-2 Office A LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155349/10.
(130190183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

GP-4 Inner City A LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155351/10.
(130190179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

148994

L

U X E M B O U R G

Get Real Estate International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 160.686.

<i>Rectificatif du dépôt du bilan au 31/12/2012. Déposé le 06 novembre 2013 n°L130188873 au Registre de Commerce et des

<i>Sociétés de Luxembourg

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GET REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2013155341/12.
(130190263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Global Telephone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 78.577.

Par la présente, j'ai l'honneur de démissionner de mon mandat de Commissaire aux Comptes au sein de votre société

GLOBAL TELEPHONE S.A., inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B78577.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

Fiduciaire Intercommunautaire S.à R.L.

Référence de publication: 2013155347/11.
(130190091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.804.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155350/10.
(130190181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

GP-5 Inner City B LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155352/10.
(130190177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Hilger, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 106.938.

Les comptes annuels de la société de droit étranger au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013155367/11.
(130190068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

148995

L

U X E M B O U R G

GP-6 Development LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.785.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155353/10.
(130190175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

GP-7 Opportunity LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 124.780.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155354/10.
(130190173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Grand Large Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.101.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013155356/12.
(130189902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Hésione S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 161.643.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hésione S.à.r.l.
Signature
<i>Le Gérant unique

Référence de publication: 2013155358/13.
(130189980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Leyla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 67.392.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155461/9.
(130190141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

148996

L

U X E M B O U R G

Innisfree ISF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.570.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67578 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155380/10.
(130190073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

IBBL, Integrated BioBank of Luxembourg, Fondation.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 6, rue Nicolas Ernest Barblé.

R.C.S. Luxembourg G 195.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013155381/11.
(130190062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Immopartner, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9943 Hautbellain, 11, Lommerscherweeg.

R.C.S. Luxembourg B 108.853.

Folgendes wurde festgestellt:
Aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderates von Troisvierges, über die Einführung von Straßennamen, lautet die

Adresse der Gesellschaft nunmehr wie folgt: L-9943 Hautbellain, 11, Lommerscherweeg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 7. November 2013.

<i>Für Immopartner
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2013155378/15.
(130189970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Levanna Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.541.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 1 

er

 juillet 2013 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Madame Monsieur Onelio Piccinelli résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 1 

er

 juillet 2013;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 1 

er

 juillet 2013, Monsieur Pier Paolo Squillante, résidant

professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui
de leur prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Levanna Sicav
Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2013155458/18.
(130190381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

148997

L

U X E M B O U R G

Lusol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 88.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155468/9.
(130190607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 8-West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.565.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155452/10.
(130190169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Laguna Verde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.093.

EXTRAIT

Il résulte de la lettre datée du 8 novembre 2013 que Monsieur Eddy DÔME a démissionné avec effet immédiat de sa

fonction d'administrateur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2013.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2013155440/14.
(130190508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Land Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 86.792.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/11/2013.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2013155444/12.
(130190081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Lux Publicité Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 80, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 67.498.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155472/9.
(130190613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

148998

L

U X E M B O U R G

Lux Publicité, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 80, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 67.498.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155473/9.
(130190719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Lux Gare, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 167.678.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 octobre 2013

1) L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Tom Deckers en sa qualité de gérant de catégorie B, à

compter de ce jour.

2) L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de catégorie B en remplacement du gérant démissionnaire,

pour une durée indéterminée, Madame Caroline Den Tandt, née le 31 août 1968 à Leuven (Belgique), demeurant au 3
Jan Van Boendalelaan, B-3080 Tervuren (Belgique).

L'assemblée  décide,  par  ailleurs,  de  nommer  la  société  PYLOS  EUROPE  S.A.,  inscrite  auprès  du  RPM  Bruxelles

0887.623.244, avec le siège social au 16 avenue Brugmann, B-1060 Bruxelles, représentée par Monsieur Tom Deckers,
71 Vinkenlaan, B-1800 Vilvoorde, aux fonctions de gérant de catégorie A de la société.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2013155471/18.
(130190293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 7-Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.707.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155451/10.
(130190170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LGT Fund Management (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 159.463.

<i>Auszug aus den Zirkularbeschlüssen des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 19. August 2013

Am 19. August 2013 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft den folgenden Beschluss gefasst:
- Ernennung von Herrn André SCHMIT, geboren am 13. Dezember 1951 in Ettelbruck, Luxemburg, mit beruflicher

Adresse in: 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg als täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 19.
August 2013 und dies für einen unbefristeten Zeitraum.

- Unterschriftenberechtiqung: Kollektivunterschrift zu zweien
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. November 2013.

LGT Fund Management (Lux) S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2013155463/17.
(130190363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

148999

L

U X E M B O U R G

Lux Technicom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, 8, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 73.788.

Les comptes consolidés au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155474/9.
(130190369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 5-South S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155449/10.
(130190174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 4-North S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.514.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155448/10.
(130190176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 6-Hessen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.704.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155450/10.
(130190172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Naga 1 (BC) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.000.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 178.972.

<i>Extrait des décisions de l'assemblée des actionnaires de la société pris en date du 28 octobre 2013

En date du 28 Octobre 2013, les actionnaires de la Société ont pris la résolution suivante:
- Nommer la société PricewaterhouseCoopers, ayant le siège sociale 400 route d'Esch à Luxembourg, immatriculé

auprès de RCSL sous le numéro B 65.477, en tant que réviseur d'entreprise agrée jusqu'à l'assemblée générale approuvant
les comptes annuels se terminant 31 Décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013154864/15.
(130189386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2013.

149000

L

U X E M B O U R G

Lux Trade Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 1, Becher Millen.

R.C.S. Luxembourg B 80.826.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155475/9.
(130190665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 2-Resi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155446/10.
(130190180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155447/10.
(130190178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.518.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 06 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013155445/10.
(130190182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Matterhorn Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 176.442.

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 05 novembre 2013:
(i) D'accepter la démission de Madame Julia KLINGEN en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au

04 novembre 2013.

(ii) De nommer avec effet au 04 novembre 2013 et ce pour une durée illimitée Monsieur Geoffrey LIMPACH, né le

11 avril 1983 à Arlon, Belgique, résidant professionnellement au 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg en tant
que gérant de catégorie A de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Référence de publication: 2013155493/15.
(130190608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

149001

L

U X E M B O U R G

MP Trans Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 23, avenue Dr Klein.

R.C.S. Luxembourg B 146.267.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155513/9.
(130190509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

MAF Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, Place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 111.649.

Par résolutions signées en date du 31 octobre 2013, l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:
- acceptation de la démission de M. David Anderson de son mandat de membre du conseil de gérance de la Société

avec effet au 31 octobre 2013.

Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:

<i>Gérants

Mme Rosa Villalobos
M. David Harrison
M. Peter Trent
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Référence de publication: 2013155497/18.
(130190695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Milux International, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 76, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 33.691.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2013155510/10.
(130190322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Mochis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.702.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'associé de la Société, à savoir Keyroy-Comercio e Serviços Inter-

nacionais S.à r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, détentrice de 125 part sociales de
Mochis S.à r.l., a cédé la totalité de ces parts, en date du 6 novembre 2013 à la société Menado-Trading e Serviços
Internacionais S.à r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, détentrice de 12.375 parts
sociales.

Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Le Gérant

Référence de publication: 2013155496/17.
(130190250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

149002

L

U X E M B O U R G

Naja Investment S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 20.475.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155517/9.
(130190017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Morgan Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.274.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Référence de publication: 2013155512/10.
(130190116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Mercurio Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 163.633.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 1 

er

 juillet 2013 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Madame Monsieur Onelio Piccinelli résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 1 

er

 juillet 2013;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 1 

er

 juillet 2013, Monsieur Pier Paolo Squillante, résidant

professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui
de leur prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Mercurio Sicav
Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2013155502/18.
(130190379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Pacific Santa Ana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NZD 20.002,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 167.700.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 30 octobre 2013

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Fred Vleghert de ses fonctions de gérant de la Société.
L'associé unique nomme, pour une période indéterminée, Monsieur Johannes BOOTS, «Vice President Treasurer»,

né à Heerhugowaard, Pays-Bas, le 11 avril 1962, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 8-10 Avenue de
la Gare aux fonctions de gérant de la Société.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la société en date du 31 octobre 2013

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155547/17.
(130190528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

149003

L

U X E M B O U R G

Pacific Sharav S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.724.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 30 octobre 2013

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Fred Vleghert de ses fonctions de gérant de la Société.
L'associé unique nomme, pour une période indéterminée, Monsieur Johannes BOOTS, «VP Treasurer», né à Hee-

rhugowaard, Pays-Bas, le 11 avril 1962, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 8-10 Avenue de la Gare
aux fonctions de gérant de la Société.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la société en date du 31 octobre 2013

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155548/17.
(130190579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Optolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 119.230.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013155540/9.
(130190642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Orbis Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 8.462.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013155541/10.
(130190654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Michelangelo Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.254.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 1 

er

 juillet 2013 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Madame Monsieur Onelio Piccinelii résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 1 

er

 juillet 2013;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet au 1 

er

 juillet 2013, Monsieur Pier Paolo Squillante, résidant

professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui
de leur prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Michelangelo Sicav
Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2013155508/18.
(130190382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

149004

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 278.250,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 118.872.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société prises en date du 21 octobre 2013

En vertu d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 21 octobre 2013, les associés de

la société ont cédé la totalité des parts sociales qu'ils détiennent respectivement dans la société, soit 11.130 parts sociales
au total, à la société Stock Spirits Group PLC, une public limited company régie par les lois d'Angleterre, ayant son siège
social à Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0HH, Royaume-Uni, immatriculée auprès
du Registrar of Companies of England &amp; Wales sous le numéro 8687223.

En conséquence de ces transferts de parts sociales, Stock Spirits Group PLC, précitée, est désormais l'associé unique

de la société et détient onze mille cent trente (11.130) parts sociales dans la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013155535/19.
(130190632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS Europäische Gesellschaft für die Leistungs- und Koste-

noptimierung gebäudetechnischer Anlagen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 22.842.

<i>Extrait de l'assemblée générale des associés en date du 21 juni 2013

L'assemblée générale constate que la modification suivante est à faire au niveau des associés:
Changement de la dénomination de l'associé HSE Technik GmbH &amp; Co KG, HRA Darmstadt Nr. 6401 avec adresse

à D-61293 Darmstadt, 24, Dornheimer Weg

en
ENTEGA Energieeffizienz GmbH &amp; Co KG, HRA Darmstadt Nr. 6401, avec adresse à D-64293 Darmstadt, 24, Dorn-

heimer Weg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2013155536/18.
(130190199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Replay Associate, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 121.063.

Madame Régine CAILLAU, demeurant à L-1463 Luxembourg, rue du Fort Elisabeth 29, a démissionné avec effet im-

médiat de son poste d'administrateur et administrateur délégué.

THANELLO INCORPORATED dont le siège social est Road Town, Tortola, British Virgin Islands Sous le numero

526564 a démissionné de son poste d'administrateur.

ULYSS BUSINESS INC., dont le siège social est Road Town, Tortola, British Virgin Islands Sous le numero 430903 a

démissionné de son poste d'administrateur.

La société WURTH &amp; ASSOCIES SA ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 5 rue Aldringen Inscrite au registre

de Commerce et des Sociétés sous le n° B 58.177 a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2013155586/17.
(130190487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

149005

L

U X E M B O U R G

Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,

(anc. Pacific Specialised Finance Capital S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.646.

In the year two thousand thirteen, on the eighteen day of October.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CREDIT SUISSE AG, a public limited company with registered office at Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland and

registered with the Zurich Trade and Companies Register under number CH-020.3.923.540-1,

here represented by Mrs Géraldine Nucera, private employee, professionally residing at L-2740 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 18 October 2013, and

NEWSHELF 1268 PROPRIETARY LIMITED (currently in the process of changing its name to "New Atlantic Holdings

(South Africa) Proprietary Limited"), a company with registered office at c/o Société Générale, Johannesburg Branch, 160
Jan Smuts Avenue, Rosebank, 2196, Gauteng, South Africa, and registered under number 2011/010447/07,

here represented by Mrs Géraldine Nucera, private employee, professionally residing at L-2740 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 18 October 2013.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Pacific Specialised Finance Capital S.A. (hereinafter

the "Company"), a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 179.646, incorporated on 12 August 2013 pursuant to a deed of Maître
Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2501 of 9 October 2013. The articles of incorporation of the Company have been amended on the date hereof
by two deeds of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders, representing the whole share capital of the Company, unanimously require the notary to act the

following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to change the name of the Company into "Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg)

S.A.".

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend the corporate object (Article 3) of the Company so that it reads as follows:

3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administer, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company  or  any  company  belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  "Connected
Companies"), it being understood that the Company will only enter into a transaction in accordance with the requirements
of all relevant laws and regulations, including the requirements of any regulated activity in the financial sector. On an
ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected
Companies. 3.3 The Company may in particular enter into the following transactions it being understood that the Com-
pany will only enter into a transaction in accordance with the requirements of all relevant laws and regulations, including
the requirements of any regulated activity in the financial sector:

3.3.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, con-
vertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;

3.3.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.3.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property, assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of any applicable legal provision; and

149006

L

U X E M B O U R G

3.3.4 to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-

keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.

3.4 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or

operation  and  in general,  all  transactions which  are  necessary or useful to fulfill its objects  as well  as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to convert the 417,306 (in words: four hundred seventeen thousand three hundred six) out

of the 917,306 (in words: nine hundred seventeen thousand three hundred six) existing ordinary shares having a nominal
value of ZAR 1.- (in words: one South African Rand) each held by CREDIT SUISSE AG into (i) 1 (in words: one) B
Preference Share having a nominal value of ZAR 1.- (in words: one South African Rand) and having the features set out
in the articles of association of the Company and (ii) to allocate the remaining ZAR 417,305 (in words: four hundred
seventeen thousand three hundred five South African Rand) to the share premium account of the Company.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by ZAR 1.- (in words: one South African Rand)

from its amount, further to the third resolution above, of ZAR 500,001.- (in words: five hundred thousand one South
African Rand) to ZAR 500,002.- (in words: five hundred thousand two South African Rand) by issuing to CREDIT SUISSE
AG 1 (in words: one), B Preference Share with a nominal value of ZAR 1.- (in words: one South African Rand) and having
the features set out in the articles of association of the Company, together with a share premium of ZAR 1,082,693.- (in
words: one million eighty-two thousand six hundred ninety-three South African Rand), such share premium being allocated
pari passu to the 2 (in words: two) B Preference Shares referred in such resolutions, in consideration for a contribution
in cash

<i>Subscription and payment

CREDIT SUISSE AG decides to subscribe to the so issued 1 (in words: one) B Preference Share in the Company having

a nominal value of ZAR 1.- (in words: one South African Rand), together with a share premium of ZAR 1,082,693 (in
words: one million eighty-two thousand six hundred ninety-three South African Rand). Such B Preference Share is entirely
paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of ZAR 1,082,694.- (in words: one million eighty-two thousand
six hundred ninety-four South African Rand). The global contribution of ZAR 1,082,694.- (in words: one million eighty-
two thousand six hundred ninety-four South African Rand) is allocated as follows: ZAR 1.- (in words: one South African
Rand) is allocated to the share capital of the Company and ZAR 1,082,693.- (in words: one million eighty-two thousand
six hundred ninety-three South African Rand) are allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend the financial year of the Company so this runs from the first day of December

and ends on the last day of November of each year and to amend the term of the current financial year which began on
the date of the incorporation of the Company and will end on the last day of November 2013.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to restate the articles of association of the Company and to replace the French translation

of the Company's articles of association with a German translation of the Company's articles of association.

Henceforth, the articles of association of the Company shall read as follows:

Preliminary chapter - Definitions

In addition to the terms defined elsewhere in the present articles of association (the "Articles"), the following terms

shall have the meaning assigned in this Preliminary Chapter.

"1915 Law" means the amended Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies.
"Available Amount" means, in accordance with article 72-1 and article 72-2 (as far as the interim dividends are con-

cerned) of the 1915 Law, the funds equal to the amount of the profits at the end of the previous financial year and any
profits carried forward and any amounts drawn from reserves which are available for that purpose, less any losses carried
forward and sums to be placed in a reserve in accordance with the 1915 Law and these Articles, plus / minus (as the case
may be), in relation to interim dividends, any profits or losses accrued in the current financial year, as shown in the relevant
interim financial statements.

"A PESCs" means the class A redeemable shares designated as a A preferred equity stock certificate ("A PESC") in

these Articles and any Shareholder Agreement (including any schedules thereto and the A PESCs Terms and Conditions).

"A PESCs Shareholders" means any holder of A PESCs.

149007

L

U X E M B O U R G

"A PESCs Terms and Conditions" means the terms and conditions of the A PESCs as set out in these Articles, as may

be agreed in any Shareholder Agreement as well any document amending such Shareholder Agreement containing the
terms and conditions of the A PESCs.

"B Preference Share" means a Share designated as a B Preference Share in these Articles and any Shareholder Agree-

ment.

"Board of Directors" means the Board of Directors of the Company appointed in accordance with these Articles.
"Business Day" has the meaning ascribed to such term in any Shareholder Agreement or PESCs Terms and Conditions.
"Calculation Agent" means Credit Suisse Specialised Investco (Luxembourg) S.A., unless the Company elects to appoint

another entity as Calculation Agent.

"Clause" means a clause of these Articles.
"Company Register" has the meaning ascribed to such term in Clause 7.1.
"Day Count Fraction" means the day count fraction specified as such in the PESCs Terms and Conditions.
"Director" means any member of the Board of Directors.
"Dividend Declaration Date" means in respect of the relevant PESC, the Dividend Declaration Date specified by the

general meeting of the Shareholders in accordance with Clause 20.2 and the PESCs Terms and Conditions.

"Dividend Payment Date" means the Dividend Payment Date specified by the general meeting of the Shareholders in

accordance with Clause 20.2 and the PESCs Terms and Conditions or, if no Dividend Payment Date is specified, the last
day of each Dividend Period.

"Dividend Period" means in respect of a Dividend Payment Date, the period from (and including) the immediately

previous Dividend Payment Date to (but excluding) the current Dividend Payment Date, provided, however that the first
Dividend Period will commence on the PESCs Issue Date and terminate on the day preceding the first Dividend Payment
Date following the PESCs Issue Date.

"Dividend Rate" means the dividend rate (if any) specified in the PESCs Terms and Conditions for the relevant PESCs

Class.

"Ordinary Shares" means a Share designated as an Ordinary Share in these
Articles and any Shareholder Agreement.
"Ordinary Shareholder" means any holder of Ordinary Shares.
"Outstanding PESCs" means any PESC which has not been redeemed in accordance with Clause 10 and the PESCs

Terms and Conditions

"PESC Issue Price" means the issue price in respect of each PESC specified in the PESCs Terms and Conditions.
"PESC Notional Amount" means the notional amount in respect of a PESC consisting of the par value plus the premium

in respect of such PESC, specified in the relevant PESCs Terms and Conditions.

"PESCs" means any class of non-voting redeemable shares designated as a preferred equity stock certificate ("PESC")

in these Articles and any Shareholder Agreement (including any schedules thereto and any PESCs Terms and Conditions),
excluding the A PESCs.

"PESCs Adjustment Event" means any one of the events referred to as an Adjustment Event in the PESCs Terms and

Conditions.

"PESCs Capped Amount" means in respect of the Preference Dividends and/or the PESCs Redemption Amount, the

amount defined as the Capped Amount in the PESCs Terms and Conditions.

"PESCs Class" means a PESCs Tranche together with any further PESCs Tranche(s) which are (i) expressed to be

consolidated and form a single series; and (ii) terms and conditions of which are identical in all respects except for their
respective PESCs Issue Dates and PESC Notional Amounts.

"PESCs Issuer Redemption Notice" a notice in writing, duly completed and delivered, as contemplated in Clause 10.2

and the PESCs Terms and Conditions.

"PESCs Early Redemption Amount" has the meaning ascribed to the term "Early Redemption Amount" in the PESCs

Terms and Conditions.

"PESCs Early Redemption Date" means the date specified as such in a PESCs Issuer Redemption Notice, in a PESCs

Shareholder Redemption Notice or in a PESCs Termination Notice.

"PESCs Issue Date" means in relation to a PESCs Tranche, the date specified as such in the PESCs Terms and Conditions

or in Clause 5 (when indicated therein).

"PESCs Redemption Amount" means the redemption amount agreed in the PESCs Terms and Conditions as the price

at which the redemption of the PESCs belonging to a specific PESCs Class shall occur pursuant to Clause 10.

"PESCs Redemption Date" means the date agreed in any Shareholder Agreement and in any PESCs Terms and Con-

ditions as the date on which the redemption of PESCs belonging to a specific PESCs Class shall occur pursuant to Clause
10.

149008

L

U X E M B O U R G

"PESCs Redemption Events" means those events (including, but not limited to Termination Events (as such term is

defined in the PESCs Terms and Conditions)) upon the occurrence of which the PESCs may be redeemed as shall be
agreed upon between the relevant PESCs Shareholders and the Company in the PESCs Terms and Conditions.

"PESCs Reference Portfolio Asset" means the portfolio of instruments underlying a PESCs Class, together with any

security provided in respect of such underlying instruments, as specified in the PESCs Terms and Conditions; for the
avoidance of doubt, the PESCs Reference Portfolio Asset may be comprised of a single underlying instrument.

"PESCs Shareholder" means any holder of PESCs.
"PESCs Shareholder Redemption Notice" means a notice in writing, duly completed and delivered, as contemplated

by the PESCs Terms and Conditions, by a PESCs Shareholder to the Company whereby a PESCs Shareholder requires
the Company to redeem its PESCs.

"PESCs Termination Costs" means the costs incurred by the Company in respect of a redemption of the PESCs, as

specified in the PESCs Terms and Conditions.

"PESCs Termination Notice" means a notice in writing, duly completed and delivered, as contemplated in the PESCs

Terms and Conditions which may be delivered on and at any time after the occurrence of a Termination Event (as such
term is defined in the PESCs Terms and Conditions) in relation to a PESCs Class.

"PESCs Terms and Conditions" means the terms and conditions of the PESCs as set out in these Articles, as may be

agreed in any Shareholder Agreement as well any document amending such Shareholder Agreement containing the terms
and conditions of the relevant PESCs Class.

"PESCs Tranche" means in relation to any particular PESCs Class, all PESCs, the terms and conditions of which are

identical in all respects and are issued or to be issued on the same PESCs Issue Date.

"Preference Dividend" means the term defined in Clause 20.3.1 and Shareholder Agreement and PESCs Terms and

Conditions where relevant.

"Preference Shareholder" means any holder of Preference Shares.
"Preference Shares" means the B Preference Shares and any additional classes of Shares designated as Preference Shares

in these Articles and any Shareholder Agreement (including any schedule thereto).

"Shareholder Agreement" means any shareholder agreement entered into from time to time between the Company

and its Shareholders in relation to the Company.

"Shareholders" means the Ordinary Shareholders, the Preference Shareholders, the A PESCs Shareholders and the

PESCs Shareholders, as well as any other holder of Shares in the Company from time to time and "Shareholder" means
any of them.

"Shares" means any share issued from time to time by the Company and being namely either an Ordinary Share, a

Preference Share, an A PESC or a PESC.

"Specified Currency" has the meaning ascribed to such term in any Shareholder Agreement or PESCs Terms and

Conditions.

"Voting Shareholder" means any holder of Ordinary Shares and/or Preference Shares, and/or A PESCs.
"Voting Shares" means the Ordinary Shares, the Preference Shares and the A PESCs.

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Name
1.1 The Company is hereby formed as a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) governed by

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (and in particular, the 1915 Law) and by these Articles.

1.2 The Company exists under the name of "Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A.".

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg-City (Grand Duchy of

Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Com-

pany's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality, which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, including in

particular but not limited to a branch in Switzerland.

149009

L

U X E M B O U R G

3. Object.
3.1 The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administer, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company  or  any  company  belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  "Connected
Companies"), it being understood that the Company will only enter into a transaction in accordance with the requirements
of all relevant laws and regulations, including the requirements of any regulated activity in the financial sector. On an
ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected
Companies.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions it being understood that the Company will

only enter into a transaction in accordance with the requirements of all relevant laws and regulations, including the
requirements of any regulated activity in the financial sector: 3.3.1 to borrow money in any form or to obtain any form
of  credit  facility  and  raise  funds  through,  including,  but  not  limited  to,  the  issue  of  bonds,  notes,  promissory  notes,
certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or other-
wise;

3.3.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.3.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property, assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of any applicable legal provision; and

3.3.4 to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-

keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.

3.4 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or

operation and  in  general, all transactions  which  are necessary  or useful to fulfill  its objects  as well  as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, authorized capital, form of shares, redemption of shares

5. Capital.
5.1 The share capital of the Company may be represented by Ordinary Shares, Preference Shares, A PESCs and/or

PESCs, with a par value of ZAR 1 (in words: one South African Rand) each.

5.2 The Shares are in registered form.
5.3 The share capital is fixed at ZAR 500,002 (in words: five hundred thousand two South African Rand), divided into

2 (in words: two) B Preference Shares and 500,000 (in words: five hundred thousand) Ordinary Shares with a par value
of ZAR 1 (in words: one South African Rand) each.

5.4 Each Share is indivisible.
5.5 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.

5.6 In addition to the share capital, the Company may have one or several free share premium accounts into which

any premium paid on any Share shall be allocated to the relevant class of Shares. The special premium reserve is at the
free disposal of the Shareholders and the Board of Directors, as the case may be, and shall be available for distribution
to the holders of the relevant Shares in relation to a decrease of the share capital, the repurchase of own shares, distri-
bution as dividends, liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a reimbursement of share premium or
reserve without prejudice to any provisions contained in any Shareholder Agreement, any A PESCs Terms and Conditions,
or any PESCs Terms and Conditions.

6. Authorized capital.
6.1 The Company shall have an authorized share capital of an aggregate amount of ZAR 10,003,500,000 (in words: ten

billion three million five hundred thousand South African Rand) represented either by Ordinary Shares, Preference Shares,

149010

L

U X E M B O U R G

A PESCs or PESCs as determined by the Board of Directors in accordance with Clause 6.2 (the "Authorized Share
Capital").

6.2 Within the limits of the Authorized Share Capital, the Board of Directors is authorized and empowered to realize

any increase of the share capital, in one or several installments, by issuing either Ordinary Shares, Preference Shares, A
PESCs or PESCs, voting or non-voting as determined by the Board of Directors only against payment in cash or in kind,
by contribution of claims, by capitalization of reserves or in any other manner determined in any Shareholder Agreement.

6.3 The authorization granted in this Clause 6 to the Board of Directors to increase the share capital of the Company

within the limits of the Authorized Share Capital will expire 5 (five) years after the publication of the articles of association
of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and can be renewed by the extraordinary
meeting of Shareholders in accordance with the applicable legal provisions.

6.4 The Board of Directors may limit or cancel the Shareholders' preferential rights to subscribe for the Shares and

may issue the Shares to such persons and at such price with or without a share premium and paid up by contribution in
kind or for cash or by incorporation of claims or capitalisation of reserves or in any other way as the Board of Directors
may determine.

6.5 The Board of Directors is authorized to do all things necessary to amend Clause 5 of the present Articles in order

to record the change of share capital following any increase pursuant to this Clause 6. The Board of Directors is empo-
wered to take or authorize the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with
the 1915 Law. Furthermore, the Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the
Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Or-
dinary Shares, Preference Shares, A PESCs or PESCs or to do all things necessary to amend Clause 5 of the Articles in
order to record the change of share capital following any increase pursuant to this Clause 6, including mentioning that
the shares issued pursuant to such increase do not carry voting rights, where applicable.

7. Register.
7.1 The Company shall keep at its registered office a register (the "Company Register") of the Shares in issue in the

Company, which register must specify:

7.1.1 the precise designation of each Shareholder and the number of Shares held by him;
7.1.2 the payments made on the Shares;
7.1.3 transfers and the dates thereof;
7.1.4 any amendments made to the deed of incorporation of the Company.
7.2 Certificates evidencing the registration of holders of Shares in the Company in the Company Register may be

delivered to each Shareholder.

7.3 In addition to the Company Register, the Company may keep, for any Shares, a register of A PESCs Shareholders,

a register of PESCs Shareholders, a register of Preference Shareholders and a register of Ordinary Shareholders (the
"Local Registers") in any foreign country in which the Company has an office (including share transfer or share registration
office) or a branch.

8. Repurchase of shares. The Company may repurchase its own Shares within the limits set by the 1915 Law and these

Articles.

9. Redemption of preference shares. Provided that such redemption is permitted in any Shareholder Agreement and

made within the limits set by the 1915 Law and these Articles, the Company may redeem the Preference Shares on the
terms and conditions laid down in any Shareholder Agreement.

10. Redemption of PESCs.
10.1 On the PESCs Redemption Date:
10.1.1 each PESC will, subject to the 1915 Law, these Articles and the PESCs Terms and Conditions, be redeemed in

cash in the Specified Currency or in kind as provided by Clause 10.6 below, by the Company in accordance with article
49-8 of the 1915 Law;

10.1.2 in addition to the share premium paid on the PESCs, the Company may use the proceeds of a new issue of

shares made with a view to use such proceeds in order to redeem the PESCs, or the share premium existing on the
Ordinary Shares or Preference Shares, in order to redeem the PESCs;

10.1.3 the Company shall be obliged to redeem the relevant PESCs for the aggregate PESCs Redemption Amount in

respect of all PESCs to be redeemed, subject to Clause 10.1.4; and

10.1.4 the payment of the PESCs Redemption Amount as contemplated in Clause 10.1.3 shall be subject to the PESCs

Redemption Amount not exceeding the PESCs Capped Amount.

10.2 Early Redemption Rights of the Company
The Company may elect to redeem all or, with the consent of the holders of the PESCs Class, any of such PESCs Class

at any time on or before the PESCs Redemption Date and such early redemption right shall be exercised by the Company
by serving a notice on the PESCs Shareholder pursuant to these Articles and the applicable PESCs Terms and Conditions.

10.3 Redemption Events

149011

L

U X E M B O U R G

The events which shall constitute PESCs Redemption Events (including, but not limited to Termination Events (as such

term is defined in the PESCs Terms and Conditions)) shall be agreed upon between the relevant PESCs Shareholders and
the Company in the PESCs Terms and Conditions.

10.4 Adjustments
10.4.1 Subject to the 1915 Law and as provided for in the relevant PESCs Terms and Conditions, a PESCs Shareholder

may request an adjustment of the PESCs Redemption Amount, or any term of the PESCs Class which may be adjusted
in accordance to the PESCs Terms and Conditions at any time on or before the PESCs Redemption Date in relation to
a PESCs Class with such adjustment being applicable to all PESCs Shareholders of the particular PESCs Class involved.

10.4.2 The events which shall constitute a PESCs Adjustment Event in which a PESCs Shareholder may act in accordance

with Clause 10.4.1 above shall be agreed upon by the relevant PESCs Shareholder and the Company in the PESCs Terms
and Conditions.

10.5 Early Redemption Amounts
10.5.1 For the purposes of this Clause 10.5, the PESCs will be redeemed on the PESCs Early Redemption Date at the

PESCs Early Redemption Amount calculated as follows:

(a) an amount equivalent to the PESCs Notional Amount or an amount calculated in the manner specified in the PESCs

Terms and Conditions;

(b) less any PESCs Termination Costs.
10.5.2 The Company shall be obliged to redeem the relevant PESCs Class for the aggregate PESCs Early Redemption

Amount referred to in Clause 10.5.1 above on the PESCs Early Redemption Date in respect of the PESCs Class being
redeemed, subject to the PESCs Early Redemption Amount not exceeding the PESCs Capped Amount.

10.5.3 Where such calculation is made for a period which is not a whole number of years, it shall be calculated on the

basis of the actual days elapsed divided by 365, or such other calculation basis as may be specified in the PESCs Terms
and Conditions. 10.6 Alternative Discharge

10.6.1 If authorised in the PESCs Terms and Conditions, the PESCs Redemption Amount (or any portion thereof) may

fully be discharged by the Company delivering in specie to the holder of a PESCs Tranche (i) any of the underlying
instruments constituting the PESCs Reference Portfolio Asset, or (ii) any asset acquired by the Company with the pro-
ceeds of any such underlying instrument, or (iii) any asset acquired by the Company in settlement of any amount payable
to the Company under any such underlying instrument, on a pro-rata basis.

10.6.2 If authorised in the PESCs Terms and Conditions, should the Company not have received, on the PESCs Re-

demption  Date,  in  cash  (for  any  reason  whatsoever,  including  that  the  PESCs  Redemption  Date  is  a  PESCs  Early
Redemption Date), an amount equivalent to the outstanding principal under the underlying instruments comprising the
PESCs Reference Portfolio Asset, then the PESCs Redemption Amount shall be fully discharged by the Company paying
or distributing to the PESCs Shareholders, in specie, all of the Company's rights to (i) the underlying instruments com-
prising  the  PESCs  Reference  Portfolio  Asset,  or  (ii)  all  assets  acquired  by  the  Company  with  the  proceeds  of  such
underlying instruments, or (iii) all assets acquired by the Company in settlement of the amounts payable to the Company
under such underlying instruments, subject to Clause 10.7 below, on a pro-rata basis.

10.7 The obligation of the Company to discharge the PESCs Redemption Amount on the PESCs Redemption Date or

on the PESCs Early Redemption Date shall be subject to:

10.7.1 the Company having received payment from the holder of any applicable PESCs Termination Costs on the PESCs

Early Redemption Date or on the PESCs Redemption Date (as the case may be); or

10.7.2 the holder providing the Company with an indemnity and security for such indemnity, each to the satisfaction

of the Company in relation to any such PESCs Termination Costs.

For the avoidance of doubt, the Company shall be entitled to withhold the payment for the PESCs Redemption Amount

until such time the requirement in Clause 10.7.1 or Clause 10.7.2 has been satisfied.

10.8 The in specie distributions contemplated by Clause 10.6.1 and 10.6.2 shall be effected in the manner set forth in

the PESCs Terms and Conditions.

10.9 Notwithstanding any provisions to the contrary, the Company shall neither be entitled nor obliged to redeem

the PESCs prior to the PESCs Redemption Date other than in the circumstances contemplated in this Clause 10 and in
accordance with the 1915 Law.

11. Redemption of a PESCs. Provided that such redemption is permitted in any A PESCs Terms and Conditions and

made within the limits set by the 1915 Law and these Articles, the Company may redeem the A PESCs on the terms and
conditions laid down in any A PESCs Terms and Conditions.

12. Transfer of shares. Unless otherwise is provided in any Shareholder Agreement, in the A PESCs Terms and Con-

ditions and in the PESCs Terms and Conditions, the Shares will be transferable in accordance with the 1915 Law.

149012

L

U X E M B O U R G

Chapter III. - Management, board of directors, independent auditor

13. Management.
13.1 Unless the Company has only one Shareholder, the Company is managed by at least three Directors (collectively,

the "Board of Directors" and each director, a "Director") appointed by a resolution of the general meeting of Shareholders.
In case the Company has only one Shareholder, the Board of Directors can consist of one Director. The majority of
Directors shall be resident in Luxembourg.

13.2 The Directors need not to be Shareholders.
13.3 Each Director shall be appointed by the general meeting of Shareholders for a term not exceeding six years.
13.4 A Director may be re-elected.
13.5 The Directors may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the Shareholder(s).
13.6 A legal entity may be a Director (a "Corporate Director"), in which case it must designate a permanent repre-

sentative to perform that role in its name and on its behalf. The revocation by a Corporate Director of its representative
is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.

13.7 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting
of Shareholders which will be asked to ratify such election.

13.8 In the event that a Director is appointed to replace a Director before the end of that Director's term of office,

the Director appointed shall serve for the remainder of the term of office of the Director he replaces subject as provided
in the 1915 Law.

14. Meetings of the board of directors.
14.1 In case of plurality of Directors, the meetings of the Board of Directors are convened by any Director.
14.2 The Board of Directors shall elect a Chairman from among its members. If the Chairman is unable to be present,

he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

14.3 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. Meetings shall be

convened with at least twenty-four (24) hour advance notice, unless in the event of an emergency. In cases where all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

14.4 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of the Directors (including the

Chairman) are physically present in Luxembourg. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by
appointing in writing, by telegram or telefax another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director
to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

14.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

14.6 All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg.
14.7 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that a majority of parti-

cipating Directors is physically present in Luxembourg, that each participating Director is able to hear and to be heard
by all other participating Directors whether or not using this technology, and each participating Director shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

14.8 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Directors

in person, with the majority of such Directors signing such circular resolutions in Luxembourg. Such approval may be in
a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same
effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

14.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the Board of Directors

or by any two Directors. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

14.10 In case the Company has only one director, Clauses 14.8 and 14.9 shall not apply and decisions of the sole

Director shall be recorded in writing and signed by the sole Director.

14.11 Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting

with that of the Company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes
of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting of Shareholders, before
any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may
have had an interest conflicting with that of the Company.

14.12 In derogation of Clause 14.11 above, if the Company has only one Director, transactions made between the

Company and the sole Director having an interest conflicting with that of the Company only need to be mentioned in
the written record of the decisions.

14.13 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors of

the Company or of the sole Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

149013

L

U X E M B O U R G

15. General powers of the board of directors.
15.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by the 1915 Law to the general meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors.

15.2 The Board of Directors may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
15.3 The Board of Directors will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

16. Representation of the Company.
16.1 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the signature of the sole Director,

or in case the Company has three or more Directors, the signatures of any two (2) Directors together or by the single
signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors, but only within the limits
of such power.

16.2 Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case a daily manager has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the daily manager, but only within the limits of such power.

17. Independent auditor(s).
17.1 The Company is supervised by one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree).
17.2 The general meeting of Shareholders appoints the independent auditor(s) and determines their number, their

remuneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In case the
external independent auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected
for six (6) years from the date of their election.

17.3 The independent auditors are re-eligible.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

18. Powers of the general meeting of shareholders - Votes.
18.1 The Voting Shares carry voting rights.
18.2 The PESCs do not carry any voting rights.
18.3 The PESCs Shareholder(s) are nevertheless entitled to vote in accordance with the 1915 Law and in particular at

every general meeting of Shareholders called upon to deal with the following matters:

18.3.1 the issue of new shares carrying preferential rights other than pursuant to the Authorized Share Capital;
18.3.2 the determination of the preferential cumulative dividend attaching to the PESCs;
18.3.3 the conversion of PESCs into Voting Shares;
18.3.4 the reduction of the capital of the Company other than pursuant to a redemption;
18.3.5 any change to the Company's corporate object;
18.3.6 the issue of convertible bonds;
18.3.7 the dissolution of the Company before its term;
18.3.8 the conversion of the Company into a company of another legal form;
18.3.9 any matter which may affect the rights of the PESCs Shareholders;
18.3.10 a change to the nationality of the Company;
18.3.11 any change to the commitments of the Shareholders;
18.3.12 any increase in the Authorized Share Capital to the extent that it relates to the PESCs.
18.4 With respect to those decisions to be taken by the general meeting of Shareholders concerning the matters listed

under Clause 18.2 above, the PESCs Shareholders shall have the same voting rights as the Voting Shareholders at all
meetings.

18.5 Save as set forth above where PESCs Shareholders have voting rights, no account shall be taken of PESCs in

determining the conditions as to quorum and majority at the general meeting of Shareholders.

18.6 For all meetings of Shareholders the following rules shall apply:
18.6.1 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns.

Each Shareholder has voting rights commensurate with the voting rights attached to its Shares.

18.6.2 A Shareholder may be represented at a general meeting of Shareholders by appointing in writing (or by fax or

e-mail or any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

18.6.3 The Board of Directors shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in

the 1915 Law.

18.6.4 The annual general meeting of Shareholders of the Company shall be held on the last Friday in May of each year

(unless such day is a public holiday, in which case on the next following business day) at 2:00 p.m. CET.

149014

L

U X E M B O U R G

18.6.5 The Board of Directors and the independent auditor may convene a general meeting of the Shareholders. They

shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of
the capital require this in writing with an indication of the agenda.

18.6.6 Convening notices for every general meeting of the Shareholders shall contain the agenda and shall take the

form of announcements published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight
days before the general meeting of the Shareholders to registered Shareholders, but no proof need be given that this
formality has been complied with. The convening notices may be made only by registered letters.

18.6.7 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

18.6.8 The Shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These must
comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are trans-
mitted in a continuing way.

Chapter V. - Financial year, distribution of profits

19. Financial year.
19.1 The financial year of the Company begins on the first day of December and ends on the last day of November of

each year or as agreed from time to time in any Shareholder Agreement (the "Financial Year"). The Shareholders may
shorten the term of the Financial Year at any time.

19.2 At the end of each Financial Year, the Company's accounts are established by the Board of Directors and the

Board of Directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

19.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

20. Distribution rights of shares.
20.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

20.2 After allocation to the legal reserve as prescribed in Clause 20.1 above, the general meeting of Shareholders will

determine, in accordance with the 1915 Law and these Articles, the appropriation and distribution of net profits and
distributable reserves. When declaring such dividends, the Shareholders may decide that such dividends are paid in one
or more installments and they may also make the payment of such dividends or installments subject to such conditions
as they may determine. If the payment of a dividend, or of an installment, is subject to a condition, then the Board of
Directors, or any person delegated to this effect by the Board of Directors shall verify whether or not the conditions for
the full payment of the dividend or installment have been satisfied and, if applicable, instruct the full or partial payment of
such dividend or installment in accordance with the decision of the Shareholders. Except where otherwise provided for
in Clause 20.3 below or in any Shareholder Agreement, no Shareholder shall have an entitlement to a dividend that has
not been paid out, or not been paid out in full and any such unpaid dividend (or part of such dividend) shall be automatically
allocated to the distributable reserves of the Company without the need for any further decision in this respect to be
taken by the Shareholders. Any entitlement of a Shareholder to a declared, but unpaid dividend shall lapse if the relevant
Share is redeemed.

The Board of Directors may resolve to pay interim dividends, which for the avoidance of doubt may take place on a

quarterly basis, in accordance with the terms prescribed by the 1915 Law and Clause 20.1 above.

20.3 Dividend rights of the PESCs
20.3.1 In accordance with the general conditions set forth in Clause 20.1 above, and the PESCs Terms and Conditions

and provided that there are Available Amounts and provided the allocation of such profits has been decided upon either
at the general meeting of the Shareholders, or by the Board of Directors, in accordance with the 1915 Law, each PESCs
shall confer upon its holder the right to receive a cumulative preference dividend (a "Preference Dividend"). For the
avoidance of doubt, in accordance with Clause 20.2 and the 1915 Law, the Board of Directors or general meeting of the
Shareholders shall resolve to pay quarterly dividends or interim dividends to the PESCs Shareholders and may pay Pre-
ference Dividends at its option during the relevant quarterly period, in accordance with the general conditions set forth
in 20.2 above and provided that there are Available Amounts.

20.3.2 Each PESCs Shareholder shall be entitled to receive, in accordance with Clause 20.3.1, a Preference Dividend

in priority to the payment of any dividend to the holders of Preference Shares, A PESCs and Ordinary Shares and ac-
cordingly, no dividend shall be paid to any holder of Preference Shares, A PESCs and Ordinary Shares for so long as any
Preference Dividend that is payable to a PESCs Shareholder is in arrears or unpaid.

20.3.3 The entitlement of each PESCs Shareholder vis-à-vis others PESCs Shareholders, to a Preference Dividend shall

rank as provided for in the PESCs Terms and Conditions and/or any Shareholder Agreement (where applicable).

20.3.4 The Preference Dividends payable on PESCs shall be calculated, declared and paid as follows:
(a) each PESCs shall confer upon the PESCs Shareholder the right to have the Preference Dividend declared and paid

out of the profits of the Company or reserves available for distribution to the Shareholders as a preference dividend;

149015

L

U X E M B O U R G

(b) a Preference Dividend shall be declared in accordance with Clause 20.2 on or before each applicable Dividend

Declaration Date and each Preference Dividend shall be payable by the Company on or before the Dividend Payment
Date or such other prior date in the sole discretion of the Company;

(c) For the purposes of calculating the Preference Dividend, applicable as per the relevant PESCs Terms and Conditions,

and to be declared on or before each Dividend Declaration Date, the Preference Dividend shall be calculated by the
Calculation Agent in arrears with reference to the relevant Dividend Declaration Date by the application of the formula
or the features referred to in the PESC Terms and Conditions; and

(d) the amount of the Preference Dividend to be declared as contemplated in Clause 20.3.4(b) above shall not exceed

the PESCs Capped Amount, subject to the provisions of the PESCs Terms and Conditions.

20.4 Each Preference Dividend shall become payable in cash on the relevant Dividend Payment Date or in accordance

with Clause 10.6 above provided that the Company has Available Amounts to pay the relevant Preference Dividend.

20.5 The dividend entitlement of the Ordinary Shareholder ranks behind the dividend entitlement of all other Share-

holders.

20.6 Dividend rights of the A PESCs
20.6.1 In accordance with the general conditions set forth in Clause 20.1 and the A PESCs Terms and Conditions, each

A PESC shall confer upon the A PESCs Shareholder the right to receive a preference cash dividend, as provided in the A
PESCs Terms and Conditions.

20.6.2  The  dividend  entitlement  of  an  A  PESCs  Shareholder  ranks  behind  the  dividend  entitlement  of  the  PESCs

Shareholders and the Preference Shareholder, but in priority to the dividend entitlement of the Ordinary Shareholders.

21. Additional preference dividends.
21.1 In accordance with these Articles, the 1915 Law, and the PESCs Terms and Conditions, the Board of Directors

or  the  general  meeting  of  the  Shareholders  may  resolve  to  pay  additional  dividends  to  the  PESCs  Shareholders  (an
"Additional Preference Dividend") pursuant to Clause 20.2 above and this Clause 21.

21.2 Subject to the PESCs Terms and Conditions, should the Company not have received an equivalent amount to any

interest amount scheduled for payment under any underlying instrument constituting the PESCs Reference Portfolio Asset
on or before the date corresponding with the Dividend Payment Date and in full, the amount of each Preference Dividend
scheduled for payment on that Dividend Payment Date on each applicable Outstanding PESC shall proportionally be
reduced by the amount of such unreceived interest. This reduction, however, may not result in the Preference Dividend
being less than the Preference Dividend calculated pursuant to Clause 20.3.4(c) and Clause 20.3.4(d) and will not duplicate
any effective reduction of the Preference Dividend in making the calculation contemplated by Clause 20.3.4(c) and 20.3.4
(d).

21.3 Should the Company receive any interest payment on account of unreceived interest contemplated in Clause

21.2 above or additional interest by reason of non-receipt of such income on or before the redemption of the applicable
Outstanding PESCs, each such Outstanding PESC shall confer upon the holder the right to be paid out of the profits or
other funds of the Company available for distribution to the Shareholders an Additional Preference Dividend equal to a
proportionate amount of the interest payment received by the Company.

21.4 Each Additional Preference Dividend shall be due for payment as provided in the PESCs Terms and Conditions.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, liquidation.
22.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

22.2 The Company may be put into dissolution by a decision of the general meeting of Shareholders taken pursuant

to the same majority and voting requirements as for the amendment of the Articles.

22.3 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators appointed by

the general meeting of Shareholders.

22.4 After (i) payment of all the debts and liabilities of the Company and (ii) constitution of the necessary provisions

for payment of taxes and the remaining charges and expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be
distributed with priority to the PESCs Shareholders, secondly to the Preference Shareholders, and thirdly to the A PESCs
Shareholders in accordance with these Articles and any Shareholder Agreement. The Ordinary Shareholders, shall, ho-
wever, retain a full participation right to any liquidation proceeds ranking behind the PESCs Shareholders, the Preference
Shareholders and the A PESCs Shareholders.

22.5 The ranking with regards to the entitlement to receive net liquidation proceeds between PESCs Shareholders of

different PESCs Classes is determined by the PESCs Terms and Conditions and/or any Shareholder Agreement. If this is
not determined therein, the PESCs Shareholders of different PESCs Classes will rank pari passu as to the entitlement to
receive net liquidation proceeds.

Chapter VII. - Miscellaneous

23. Applicable law. All matters not dealt with in these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.

149016

L

U X E M B O U R G

24. Language. These Articles are drawn up in English and are followed by a translation into German. In case of diver-

gence between the English text and the German translation, the English text shall prevail."

<i>Estimate of costs

The above-named parties has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at one thousand eight hundred
euros (EUR 1,800).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, represented as stated above, all of whom are known to the

notary, by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the
notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Am achtzehnten Oktober des Jahres zweitausenddreizehn.
Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Erschien:

CREDIT SUISSE AG, eine Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftsitz Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Schweiz, eingetragen im

Handelsregisteramt Zurich unter Nummer CH-020.3.923.540-1,

hier vertreten durch Dame Géraldine Nucera, Privatbeamtin, geschäftsansässig in L-2740 Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, aufgrund einer am 18. Oktober eingereichten privatschriftlichen Vollmacht.

NEWSHELF 1268 PROPRIETARY LIMITED (derzeit im Prozess den Firmenamen in "New Atlantic Holdings (South

Africa) Proprietary Limited" zu ändern), eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz c/o Société Générale, Johannesburg Branch,
160 Jan Smuts Avenue, Rosebank, 2196, Gauteng, Südafrika, den Gesetzen Südafrikas unterliegend und unter Nummer
2011/010447/07 eingetragen,

hier vertreten durch Dame Géraldine Nucera, Privatbeamtin, geschäftsansässig in L-2740, Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, aufgrund einer am 18. Oktober 2013 eingereichten privatschriftlichen Vollmacht.

Die durch den Vertreter der Erschienen und den unterzeichneten Notar mit ne variatur paraphierten Vollmachten,

sollen dieser Urkunde beigefügt bleiben und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht werden.

Die Erschienenen sind die Aktionäre (nachstehend die "Aktionäre") von Pacific Specialised Finance Capital S.A. (nach-

stehend die "Gesellschaft"), eine Aktiengesellschaft, société anonyme, unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxem-
burg  existierend,  mit  Gesellschaftsitz  46A,  Avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 179.646, gegründet am zwölften August
des Jahres 2013, infolge einer notariellen Urkunde von Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, die
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nummer 2501 vom 9. Oktober 2013 publiziert wurde.

Die Gesellschaftssatzung wurde seit der Gründung der Gesellschaft durch zwei Urkunden von diesem Tage geändert

die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations publiziert wurden.

Die Aktionäre, die alle Aktien der Gesellschaft halten erbitten einstimmig den Notar die folgenden Schriftlichen Ent-

schlüsse aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschließen den Namen der Gesellschaft in "Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A." zu

ändern.

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschließen den Gesellschaftzweck (Artikel 3) der Gesellschaft zu ändern, sodass es folgendermaßen

lauten soll:

3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, Beteiligungen jeglicher Art an anderen luxemburgischen oder an aus-

ländischen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu erwerben und zu halten, beispielsweise durch Zeichnung oder
Erwerb von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage, Übernahme einer Emission, Kauf oder Option, Bege-
bung oder in sonstiger Weise, oder in Form von Schuldinstrumenten jeglicher Art, und die entsprechenden Portfolios zu
verwalten, auszubauen und damit zu wirtschaften.

3.2 Zudem kann die Gesellschaft ihren Tochtergesellschaften oder anderen Gesellschaften, an denen sie unmittelbare

oder mittelbare Rechte hält, oder die ihrerseits unmittelbare oder mittelbare Aktionäre der Gesellschaft sind, sowie
Gesellschaften, die zum selben Konzern gehören (nachstehend "verbundene Gesellschaften") Unterstützung jeglicher Art

149017

L

U X E M B O U R G

gewähren, beispielsweise durch Darlehen, Garantien oder sonstiges, wobei die Gesellschaft nur Rechtsgeschäfte tätigen
wird, die mit allen geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Anforderungen an Geschäfte,
die der Finanzaufsicht unterstehen, in Einklang stehen. Ergänzend zur Unterstützung in der vorstehend genannten Weise
kann die Gesellschaft ihren verbundenen Gesellschaften auch Unterstützung auf den Gebieten der Verwaltung und des
Marketing gewähren.

3.3 Sofern es sich um Rechtsgeschäfte handelt, die mit allen geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen, ins-

besondere  mit  den  Anforderungen  an  Geschäfte,  die  der  Finanzaufsicht  unterstehen,  in  Einklang  stehen,  kann  die
Gesellschaft insbesondere

3.3.1 Gelder oder Kredite aufnehmen, oder durch Ausgabe von Wandelanleihen oder sonstigen Anleihen, Schuldver-

schreibungen, Schuldscheinen, Zertifikaten oder anderen Schuldtiteln oder durch Einsatz von Finanzderivaten oder in
sonstiger Art und Weise Mittel aufbringen;

3.3.2 zu Konditionen, die nach Auffassung der Gesellschaft angemessen sind, mit oder ohne Sicherheiten Gelder an

luxemburgische oder ausländische Unternehmen ausreichen oder verleihen oder dort einlegen, solchen Unternehmen
Kredite gewähren oder Schuldtitel solcher Unternehmen zeichnen oder erwerben;

3.3.3 innerhalb der nach geltendem Recht vorgegebenen Grenzen als Sicherheit für die Erfüllung von Verträgen oder

Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften Garantien abgeben, Pfandrechte bestellen oder Si-
cherheiten  anderer  Art  gewähren,  indem  sie  ein  persönliches  Versprechen  abgibt,  eine  dingliche  Sicherheit  an  einer
Immobilie bestellt oder Unternehmen, Vermögen, (gegenwärtige oder künftige) Vermögenswerte ganz oder teilweise
mittels einer oder mehrerer der vorstehend genannten Arten belastet; und

3.3.4  Verträge  abschließen,  insbesondere  Gesellschaftsverträge,  Übernahmeverträge,  Marketingverträge,  Manage-

mentverträge, Beratungsverträge, Verwaltungsverträge und andere Dienstleistungsverträge, Kaufverträge, Zins- und/oder
Währungsswaps und andere Finanzderivatgeschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

3.4 Ergänzend dazu kann die Gesellschaft alle rechtmäßigen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Investitionen

oder Geschäfte tätigen, und ganz allgemein sämtliche Transaktionen vornehmen, die zur Erreichung ihres Gesellschafts-
zwecks erforderlich oder sinnvoll sind, wie auch sämtliche Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar mit der Erreichung
des Gesellschaftszwecks in allen oben genannten Bereichen in Zusammenhang stehen.

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschließen 417.306 (in Worten: vierhundertsiebzehntausenddreihundertsechs) der 917.306 (in Wor-

ten: neunhundertsiebzehntausenddreihundertsechs) bestehenden Aktien Stammaktien, die jeweils einen Nominalwert
von ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanischen Rand) haben und die alle von CREDIT SUISSE AG gehalten werden in (i)
1 (in Worten: eine) Vorzugsaktie B, die jeweils einen Nominalwert von ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanischen Rand)
und die gleiche Gattung wie in der Satzung beschrieben hatt, umzuwandeln und (ii) den Restbetrag von ZAR 417.305 (in
Worten: vierhundertsiebzehntausenddreihundertfünf Südafrikanischen Rand) an das Aktien Premium Konto der Gesell-
schaft zuzuteilen.

<i>Vierter Beschluss

Die Aktionäre beschließen das Kapital der Gesellschaft um ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanische Rand) von seinen

jetzigen Betrag folglich des dritten Beschlusss von ZAR 500.001 (in Worten: fünfhunderttausendeins Südafrikanische Rand)
auf ZAR 500.002 (in Worten: fünfhunderttausendzwei Südafrikanische Rand) zu erhöhen, (i) durch die Ausgabe an CRE-
DIT SUISSE AG von 1 (einer) Vorzugsaktie B mit einem Nominalwert von ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanischen
Rand), und die dieselbe Gattung wie in der Satzung beschrieben haben, zusammen mit einen gesamt Aktien Premium von
ZAR 1.082.693 (in Worten: eine Million zweiundachtzigtausendsechshundertdreiundneunzig Südafrikanische Rand), wel-
cher Aktien Premium pari passu an die 2 (in Worten: zwei) Vorzugsaktien B die in solchen Beschlüssen genannt werden
zugeteilt wird, gegen eine Barabfindung.

<i>Zeichnung und Zahlung

CREDIT SUISSE AG beschließt die 1 (in Worten: eine) so ausgegebene Vorzugsaktie B, mit jeweils einen Nominalwert

von ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanischen Rand), zusammen mit einen Gesamt Aktien Premium von ZAR 1.082.693
(in Worten: eine Million zweiundachtzigtausendsechshundertdreiundneunzig Südafrikanische Rand) zu zeichnen. Diese
Vorzugsaktie B wird vollständig durch eine Barabfindung in einen gesamt Betrag von ZAR 1.082.694 (in Worten: eine
Million zweiundachtzigtausendsechshundertvierundneunzig Südafrikanische Rand) bezahlt. Die vollständige Zahlung der
ZAR 1.082.694 (in Worten: eine Million zweiundachtzigtausendsechshundertvierundneunzig Südafrikanische Rand) wird
wie folglich zugeteilt: ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanische Rand) wird an das Grundkapital der Gesellschaft zugeteilt
und ZAR 1.082.693 (in Worten: eine Million zweiundachtzigtausendsechshundertdreiundneunzig Südafrikanische Rand)
werden an das Aktien Premium Konto der Gesellschaft zugeteilt.

Der Beweis für das Bestehen der oben genannten Zahlungen wurde dem unterzeichnendem Notar vorgezeigt.

149018

L

U X E M B O U R G

<i>Fünfter Beschluss

Die Aktionäre beschließen das Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ändern, sodass es ab den ersten Tag Dezembers bis

zum letzten Tag Novembers jedes Jahres laufen soll und die Daten des gegenwärtigen Geschäftsjahres zu ändern, welches
am Tag der Gesellschaftsgründung anfing zu laufen und am letzten Tag Novembers 2013 enden wird.

<i>Sechster Beschluss

Die Aktionäre der Gesellschaft beschließen die Gesellschaftssatzung zu ändern und die Französische Übersetzung der

Satzung durch eine Deutsche Übersetzung der Satzung, zu ersetzen.

Fortan, soll die Satzung der Gesellschaft folgendermaßen lauten:

Einleitung - Definitionen

Neben den an anderer Stelle dieser Satzung ("Satzung") definierten Begriffen besitzen die nachfolgenden Begriffe die

ihnen in dieser Einleitung zugewiesene Bedeutung.

"Gesetz von 1915" (1915 Law) ist das luxemburgische Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (Lu-

xembourg law of 10 August 1915 on commercial companies) in der jeweils geltenden Fassung.

"Verfügbarer Betrag" (Available Amount) meint gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes von 1915, und, sofern es um Zwi-

schendividenden  geht,  gemäß  Artikel  72-2  des  Gesetzes  von  1915,  die  Gewinne  zum  Ende  des  vorangegangenen
Geschäftsjahres,  vorgetragene  Gewinne  und  Entnahmen  aus  Rücklagen,  die  insoweit  zur  Verfügung  stehen,  abzüglich
vorgetragener Verluste und solcher Beträge, die gemäß dem Gesetz von 1915 und der Satzung in die Reserven einzustellen
sind; bezüglich Zwischendividenden gegebenenfalls zuzüglich/abzüglich etwaiger Gewinne oder Verluste des laufenden
Geschäftsjahres, wie in den entsprechenden Zwischenberichten ausgewiesen.

"A PESCs" (A PESC) sind alle rücknahmefähige Aktien der Klasse A, die als bevorzugte Beteiligungszertifikate A ("A

PESC") in der Satzung und in einer Vereinbarung zwischen den Aktionären (einschließlich der insoweit vorhandenen
Anhänge und der A PESCs Emissionsbedingungen), ausgewiesen ist.

"Inhaber von A PESCs" (A PESCs Shareholders) sind jede Aktionäre von A PESCs.
"A PESCs Emissionsbedingungen" (A PESCs Terms and Conditions) sind die Emissionsbedingungen der A PESCs wie

in dieser Satzung beschrieben, wie in einer die Aktionärsvereinbarung vereinbart und jedes Dokument, der die der diese
Aktionärsvereinbarung ändert.

"Vorzugsaktie B" (B Preference Share) ist eine Aktie die als solche in dieser Satzung und in einer Aktionärsvereinbarung

(Shareholder Agreement) ausgewiesen ist.

"Verwaltungsrat" (Board of Directors) ist der gemäß dieser Satzung bestellte Verwaltungsrat der Gesellschaft.
"Geschäftstag" (Business Day) besitzt die diesem Begriff in einer Aktionärsvereinbarung oder den geltenden Emissi-

onsbedingungen für PESCs zugewiesene Bedeutung.

"Berechnungsstelle" (Calculation Agent) meint Credit Suisse Specialised Investco (Luxembourg) S.A., sofern die Ge-

sellschaft nicht ein anderes Unternehmen beauftragt, welches dann die Aufgaben einer Berechnungsstelle übernimmt.

"Artikel" (Clause) ist jeder Artikel dieser Satzung.
"Gesellschaftsregister" (Company Register) hat die Bedeutung in Artikel 7.1.
"Zinstagequotient" (Day Count Fraction) ist der in den geltenden Emissionsbedingungen für PESCs angegebene Zins-

tagequotient.

"Verwaltungsratsmitglied" (Director) ist jedes Mitglied des Verwaltungsrats.
"Dividendenfestsetzungstermin" (Dividend Declaration Date) ist in Bezug auf die jeweiligen PESCs der Dividenden-

festsetzungstermin, welcher von der Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit Artikel 20.2 festgesetzt wird und
in den geltenden Emissionsbedingungen für PESCs angegeben ist.

"Dividendenzahltag" (Dividend Payment Date) ist der Dividendenzahltag, welcher von der Hauptversammlung der

Aktionäre im Einklang mit Artikel 20.2 festgesetzt wird und in den geltenden Emissionsbedingungen für PESCs angegeben
ist; bzw. bei Fehlen einer Angabe zum Dividendenzahltag, der letzte Tag jeder Dividendenperiode.

"Dividendenperiode" (Dividend Period) meint in Bezug auf einen Dividendenzahltag den Zeitraum vom unmittelbar

vorangegangenen Dividendenzahltag (einschließlich) bis zum gegenwärtigen Dividendenzahltag (ausschließlich); wobei al-
lerdings die erste Dividendenperiode am PESCs-Ausgabetag beginnt und an dem Tag vor dem ersten Dividendenzahltag
nach dem PESCs-Ausgabetag endet.

"Dividendensatz" (Dividend Rate) ist der in den Emissionsbedingungen für PESCs für die betreffende Klasse von PESCs,

wenn überhaupt, festgelegte Dividenensatz.

"Stammaktien" (Ordinary Shares) ist jede in der Satzung und in einer Aktionärsvereinbarung als Stammaktie ausge-

wiesene Aktie.

"Inhaber von Stammaktien" (Ordinary Shareholder) ist jeder Inhaber von Stammaktien.
"In Umlauf befindliche PESCs" (Outstanding PESCS) sind PESCs, die nicht gemäß Artikel 10 und den geltenden Emis-

sionsbedingungen für PESCs, zurückgenommen wurden.

149019

L

U X E M B O U R G

"PESC-Ausgabepreis" (PESC Issue Price) ist der Ausgabepreis für eine PESC, wie in den geltenden Emissionsbedingun-

gen für PESCs angegeben.

"PESC-Nominalbetrag" (PESC Notional Amount) ist der Nominalbetrag einer PESC, bestehend aus dem Nennwert

zuzüglich der Prämie für die PESC, wie in den jeweiligen Emissionsbedingungen für PESCs angegeben.

"PESCs" (PESCs) ist jede rücknahmefähige Klasse von Aktien, die als bevorzugte Beteiligungszertifikate (preferred

equity stock certificates) in der Satzung und in einer Vereinbarung zwischen den Aktionären (einschließlich der insoweit
vorhandenen Anhänge und der Emissionsbedingungen für PESCs), ausschließlich von A PESCs, ausgewiesen ist.

"Zur Anpassung von PESCs berechtigendes Ereignis" (PESCs Adjustment Event) meint eines der entsprechenden, in

den Emissionsbedingungen für PESCs genannten, zur Anpassung berechtigenden Ereignisse.

"Für PESCs vorgesehener Höchstbetrag" (PESCs Capped Amount) meint in Bezug auf die Vorzugsdividenden und/oder

den PESCs-Rücknahmebetrag den in den geltenden Emissionsbedingungen für PESCs jeweils festgelegten vorgesehenen
Höchstbetrag.

"Klasse von PESCs" (PESCs Class) ist eine PESCs-Tranche zusammen mit einer oder mehreren anderen PESCs-Tran-

chen,  die  (i)  zusammengefasst  werden  und  eine  einzige  Serie  darstellen  sollen;  und  (ii)  für  die,  abgesehen  von  ihren
jeweiligen PESCs-Ausgabetagen und PESC-Nominalbeträgen, in jeder sonstigen Hinsicht identische Regelungen gelten.

"Rücknahmemitteilung des Ausgebers für PESCs" (PESCs Issuer Redemption Notice) ist eine gemäß Artikel 10.2 und

den Emissionsbedingungen für PESCs ordnungsgemäß ausgefüllte und übermittelte schriftliche Mitteilung.

"Vorzeitiger  Rücknahmebetrag  für  PESCs"  (PESCs  Early  Redemption  Amount)  hat  die  dem  Begriff  "Vorzeitiger

Rücknahmebetrag" (Early Redemption Amount) in den jeweiligen Emissionsbedingungen für PESCs zugeschriebene Be-
deutung.

"Vorzeitiger Rücknahmetermin für PESCs" (PESCs Early Redemption Date) ist der in einer Rücknahmemitteilung des

Ausgebers für PESCs, Rücknahmemitteilung eines Inhabers für PESCs oder einer Kündigungserklärung für PESCs jeweils
angegebene Termin.

"PESCs-Ausgabetag" (PESCs Issue Date) ist in Zusammenhang mit einer PESCs-Tranche der in den geltenden Emissi-

onsbedingungen  für  PESCs  oder  in  Artikel  5  entsprechend  angegebene  Termin  (wenn  darin  bezeichnet).  "  PESCs-
Rücknahmebetrag" (PESC Redemption Amount) ist der in einer Aktionärsvereinbarung und den Emissionsbedingungen
für PESCs vereinbarte Preis, zu dem die Rücknähme der zu einer bestimmten Aktienklasse gehörigen PESCs gemäß Artikel
10 erfolgen soll.

"Rücknahmedatum für PESCs" (PESCs Redemption Date) ist das in einer Aktionärsvereinbarung und in den Emissi-

onsbedingungen für PESCs vereinbarte Datum, zu dem die Rücknähme von zu einer bestimmten Aktienklasse gehörenden
PESCs gemäß Artikel 10 erfolgen soll.

"Zur Rücknähme von PESCs berechtigende Ereignisse" (PESCs Redemption Events) sind Ereignisse (insbesondere zur

Kündigung berechtigende Ereignisse (im Sinne der Definition dieses Begriffs in den Emissionsbedingungen für PESCs)), bei
deren Eintritt die PESCs zurückgenommen werden können, wie zwischen den PESCs-Aktionären und der Gesellschaft in
den den Emissionsbedingungen für PESCs geregelt.

"PESCs-Referenzportfoliovermögenswert" (PESCs Reference Portfolio Asset) meint das Portfolio der unterligenden

Basiswerte für eine Klasse von PESCs, samt der für diese Basiswerte bestellten Sicherheiten, wie in den geltenden Emis-
sionsbedingungen für PESCs angegeben; klarstellend wird an dieser Stelle festgehalten, dass der PESCs-Referenzportfo-
liovermögenswert aus einem einzelnen Basiswert bestehen kann.

"Inhaber von PESCs" (PESCs Shareholder) ist jeder Inhaber von PESCs.
"Rücknahmemitteilung eines Inhabers für PESCs" (PESCs Shareholder Redemption Notice) ist eine gemäß den Emis-

sionsbedingungen von dem jeweiligen PESCs-Aktionär ordnungsgemäß ausgefüllte und an die Gesellschaft übermittelte
schriftliche Mitteilung, in der der jeweilige PESCs-Aktionär die Gesellschaft zur Rücknähme seiner PESCs auffordert.

"Kosten bei Kündigung von PESCs" (PESCs Termination Costs) sind die Kosten, die bei der Gesellschaft im Falle einer

Rücknähme der PESCs anfallen, wie in den Emissionsbedingungen für PESCs näher geregelt.

"PESCs-Kündigungserklärung" (PESCs Termination Notice) ist eine gemäß den Emissionsbedingungen für PESCs ord-

nungsgemäß ausgefüllte und übermittelte schriftliche Mitteilung, die jederzeit nach dem Eintritt eines hinsichtlich einer
Klasse  von  PESCs  zur  Kündigung  berechtigenden  Ereignisses  (wie  in  den  Emissionsbedingungen  für  PESCs  definiert)
übermittelt werden kann.

"Emissionsbedingungen für PESCs" (PESCs Terms and Conditions) meint die Bedingungen der PESCs wie sie in dieser

Satzung beschrieben werden und wie vereinbart in einer Aktionärsvereinbarung werden und andere Dokumente, die die
Aktionärsvereinbarung ändern.

"PESCs-Tranche" (PESCs Tranche) meint alle PESCs einer bestimmten PESCs-Klasse, für die in jeder Hinsicht identische

Regelungen gelten, und die am selben PESCs-Ausgabetag ausgegeben wurden oder werden.

"Vorzugsdividende" (Preference Dividend) hat die in Artikel 20.3.1, und wo dies relevant ist, in der Aktionärsverein-

barung und in den geltenden Emissionsbedingungen für PESCs, definierte Bedeutung.

"Inhaber von Vorzugsaktien" (Preference Shareholder) ist jeder Inhaber von Vorzugsaktien.

149020

L

U X E M B O U R G

"Vorzugsaktien" (Preference Shares) sind die Vorzugsaktien B und alle zusätzlichen in der Satzung und in einer Aktio-

närsvereinbarung (einschließlich der insoweit vorhandenen Anhänge) als Vorzugsaktien bezeichneten Aktienklassen.

"Aktionärsvereinbarung" (Shareholder Agreement) ist jede in Bezug auf die Gesellschaft jeweils zwischen der Gesell-

schaft und ihren Aktionären geschlossene Aktionärsvereinbarung.

"Aktionäre" (Shareholders) sind die Inhaber von Stammaktien, die Inhaber von Vorzugsaktien, die Inhaber von A PESCs

sowie die Inhaber von PESCs, sowie jeder andere Inhaber von Aktien der Gesellschaft, und der/ein "Aktionär" ist jeder
einzelne von ihnen.

"Aktien" (Shares) sind alle jeweils von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien, gleich ob Stammaktien, Vorzugsaktien,

A PESCs oder PESCs. " Festgelegte Währung" (Specified Currency) hat die diesem Begriff in einer Aktionärsvereinbarung
oder in den Emissionsbedingungen für PESCs zugeschriebene Bedeutung.

"Inhaber stimmberechtigter Aktien" (Voting Shareholders) sind Inhaber von Stammaktien und Vorzugsaktien und oder

A PESCs.

"Stimmberechtigte Aktien" (Voting Shares) sind die Stammaktien und Vorzugsaktien und oder A PESCs.

Kapitel I. - Firma, Sitz, Gegenstand und Dauer

1. Form, Firma.
1.1 Die Gesellschaft wird hiermit als Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht (société anonyme) gegründet, auf die

die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg (insbesondere das Gesetz von 1915) und diese Satzung Anwendung finden.
1.2 Die Gesellschaft hat die Firmennamen "Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A.".

2. Sitz.
2.1 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Sitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung, der in der für

Änderungen der Satzung vorgesehenen Weise gefasst wurde, an einen beliebigen anderen Ort im Großherzogtum Lu-
xemburg verlegt werden.

2.3 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Stadt, in der die Gesellschaft ihren

Sitz hat, zu ändern.

2.4 Sollten politische, wirtschaftliche oder soziale Umstände eintreten oder vermutlich unmittelbar bevorstehen, die

den normalen Geschäftsgang am Sitz der Gesellschaft oder die Kommunikation mit dem Ausland behindern würden, kann
der Sitz der Gesellschaft solange vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die Situation sich normalisiert hat; solche
vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet
der vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des
Sitzes der Gesellschaft ins Ausland trifft der Verwaltungsrat.

2.5 Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, insbesondere

eine Niederlassung in der Schweiz unterhalten.

3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, Beteiligungen jeglicher Art an anderen luxemburgischen oder an aus-

ländischen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu erwerben und zu halten, beispielsweise durch Zeichnung oder
Erwerb von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage, Übernahme einer Emission, Kauf oder Option, Bege-
bung oder in sonstiger Weise, oder in Form von Schuldinstrumenten jeglicher Art, und die entsprechenden Portfolios zu
verwalten, auszubauen und damit zu wirtschaften.

3.2 Zudem kann die Gesellschaft ihren Tochtergesellschaften oder anderen Gesellschaften, an denen sie unmittelbare

oder mittelbare Rechte hält, oder die ihrerseits unmittelbare oder mittelbare Aktionäre der Gesellschaft sind, sowie
Gesellschaften, die zum selben Konzern gehören (nachstehend "verbundene Gesellschaften") Unterstützung jeglicher Art
gewähren, beispielsweise durch Darlehen, Garantien oder sonstiges, wobei die Gesellschaft nur Rechtsgeschäfte tätigen
wird, die mit allen geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Anforderungen an Geschäfte,
die der Finanzaufsicht unterstehen, in Einklang stehen. Ergänzend zur Unterstützung in der vorstehend genannten Weise
kann die Gesellschaft ihren verbundenen Gesellschaften auch Unterstützung auf den Gebieten der Verwaltung und des
Marketing gewähren.

3.3 Sofern es sich um Rechtsgeschäfte handelt, die mit allen geltenden Gesetzen und rechtlichen Bestimmungen, ins-

besondere  mit  den  Anforderungen  an  Geschäfte,  die  der  Finanzaufsicht  unterstehen,  in  Einklang  stehen,  kann  die
Gesellschaft insbesondere

3.3.1 Gelder oder Kredite aufnehmen, oder durch Ausgabe von Wandelanleihen oder sonstigen Anleihen, Schuldver-

schreibungen, Schuldscheinen, Zertifikaten oder anderen Schuldtiteln oder durch Einsatz von Finanzderivaten oder in
sonstiger Art und Weise Mittel aufbringen;

3.3.2 zu Konditionen, die nach Auffassung der Gesellschaft angemessen sind, mit oder ohne Sicherheiten Gelder an

luxemburgische oder ausländische Unternehmen ausreichen oder verleihen oder dort einlegen, solchen Unternehmen
Kredite gewähren oder Schuldtitel solcher Unternehmen zeichnen oder erwerben;

149021

L

U X E M B O U R G

3.3.3 innerhalb der nach geltendem Recht vorgegebenen Grenzen als Sicherheit für die Erfüllung von Verträgen oder

Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften Garantien abgeben, Pfandrechte bestellen oder Si-
cherheiten  anderer  Art  gewähren,  indem  sie  ein  persönliches  Versprechen  abgibt,  eine  dingliche  Sicherheit  an  einer
Immobilie bestellt oder Unternehmen, Vermögen, (gegenwärtige oder künftige) Vermögenswerte ganz oder teilweise
mittels einer oder mehrerer der vorstehend genannten Arten belastet; und

3.3.4  Verträge  abschließen,  insbesondere  Gesellschaftsverträge,  Übernahmeverträge,  Marketingverträge,  Manage-

mentverträge, Beratungsverträge, Verwaltungsverträge und andere Dienstleistungsverträge, Kaufverträge, Zins- und/oder
Währungsswaps und andere Finanzderivatgeschäfte, die mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

3.4 Ergänzend dazu kann die Gesellschaft alle rechtmäßigen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Investitionen

oder Geschäfte tätigen, und ganz allgemein sämtliche Transaktionen vornehmen, die zur Erreichung ihres Gesellschafts-
zwecks erforderlich oder sinnvoll sind, wie auch sämtliche Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar mit der Erreichung
des Gesellschaftszwecks in allen oben genannten Bereichen in Zusammenhang stehen.

4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Kapitel II. - Kapital, genehmigtes Kapital, Aktienformen, Rücknähme von Aktien

5. Kapital.
5.1 Das Kapital der Gesellschaft kann aus Stammaktien, Vorzugsaktien, A PESCs und PESCs mit einem Wert von je

ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanischen Rand) bestehen.

5.2 Die Aktien lauten auf den Namen.
5.3 Das Kapital beträgt ZAR 500.002 (in Worten: fünfhunderttausendzwei Südafrikanische Rand) und ist aufgeteilt in

2 (in Worten: zwei) Vorzugsaktien B und 500.000 (in Worten: fünfhunderttausend) Stammaktien, jeweils mit einem Wert
von ZAR 1 (in Worten: einen Südafrikanischen Rand).

5.4 Die Aktien sind unteilbar.
5.5 Eine Aktie kann auf den Namen von mehr als einer Person eingetragen sein, mit der Maßgabe, dass alle Inhaber

einer Aktie der Gesellschaft schriftlich mitteilen, welche Person als Vertreter anzusehen ist; die Gesellschaft wird diesen
Vertreter so behandeln, als sei er der Alleinaktionär hinsichtlich dieser Aktie, einschließlich für die Zwecke der Abstim-
mung, Dividenden- und anderer Zahlungsrechte.

5.6 Zusätzlich zum Kapital kann die Gesellschaft ein oder mehrere Aufgeldrücklagenkonten, in welche auf jede Aktie

gezahltes Aufgeld zugeordnet werden soll und deren Gesamtwert für Ausschüttungen an die Eigentümer der relevanten
Aktien im Zusammenhang mit einer Kapitalherabsetzung, dem Rückkauf eigener Aktien, Ausschüttungen als Dividende,
Liquidation oder jede andere Transaktion wie auch immer resultierend in der Rückzahlung des Aufgeldes oder der Rück-
lage, vorbehaltlich der Bestimmungen von Aktionärsvereinbarungen, Emissionsbedingungen für PESCs und Emissionsbe-
dingungen für A PESCs dem Verwaltungsrat und den Aktionären zur Verfügung stehen soll.

6. Genehmigtes Kapital.
6.1 Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital von insgesamt ZAR 10.003.500.000 (in Worten: zehn Milliarden drei

Millionen fünfhunderttausend Südafrikanische Rand), welches durch Stammaktien, Vorzugsaktien, A PESCs oder PESCs
gemäß Festlegung des Verwaltungsrats gemäß Artikel 6.2 verbrieft werden kann ("genehmigtes Kapital").

6.2 Im Rahmen des genehmigten Kapitals ist der Verwaltungsrat berechtigt und bevollmächtigt, eine ein- oder mehr-

malige Erhöhung des Kapitals durch Ausgabe von, stimm- oder nicht stimmberechtigte, Stammaktien, Vorzugsaktien, A
PESCs oder PESCs gemäß Festlegung des Verwaltungsrats vorzunehmen, wobei dies nur gegen Barzahlung oder Sach-
leistung, durch Einbringung von Forderungen, die Umwandlung von Rücklagen in Aktienkapital oder auf andere in einer
Aktionärsvereinbarung bestimmte Weise erfolgen darf.

6.3 Die dem Verwaltungsrat in dieser Artikel 6 gewährte Befugnis zur Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft im

Rahmen des genehmigten Kapitals erlischt 5 (fünf) Jahre nach der Veröffentlichung der Satzung der Gesellschaft im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations und kann durch eine außerordentliche Hauptversammlung gemäß den
jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen verlängert werden.

6.4 Der Verwaltungsrat kann die Vorzugsrechte der Aktionäre zur Zeichnung der Aktien begrenzen oder aufheben

und die Aktien an die Personen und zu den Preisen, mit oder ohne Aufgeld und eingezahlt als Sacheinlage oder in bar
oder im Wege der Eintragung (incorporation) von Ansprüchen oder der Kapitalisierung von Rücklagen, ausgeben, die der
Verwaltungsrat für angemessen hält.

6.5 Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um Artikel 5 der aktuellen Satzung

dahingehend zu ändern, dass sie die Änderung des Kapitals nach einer Erhöhung gemäß Artikel 6 widerspiegelt. Der
Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, die Maßnahmen zu ergreifen oder zu genehmigen, die für die Durchführung und Ver-
öffentlichung der jeweiligen Änderung gemäß dem Gesetz von 1915 notwendig sind. Darüber hinaus kann der Verwal-
tungsrat einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Verwaltungsratsmitglied oder einem Amtsträger der Gesellschaft oder
jeder anderen ordnungsgemäß bevollmächtigten Person die Aufgabe übertragen, Zeichnungen und Zahlungen im Hinblick
auf Stammaktien, Vorzugsaktien, A PESCs oder PESCs an- bzw. entgegenzunehmen oder alle Maßnahmen zu ergreifen,

149022

L

U X E M B O U R G

die notwendig sind, um Artikel 5 der aktuellen Satzung dahingehend zu ändern, dass sie die Änderung des Kapitals nach
einer Erhöhung gemäß Artikel 6 widerspiegelt, einschließlich mit einem Vermerk, dass die durch die Erhöhung ausgege-
benen Aktien gegebenenfalls keine Stimmenrechte beinhalten.

7. Register.
7.1 Die Gesellschaft führt an ihrem Sitz ein Register ("Gesellschaftsregister") der Aktien der Gesellschaft, das folgende

Angaben enthalten muss:

7.1.1 die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs und die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien;
7.1.2 die im Hinblick auf die Aktien vorgenommenen Einzahlungen;
7.1.3 Übertragungen und Daten;
7.1.4 hinsichtlich der Gründungsurkunde der Gesellschaft vorgenommene Änderungen.
7.2 Den Aktionären können Bescheinigungen ausgestellt werden, die die Eintragung von Inhabern von Aktien der

Gesellschaft im Gesellschaftsregister nachweisen.

7.3 Die Gesellschaft kann zusätzlich zu dem Gesellschaftsregister für alle Aktien ein Register für Inhaber von A PESCs,

ein Register der PESCs-Aktionäre, ein Register der Inhaber von Stammaktien und ein Register der Inhaber von Vorzugs-
aktien ("lokale Register") in jedem Land führen, in dem die Gesellschaft ein Büro unterhält (einschließlich Aktienübert-
ragungs- oder Aktienregisterbüro) oder eine Niederlassung besitzt.

8. Rücknähme von Aktien und PESCs. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien innerhalb der Grenzen des Gesetzes

von 1915 und dieser Satzung zurücknehmen.

9. Rücknähme von Vorzugsaktien. Die Gesellschaft kann PESCs und Vorzugsaktien zu den im Aktionärsvertrag be-

stimmten Bedingungen zurücknehmen, soweit eine solche Rücknähme laut einer Aktionärsvereinbarung zulässig ist und
gemäß dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung erfolgt.

10. Rücknähme von PEESCs.
10.1 Am Rücknahmedatum für PESCs
10.1.1 wird jede PESC vorbehaltlich des Gesetzes von 1915, dieser Satzung und der Emissionsbedingungen für PESCs

von der Gesellschaft gemäß Artikel 49-8 des Gesetzes von 1915 in der festgesetzten Währung in bar oder gemäß Artikel
10.6 in Sachleistungen zurückgezahlt;

10.1.2 kann die Gesellschaft, zusätzlich zu dem auf die PESCs gezahlte Aktienagio, die aus einer Neuemission von Aktien

erhaltenen Einnahmen verwenden, um die PESCs oder das auf die Stammaktien oder die Vorzugsaktien gezahlte Aktienagio
zurückzuzahlen, um die PESCs einzulösen;

10.1.3 ist die Gesellschaft vorbehaltlich Artikel 10.1.4 verpflichtet, die relevanten PESCs zum PESCs-Rücknahmebetrag

für die gesamten PESCs zurückzunehmen; und

10.1.4 die Zahlung des PESCs-Rücknahmebetrags gemäß Artikel 10.1.3 darf den für PESCs vorgesehenen Höchstbetrag

nicht übersteigen.

10.2 Rechte der Gesellschaft auf vorzeitige Rücknähme
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Klassen von PESCs, oder mit der Zustimmung der Inhaber der jeweiligen Klasse

von PESCs, auch einzelne Klassen von PESCs jederzeit am oder vor dem planmäßigen Rücknahmedatum für PESCs zu-
rückzunehmen; die Gesellschaft übt dieses Recht zur vorzeitigen Rücknähme durch Zustellung einer Mitteilung an den
Inhaber der PESCs / PESCs-Aktionär gemäß dieser Satzung und den Emissionsbedingungen für PESCs aus.

10.3 Zur Rücknähme berechtigende Ereignisse
Die jeweiligen PESCs-Aktionäre und die Gesellschaft werden sich in den Emissionsbedingungen für PESCs über die

Ereignisse einigen, die zur Rücknähme von PESCs berechtigende Ereignisse (insbesondere zur Kündigung berechtigende
Ereignisse (gemäß der Definition in den Emissionsbedingungen für PESCs) darstellen.

10.4 Anpassungen
10.4.1 Vorbehaltlich des Gesetzes von 1915 kann der PESCs-Aktionär gemäß den Regelungen in den geltenden Emis-

sionsbedingungen für PESCs zu oder vor dem Rücknahmedatum für PESCs jederzeit hinsichtlich einer Klasse von PESCs
eine Anpassung des PESCs-Rücknahmebetrags oder einer anderen Bedingung der Klasse von PESCs beantragen, der
gemäß den Emissionsbedingungen für PESCs angepasst werden kann, wobei eine solche Anpassung für alle PESCs-Akti-
onäre der betreffenden Klasse von PESCs gilt.

10.4.2 Die Ereignisse, die zur Anpassung von PESCs berechtigende Ereignisse darstellen, bei deren Eintritt ein PESCs-

Aktionär  gemäß  Artikel  10.4.1  dieser  Satzung  vorgehen  darf,  werden  von  dem  jeweiligen  PESCs-Aktionär  und  der
Gesellschaft in den Emissionsbedingungen für PESCs vereinbart.

10.5 Vorzeitige Rücknahmebeträge
10.5.1 Für die Zwecke dieses Artikels 10.5 werden die PESCs am vorzeitigen Rücknahmetermin für PESCs zum vor-

zeitigen Rücknahmebetrag für PESCs zurückgenommen, der sich wie folgt berechnet:

(a) ein Betrag, der dem PESCs-Nominalbetrag oder einem Betrag entspricht, der in der in den Emissionsbedingungen

für PESCs genannten Weise berechnet wird;

149023

L

U X E M B O U R G

(b) abzüglich der Kosten bei Kündigung von PESCs.
10.5.2 Die Gesellschaft ist verpflichtet, die relevante Klasse von PESCs zu dem in Artikel 10.5.1 genannten gesamten

vorzeitigen  Rücknahmebetrag  für  PESCs  zu  dem  für  die  zurückgenommene  Klasse  von  PESCs  geltenden  vorzeitigen
Rücknahmetermin für PESCs zurückzunehmen; dies erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der vorzeitige Rücknahmebetrag
den für PESCs vorgesehenen Höchstbetrag nicht übersteigt.

10.5.3 Soweit eine solche Berechnung für Zeiträume erfolgt, bei denen es sich nicht um vollständige Jahre handelt,

erfolgt sie auf der Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage dividiert durch 365, oder auf der in den Emissionsbe-
dingungen für PESCs genannten Berechnungsrundlage.

10.6 Alternative Zahlung
10.6.1 Sofern nach den Emissionsbedingungen für PESCs zulässig, kann die Gesellschaft den PESCs-Rücknahmebetrag

(oder Teile desselben) vollumfänglich zurückzahlen, indem sie dem Inhaber einer PESCs-Tranche als Sachleistung in Form
von Basiswerten einen entsprechenden Anteil am (i) PESCs-Referenzportfoliovermögenswert, oder (ii) einem beliebigen
Vermögenswert, den die Gesellschaft mit dem Erlös aus einem solchen Basisinstruments erworben hat, oder (iii) einem
beliebigen Vermögenswert, den die Gesellschaft im Zuge der Abwicklung von an die Gesellschaft gemäß eines solchen
Basisinstruments zu zahlenden Betrags erworben hat, zukommen lässt.

10.6.2 Sofern nach den Emissionsbedingungen für PESCs zulässig, wird die Gesellschaft, wenn bei der Gesellschaft

(gleich aus welchem Grund) zum Rücknahmedatum für PESCs (auch wenn das Rücknahmedatum für PESCs ein vorzeitiger
Rücknahmetermin für PESCs ist) kein Barbetrag eingegangen ist, der dem ausstehenden Kapitalbetrag (principal) der
Basiswerte entspricht, aus denen sich das PESCs-Referenzportfolio zusammensetzt, den PESCs-Rücknahmebetrag wirk-
sam zahlen, indem die Gesellschaft den PESCs-Aktionären alle Rechte der Gesellschaft an (i) den Basiswerten, aus denen
der PESCs-Referenzportfoliovermögenswert besteht, oder (ii) alle Vermögenswert, die die Gesellschaft mit dem Erlös
aus einem solchen Basisinstruments erworben hat, oder (iii) alle Vermögenswerte, die die Gesellschaft im Zuge der
Abwicklung von an die Gesellschaft gemäß eines solchen Basisinstruments zu zahlenden Beträge erworben hat, als Sach-
leistung anteilig überträgt oder ausgeschüttet; dies gilt vorbehaltlich Artikel 10.7 dieser Satzung.

10.7 Die Verpflichtung der Gesellschaft zur Erbringung des PESCs- Rücknahmebetrags am Rücknahmedatum für PESCs

oder am vorzeitigen Rücknahmetermin für PESCs steht unter dem Vorbehalt:

10.7.1 dass die Gesellschaft etwaige Kosten bei Kündigung von PEScs zum vorzeitigen Rücknahmetermin für PESCs

oder am Rücknahmedatum für PESCs (je nach Lage des Falles) bereits vom Inhaber erhalten hat; oder

10.7.2 dass der Inhaber die Gesellschaft hinsichtlich dieser Kosten bei Kündigung von PESCs in einer diese zufriedens-

tellenden Weise schadlos hält und eine Sicherheit für eine derartige Schadloshaltung bereitstellt.

Klarstellend wird an dieser Stelle festgehalten, dass die Gesellschaft solange zur Zurückhaltung der Zahlung des PESCs-

Rücknahmebetrags berechtigt ist, bis die in Artikel 10.7.1 bzw. Artikel 10.7.2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

10.8 Die in Artikel 10.6.1 und 10.6.2 geregelten Sachausschüttungen sind in der in den Emissionsbedingungen für PESCs

genannten Weise vorzunehmen.

10.9 Ungeachtet abweichender Regelungen ist die Gesellschaft unter anderen als den in diesem Artikel 10 und im

Gesetz von 1915 geregelten Umständen weder berechtigt noch verpflichtet, die PESCs vor dem Rücknahmedatum für
PESCs zurückzunehmen.

11. Rücknähme von A PESCs. Soweit diese Rücknähme in einer A PESCs Emissionsbedingung zulässig ist, und im

Rahmen der Beschränkungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 unternommen wird, kann die Gesellschaft die A
PESCs unter den Bedingungen, die in einer A PESCs Emissionsbedingung niedergelegt sind, rücknehmen.

12. Aktienübertragung.
12.1 Soweit nicht anders in jeglicher Aktionärsvereinbarung, in den Emissionsbedingungen für PESCS und in den Emis-

sionsbedingungen für A PECs angegeben, sind die Aktien gemäß dem Gesetz von 1915 übertragbar.

Kapitel III. - Geschäftsführung, Verwaltungsrat, unabhängiger Abschlussprüfer

13. Geschäftsführung.
13.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch mindestens drei Verwaltungsratsmitglieder (gemeinsam, "Verwal-

tungsrat" und jeweils einzeln, "Verwaltungsratsmitglied") geführt, die durch Beschluss der Hauptversammlung bestimmt
werden, es sei denn, die Gesellschaft hat nur einen Aktionär. Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär besitzt, kann der
Verwaltungsrat aus einem Verwaltungsratsmitglied bestehen. Die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder muss in Lu-
xemburg ansässig sein.

13.2 Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre sein.
13.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird von der Hauptversammlung für eine maximale Dauer von sechs Jahren bestellt.
13.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann wiedergewählt werden.
13.5 Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit durch Beschluss des/der Aktionäre mit oder ohne Angabe von

Gründen abberufen werden.

13.6  Eine  juristische  Person  kann  Verwaltungsratsmitglied  sein  ("Juristische  Person  Als  Verwaltungsratsmitglied")

(Corporate Director). In einem solchen Fall muss die Juristische Person Als Verwaltungsratsmitglied -einen ständigen

149024

L

U X E M B O U R G

Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der Juristischen Person Als Verwaltungsratsmitglied erfüllt.
Die jeweilige Juristische Person Als Verwaltungsratsmitglied kann seinen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie
gleichzeitig einen Nachfolger bestellt.

13.7 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes oder Ausscheidens eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder aus

anderen  Gründen  frei,  können  die  verbleibenden  Verwaltungsratsmitglieder  eine  Sitzung  abhalten  und  mit  Stimmen-
mehrheit ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung stattfindet,
die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert wird.

13.8 Falls ein Verwaltungsratsmitglied vor der Beendigung der Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds als dessen

Ersatz bestellt wird, wird das bestellte Verwaltungsratsmitglied dieses Amt für die restliche Amtszeit des Verwaltungs-
ratsmitglieds, welches er ablöst, übernehmen, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915.

14. Sitzungen des Verwaltungsrats.
14.1 Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, können die Sitzungen des Verwaltungsrats von einem beliebigen

Verwaltungsratsmitglied einberufen werden.

14.2 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann,

wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied vertreten, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden
Verwaltungsratsmitgliedern gewählt wird.

14.3 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglieds

einberufen. Die Sitzungen des Verwaltungsrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus einberufen
werden; diese Frist gilt nicht für Notfälle. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten
sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten
verzichten.

14.4 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit der Ver-

waltungsratsmitglieder (einschließlich des Vorsitzenden) persönlich in Luxemburg anwesend ist. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich, per Telegramm oder Telefax einen anderes
Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen anderes
Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

14.5 Alle Beschlüsse des Verwaltungsratsratsbedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Ab-

stimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

14.6 Sämtliche Sitzungen des Verwaltungsrats sind in Luxemburg abzuhalten.
14.7 Video- und Telefonkonferenzen sind unter der Voraussetzung zulässig, dass eine Mehrheit der teilnehmenden

Verwaltungsratsmitglieder persönlich in Luxemburg anwesend ist, dass sie alle anderen unter Einsatz oder Nicht-Einsatz
der entsprechenden Technologie teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder hören und von diesen gehört werden können,
womit jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied als anwesend gilt und zur Abstimmung per Video oder Telefon er-
mächtigt ist.

14.8 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrats kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-

terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen, wobei die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder
die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse in Luxemburg unterschreiben muss. Die Zustimmung kann in einem oder
mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax, E-Mail, Telegramm oder Telex übermittelt werden. Auf
diesem Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des
Verwaltungsrats gefasste Beschlüsse.

14.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsratsrats wird vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern

des Verwaltungsratsrats unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei beliebigen Mitgliedern des
Verwaltungsratsrats beglaubigt.

14.10 Hat die Gesellschaft nur ein Verwaltungsratsmitglied, gelten Artikel 14.8 und 14.9 nicht und die Beschlüsse des

alleinigen Verwaltungsratsratsmitglieds sind schriftlich niederzulegen und von dem alleinigen Verwaltungsratsratsmitglied
zu unterzeichnen.

14.11 Ein Verwaltungsratsmitglied, das ein Interesse an einer Transaktion hat, die dem Verwaltungsratsrat zur Ge-

nehmigung vorgelegt wurde und die dem Interesse der Gesellschaft entgegensteht, teilt dem Verwaltungsrat dies mit und
veranlasst, dass seine Erklärung im Protokoll der Sitzung festgehalten wird. An den entsprechenden Beratungen nimmt
er nicht teil. Bei der nächsten Hauptversammlung wird vor der Abstimmung über einen anderen Beschluss gesondert
über Transaktionen berichtet, an denen einer das Verwaltungsratsmitglied ein Interesse gehabt haben könnte, das dem
Interesse der Gesellschaft entgegenstand.

14.12 Sofern die Gesellschaft nur einen einziges Verwaltungsratsratsmitglied hat, müssen Transaktionen zwischen der

Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsratsratsmitglied, an denen das alleinige Verwaltungsratsratsmitglied ein Inte-
resse hat, das dem Interesse der Gesellschaft entgegensteht, abweichend von dem vorstehenden Artikel 14.11 nur in der
schriftlichen Aufzeichnung der Beschlüsse erwähnt werden.

14.13 Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Ge-

sellschaft oder des alleinigen Verwaltungsratsratsmitglied laufende Geschäfte betreffen, die unter normalen Bedingungen
abgeschlossen werden.

149025

L

U X E M B O U R G

15. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats.
15.1 Dem Verwaltungsrat stehen die weitest möglichen Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungs-

maßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nach dem Gesetz von 1915 nicht ausdrücklich der
Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

15.2 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben auf einen oder mehrere ad hoc-Bevollmächtigte

übertragen.

15.3 Der Verwaltungsratsrat bestimmt über die Verantwortungsbereiche und (ggf.) die Vergütung, die Dauer der

Bevollmächtigung, sowie über sonstige relevante Aspekte der Bevollmächtigung.

16. Vertretung der Gesellschaft.
16.1 Die Gesellschaft wird unter allen Umständen gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Verwal-

tungsratsratsmitglieds oder in den Fällen, in denen die Gesellschaft drei oder mehr Verwaltungsratsratsmitglieder hat,
durch die gemeinsamen Unterschriften zweier (2) Verwaltungsratsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift
einer Person verpflichtet, die von zwei (2) Verwaltungsratsratsmitgliedern mit einer solchen Zeichnungsbefugnis ausge-
stattet wurde, jedoch nur im Umfang der betreffenden Befugnis.

16.2 Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt ebenso, durch die alleinige Unterschrift des ope-

rativen tätigen Managers, wenn ein operativ tätiger Manager für die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die
Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts bestellt wurde, jedoch nur im Umfang der betreffenden Be-
fugnis.

17. Unabhängige(r) Abschlussprüfer.
17.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren unabhängigen Abschlussprüfern überwacht (réviseur(s) d'ent-

reprises agréé).

17.2 Die Hauptversammlung bestellt den/die unabhängigen Abschlussprüfer und bestimmt deren Anzahl, Vergütung

und Amtszeit. Die Amtszeit darf jedoch maximal sechs Jahre betragen. In den Fällen, in denen die externen Abschlussprüfer
ohne Verweis auf die Länge ihrer Amtszeit bestellt werden, werden sie für sechs (6) Jahre ab dem Datum ihrer Bestellung
gewählt.

17.3 Die externen Abschlussprüfer können wiedergewählt werden.

Kapitel IV. - Hauptversammlung

18. Befugnisse der Hauptversammlung - Abstimmungen.
18.1 Die Stimmberechtigte Aktien tragen Stimmenrechte.
18.2 Die PESCs tragen keine Stimmenrechte.
18.3 Die Inhaber von PESCs sind dennoch berechtigt, gemäß dem Gesetz von 1915 und insbesondere bei jeder Haupt-

versammlung abzustimmen, die zur Erörterung der nachstehenden Fragen einberufen wurde:

18.3.1 Ausgabe neuer Aktien mit Vorzugsrechten außerhalb der Bestimmungen über genehmigtes Kapital;
18.3.2 Festsetzung der auf die PESCs entfallenden kumulativen Vorzugsdividende (preferential cumulative dividend);
18.3.3 Umwandlung von PESCs in stimmberechtigte Aktien;
18.3.4 Herabsetzung des Kapitals der Gesellschaft außer bei einer Rücknähme;
18.3.5 Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;
18.3.6 Ausgabe von Wandelanleihen (convertible bonds);
18.3.7 Auflösung der Gesellschaft vor Ende der vereinbarten Dauer ihres Bestehens;
18.3.8 Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;
18.3.9 Angelegenheiten, die die Rechte der Inhaber der PESCs beeinträchtigen können;
18.3.10 Änderung der Nationalität der Gesellschaft;
18.3.11 Änderung der Zahlungsverpflichtung (commitments) der Aktionäre;
18.3.12 Jede Erhöhung des genehmigten Kapitals soweit sie die PESCs betreffen.
18.4 Wenn die Hauptversammlung zu den im vorstehenden Artikel 18.2 genannten Angelegenheiten einen Beschluss

fasst, sind die Inhaber von PESCs in gleicher Weise stimmberechtigt wie die Inhaber stimmberechtigter Aktien.

18.5 Außer in den vorstehend beschriebenen Fällen, in denen Inhaber von PESCs stimmberechtigt sind, bleiben PESCs

bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheiten bei der Hauptversammlung außer Acht.

18.6 Für alle Hauptversammlungen gelten die folgenden Regeln:
18.6.1 Jeder Aktionär kann sich unabhängig von der Anzahl der in seinem Besitz befindlichen Aktien an gemeinsamen

Beschlüssen beteiligen. Jeder Aktionär besitzt die mit seinen Aktien verbundenen Stimmrechte.

18.6.2 Ein Aktionär kann sich bei einer Hauptversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf

vergleichbarem Wege) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss.

18.6.3 Der Verwaltungsrat besitzt die Befugnis und Verpflichtung, eine Hauptversammlung gemäß dem Gesetz von

1915 zu vertagen.

149026

L

U X E M B O U R G

18.6.4 Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird am letzten Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres abgehalten

(bzw., soweit dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, am nächsten Geschäftstag) um 14.00 Uhr MEZ.

18.6.5 Der Verwaltungsrat und der unabhängige Abschlussprüfer können eine Hauptversammlung der Aktionäre ein-

berufen. Sie sind verpflichtet, eine Hauptversammlung so einzuberufen, dass sie innerhalb eines Monats abgehalten wird,
wenn Aktionäre, die mehr als ein Zehntel des Kapitals repräsentieren, dies schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
verlangen.

18.6.6 Einladungen zu Hauptversammlungen der Aktionäre müssen die Tagesordnung enthalten und müssen in Form

von Ankündigungen zweimal im Abstand von mindestens acht Tagen sowie acht Tage vor der Sitzung sowohl im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association als auch in einer luxemburgischen Zeitung veröffentlicht werden. Acht Tage vor
der Hauptversammlung der Aktionäre sind Einladungen auf dem Postwege an die eingetragenen Aktionäre zu schicken;
eines Nachweises, dass diese Formalität erfüllt wurde, bedarf es nicht. Die Einladung kann nur per Einschreiben erfolgen.

18.6.7 Wenn alle Aktionäre anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der

Einberufung einer Sitzung verbundenen Formalitäten verzichten und eine Sitzung kann ohne vorherige Einladung wirksam
abgehalten werden.

18.6.8 Die Aktionäre sind berechtigt, über Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer die Fest-

stellung ihrer Identität möglich ist, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der
Beschlussfähigkeit und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Diesbezüglich verwendete Kommunikationsmittel müssen
in technischer Hinsicht geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen
und Beschlussfassungen ständig zu übertragen sind. Kapitel V.- Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

19. Geschäftsjahr.
19.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Dezember und endet am letzten Tag des

Monats November eines jeden Jahres oder wie jeweils in der jeweiligen Aktionärsvereinbarung vereinbart (das "Ge-
schäftsjahr"). Die Aktionäre können die Zeitdauer des Geschäftsjahrs der Gesellschaft jederzeit kürzen.

19.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss und ein Inventar mit dem

Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

19.3 Jeder Aktionär hat das Recht, das obige Verzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

20. Ausschüttung des Gewinns.
20.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent des Nettogewinns in die gesetzlichen Rücklagekonten einzustellen. Eine

solche Einstellung in die Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens
ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

20.2 Nach der wie in Artikel 20.1 vorgesehenen Zuteilung zu den gesetzlichen Rücklagekonten, bestimmt die Haupt-

versammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung die Zuwendung und Ausschüttung
der Nettogewinne und ausschüttungsfähigen Rücklagen. Bei der Ankündigung solcher Dividenden dürfen die Aktionäre
beschließen, dass diese Dividenden in einer Zahlung oder mehreren Teilzahlungen ausbezahlt werden, und dass die Zah-
lung der Dividenden oder die Teilzahlungen der von ihnen festgesetzen Bedingungen unterliegt bzw. unterliegen. Wenn
die Zahlung einer Dividende, oder eine Teilzahlung einer Bedingung unterliegt, soll der Verwaltungsrat oder eine von
dem Verwaltungsrat hierzu bestimmte Person prüfen, ob die Bedingungen für die vollständige Ausbezahlung der Dividende
oder der Teilzahlung erfüllt wurden, und, soweit anwendbar, die vollständige oder teilweise Zahlung der Dividende oder
Teilzahlung im Einklang mit der Entscheidung der Aktionäre anweisen. Soweit nicht anders als in Artikel 20.3 oder in einer
Aktionärsvereinbarung bestimmt, soll kein Aktionär einen Anspruch auf eine Dividende, die nicht ausbezahlt oder nicht
vollständig ausbezahlt wurde, haben, und eine solche unbezahlte Dividende (oder der Teil einer solchen Dividende) soll
automatisch, ohne dass diesbezüglich eine weitere Entscheidung der Aktionäre getroffen werden muss, der ausschüt-
tungsfähigen Rücklagen der Gesellschaft zugewiesen werden. Jeder Anspruch eines Aktionärs auf eine angekündigte, aber
unbezahlte Dividende verfällt, wenn die betroffene Aktie zurückgezahlt wurde.

Der  Verwaltungsrat  kann  beschließen,  gemäß  den  Bestimmungen  des  Gesetzes  von  1915  und  Artikel  20.1  dieser

Satzung Zwischendividenden auszuschütten; im Zweifel erfolgen diese Ausschüttungen vierteljährlich.

20.3 Dividendenrechte bei den PESCs
20.3.1 Gemäß den allgemeinen Bestimmungen des vorstehenden Artikels 20.1 und der Emissionsbedingungen für PESCs

gewährt jede PESC ihrem Inhaber das Recht auf eine kumulative Vorzugsdividende ("Vorzugsdividende" (Preference Di-
vidend)), sofern verfügbare Beträge vorhanden sind und gemäß dem Gesetz von 1915 über die Gewinnzurechnung von
der Hauptversammlung beschlossen oder dem Verwaltungsrat entschieden wurde. Klarstellend wird an dieser Stelle
festgehalten, dass der Verwaltungsrat oder die Hauptversammlung der Aktionäre gemäß Artikel 20.2 und dem Gesetz
von 1915 beschließen können, vierteljährliche Dividenden oder Interimsdividenden an die PESCs-Aktionäre auszuschüt-
ten, und dass es während des jeweiligen Quartalszeitraums nach eigener Wahl gemäß dem vorstehenden Artikel 20.2
Vorzugsdividenden ausschütten kann, sofern verfügbare Beträge vorhanden sind.

20.3.2 Jeder PESCs-Aktionär hat gemäß Artikel 20.3.1 Anspruch auf eine Vorzugsdividende, die gegenüber Dividen-

denzahlungen an die Inhaber von Vorzugsaktien, Stammaktien und A PESCs vorrangig ist; mit der Folge, dass an Inhaber
von Vorzugsaktien, Stammaktien und A PESCs keine Dividenden gezahlt werden, solange an PESCs-Aktionäre zu ent-
richtende Vorzugsdividenden rückständig oder noch nicht ausbezahlt sind.

149027

L

U X E M B O U R G

20.3.3 Der Anspruch eines PESCs-Aktionärs gegenüber andere PESCs Aktionäre auf eine Vorzugsdividende soll wie

in den Emissionsbedingungen für PESCs und/oder in der gegebenenfalls anwendbaren Aktionärsvereinbarung, bestimmt
sein.

20.3.4 Die auf PESCs zahlbaren Vorzugsdividenden werden wie folgt berechnet, festgesetzt und ausgezahlt:
(a) Jede PESCs gewährt ihrem jeweiligen PESCs-Aktionär einen Anspruch auf Festsetzung und Auszahlung der Vor-

zugsdividende aus solchen Gewinnen oder Rücklagen der Gesellschaft, die zur Ausschüttung von Vorzugsdividenden an
die Aktionäre zur Verfügung stehen;

(b) eine Vorzugsdividende wird gemäß Artikel 20.2 an oder vor jedem maßgeblichen Dividendenfestsetzungstermin

festgesetzt, und jede Vorzugsdividende ist an oder vor dem Dividendenzahltag, oder einem früheren Termin, den die
Gesellschaft nach alleinigem Ermessen bestimmt, von der Gesellschaft zu zahlen;

(c) die Berechnung der an oder vor einem Dividendenfestsetzungstermin gemäß den Emissionsbedingungen für die

PESCs festzusetzende Vorzugsdividende erfolgt durch die Berechnungsstelle unter Verweis auf den jeweiligen Dividen-
denfestsetzungstermin im Nachhinein (in arrears) und unter Anwendung der in den Emissionsbedingungen für die PESCs
genannte Formel oder Gattung; und

(d) die gemäß Artikel 20.3.4 (b) festgesetzte Vorzugsdividende wird den für PESCs vorgesehenen Höchstbetrag nicht

überschreiten; vorbehaltlich der Emissionsbedingungen für die PESCs.

20.4 Jede Vorzugsdividende ist an dem jeweiligen Dividendenzahltag in bar oder gemäß Artikel 10.6 auszuzahlen, sofern

die Gesellschaft verfügbare Beträge zur Zahlung der jeweiligen Vorzugsdividende hat.

20.5 Der Dividendenanspruch des Inhabers von Stammaktien (Ordinary Shareholder) rangiert hinter dem Dividen-

denanspruch aller anderen Aktionäre.

20.6 Dividendenanspruch von A PESCS
20.6.1 Im Einklang mit Artikel 20.1 und den A PESCs Emissionsbedingungen, haben die A PESCs Aktionäre Anspruch

pro A PESC auf ein in bar bezahltes Vorzugsdividend, wie in den A PESCs Emissionsbedingungen bestimmt.

20.6.2 Der Dividendenanspruch der Inhaber von A PESCs rangiert hinter dem Dividendenanspruch der Inhaber von

PESCs und der Inhaber von Vorzugsaktien, jedoch vor dem Dividendenanspruch der Inhaber von Stammaktien.

21. Zusätzliche Vorzugsdividenden.
21.1 Gemäß dieser Satzung, dem Gesetz von 1915 und gemäß den Bestimmungen der Emissionsbedingungen für PESCs

kann der Vewaltungsrat oder die Hauptversammlung der Aktionäre die Ausschüttung zusätzlicher Dividenden im Sinne
von Artikel 20.2 und dieses Artikels 21 an die PESCs-Aktionäre beschließen ("zusätzliche Vorzugsdividende" (Additional
Preference Dividend)).

21.2 Sind, vorbehaltlich der Emissionsbedingungen für die PESCs, geschuldete Zinszahlungen oder ein entsprechender

Gegenwert in Zusammenhang mit Basiswerten, die Teile des PESCs-Referenzportfoliovermögenswerts darstellen, bei der
Gesellschaft nicht an oder vor dem Dividendenzahltag vollständig eingegangen, wird der nicht eingegangene Zinsbetrag
anteilig von allen zu diesem Dividendenzahltag planmäßig zu zahlenden Vorzugsdividenden auf in Umlauf befindliche PESCs
anteilig abgezogen. Dieser Abzug darf jedoch nicht dazu führen, dass diese Vorzugsdividende geringer ist als die gemäß
Artikel 20.3.4(c) und Artikel 20.3.4(d) berechnete Vorzugsdividende, und wird nicht zur Folge haben, dass bei der Be-
rechnung, die in Artikel 20.3.4(c) und 20.3.4(d) vorgesehen ist, Abzüge von der Vorzugsrendite doppelt vorgenommen
werden.

21.3 Erhält die Gesellschaft die in Artikel 21.2 der Satzung geregelten Zinszahlungen oder deswegen anfallende weitere

Zinsen bei oder vor Rücknähme der jeweiligen in Umlauf befindlichen PESCs, gewährt jede dieser in Umlauf befindlichen
PESCs dem Inhaber das Recht auf Auszahlung einer zusätzlichen Vorzugsdividende - die einem anteiligen Betrag der bei
der Gesellschaft eingegangenen Zinszahlung entspricht -aus den Gewinnen oder aus zur Ausschüttung an die Aktionäre
zur Verfügung stehenden Mitteln der Gesellschaft.

21.4 Jede zusätzliche Vorzugsdividende ist zur Zahlung fällig, wie in den Emissionsbedingungen für PESCs geregelt.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

22. Auflösung, Liquidation.
22.1 Die Gesellschaft wird wegen Todes, Außerkraftsetzung von Grundrechten (civil rights), Insolvenz oder Bankrott

des Alleinaktionärs oder von einem der Aktionäre nicht aufgelöst.

22.2 Die Gesellschaft kann aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung aufgelöst werden, für den dieselben

Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten, wie für die Änderung der Satzung.

22.3 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Abwicklung durch einen oder mehrere von der Hauptver-

sammlung bestellte Liquidatoren.

22.4 Gemäß dieser Satzung und der Aktionärsvereinbarung (Shareholder Agreement) sind die Nettoliquidationserlöse

nach (i) Zahlung sämtlicher Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und (ii) Vornahme der notwendigen Rück-
stellungen für die Zahlung von Steuern und verbleibende Liquidationsgebühren und -kosten vorrangig an die PESCs-
Aktionäre, anschließend an die Inhaber von Vorzugsaktien auszuschütten, und letztlich an den A PESCs Aktionäre. Den

149028

L

U X E M B O U R G

Inhabern von Stammaktien bleibt jedoch ein vollumfängliches Recht auf Teilhabe an den Liquidationserlösen, wobei sie
hier hinter den PESCs-Aktionären, den Inhaber von Vorzugsaktien und den A PESCs Aktionäre rangieren.

22.5 Der Rang der Ansprüche auf die Nettoliquidationserlöse zwischen PESCs Aktionäre von unterschiedlichen PESCs

Klassen wird anhand der Emissionsbedingungen für PESC und/oder der etwaigen Aktionärsvereinbarung bestimmt. Wenn
dies nicht dadurch bestimmbar ist, sollen die PESCs Aktionäre von unterschiedlichen PESCs Klassen gleichrangingen (pari
passu) Anspruch auf die Nettoliquidationserlöse haben.

Kapitel VII. - Verschiedenes

23. Geltendes Recht. Für sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten gelten die Bestimmungen des

Gesetzes von 1915.

24. Sprache. Diese Satzung ist in englischer Sprache abgefasst und wird in die deutsche Sprache übersetzt. Bei Wider-

sprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

<i>Kostenschätzung

Die vorstehend genannten Parteien haben die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der

Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind bzw. ihr in Rechnung gestellt werden, auf ca. ein tausend
acht hundert Euro (EUR 1.800) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Wunsch der

obigen Erschienenen in englischer Sprache verfasst ist, und dem englischen Text eine deutsche Version folgt. Auf Wunsch
derselben Erschienenen hat im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische
Version Vorrang.

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde an dem eingangs genannten Tag in Luxemburg errichtet.
Nachdem die Urkunde den Erschienenen, repräsentiert wie oben beschrieben, die dem Notar mit Familiennamen,

Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, unterzeichneten die besagten Erschienenen
gemeinsam mit dem Notar diese Originalurkunde.

Signé: G.NUCERA, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2013. Relation: LAC/2013/47935. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Référence de publication: 2013154319/1317.
(130188864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2013.

Essential Trust Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 181.108.

STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the eighth day of October.
Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr. Gabriele Elie BENEZRA,lawyer, born in Milano (Italy), on April, 23, 1969, residing rue Le-Corbusier, 31 CH-1208

Geneva

duly represented by Mr Philippe AFLALO, Company's Director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

by virtue of a proxy under private seal dated of October, 4 

th

 , 2013.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has drawn up the following articles of a joint stock company

to be incorporated.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A Private Wealth Management Company ("SPF") in the form of a public limited company is hereby formed, that

will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is Essential Trust Holding S.A. SPF.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.

149029

L

U X E M B O U R G

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy by a decision of the general meeting.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal

of financial assets (within the meaning of the Law of 5 August 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of
any kind held in an account.

The company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role

in its subsidiary.

The company is not allowed to exercise any commercial activity.
The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management,

either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons,
or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on

the stock exchange.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the
limits of the Law of 11 May 2007 on creation of a Private Wealth Management Company ("SPF").

Art. 5. The corporate capital is set at TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS (250.000.- EUR) represented

by TWO HUNDRED FIFTY (250) shares with a par value of ONE THOUSAND EUROS (1.000.- EUR) each.

The shares are held by the investors as defined hereafter.
An eligible investor within the meaning of this law is any person as follows:
a) an individual acting within the context of managing his/her private asset or
b) an asset management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals,

or

c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.
Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors

of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock

exchange.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting

with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law of 10 August 1915, purchase its own shares.

Board of directors and Statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than 3 (three) members, the exact number being determined

by the general meeting. The directors may be elected as Class A directors and Class B directors.

If it has been established at a general meeting of shareholders that the company has a single shareholder, the board of

directors can be made up by 1 (one) member until the ordinary general meeting following the establishment of the
existence of more than 1 (one) shareholder.

The directors do not need to be shareholders. They are elected by the general meeting for a term which may not

exceed 6 (six) years and can be dismissed at any time by the general meeting.

If the office of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any 2 (two) directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent 1 (one) of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in

the forms foreseen by the law.

149030

L

U X E M B O U R G

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at least 1

(one) A signatory director and by 1 (one) B signatory director. In case of an equality of votes, the chairman has a casting
vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10, 1915, as
subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the
board of directors. If there is only one Director, all such powers shall be reserved to the Sole Director.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole

signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signatures of 1 (one) A and 1 (one) B
signatory directors, or by the sole signature of a delegate acting within the limits of his powers. In its current relations
with the public administration, the company is validly represented by 1 (one) director, whose signature legally commits
the company.

Art. 13. The company is supervised by 1 (one) or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding 6 (six)

years.

General meeting

Art. 14. In the case of a sole shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of shareholders and takes the decisions in writing. In these Articles, a reference to decisions taken or powers exercised
by the general meeting shall be a reference to decisions taken or powers exercised by the sole shareholder as long as
the company has only 1 (one) shareholder.

In the case of a plurality of shareholders, the general meeting represents the whole body of shareholders. It has the

most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the last Friday of the month of June, at 11.15 am.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened

at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of 1 (one) vote.
The company will recognise only 1 (one) holder for each share; in case a share is held by more than 1 (one) person,

the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until 1 (one) person has been
appointed as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least 1 (one) month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the subscribed capital.

149031

L

U X E M B O U R G

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by 1 (one) or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended and the Law of May 11,

2007 on creation of a Private Wealth Management Company ("SPF") shall apply in-so-far as these Articles of Incorporation
do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 

st

 December 2014.

2) The first annual general meeting shall be held in 2015.
3) The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and Payment

The 250 (TWO HUNDRED FIFTY) shares have been entirely subscribed by the sole shareholder, Mr. Gabriele Elie

BENEZRA, prenamed.

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 250.000,-

(TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1.100,- (one thousand one hundred euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the share capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at 4 (four).
The following have been elected as directors:

<i>A signatory director:

1. Mr Maurice BENEZRA, company's director, born on September 30, 1956 in Milano, Italy, with professional address

at rue du Prince, 9-11, CH-1204 Geneva,

2.Mr Gabriele Elie BENEZRA, lawyer, born on April 23, 1969 in Milano, Italy, with address at 31, rue Le-Corbusier,

CH-1208 Geneva.

<i>B signatory directors:

3. Mrs Marie-Laure AFLALO, company's director, born in Fes (Morocco), on October 22, 1966, with professional

address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

4. Mr Philippe AFLALO, company's director, born in Fes (Morocco), on December 18, 1970, with professional address

in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2019.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor:
GESTMAN S.A., having its registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg B 37.378.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2019.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

149032

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
proxyholder and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, known to

the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Follows the french version of the preceding text

L'an deux mille treize, le huit octobre.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Gabriele Elie BENEZRA, avocat, né à Milan (Italie) le 23 avril 1969, demeurant au 31, rue Le-Corbusier,

CH-1208 Genève,

ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970,

demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé en date du 4 octobre 2013.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», sous la forme

d'une société anonyme qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Essential Trust Holding S.A. SPF.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 5. Le capital social est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000.- EUR) représenté par DEUX

CENT CINQUANTE (250) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1000.- EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

149033

L

U X E M B O U R G

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 3 (trois) membres, le nombre

exact étant déterminé par l'assemblée générale. Les administrateurs peuvent être élus comme administrateurs de caté-
gorie A et administrateurs de catégorie B.

Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un actionnaire unique,

la composition du conseil d'administration peut être limitée à 1 (un) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant
la constatation de l'existence de plus d'1 (un) actionnaire.

Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires. Ils sont élus par l'assemblée générale pour une période ne

dépassant pas 6 (six) ans et peuvent être révoqués à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de 2 (deux) administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'1
(un) de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant com-

porter obligatoirement le vote d'1 (un) administrateur de catégorie A et le vote d'1 (un) administrateur de catégorie B.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément  par  la  loi  du  10  août  1915  et  ses  modifications  ultérieures  et  les  statuts  à  l'assemblée  générale.  En  cas
d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d'administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe d'1
(un) administrateur de catégorie A et d'1 (un) administrateur de catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué
dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'1 (un) seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par 1 (un) ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser 6 (six)

années.

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement 1 (un) actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée

générale des actionnaires et prend les décisions par écrit. Dans les présents statuts, toute référence aux décisions prises

149034

L

U X E M B O U R G

ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'actionnaire unique tant que la société n'a qu'1 (un) actionnaire.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations de l'assemblée générale se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier vendredi du mois de juin à 11 h 15.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à 1 (une) voix.
La société ne reconnaît qu'1 (un) propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs pro-

priétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce
qu'1 (une) seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société 1 (un) mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'1 (un) ou de plusieurs liquidateurs, per-

sonnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial («SPF») trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
3) Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 250 (DEUX CENT CINQUANTE) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, M. Gabriele Elie BENEZRA,

prénommé.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

250.000 (DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve
en ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.100 (mille cent euros).

149035

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à 4 (QUATRE).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

<i>Administrateurs de catégorie A:

1. Monsieur Maurice BENEZRA, administrateur de sociétés, né le 30 septembre 1956 à Milan (Italie), demeurant

professionnellement à rue du Prince, 9-11, CH-1204 Genève (Suisse),

2. Monsieur Gabriele Elie BENEZRA, avocat, né le 23 avril 1969 à Milan (Italie), demeurant au 31 rue Le-Corbusier,

CH-1208 Genève.

<i>Administrateurs de catégorie B:

3.  Madame  Marie-Laure  AFLALO,  administrateur  de  sociétés,  née  à  Fès  (Maroc)  le  22  octobre  1966,  demeurant

professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen 23,

4. Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant pro-

fessionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2019.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: GESTMAN S.A., ayant son siège au 23, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 37.378. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année
2019.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du mandataire du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 octobre 2013. Relation: LAC/2013/46019. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Référence de publication: 2013148617/370.
(130182006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Topfashionesch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 81, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 181.094.

STATUTS

L'an deux mille treize.
Le dix-sept octobre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU

1.- Monsieur Jean-Luc KREMER, indépendant, né à Esch/Alzette, le 21 octobre 1968,
demeurant à L-4993 Sanem, 73, Cité Schmiedenacht
déclarant avoir signé une déclaration de partenariat avec Madame Claudine WANDERSCHEID,

149036

L

U X E M B O U R G

déclarant agir pour son propre compte et à l'exclusion de sa partenaire
2.- Monsieur Daniel KREMER, indépendant, né à Esch/Alzette, le 26 février 1971
demeurant à L-7362 Bofferdange, 51, An de Strachen
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité

limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

TOPFASHIONESCH S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet social le commerce d'articles de confection pour adultes et enfants ainsi que leurs

accessoires et gadgets.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch/Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Jean-Luc KREMER, prénommé QUARANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- Monsieur Daniel KREMER, prénommé SOIXANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ils ont pris les décisions suivantes:

149037

L

U X E M B O U R G

I.- Sont nommés gérants de la société:
Monsieur Daniel KREMER, prénommé
Monsieur Jean-Luc KREMER, prénommé,
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-4011 Esch/Alzette, 81, rue de l'Alzette.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: J.-L. Kremer, D. Kremer, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13614.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013148973/77.
(130181735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Zitro S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 502.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.648.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth September.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Zitro International S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the

laws of the Netherlands but governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, further to the transfer of its
registered office and principal establishment to Luxembourg on October 9, 2009, currently having its registered office at
16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 149.254 and having a share capital amounting to EUR 1,518,151.-, (the Sole Shareholder)

here  represented by  Hugo ARELLANO, lawyer, with  professional address  at  18-20  rue Edward Steichen,  L-2540

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under a private seal.

The aforementioned proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purposes of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
Zitro International S.à r.l., is the sole shareholder of Zitro S.à r.l., a private limited liability company (société à res-

ponsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on October
31, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated December 14, 2007 number 2914 (the
Company).

That the meeting has the following agenda:
1. Amendment to article 8.2 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"  8.2.  The  single  manager  or,  if  the  Company  is  managed  by  more  than  one  manager,  the  board  of  managers,  is

authorised to delegate the day-to-day management to the Class B Manager who holds the business licence for the benefit
of the Company, acting individually (the General Manager).

Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the single manager or, if

the Company is managed by more than one manager, by the board of managers and, within the scope of the day-to-day
management, by the General Manager acting individually."

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend article 8.2 of the articles of association of the Company, which will henceforth

have the following wording:

"  8.2.  The  single  manager  or,  if  the  Company  is  managed  by  more  than  one  manager,  the  board  of  managers,  is

authorised to delegate the day-to-day management to the Class B Manager who holds the business license for the benefit
of the Company, acting individually (the General Manager).

149038

L

U X E M B O U R G

Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the single manager or, if

the Company is managed by more than one manager, by the board of managers and, within the scope of the day-to-day
management, by the General Manager acting individually."

<i>Costs

The parties have evaluated the total amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form

whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, at approxi-
mately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER., notaire de résidence à Esch/Alzette.

A COMPARU:

Zitro International S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas et gouvernée par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, suite au transfert de son siège social et principal établissement le 9 octobre
2009 au Luxembourg, actuellement ayant son siège social au 16,avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.254 et ayant un capital social de EUR 1.518.151,-, (l'Associé
Unique)

ici représentée par Maître Hugo ARELLANO, avocat, résidant à Luxembourg, 18-20 rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Zitro International S.à r.l., est l'associé unique de Zitro S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois constituée suivant acte reçu par Me Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, en date du 31 octobre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 décembre 2007 numéro 2914 (la Société).

- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Modification de l'article 8.2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante;

« 8.2. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à déléguer la gestion

journalière au Gérant de Catégorie B qui détient l'autorisation d'établissement en faveur de la Société, agissant indivi-
duellement (le Gérant Délégué).

Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par le

conseil de gérance à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques, et dans le cadre de la gestion journalière, par le
Gérant Délégué agissant individuellement.»

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique décide de modifier l'article 8.2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 8.2. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à déléguer la gestion

journalière au Gérant de Catégorie B qui détient l'autorisation d'établissement en faveur de la Société, agissant indivi-
duellement (le Gérant Délégué).

Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par le

conseil de gérance à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques, et dans le cadre de la gestion journalière, par le
Gérant Délégué agissant individuellement.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie

comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

149039

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Arellano, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12414.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013149019/103.
(130181695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Flying Bird S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 125.222.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FLYING BIRD S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013155316/12.
(130190122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Hitech Futur Car Center SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 130.259.

<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale tenue au siège social le 17 septembre 2013

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Berlerstrooss 7 L-9638 Pommerloch à Duerfstrooss

98 L-9647 Doncols avec effet au 1 

er

 juin 2013.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013155368/11.
(130190072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Spanish Residential (REIT) Holdco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.202.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 31 octobre 2013 que la société BRE/Management

6 S.A. a démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 31 octobre 2013.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BRE/Management 7 S.A., société anonyme de droit

Luxembourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 180.304, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au
31 octobre 2013 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société BRE/Management 7 S.A. en qualité de gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2013155605/20.
(130190037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

149040


Document Outline

Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A.

Essential Trust Holding S.A. SPF

Flying Bird S.A.

GBS S.A.

Georges Sàrl

Georges Sàrl

Get Real Estate International S.A.

Global Telephone S.A.

GP-2 Office A LBC Luxco S.à r.l.

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l.

GP-4 Inner City A LBC Luxco S.à r.l.

GP-5 Inner City B LBC Luxco S.à r.l.

GP-6 Development LBC Luxco S.à r.l.

GP-7 Opportunity LBC Luxco S.à r.l.

Grand Large Finance S.A.

Hésione S.à r.l.

Hilger

Hitech Futur Car Center SA

Immopartner

Innisfree ISF S.à r.l.

Integrated BioBank of Luxembourg

Laguna Verde S.A.

Land Immo S.A.

LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l.

LBP Luxco GP 2-Resi S.à r.l.

LBP Luxco GP 3-Condo S.à r.l.

LBP Luxco GP 4-North S.à r.l.

LBP Luxco GP 5-South S.à r.l.

LBP Luxco GP 6-Hessen S.à r.l.

LBP Luxco GP 7-Office S.à r.l.

LBP Luxco GP 8-West S.à r.l.

Levanna Sicav

Leyla S.A.

LGT Fund Management (Lux) S.A.

Lusol S.A.

Lux Gare

Lux Publicité

Lux Publicité Immobilière S.à r.l.

Lux Technicom S.à r.l.

Lux Trade Holding S.A.

MAF Finance S.à r.l.

Matterhorn Midco S.à r.l.

Mercurio Sicav

Michelangelo Sicav

Milux International

Mochis S.à r.l.

Morgan Real Estate S.A.

MP Trans Sàrl

Naga 1 (BC) S.à r.l.

Naja Investment S.A. SPF

OCM Luxembourg Spirits Holdings S.à r.l.

OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS Europäische Gesellschaft für die Leistungs- und Kostenoptimierung gebäudetechnischer Anlagen

Optolux S.A.

Orbis Invest S.A., SPF

Pacific Santa Ana S.à r.l.

Pacific Sharav S.à r.l.

Pacific Specialised Finance Capital S.A.

Replay Associate

Spanish Residential (REIT) Holdco I S.à r.l.

Topfashionesch S.à r.l.

Zitro S.àr.l.