logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2981

26 novembre 2013

SOMMAIRE

A3 Construction Métallique S.à r.l.  . . . . . .

143084

ACMO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143086

ADNEOM Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

143071

Advanced Network Solutions S.à r.l.  . . . . .

143065

Agence Uelzecht S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143087

AIO III Aircraft Finance (Lux) S.à r.l.  . . . .

143084

Alliance Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143077

Alliance Industries B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

143085

America Corporation International S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143085

Ancelux Topco S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143078

Ancelux Topco S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143071

Anchorage Capital Luxembourg S.à r.l.  . .

143085

Arilco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143077

Arilco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143071

Arjufra Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

143064

Arlette Schneiders Architectes S.à r.l.  . . .

143070

Asteo Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143069

Auluxe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143077

Axelan Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143077

Banking Services Luxembourg S.à r.l.  . . . .

143084

BCP Lisa Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143083

Beim Struwwelpeter S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

143083

Bestair S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143083

Bierbrauer - Spanier Kachelofen und Ka-

minbau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143087

Biscarosse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143052

Blackstone Perpetual Midco S.à r.l.  . . . . . .

143083

Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.  . . . . . .

143078

Boise European Holdings 1 S. à r. l.  . . . . . .

143078

Boise European Holdings 2 S.à r.l.  . . . . . . .

143071

Celsius Managed Funds SICAV  . . . . . . . . . .

143086

Cohe, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143087

Columbus Holding Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

143087

Columbus Participations Lux S.à.r.l.  . . . . .

143087

Conseils Développement Associés

(C.D.A.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143088

Controlinveste International  . . . . . . . . . . . .

143063

Copper Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

143086

ECommerce Holding IV S.à r.l.  . . . . . . . . . .

143042

Industrial Securities Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143088

Michel Greco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143088

Rowan Finanz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143053

Underground S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143068

Valley Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

143067

Valmar Lux S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143068

Varfor Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143066

Varian Semiconductor Equipment Asso-

ciates Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

143067

Vianden Invest Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143067

Villa Remacum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143067

Vopium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143066

W2005/W2007 Bora S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

143065

W2007 Parallel Amelia S.à r.l. . . . . . . . . . . .

143064

W2007 Parallel Bear S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

143064

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143064

Walvek S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143070

Watt Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143070

WM Belvaux (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . .

143066

WM Kehlen (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

143065

WPP TNS US S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143065

Zentraleuropäische Immobilien Anlagege-

sellschaft A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143066

143041

L

U X E M B O U R G

ECommerce Holding IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 180.904.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September,
Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of

Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

here represented by Mrs. Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany on 24 September 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

ECommerce Holding IV S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

143042

L

U X E M B O U R G

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

143043

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, Removal and Term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes

143044

L

U X E M B O U R G

of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22. 6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

143045

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-

tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR
1,000.-).

<i>Resolution of the sole Shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr. Alexander KUDLICH, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin; and

- Mr. Christian SENITZ, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr. Ulrich BINNINGER, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

143046

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebenundzwanzigsten September,
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Carlo Wersandt mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,

hier vertreten durch Frau Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 24. September 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen ECommerce Holding IV S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12 500,-) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

143047

L

U X E M B O U R G

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden. 5.3 Die Ge-
sellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-

143048

L

U X E M B O U R G

scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-

schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats  ist  nicht  erforderlich,  wenn  Zeit  und  Ort  in  einem  vorausgehenden  Beschluss  des  Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

143049

L

U X E M B O U R G

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung und wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer  der  Kategorie  B),  werden  Beschlüsse  des  Geschäftsführungsrats  nur  dann  wirksam  gefasst,  wenn  sie  von  der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer  unterzeichnet  wird.  Kopien  und  Auszüge  solcher  Protokolle,  die  in  einem  Gerichtsverfahren  oder  auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-

schrift  des  Einzelgeschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere  Geschäftsführer  hat,  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

143050

L

U X E M B O U R G

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung  stehen.  Der  ausschüttbare  Betrag  darf  nicht  die  Summe  der  seit  dem  Ende  des  vergangenen  Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetzes von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember

2013.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

143051

L

U X E M B O U R G

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf tausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander KUDLICH, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin; und

- Herr Christian SENITZ, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannis-

strasse 20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich BINNINGER, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: K. GAUZÈS, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 octobre 2013. LAC/2013/44369. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145392/572.
(130177766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Biscarosse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5680 Dalheim, 6, Wenkelhiel.

R.C.S. Luxembourg B 98.972.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2013 que:
- Le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à six
- Ont été nommés aux fonctions d'administrateurs pour un terme expirant lors de l'assemblée générale de 2019:
* Laure Ries, demeurant à L-5680 Dalheim, 6 Wenkelhiel
* Sébastien Ries, demeurant à L-5680 Dalheim, 6 Wenkelhiel
* Valérie Ries, demeurant à L-5680 Dalheim, 6 Wenkelhiel
* Marie-Daphnée Ries, demeurant à L-5680 Dalheim, 6 Wenkelhiel
- Les mandats de Jean Ries, demeurant à L-5680 Dalheim,6 Wenkelhiel et Jeanne Ries-Fonck, demeurant à L-5680

Dalheim, 6 Wenkelhiel ont été reconduits pour un terme expirant lors de l'assemblée générale de 2019

- Monsieur Jean-Jacques Scherer, demeurant à L-8041 Bertrange, 229 rue des Romains a été élu aux fonctions de

commissaire aux comptes pour un terme expirant lors de l'assemblée générale de 2019.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013148519/22.
(130182018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

143052

L

U X E M B O U R G

Rowan Finanz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 180.891.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of October.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

- Rowan Finance LLC, a limited liability company governed by the laws of Delaware, having its registered office at 2711

Centerville Road, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao
Conde, private employee, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a

"société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate.

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed

by the present articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law
of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28
December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée'" (the "Commercial Companies Law").

Art. 2. The Company's name is "Rowan Finanz S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,

Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other

way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the

Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same

group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favour of a third-party lender of the Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;
(7) To purchase, sell, transport freight, charter and manage sea-going vessels, and perform all financial and commercial

operations and activities relating directly or indirectly thereto. In addition, the Company may own, lease, operate, and/
or provide equipment used in contract drilling services in oil and gas drilling operations; acquire, hold, manage, sell or
dispose of any such related equipment as well as sea-going vessels; enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions relating to contract drilling services and sea-going vessels; and

(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment

of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the

143053

L

U X E M B O U R G

registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Shares

Art. 8. The Company's share capital is set at USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars), represented

by 25,000 (twenty-five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The  amount  of  the  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  means  of  a  resolution  of  the

extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-

reholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred "inter vivos" to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter

of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their

remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes
cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution
taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and "ad nutum",

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one category A manager and one category B manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its

powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

143054

L

U X E M B O U R G

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration

(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting

vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board
of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening  notices  can  be  given  to  each  manager  by  word  of  mouth,  in  writing  or  by  fax,  cable,  telegram,  telex,

electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.
The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,

including at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-

five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each sha-
reholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the

board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.

143055

L

U X E M B O U R G

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken

in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened

or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)

days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the Company

Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to

one or more statutory auditor(s) ("commissaires"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function

by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies

Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs
d'entreprises agréés") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be)
amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission ("Commission de Surveillance
du Secteur Financier")^ public register.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/her/its/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

143056

L

U X E M B O U R G

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the

sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.

<i>Subscription - Payment

Rowan Finance LLC here represented as mentioned above, subscribes to 25,000 (twenty-five thousand) shares. The

shares having been fully paid up in cash.

<i>Description of the contribution

The contribution made by Rowan Finance LLC against the issuance of shares in the Company is composed of USD

25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) in cash, so that the amount of USD 25,000 (twenty-five thousand
United States Dollars) is at of the disposal of the Company.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of

the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as category A managers:
- Gregory Michael Hatfield, born in Michigan, USA, on 29 April 1969, residing professionally at 2800 Post Oak Bou-

levard, USA - 77056 Houston, Texas.

- Michael Doyle Boykin, born in Texas, USA, on 16 November 1966, residing professionally at 2800 Post Oak Boulevard,

USA - 77056 Houston, Texas.

2) Are appointed as category B managers:
- Fabrice Stéphane Rota, born in Mont-Saint-Martin, France, on 19 February 1975, residing professionally at 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, born in Geleen, Pays-Bas, on 28 February 1971, residing professionally at

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager

and one category B manager.

143057

L

U X E M B O U R G

3) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proy holder signed with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

- Rowan Finance LLC, une société constituée selon les lois du Delaware, ayant son siège social sis à 2711 Centerville

Road, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, ici dûment représentée par Mme. Sofia Afonso Da
Chao Conde, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée

au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à

responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la société est "Rowan Finanz S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation

et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;

3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix

que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou

à toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans
ce dernier cas, même en faveur d'un tiers-prêteur des Affiliées);

6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute

somme empruntée;

7) D'acheter, de vendre, d'affréter et de gérer des navires de mer, et d'effectuer toutes les opérations financières et

commerciales et les activités liées directement ou indirectement s'y rapportant. En outre, la société peut détenir, louer,
exploiter et/ou fournir de l'équipement utilisé dans les services de forage dans les opérations de forage pétrolier et gazier;
acquérir, détenir, gérer, vendre ou disposer de tout matériel connexe ainsi que des navires de mer; conclure, aider ou
participer à des opérations financières, commerciales et autres se rapportant aux contrats de services de forage et de
navires de mer; et

7) De manière générale, de faire toute chose que la Société juge circonstanciel ou favorable à la réalisation des objets

ci-dessus décrits ou à l'un quelconque d'entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant

unique (selon le cas).

143058

L

U X E M B O U R G

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil
de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars américains) représenté par 25.000 (vingt-cinq

mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune.

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des

associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux

nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas)

par décision adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été
proposé à chaque associé de même catégorie en proportion de sa participation dans le capital social ou de la catégorie
de parts sociales concernée, représentée par ses parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B, et sa/leur

rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, «ad nutum» et à tout moment, révoquer ou

remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

143059

L

U X E M B O U R G

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en

toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses

pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération

(s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, aura un vote prépon-

dérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de
gérance sera présidé par un gérant présent et nommé à cette fonction. Il peut également choisir un secrétaire, lequel
n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de
gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)

jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans
le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment

représentés.

Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l'heure et au

lieu précisés dans d'une précédente résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen

de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer
simultanément.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité des gérants y est présente ou re-

présentée, dont au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés,

incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou par

un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B conjointement. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra
être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B conjointement.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul et même document, soit dans

plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, télex, moyens élec-

troniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Art. 14. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d'obligation personnelle quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

143060

L

U X E M B O U R G

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Cha-
que associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des

associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à
l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d'associés sont proposées

par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.

Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la

Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle
pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement

adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont

immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)

jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale

annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront

être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront

atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés

143061

L

U X E M B O U R G

par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public
des réviseurs d'entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent

être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.

L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment

que l'excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de
la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé

unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts

du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

La  liquidation  terminée,  les  avoirs  de  la  Société  seront  attribués  aux  associés  au  prorata  des  parts  sociales  qu'ils

détiennent.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Paiement

Rowan Finance LLC, ici représentée comme mentionné ci-dessus, souscrit aux 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales.

Les parts sociales ont été entièrement payés par apport en numéraire.

<i>Description de l'apport

L'apport fait par Rowan Finance LLC en échange de l'émission des parts sociales de la Société consiste en la somme

de 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars américains), de sorte que le montant de 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars
américains) est à la disposition de la société.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l'associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant la totalité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de catégorie A:

143062

L

U X E M B O U R G

- Gregory Michael Hatfield, né au Michigan, Etats-Unis d'Amérique, le 29 avril 1969, résidant professionnellement à

2800 Post Oak Blvd., Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique.

- Michael D. Boykin, né au Texas, Etats-Unis d'Amérique, le 16 novembre 1966, résidant professionnellement à 2800

Post Oak Blvd., Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique.

2) Sont nommés gérants de catégorie B de la Société:

- Fabrice Stéphane Rota, né à Mont-Saint-Martin, France, le 19 février 1975, résidant professionnellement au 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né à Geleen, Pays-Bas, le 28 février 1971, résidant professionnellement au

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un

gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

3) Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents

Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13370. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013145690/562.

(130177546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Controlinveste International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 233.900.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 149.949.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 14 octobre 2013

1. Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 octobre 2013.

2. Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Georges GUDENBURG de son mandat de gérant B de la Société,

avec effet au 3 octobre 2013.

3. Le conseil décide de coopter Monsieur Michel BULACH, né le 6 avril 1974 à Metz (France), résidant profession-

nellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en qualité de gérant B de la Société, avec effet immédiat
et décide ensuite que sa nomination sera effective jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société
en relation avec l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2013.

L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY, gérant B de la Société, est la suivante: 8-10, avenue de

la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013147897/20.

(130181139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

143063

L

U X E M B O U R G

Arjufra Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert Ier.

R.C.S. Luxembourg B 152.288.

Il résulte de résolutions écrites du gérant datées du 24 octobre 2013 que la société à responsabilité limitée Arjufra

Group Holding S.à r.l. a transféré son siège social du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 33 rue Albert 1

er

 , L-1117 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149032/12.
(130182255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

W2007 Parallel Bear S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 131.044.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 2007, acte publié

au Mémorial C no 2195

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W2007 Parallel Bear S.à r.l.
Marielle Stjiger
<i>Gérant

Référence de publication: 2013149014/14.
(130181525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

W2007 Parallel Amelia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 129.707.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 2007, acte publié au

Mémorial C no 1819

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W2007 Parallel Amelia S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérant

Référence de publication: 2013149013/14.
(130181524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 138.894.

Constituée par devant Me Paul Bettigen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 Mai 2008, acte publié au

Mémorial C no 1520

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

143064

L

U X E M B O U R G

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérant

Référence de publication: 2013149015/14.
(130181589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Advanced Network Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 74.707.

Les Comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stessen, le 24/10/2013.

<i>Pour ADVANCED NETWORK SOLUTIONS S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2013149027/12.
(130182422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

W2005/W2007 Bora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.649,64.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.399.

Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 Mai 2007, acte publié au

Mémorial C no 1488

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W2005/W2007 Bora S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérant

Référence de publication: 2013149012/14.
(130181523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

WM Kehlen (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 262.665.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.995.

Par résolutions prises en date du 15 octobre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission Göran Thorstensson, avec adresse professionnelle au 67, Grevgatan, 114 59 Stockholm,

Suède, de son mandat de gérant, avec effet au 16 octobre 2013.

2. Nomination de Lars Ek, avec adresse professionnelle au 57B, Birger Jarlsgatan, 11396 Stockhölm, Suède, au mandat

de gérant, avec effet au 16 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149007/15.
(130181754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

WPP TNS US S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 762.498.900,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 146.293.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

143065

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149011/11.
(130182156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Varfor Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 74.120.

EXTRAIT

Il résulte des lettres datées du 18 octobre 2013 que Monsieur Eddy DÔME et Mlle Aline MIQUEL ont démissionné

avec effet immédiat de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2013148989/14.
(130181954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

ZIAG A.G., Zentraleuropäische Immobilien Anlagegesellschaft A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 161.233.

Il résulte de la résolution des actionnaires de la Société tenue le 17 octobre 2013 que:
- les administrateurs ALICE MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151921, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxem-

bourg), BEATRICE MANAGEMENT S.A., (R.C.S. Luxembourg B151931, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) et
CLAIRE MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151898, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) ont été révoqués;
et

- Monsieur Zoltán Bajka (resident à Pasaréti út. 84.b., 1026 Budapest, Hongrie), Monsieur Gábor Kacsóh (résident

professionnellement à 7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg) et Madame Inessa Wendland (résident professionnellement
à 7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg) ont été nommés en tant qu'administrateurs avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013149018/18.
(130182088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

WM Belvaux (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 262.705.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.002.

Par résolutions prises en date du 15 octobre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission Göran Thorstensson, avec adresse professionnelle au 67, Grevgatan, 114 59 Stockholm,

Suède, de son mandat de gérant, avec effet au 16 octobre 2013.

2. Nomination de Lars Ek, avec adresse professionnelle au 57B, Birger Jarlsgatan, 11396 Stockhölm, Suède, au mandat

de gérant, avec effet au 16 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149005/15.
(130181753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Vopium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 141.459.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

143066

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013148991/11.
(130181541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Vianden Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.656.900,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 143.617.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013148990/10.
(130181816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Villa Remacum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 106.622.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire teinte en date du 20 juin 2013

Les actionnaires décident de nommer la société anonyme Compliance &amp; Control, inscrite au R.C.S. de Luxembourg

sous le numéro B 172.482, ayant son siège au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg en remplacement de la société
anonyme PKF Weber &amp; Bontemps au poste de commissaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en 2016.

Luxembourg le 17 octobre 2013.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2013148983/14.
(130182153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Valley Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.121.200,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 136.139.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 août 2013

Les associés de la société ont décidé
- D'approuver le changement d'adresse du siège social de Valley Investment S.à r.l. du 42, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg, au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013148984/14.
(130181479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Varian Semiconductor Equipment Associates Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.212.

Les comptes annuels au 31 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

143067

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 23 Octobre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013148981/13.
(130181460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Underground S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 55.966.

Avec effet au 2 octobre 2013, la répartition des parts sociales est la suivante:

- Mme Patricia Barthels -Sirokin
Domiciliée au 19, Rue des Près L-8147 Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

500 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Référence de publication: 2013148980/13.
(130181789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Valmar Lux S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 67, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg E 198.

L'an deux mil treize, le premier octobre,
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

Madame Sophie Mathot, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Senningerberg,
Lequel comparant a remis entre les mains du notaire instrumentant aux fins de dépôt au rang de ses minutes l'expédition

d'un acte authentique reçu en date du 24 décembre 2012 par le notaire associé Catherine GRANDIDIER-MAJERCSIK,
de résidence à Thionville (France), numéro 18.255 de son répertoire, enregistré à S I E de Thionville (France) le 17 janvier
2013 bordereau numéro 2013/56 Case numéro 2, ext 507, ledit acte contenant:

Donation à titre de partage anticipé consentie par Monsieur Robert Joseph Marie Thoma, gérant de société, et Madame

Marguerite Marie-Claire dite Rita Bour, rentière, son épouse, demeurant ensemble à L - 1750 Luxembourg, 67, avenue
Victor Hugo, au profit de leur fils Monsieur Marc Olivier WEILER, Stewart, né à Luxembourg le 23 janvier 1975, domicilié
à L - 1750 Luxembourg, 67 avenue Victor Hugo et résidant à Londres (Royaume Uni), 35 ClapHam Park Road, Kentom
appartements et de leur fille Madame Valérie THOMA, éducatrice graduée, née le 25 octobre 1977, demeurant à L - 1750
Luxembourg, 67 avenue Victor Hugo, portant sur la nue propriété de 260 parts numérotées 1 à 130 et de 151 à 280
inclus de la société civile immobilière de droit luxembourgeois VALMAR LUX S.C.I. avec siège social au 67 avenue Victor
Hugo, L - 1750 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro E 198 et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 2003 publié au Mémorial
C numéro 1367 du 24 décembre 2003.

Le prédit acte contenant en outre notamment les clauses suivantes:

<i>«Formalités

II. Registre de commerce et des Sociétés.
Mention des présentes est consentie où besoin est.
Toutes formalités de publicité légales et autres qu'il y aurait lieu et notamment dépôt de deux copies du présent acte

au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg.»

<i>«Signification

Monsieur et Madame Robert Thoma agissant en qualité de gérants de la société:
- (...)
- déclarent expressément dispenser de sa signification à la société, conformément à l'article 1690 du code civil.»

<i>«Modification des statuts

Comme conséquence de la donation de parts sociales qui précède, les articles ci après des statuts sont modifiés comme

suit:

143068

L

U X E M B O U R G

Art. 5. (Ancienne rédaction). Le capital social est fixé à trois mille euro (EUR 3.000,-), représenté par trois cents (300)

parts d'une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune, réparties comme suit:

a) Monsieur Robert Thoma, prénommé, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
b) Madame Marguerite Bour épouse Thoma, prénommée, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Total: trois cents parts sociales

Art. 5. (Nouvelle rédaction). Le capital social est fixé à trois mille euro (EUR 3.000,-), représenté par trois cents (300)

parts d'une valeur nominale de dix euro (EUR 10,-) chacune, réparties comme suit:

a) Monsieur Robert Thoma, prénommé:
Cent trente parts sociales en usufruit
Vingt parts sociales en pleine propriété
b) Madame Marguerite Bour épouse Thoma, prénommée:
Cent trente parts sociales en usufruit
Vingt parts sociales en pleine propriété
c) Monsieur Marc Olivier Weiler, prénommé, né à Luxembourg le 23 janvier 1975
cent trente parts sociales en nue propriété
d) Madame Valérie Thoma, prénommée, née à Thionville (57100) le 25 octobre 1977:
cent trente parts sociales en nue propriété
Total: trois cents parts sociales 300»
Pour le surplus, il est renvoyé expressément aux dispositions de l'acte dont l'expédition, paraphée «ne varietur» par

le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualité qu'il agisse, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 octobre 2013. LAC / 2013 / 45439. Reçu 24.-€ / 12,00.-€ Amende 12,00.-€ /

24,00.-€

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 octobre 2013.

Référence de publication: 2013148986/67.
(130181494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Asteo Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, Boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 164.062.

L'an deux mille treize, le trois octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Aubin THOMINE-DESMAZURES, chef d'entreprise, né le 7 juillet 1966 à Neuilly sur Seine (F), demeurant

professionnellement à L-2330 Luxembourg, 120, Boulevard de la Pétrusse

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que il est le seul associé actuel de «Asteo Luxembourg», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à

L-2330 Luxembourg, 120, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 164.062, que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 19 septembre 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 2921 du 29 novembre 2011.

et qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-sept mille cinq cents euros

(EUR 37.500,-), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), à cinquante mille
euros (EUR 50.000,-), par l'émission et la création de quatre cents (400) parts sociales nouvelles sans valeur nominale.

143069

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et Libération

Les quatre cents (400) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par l'associé

unique par incorporation de réserves à concurrence de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-).

La justification de l'existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sans désignation de la valeur nominale.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ mille deux cinquante euros (EUR 1.250,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Aubin THOMINE-DESMAZURES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 octobre 2013. Relation GRE/2013/4080. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149036/41.
(130182627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Watt Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1632 Luxembourg, 27, rue Gluck.

R.C.S. Luxembourg B 130.477.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013149003/10.
(130182143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Arlette Schneiders Architectes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 3, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.714.

Les Comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 24/10/2013.

<i>Pour Arlette Schneiders Architectes S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2013149033/12.
(130182418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Walvek S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 74.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149001/9.
(130181595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

143070

L

U X E M B O U R G

ADNEOM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 25/10/2013.

Référence de publication: 2013149555/10.
(130183119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Boise European Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.001,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 164.553.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Octobre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013149589/13.
(130183736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Arilco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 71.232.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 11 octobre 2013

L'administrateur unique, à savoir, Monsieur Philippe DERVILLE, né le 20/08/1956 à Paris (France), tient à notifier son

changement d'adresse:

16, rue du Cimetière
L-8286 Kehlen

Windhof, le 11 octobre 2013.

Pour extrait conforme
<i>L'actionnaire unique

Référence de publication: 2013149572/15.
(130183162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Ancelux Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 174.036.

In the year two thousand thirteen, on the seventeenth of September.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Mrs. Alexia UHL, private employee, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of managers of Ancelux S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.035, acting as the general partner and
sole manager (the "Manager") of Ancelux Topco S.C.A., a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société
en commandite par actions), having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.036 (the "Company"),

duly authorised to that effect pursuant to the resolutions of the Manager, acting in its capacity as general partner and

sole manager of the Company, dated 16 September 2013.

143071

L

U X E M B O U R G

The appearing party has required the undersigned notary to enact the following:
1) Pursuant to article 5.1 of the articles of association of the Company (the "Articles"), the issued share capital of the

Company is fixed at three hundred twenty-one thousand two hundred ninety one US Dollars and forty cents (USD
321,291.40) divided into:

- one hundred (100) unlimited shares (the "Unlimited Shares"),
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) ordinary non-redeemable shares (the "Ordinary

Shares"),

- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A1 shares,
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A2 shares,
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A3 shares,
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A4 shares,
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A5 shares,
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A6 shares,
- four million sixteen thousand one hundred and thirty (4,016,130) redeemable class A7 shares.
all class A1 to class A7 shares are referred as the "Special Shares", with a nominal value of one US Dollar cent (USD

0.01) per share, all fully paid up (by 100%).

2) Pursuant to article 5.3 of the Articles, within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized

and empowered to realize any increase of the share capital or equity of the Company with or without the issuance of
new Capital Shares, it being understood that the Manager is authorized to issue such new shares in one or several issues
and that the Manager is free to determine in relation to each issue which class(es) of new shares such issue will relate to
and (ii) issue bonds, preferred equity certificates, warrants, options or other instruments convertible, exchangeable or
exercisable into shares and to issue shares further to the conversion or exercise of the above mentioned instruments, it
being understood that if such instruments are issued during the period set forth in article 5.3.5 below, the shares upon
the conversion or exercise of such instruments may be issued after the expiry of said period, it being understood that
the Manager is authorized to issue such new shares in one or several issues and that the Manager is free to determine in
relation to each issue which class(es) of new shares such issue will relate to.

The shares and the instruments to be issued in accordance with the provisions of article 5.3.2 of the Articles may be

paid up through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings,
including in the three latter cases in favor of new shareholders. The shares to be issued in accordance with the provisions
of article 5.3 of the Articles may be issued with or without share premium, it being understood that (i) such shares shall
not be issued at a price below their nominal value and (ii) if the consideration payable to the Company for thus newly
issued shares exceeds their nominal value, the excess is to be treated as share premium in respect of such shares in the
books of the Company.

The Manager is specially authorized to issue such shares and, where applicable, the instruments to be issued in ac-

cordance with the provisions of article 5.3 of the Articles without reserving (i.e. by cancelling or limiting) for the existing
Shareholders the preferential right to subscribe for such shares. The cancellation of preferential subscription rights is to
be made in compliance with the relevant provisions of any Shareholders' agreement that may be entered into by the
Shareholders from time to time.

The authorization will expire on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg official gazette of

the minutes of the general meeting held on 28 December 2012 and can be renewed in accordance with the applicable
legal provisions, it being understood that the Manager can proceed to an increase of share capital or issue of the above
mentioned instruments as of date of the shareholder's meeting adopting this clause.

The Manager is authorized to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the

terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares (referred to in article 5.3 of the Articles)
and, if applicable, the duration, amortization, other rights (including early repayment), interest rates, conversion rates and
exchange rates of the aforesaid instruments (referred to in article 5.3 of the Articles) as well as all the other conditions
and terms of such instruments including as to their subscription, issue and payment.

The Manager is authorized to do all things necessary to amend articles 5.1 and 5.3 of the Articles in order to record

the change of issued and authorized share capital following any increase pursuant to the present article. The Manager is
empowered to take or authorize the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the Law. Furthermore, the Manager may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions,
conversions or exchanges and receiving payment for shares, bonds, preferred equity certificates, warrants, options or
instruments and to do all things necessary to amend article 5 of the present Articles in order to record the change of
issued and authorized share capital following any increase pursuant to article 5.3 of the Articles.

3) By resolutions dated 27 June 2013, 16 July 2013 and 16 September 2013, the Manager has resolved to approve the

following issuances of new shares of the Company:

a) 1,613 new non redeemable ordinary shares, 1,613 new class A1 shares, 1,613 new class A2 shares, 1,613 new class

A3 shares, 1,613 new class A4 shares, 1,613 new class A5 shares, 1,613 new class A6 shares, 1,613 new class A7 shares
with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each (the "June New Shares"), by cancelling the preferential

143072

L

U X E M B O U R G

subscription rights of the existing shareholders, pursuant to article 5.3 of the Articles, so as to increase the share capital
of the Company by a total amount of one hundred twenty-nine US Dollars and four cents (USD 129.04) so as to raise it
from its current amount of three hundred twenty-one thousand two hundred ninety-one US Dollars and forty cents
(USD 321,291.40) to three hundred twenty-one thousand four hundred twenty US Dollars and forty-four cents (USD
321,420.44), together with the payment of a share premium of a total amount of two hundred forty-nine thousand eight
hundred sixty-nine US Dollars and eighty-three cents (USD 249,869.83).

b) The June New Shares have been subscribed and fully paid up by Anvil MIV LLC, with effect as of 27 June 2013, as

indicated in the Manager resolutions dated 16 September 2013.

c) 645 new non redeemable ordinary shares, 645 new class A1 shares, 645 new class A2 shares, 645 new class A3

shares, 645 new class A4 shares, 645 new class A5 shares, 645 new class A6 shares, 645 new class A7 shares with a
nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each (the "July New Shares"), by cancelling the preferential subscription
rights of the existing shareholders, pursuant to article 5.3 of the Articles, so as to increase the share capital of the Company
by a total amount of fifty-one US Dollars and sixty cents (USD 51.60) so as to raise it from its current amount of three
hundred twenty-one thousand four hundred twenty US Dollars and forty-four cents (USD 321,420.44) to three hundred
twenty-one thousand four hundred seventy-two US Dollars and four cents (USD 321,472.04), together with the payment
of a share premium of a total amount of ninety-nine thousand nine hundred sixteen US Dollars and ninety-five cents (USD
99,916.95).

d) The July New Shares have been subscribed and fully paid up by Anvil MIV LLC, with effect as of 13 August 2013, as

indicated in the Manager resolutions dated 16 September 2013.

e) 7,156 new non redeemable ordinary shares, 7,156 new class A1 shares, 7,156 new class A2 shares, 7,156 new class

A3 shares, 7,156 new class A4 shares, 7,156 new class A5 shares, 7,156 new class A6 shares, 7,156 new class A7 shares
with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each (the "September New Shares"), by cancelling the preferential
subscription rights of the existing shareholders, pursuant to article 5.3 of the Articles, so as to increase the share capital
of the Company by a total amount of five hundred seventy-two US Dollars and forty-eight cents (USD 572.48) so as to
raise it from its current amount of three hundred twenty-one thousand four hundred seventy-two US Dollars and four
cents  (USD  321,472.04)  to  three  hundred  twenty-two  thousand  forty-four  US  Dollars  and  fifty-two  cents  (USD
322,044.52).

f) The September New Shares have been subscribed and fully paid up, with effect as of 16 September 2013, as follows:
- 2,618 new non redeemable ordinary shares, 2,618 new class A1 shares, 2,618 new class A2 shares, 2,618 new class

A3 shares, 2,618 new class A4 shares, 2,618 new class A5 shares, 2,618 new class A6 shares, 2,618 new class A7 shares
by Howard Hochhauser; and

- 4,538 new non redeemable ordinary shares, 4,538 new class A1 shares, 4,538 new class A2 shares, 4,538 new class

A3 shares, 4,538 new class A4 shares, 4,538 new class A5 shares, 4,538 new class A6 shares, 4,538 new class A7 shares
by Scott Sorensen.

4) The justifying documents for the issuance and subscription of the June New Shares, the July New Shares and the

September New Shares have been shown to the undersigned notary, who expressly acknowledges them.

5) As a consequence of the several increases of the share capital, with effect as of 16 September 2013, the subscribed

share capital of the Company presently amounts to three hundred twenty-two thousand forty-four US Dollars and fifty-
two cents (USD 322,044.52).

Therefore article 5.1 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:

5.1. The issued share capital of the Company is set at three hundred twenty-two thousand forty-four US Dollars and

fifty-two cents (USD 322,044.52) divided into:

- one hundred (100) unlimited shares (the "Unlimited Shares"),
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) ordinary non-redeemable shares (the "Or-

dinary Shares"),

- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A1 shares,
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A2 shares,
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A3 shares,
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A4 shares,
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A5 shares,
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A6 shares,
- four million twenty-five thousand five hundred and forty-four (4,025,544) redeemable class A7shares,
all class A1 to class A7 shares are referred as the "Special Shares", with a nominal value of one United States Dollar

cent (USD 0.01) per share, fully paid up. The Special Shares and the Ordinary Shares are hereinafter referred to as the
"Capital Shares"."

6) Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorized capital

clause, the amount of the authorized share capital as set out in the first paragraph of article 5.3 of the Articles of the
Company has been decreased to eighty-nine million nine hundred ninety-seven thousand nine hundred fifty-six US Dollars

143073

L

U X E M B O U R G

and forty-eight cents (USD 89,997,956.48), so that the first sentence of article 5.3 of the Articles is amended accordingly
and now reads as follows:

5.3. The un-issued but authorized share capital of the Company is set at eighty-nine million nine hundred ninety-

seven thousand nine hundred fifty-six US Dollars and forty-eight cents (USD 89,997,956.48)."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said appearing person has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-sept septembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Madame Alexia UHL, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire du conseil de gérance de Ancelux S.à r.l., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.035, en sa qualité de gérant commandité et gérant
unique (le "Gérant Commandité") de Ancelux Topco S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise,
ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.036 (la "Société"),

dûment autorisée à cet effet conformément aux résolutions du Gérant Commandité, agissant en sa capacité de gérant

commandité et gérant unique de la Société, en date du 16 septembre 2013.

La comparante a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
1) Conformément à l'article 5.1 des statuts de la Société (les "Statuts"), le capital social de la Société est fixé à trois

cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt onze US Dollars et quarante centimes (USD 321.291,40) représenté par:

- cent (100) actions de commandité ("Actions de Commandité"),
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions ordinaires ("Actions Ordinaires"),
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A1 rachetables,
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A2 rachetables,
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A3 rachetables,
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A4 rachetables,
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A5 rachetables,
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A6 rachetables,
- quatre millions seize mille cent trente (4.016,130) actions A7 rachetables, toutes les actions de catégorie A1 à A7

sont dénommées ci-après comme les "Actions Spéciales", ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar Américain
(USD 0,01) chacune, toutes les actions susmentionnées sont entièrement libérées.

Conformément à l'article 5.3 des Statuts, le Gérant Commandité est autorisé, dans les limites du capital autorisé, à (i)

réaliser toute augmentation du capital social ou des fonds de la Société avec ou sans l'émission de nouvelles Actions de
Capital, étant entendu que le Gérant Commandité est autorisé à émettre de telles nouvelles Actions de Capital en une
ou plusieurs émissions et que le Gérant Commandité est libre de déterminer la/les catégorie(s) de nouvelles actions
concernée(s) par chaque émission et (ii) l'émission d'obligations, de preferred equity certificates, warrants, options ou
tous autres instruments convertibles, échangeables ou exerçables en actions et d'émettre des actions suite à la conversion
ou l'exercice des instruments susmentionnés, étant entendu que si de tels instruments sont émis dans la période fixée à
l'article 5.3.5 des Statuts, les actions suite à la conversion ou l'exercice de tels instruments peuvent être émises après
l'expiration de ladite période, il est entendu que le Gérant Commandité est autorisé à émettre lesdites nouvelles actions
en une ou plusieurs fois et que le Gérant Commandité est libre de déterminer la/les nouvelles catégorie(s) d'actions qui
seront concernée(s) par chaque émission.

143074

L

U X E M B O U R G

Les actions et les instruments à émettre conformément aux dispositions de l'article 5.3.2 des Statuts peuvent être

payés par le biais d'apports en numéraire ou en nature par l'incorporation de réserves, de primes d'émission ou de profits
non distribués, y compris en faveur de nouveaux actionnaires pour les trois derniers. Les actions à émettre conformément
à l'article 5.3.2 des Statuts peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, étant entendu que (i) de telles actions ne
peuvent être émises à un prix inférieur à leur valeur nominale et (ii) si la contrepartie due à la Société pour les nouvelles
actions émises était supérieure à leur valeur nominale, alors l'excédent devrait être inscrit en tant que prime d'émission
à l'égard desdites actions dans les comptes de la Société.

Le Gérant Commandité est spécialement autorisé à émettre lesdites actions et, lorsqu'applicable, les instruments à

émettre conformément aux dispositions de l'article 5.3.2 des Statuts, sans réserver (par annulation ou limitation) le droit
préférentiel  de  souscription  des  Actionnaires  existants  pour  souscrire  à  de  telles  actions.  La  suppression  des  droits
préférentiels de souscription doit être réalisée conformément aux dispositions applicables de tout pacte d'Actionnaires
ayant pu être conclu par les Actionnaires de temps à autre.

L'autorisation expirera au cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial C du procès-verbal d'assemblée

générale tenue le 28 décembre 2012 et peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables, étant
entendu que le Gérant Commandité peut procéder à une augmentation de capital ou à une émission des instruments
susmentionnés tel qu'à la date de l'assemblée générale ayant adopté cet article.

Le Gérant Commandité est autorisé à déterminer la place et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix

d'émission, les termes et conditions de la souscription et de libération des Actions (mentionnées dans cet article 5.3 des
Statuts) et si applicable, la durée, l'amortissement, les autres droits (y compris le remboursement anticipé), les taux
d'intérêt, les taux de conversion et d'échange desdits instruments (mentionnés dans cet article 5.3 des Statuts) ainsi que
tous les autres termes et conditions de tels instruments, y compris leur souscription, émission et paiement.

Le Gérant Commandité et autorisé à effectuer toutes les actions nécessaires pour modifier les articles 5.1 et 5.3 des

Statuts afin d'acter le changement du capital social émis et du capital social autorisé suivant toute augmentation confor-
mément au présent article. Le Gérant Commandité est habilité à prendre ou autoriser les actions requises pour l'exécution
et la publication d'une telle modification conformément à la Loi. De plus, le Gérant Commandité peut déléguer à toute
personne dûment autorisée les fonctions d'accepter les souscriptions, les conversions ou échanges de recevoir le paiement
pour les actions, obligations, preferred equity certificates, warrants, options ou instruments et faire toutes les actions
nécessaires pour modifier l'article 5 des présents Statuts afin d'enregistrer le changement du capital social émis et autorisé
suivant toute augmentation conformément à l'article 5.3 des Statuts.

2) Par résolutions prises en date du 27 juin 2013, 16 juillet 2013 et 16 septembre 2013, le Gérant Commandité a

décidé d'approuver les émissions suivantes de nouvelles actions de la Société:

a) 1.613 nouvelles actions ordinaires non rachetables, 1.613 nouvelles actions A1, 1.613 nouvelles actions A2, 1.613

nouvelles actions A3, 1.613 nouvelles actions A4, 1.613 nouvelles actions A5, 1.613 nouvelles actions A6 et 1.613 nouvelles
actions A7, avec une valeur nominale d'un centime de US Dollar (USD 0,01) chacune (les "Nouvelles Actions de Juin"),
en annulant les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels, conformément à l'article 5.3 des Statuts, de
manière à augmenter le capital social de la Société d'un montant total de cent vingt-neuf US Dollars et quatre centimes
(USD 129.04) afin de l'élever de son montant actuel de trois cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-onze US Dollars
et quarante centimes (USD 321.291,40,-) à trois cent vingt et un mille quatre cent vingt US Dollars et quarante-quatre
centimes (USD 321.420,44), avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent quarante-neuf mille huit cent
soixante-neuf US Dollars et quatre-vingt-trois centimes (USD 249.869,83).

b) Les Nouvelles Actions de Juin ont été souscrites et entièrement libérées par Anvil MIV LLC, avec effet au 27 juin

2013, tel qu'indiqué dans les résolutions du Gérant Commandité en date du 16 septembre 2013.

c) 645 nouvelles actions ordinaires non rachetables, 645 nouvelles actions A1, 645 nouvelles actions A2, 645 nouvelles

actions A3, 645 nouvelles actions A4, 645 nouvelles actions A5, 645 nouvelles actions A6 et 645 nouvelles actions A7,
avec une valeur nominale d'un centime de US Dollar (USD 0,01) chacune (les "Nouvelles Actions de Juillet"), en annulant
les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels, conformément à l'article 5.3 des Statuts, de manière à
augmenter le capital social de la Société d'un montant total de cinquante et un US Dollars et soixante centimes (USD
51.60) afin de l'élever de son montant actuel de trois cent vingt et un mille quatre cent vingt US Dollars et quarante-
quatre centimes (USD 321.420,44) à trois cent vingt et un mille quatre cent soixante-douze US Dollars et quatre centimes
(USD 321.472,04), avec une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent seize US Dollars
et quatre-vingt-quinze centimes (USD 99.916,95).

d) Les Nouvelles Actions de Juillet ont été souscrites et entièrement libérées par Anvil MIV LLC, avec effet au 13

August 2013, tel qu'indiqué dans les résolutions du Gérant Commandité en date du 16 septembre 2013.

e) 7.156 nouvelles actions ordinaires non rachetables, 7.156 nouvelles actions A1, 7.156 nouvelles actions A2, 7.156

nouvelles actions A3, 7.156 nouvelles actions A4, 7.156 nouvelles actions A5, 7.156 nouvelles actions A6 et 7.156 nouvelles
actions A7, avec une valeur nominale d'un centime de US Dollar (USD 0,01) chacune (les "Nouvelles Actions de Sep-
tembre"), en annulant les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels, conformément à l'article 5.3 des
Statuts, de manière à augmenter le capital social de la Société d'un montant total de cinq cent soixante-douze US Dollars
et quarante-huit centimes (USD 572.48) afin de l'élever de son montant actuel de trois cent vingt et un mille quatre cent

143075

L

U X E M B O U R G

soixante-douze US Dollars et quatre centimes (USD 321.472,04) à trois cent vingt deux mille quarante-quatre US Dollars
et cinquante-deux centimes (USD 322.044,52).

f) Les Nouvelles Actions de Septembre ont été souscrites et entièrement libérées par Anvil MIV LLC, avec effet au 16

Septembre 2013, tel qu'indiqué dans les résolutions du Gérant Commandité en date du 16 septembre 2013:

- 2.618 nouvelles actions ordinaires non rachetables, 2.618 nouvelles actions A1, 2.618 nouvelles actions A2, 2.618

nouvelles actions A3, 2.618 nouvelles actions A4, 2.618 nouvelles actions A5, 2.618 nouvelles actions A6 et 2.618 nouvelles
actions A7 par Howard Hochhauser; et

- 4.538 nouvelles actions ordinaires non rachetables, 4.538 nouvelles actions A1, 4.538 nouvelles actions A2, 4.538

nouvelles actions A3, 4.538 nouvelles actions A4, 4.538 nouvelles actions A5, 4.538 nouvelles actions A6 et 4.538 nouvelles
actions A7 par Scott Sorensen.

3) Les documents justificatifs de la souscription et libération des Nouvelles Actions de Juin, des Nouvelles Actions de

Juillet et des Nouvelles Actions de Septembre ont été montrés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.

4) Suite aux diverses augmentations de capital susmentionnées, avec effet au 16 Septembre 2013, le capital souscrit

de la Société s'élève à présent à trois cent vingt deux mille quarante-quatre US Dollars et cinquante-deux centimes (USD
322.044,52).

Il s'ensuit que l'article 5.1 des Statuts est modifié et doit être lu comme suit:

5.7. Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent vingt deux mille quarante-quatre US Dollars et cinquante-

deux centimes (USD 322.044,52) représenté par:

- cent (700) actions de commandité ("Actions de Commandité"),
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions ordinaires ("Actions Ordinaires"),
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A7 rachetables,
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A2 rachetables,
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A3 rachetables,
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A4 rachetables,
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A5 rachetables,
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A6 rachetables,
- quatre millions vingt-cinq mille cinq cent quarante-quatre (4.025.544) actions A7 rachetables,
toutes les actions de catégorie A7 à A7 sont dénommées ci-après comme les "Actions Spéciales", ayant une valeur

nominale d'un centime de US Dollars (USD 0,07) chacune, entièrement libérées. Les Actions Spéciales et les Actions
Ordinaires sont ensuite dénommées les "Actions de Capital".

5) De plus, en conséquence de l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus intervenue dans le cadre de la clause

de capital autorisé, le montant du capital autorisé tel qu'il figure dans l'article 5.3 des Statuts a été réduit à quatre-vingt-
neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent cinquante-six US Dollars et quarante-huit centimes (USD
89.997.956,48) de sorte que le premier paragraphe de l'article 5.3 des Statuts est modifié et doit être lu comme suit:

5.3. Le capital social de la Société non-émis mais autorisé est fixé à quatre-vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-

dix-sept mille neuf cent cinquante-six US Dollars et quarante-huit centimes (USD 89.997.956,48)."

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte de

la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à mille cinq cents euros (1.500,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne
comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la personne comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par son nom,

prénom, état civil et domicile, ladite personne comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2013. LAC/2013/42590. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149540/299.
(130183267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

143076

L

U X E M B O U R G

Arilco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 71.232.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 25/10/2013.

Référence de publication: 2013149571/10.
(130183127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Axelan Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.956.

<i>Résolution du Gérant Unique prise le 22 avril 2013

Est présent:
- Monsieur Alistair Brown
La présente réunion a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société;
2. Divers.
Le Gérant Unique prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Gérant Unique décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 43,

avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Monsieur Alistair Brown.

Référence de publication: 2013149576/20.
(130183561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Auluxe, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 108.133.

<i>Extrait du Conseil d'Administration du 9 octobre 2013

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 28, boulevard Joseph II, L-1840 Lu-

xembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149575/11.
(130182984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Alliance Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4779 Pétange, 15, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 75.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ALLIANCE GESTION S.A.

Référence de publication: 2013149566/10.
(130182946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

143077

L

U X E M B O U R G

Boise European Holdings 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.001,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 164.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Octobre 2013.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013149588/13.
(130183737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 173.008.

<i>Extrait des décisions prises par les gérants en date du 3 septembre 2013

Le siège social a été transféré de L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013149587/14.
(130183208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Ancelux Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 174.036.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth of September,
Before the undersigned, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Ancelux Topco S.C.A., a Luxem-

bourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 282,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 174036 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 7 December 2012, whose articles
of incorporation (the "Articles") been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 393 on
18 February 2013 (page 18852). The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 14 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1039 on 2
May 2013 (page 49836).

The Meeting elected as chairman, Mrs Monique GOERES, private employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Alexia UHL, private employee, with

professional address in Luxembourg.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
(i) The names of the shareholders present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies (together the

"Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these
minutes. This attendance list, signed by the shareholders present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies,
by the office of the Meeting and the by undersigned notary, will remain annexed to the present minutes to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the
proxyholder(s) of the represented shareholders, by the office of the Meeting and by the undersigned notary, will also
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(ii) The attendance list shows that the Appearing Shareholders holding all of the 100 unlimited shares, 4,025,544

ordinary shares, 4,025,544 class A1 shares, 4,025,544 class A2 shares, 4,025,544 class A3 shares, 4,025,544 class A4 shares,
4,025,544 class A5 shares, 4,025,544 class A6 shares and 4,025,544 class A7 shares, representing the whole share capital

143078

L

U X E M B O U R G

of the Company are present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies. All the Appearing Shareholders
have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all
convening requirements and formalities. The Meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items
of the agenda.

(iii) The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. To reduce the Company's share capital by an amount of USD 320.32 in order to reduce it from its current amount

of USD 322,044.52 to USD 321,724.20 by cancellation of 4,004 ordinary shares, 4,004 class A1 shares, 4,004 class A2
shares, 4,004 class A3 shares, 4,004 class A4 shares, 4,004 class A5 shares, 4,004 class A6 shares and 4,004 class A 7
shares, with a nominal value of USD 0.01 each and owned by the Company at the time of the decision to cancel them.

2. To acknowledge and approve the repurchase by the Company, pursuant to a resolution of the board of managers

of the Company's manager passed on the date of this meeting of shareholders and based on interim accounts dated 17
September 2013, of each of the 4,021,540 class A7 shares in the Company, representing all of the Company's class A7
shares,  with  a  nominal  value  of  USD  0.01  each  (the  "Repurchased  Shares")  at  a  total  repurchase  price  of  USD
265,559,321.18 and to reduce the Company's share capital by an amount of USD 40,215.40 in order to bring it from its
amount of USD 321,724.20 to USD 281,508.80 by the cancellation of the Repurchased Shares.

3. To amend articles 5.1 and 5.6 (first paragraph) of the Articles to reflect the foregoing.
4. To amend article 26.2.1 of the Articles to remove the reference to class A7 shares.
After due and careful deliberation, the Appearing Shareholders unanimously pass the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of USD 320.32 in order to reduce it from

its current amount of USD 322,044.52 to USD 321,724.20 by cancellation of 4,004 ordinary shares, 4,004 class A1 shares,
4,004 class A2 shares, 4,004 class A3 shares, 4,004 class A4 shares, 4,004 class A5 shares, 4,004 class A6 shares and 4,004
class A7 shares, with a nominal value of USD 0.01 each and owned by the Company at the time of the decision to cancel
them.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge and approve the repurchase by the Company, pursuant to a resolution of the

board of managers of the Company's manager passed on the date of this meeting of shareholders and based on interim
accounts dated 17 September 2013, of each of the 4,021,540 class A7 shares in the Company, representing all of the
Company's class A7 shares, with a nominal value of USD 0.01 each (the "Repurchased Shares") at a total repurchase price
of USD 265,559,321.18 and to reduce the Company's share capital by an amount of USD 40,215.40 in order to bring it
from its amount of USD 321,724.20 to USD 281,508.80 by the cancellation of the Repurchased Shares.

Authorisation: The Meeting authorises and instructs the Company's manager to update the Company's shareholders

register.

<i>Third resolution

In order to reflect the foregoing, the Meeting resolves to amend articles 5.1 and 5.6 (first paragraph) of the Articles,

which shall now read as follows:

5.1. The issued share capital of the Company is set at two hundred and eighty-one thousand five hundred and eight

US dollars and eighty cents (USD 281,508.80) divided into:

- one hundred (100) unlimited shares (the "UnlimitedShares"),
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) redeemable class A1 shares,
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) redeemable class A2 shares,
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) redeemable class A3 shares,
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) redeemable class A4 shares,
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) redeemable class A5 shares, and
- four million twenty-one thousand five hundred and forty (4,021,540) redeemable class A6 shares.
All class A1 to class A6 shares are referred to as the "Special Shares". The Special Shares and the Ordinary Shares are

hereinafter referred to as the "Capital Shares" or the "Shares", with a nominal value of one US dollar cent (USD 0.01)
per share, fully paid up."

5.6. The share capital of the Company may be reduced by the cancellation of one or more entire classes of Special

Shares through the repurchase and cancellation of all the Special Shares in issue in such class(es), in accordance with the
provisions as set out in these articles 5.6 to 5.7 included. In the case of repurchases and cancellations of classes of Special
Shares such cancellations and repurchases shall be made in the reverse numerical order (starting with the class A6 shares)."

143079

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 26.2.1 of the Articles to remove the reference to class A7 shares, which article

shall now read as follows:

26.2.1. Fixed dividends. The holder(s) of the Unlimited Shares shall receive an annual fixed dividend calculated as a

percentage corresponding to 10% of the nominal value of each Unlimited Shares.

The holders of the Special Shares are entitled to the following annual fixed dividends to be paid proportionally between

each classes of shares:

- the holders of class A1 shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point ten per

cent (0.10%) of the nominal value of the class A1 shares held by them,

- the holders of class A2 shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point fifteen

per cent (0.15%) of the nominal value of the class A2 shares held by them,

- the holders of class A3 shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point twenty

per cent (0.20%) of the nominal value of the class A3 shares held by them,

- the holders of class A4 shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point twenty-

five per cent (0.25%) of the nominal value of the class A4 shares held by them,

- the holders of class A5 shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point thirty per

cent (0.30%) of the nominal value of the class A5 shares held by them,

- the holders of class A6 shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of zero point thirty-

five  per  cent  (0.35%)  of  the  nominal  value  of  the  class  A6  shares  held  by  them  plus  the  remainder  of  any  dividend
distribution.

Should any class of shares have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the

distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the next outstanding class of shares to
be redeemed in the reverse numerical order (e.g. initially class A6 Shares).

In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distributable

sums within the meaning of the 1915 Law and in accordance with the applicable provisions of the 1915 Law."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).

<i>Statement

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huit septembre,
Par-devant le soussigné, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de Ancelux Topco S.C.A., une société

en  commandite  par  actions  luxembourgeoise,  ayant  son  siège  social  au  282,  route  de  Longwy,  L-1940  Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174036 (la "Société") et
constituée en vertu d'un acte rédigé par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2012, dont les statuts (les
"Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 393 en date du 18 février 2013
(page 18852). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte rédigé par le notaire soussigné en date du 14
février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1039 en date du 2 mai 2013 (page
49836).

L'Assemblée élit comme président Madame Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne en qualité de secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Alexia UHL, employée

privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre

acte que:

(i) Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée par des mandataires (collectivement les "Action-

naires Comparants") et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur la liste de présence à la fin de ce procès-

143080

L

U X E M B O U R G

verbal. Cette liste de présence, signée par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée par des mandataires,
par les membres du bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par le(s)
mandataire(s) des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné, res-
teront également annexées au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(ii) La liste de présence montre que les Actionnaires Comparants détenant toutes les 100 actions de commandité,

4.025.544 actions ordinaires, 4.025.544 actions A1, 4.025.544 actions A2, 4.025.544 actions A3, 4.025.544 actions A4,
4.025.544 actions A5, 4.025.544 actions A6 et 4.025.544 actions A7, représentant la totalité du capital social de la Société
sont présents à l'Assemblée ou représentés par des mandataires. Tous les Actionnaires Comparants ont déclaré qu'ils
avaient été suffisamment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée préalablement à celle-ci et qu'ils renonçaient aux
formalités de convocation. L'Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du
jour.

(iii) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 320,32 afin de le réduire de son montant actuel de USD

322.044,52 à USD 321.724,20 par l'annulation de 4.004 actions ordinaires, 4.004 actions A1, 4.004 actions A2, 4.004
actions A3, 4.004 actions A4, 4.004 actions A5, 4.004 actions A6 et 4.004 actions A7, ayant une valeur nominale de USD
0,01 chacune et détenues par la Société au moment de la décision de leur annulation.

2. Reconnaître et approuver le rachat par la Société, en vertu d'une résolution du conseil de gérance du gérant com-

mandité de la Société passée à la date de cet assemblée des actionnaires et basée sur des comptes intérimaires datés 17
septembre 2013, de chacune des 4.021.540 actions A7 de la Société ayant une valeur nominale de USD 0,01 chacune (les
"Actions Rachetées") à un prix de rachat total de USD 265.559.321,18 et réduire le capital social de la Société d'un
montant de USD 40.215,40 pour le réduire de son montant actuel de USD 321.724,20 à USD 281.508,80 par l'annulation
des Actions Rachetées.

3. Modifier les articles 5.1 et 5.6 (premier paragraphe) des Statuts afin de refléter ce qui précède.
4. Modifier l'article 26.2.1 des Statuts afin d'enlever la référence aux actions A7.
Après délibération attentive, les Actionnaires Comparants ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 320,32 afin de le réduire de son

montant actuel de USD 322.044,52 à USD 321.724,20 par l'annulation de 4.004 actions ordinaires, 4.004 actions Al, 4.004
actions A2, 4.004 actions A3, 4.004 actions A4, 4.004 actions A5, 4.004 actions A6 et 4.004 actions A7, ayant une valeur
nominale de USD 0,01 chacune et détenues par la Société au moment de la décision de leur annulation.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reconnaître et d'approuver le rachat par la Société, en vertu d'une résolution du conseil de

gérance du gérant commandité de la Société passée à la date de cet assemblée des actionnaires et basée sur des comptes
intérimaires datés 17 septembre 2013, de chacune des 4.021.540 actions A7 de la Société ayant une valeur nominale de
USD 0,01 chacune (les "Actions Rachetées") à un prix de rachat total de USD 265.559.321,18 et réduire le capital social
de la Société d'un montant de USD 40.215,40 pour le réduire de son montant actuel de USD 321.724,20 à USD 281.508,80
par l'annulation des Actions Rachetées.

Autorisation: L'Assemblée autorise et instruit le conseil de gérance de la Société de mettre à jour la registre des

associés de la Société.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l'Assemblée décide modifier les articles 5.1 et 5.6 (premier paragraphe) des Statuts,

qui seront désormais rédigés comme suit:

5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-un mille cinq cent huit US dollars et quatre

vingt centimes (USD 287.508,80) représenté par:

- cent (700) actions de commandité (les "Actions de Commandité"),
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.027.540) d'actions ordinaires (les "Actions Ordinaires"),
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.027.540) actions A7 rachetables,
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.027.540) actions A2 rachetables,
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.027.540) actions A3 rachetables,
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.027.540) actions A4 rachetables,
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.027.540) actions A5 rachetables, et
- quatre millions vingt et un mille cinq cent quarante (4.021.540) actions A6 rachetables.

143081

L

U X E M B O U R G

Toutes les actions de catégorie A1 à A6 sont dénommées ci-après comme les "Actions Spéciales". Les Actions Spéciales

et les Actions Ordinaires sont ci-après désignées les "Actions de Capital" ou les "Actions", ayant une valeur nominale
d'un centime de US dollar (USD 0,01) chacune, entièrement libérées."

5.6. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'une ou plusieurs catégories entières d'Actions

Spéciales par le rachat et l'annulation de toutes les Actions Spéciales émises dans de telle(s) catégorie(s) conformément
aux dispositions contenues aux articles 5.6 et 5.7 inclus. Dans le cas de rachats et annulations des catégories d'Actions
Spéciales, de telles annulations et rachats devront être effectués dans l'ordre numérique inverse (en commençant par la
catégorie d'actions A6)."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide modifier l'article 26.2.1 des Statuts afin d'enlever la référence aux actions A7, qui sera désormais

rédigé comme suit:

26.2.1. Dividendes fixes. Les détenteurs des Actions de Commandité recevront un dividende fixe annuel calculé comme

un pourcentage correspondant à 10% de la valeur nominale de chaque Action de Commandité.

Les détenteurs des Actions Spéciales ont droit aux dividendes fixes annuels suivants à payer proportionnellement entre

chaque catégorie d'actions:

- Les détenteurs des Actions de catégorie A1 ont le droit de recevoir une distribution de dividendes d'un montant de

zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale des Actions de catégorie A1 détenues par eux;

- Les détenteurs des Actions de catégorie A2 ont le droit de recevoir une distribution de dividendes d'un montant de

zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale des Actions de catégorie A2 détenues par eux;

- Les détenteurs des Actions de catégorie A3 ont le droit de recevoir zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur

nominale des Actions de catégorie A3 détenues par eux;

- Les détenteurs des Actions de catégorie A4 ont le droit de recevoir zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la

valeur nominale des Actions de catégorie A4 détenues par eux;

- Les détenteurs des Actions de catégorie A5 ont le droit de recevoir zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur

nominale des Actions de catégorie A5 détenues par eux;

- Les détenteurs des Actions de catégorie A6 ont le droit de recevoir zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la

valeur nominale des Actions de catégorie A6 détenues par eux, ainsi que le reliquat de toute distribution de dividende.

Si toute catégorie d'actions est annulée suivant son rachat, remboursement ou autres au moment de la distribution,

le reste de toute distribution de dividendes devra être alloué à la prochaine catégorie d'actions ordinaires à rembourser
dans l'ordre numérique inverse (par exemple au début les Actions de catégorie A6).

Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribuées et les Actions remboursées que dans la mesure où la

Société a des sommes distribuables au sens de la Loi de 1915 et conformément aux dispositions applicables de la Loi de
1915."

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des

personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes per-
sonnes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux personnes comparantes, connues du notaire par nom, prénoms, états civils et

domiciles, lesdites personnes comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. GOERES, A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2013. LAC/2013/42599. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149541/242.
(130183267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

143082

L

U X E M B O U R G

Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 173.039.

<i>Extrait des décisions prises par les gérants en date du 3 septembre 2013

Le siège social a été transféré de L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Blackstone Perpetual Midco S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013149586/14.
(130183198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

BCP Lisa Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 164.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149592/10.
(130183424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Bestair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.197.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Octobre 2013.

Bestair S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager

Référence de publication: 2013149584/14.
(130182849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Beim Struwwelpeter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 12, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 113.252.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013149582/10.
(130182906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

143083

L

U X E M B O U R G

Banking Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 72.120.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug

Es erhellt aus einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 15. Oktober

2013, einregistriert in Luxemburg A.C., am 18. Oktober 2013, LAC/2013/47474, dass die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung «Banking Services Luxembourg S.à r.l», in Liquidation, mit Sitz in L-1912 Luxemburg, 3, rue des Labours, die
gegründet am 19. Oktober 1999 gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz in Luxem-
burg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 978 vom 20. Dezember 1999, zu
schließen.

Die Gesellschaft wurde in Liquidation gesetzt gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 17. Juni 2013.
Die Bücher, Dokumente und Aufzeichnungen der Gesellschaft werden für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Zeit-

punkt der Veröffentlichung der Liquidation an der ehemaligen Adresse der Gesellschaft hinterlegt bleiben.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Oktober 2013.

Référence de publication: 2013149580/20.
(130183633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

A3 Construction Métallique S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6480 Echternach, 7, Val des Roses.

R.C.S. Luxembourg B 146.238.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 7.10.2013:

In der am 7.10.2013 am Sitz der Gesellschaft in Echternach gehaltenen Gesellschafterversammlung wurden folgende

Beschlüsse gefasst:

- dass Herr Herbert Orth als technischer Leiter abberufen wird,
- dass Herr Walter Orth zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt ist, ferner wurde festgestellt, dass

die Anschrift von Herrn Walter Orth 7, Rue Haerewiss, L-6315 Beaufort lautet.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Echternach, den 7.10.2013.

Référence de publication: 2013149577/15.
(130183488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

AIO III Aircraft Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 175.692.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance tenu en date du 21 octobre 2013:

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de la société a fait l'objet d'un changement à partir du 1 

er

octobre 2013. A savoir:

26-28 Rue Edward Steichen
L-2540
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013149561/17.
(130182917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

143084

L

U X E M B O U R G

Alliance Industries B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.000,00.

Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.889.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 22 avril 2013

Sont présents:
- Monsieur Patrick Biehler
- Monsieur Jean-Jacques Lafont
- Monsieur Alistair Stuart Brown
La présente réunion a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société;
2. Divers.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de Gérance prennent la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

au 43, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Monsieur Patrick Biehler / Monsieur J.-J. Lafont / Monsieur Alistair S.Brown.

Référence de publication: 2013149534/22.
(130183540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

America Corporation International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.065.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 31 août 2013

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Monsieur Raphaël ROZANSKI, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 31 juillet 1972, demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour America Corporation International S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013149539/16.
(130183205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Anchorage Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 164.466.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance tenu en date du 10 septembre 2013:

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de la société a faits l'objet d'un changement à partir du 1 

er

octobre 2013. A savoir:

26-28 Rue Edward Steichen
L-2540
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

143085

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013149543/17.
(130182883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Copper Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.946.

EXTRAIT

La société Exopack Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, associé de la Société, ayant son siège social

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro B 178003, a changé de dénomination sociale.

Sa nouvelle dénomination est la suivante: Exopack Holdings S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 25 octobre 2013.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2013149619/21.
(130183370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

ACMO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.517.200,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 140.857.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil de Gérance tenu en date du 10 septembre 2013:

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de la société a faits l'objet d'un changement à partir du 1 

er

octobre 2013. A savoir:

26-28 Rue Edward Steichen
L-2540
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013149554/17.
(130182853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Celsius Managed Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.736.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de Celsisus Managed Funds, SICAV (la «Société») a été clôturée le 11 octobre 2013, en vertu d'une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les livres et documents sociaux de la Société ont été déposés et seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux

de State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

143086

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

<i>Pour Celsius Managed Funds, SICAV (liquidée)
KPMG Luxembourg S.à r.l
Zia Hossen
<i>Associé / Le liquidateur

Référence de publication: 2013149614/17.
(130183675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Bierbrauer - Spanier Kachelofen und Kaminbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 113.019.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013149585/10.
(130182914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Agence Uelzecht S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 28, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 87.635.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013149559/10.
(130183604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Columbus Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 127.102.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149650/9.
(130183555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Columbus Participations Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 126.816.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149651/9.
(130183538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Cohe, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R.C.S. Luxembourg B 114.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149649/9.
(130183328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

143087

L

U X E M B O U R G

Conseils Développement Associés (C.D.A.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 30.933.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013149658/9.
(130183135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Industrial Securities Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 103.763.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 24 septembre 2013 approvant

<i>les comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2012

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013149868/18.
(130183339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Michel Greco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 38.255.

<i>Extrait du procès-verbal

[...]
Considérant que:
- les statuts coordonnés de Michel Greco S.A. stipulent dans l’article 10 qu’«en cas de vacance d’une place d’adminis-

trateur,  les  administrateurs  ont  le  droit  d’y  pourvoir  provisoirement,  conformément  aux  dispositions  légales»,  que
l’assemblée générale suivante «procède à l’élection définitive» et que «L’administrateur ainsi nommé en remplacement
d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir pour l’achèvement du mandat de son prédé-
cesseur.», soit en l’occurrence jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- Le Conseil d’administration décide
* de coopter, sous réserve de l’approbation par la CSSF, Monsieur Roland Schiltz, né le 17 janvier 1968 à Luxembourg,

Luxembourg, adresse professionnelle 38, Place de la Gare, L-2998 Luxembourg, avec effet au 15 octobre 2013 comme
membre du Conseil d’administration de Michel Greco S.A.;

* de soumettre la cooptation susmentionnée de M. Schiltz pour élection définitive à la prochaine assemblée générale,

l’achèvement du mandat étant, à l’instar de celui du prédécesseur, lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2016.

[...]
Référence de publication: 2013147506/22.
(130179597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

143088


Document Outline

A3 Construction Métallique S.à r.l.

ACMO S.à r.l.

ADNEOM Luxembourg S.à r.l.

Advanced Network Solutions S.à r.l.

Agence Uelzecht S.A.

AIO III Aircraft Finance (Lux) S.à r.l.

Alliance Gestion S.A.

Alliance Industries B.V.

America Corporation International S.à r.l.

Ancelux Topco S.C.A.

Ancelux Topco S.C.A.

Anchorage Capital Luxembourg S.à r.l.

Arilco S.A.

Arilco S.A.

Arjufra Group Holding S.à r.l.

Arlette Schneiders Architectes S.à r.l.

Asteo Luxembourg

Auluxe

Axelan Sàrl

Banking Services Luxembourg S.à r.l.

BCP Lisa Luxembourg

Beim Struwwelpeter S.à r.l.

Bestair S.à r.l.

Bierbrauer - Spanier Kachelofen und Kaminbau S.à r.l.

Biscarosse S.A.

Blackstone Perpetual Midco S.à r.l.

Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.

Boise European Holdings 1 S. à r. l.

Boise European Holdings 2 S.à r.l.

Celsius Managed Funds SICAV

Cohe, s.à r.l.

Columbus Holding Lux S.à r.l.

Columbus Participations Lux S.à.r.l.

Conseils Développement Associés (C.D.A.)

Controlinveste International

Copper Management S.à r.l.

ECommerce Holding IV S.à r.l.

Industrial Securities Luxembourg S.à r.l.

Michel Greco S.A.

Rowan Finanz S.à r.l.

Underground S.à r.l.

Valley Investment S.à r.l.

Valmar Lux S.C.I.

Varfor Holding S.A.

Varian Semiconductor Equipment Associates Luxembourg S.à r.l.

Vianden Invest Sàrl

Villa Remacum S.A.

Vopium S.A.

W2005/W2007 Bora S.à r.l.

W2007 Parallel Amelia S.à r.l.

W2007 Parallel Bear S.à r.l.

W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.

Walvek S.A.

Watt Lux S.A.

WM Belvaux (Luxembourg) S.à r.l.

WM Kehlen (Luxembourg) S.à r.l.

WPP TNS US S.à r.l.

Zentraleuropäische Immobilien Anlagegesellschaft A.G.