This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2968
25 novembre 2013
SOMMAIRE
Atoles S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142464
BaC4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142426
Beverage Packaging Holdings (Luxem-
bourg) IV S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142461
Blackbird Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
142464
Brasserie Fatiha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142462
By Jeremy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142429
Digital Services Holding II S.à r.l. . . . . . . . .
142444
Digital Services Holding I S.à r.l. . . . . . . . . .
142431
Dyamatosa Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142418
Emotions Interior Design S.à r.l. . . . . . . . . .
142418
"Europe Commerce Refractory S.à.r.l."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142421
FR Solar Luxco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142419
Gestion Fiera Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
142420
Glencoe Sky Dome S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
142420
G.O. II - Luxembourg One S.à r.l. . . . . . . . .
142420
Green Mountains S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
142420
Hapelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142421
Heimsveldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142455
Hena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142421
Henderson Global Investors Limited, Lu-
xembourg Branch Office . . . . . . . . . . . . . . .
142419
High Wealth Investments International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142419
Home Depot International Enterprises, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142421
Indaba Boutique s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142418
Interfrut Marketing Corporation S.A. . . . .
142423
Lincoln Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142422
Logistikpark Rhein-Main S.à r.l. . . . . . . . . . .
142423
Lol School S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142423
Luxcartera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142424
Luxembourg Corporation Company S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142424
Luxevents S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142424
Luxmétal Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142424
Maitagaria-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142425
Malaga S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142464
Manwin Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142425
Manwin Media Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142425
Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l. . . .
142422
Menuiserie Thies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
142422
Mercury International Consulting S.A. . . .
142426
Methalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142425
Mexx Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
142424
Milestone Finance Company S.A., SPF . . .
142427
Millesima 99 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142426
Miracles SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142426
Mokatine SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142426
Monoks S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142426
Morninglight Investments S.à r.l. . . . . . . . .
142422
Motor Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142425
NEO Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142427
Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142441
Northern & Shell Property Luxembourg
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142427
Novae Energies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142427
Novelis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
142418
Oban Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142428
OCM Njord Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
142457
Office Center Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
142428
OLFI Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
142428
Oroluk Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
142428
Outlet Mall Sub Group Holding No. 5 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142427
Prévention.Sécurité.Santé . . . . . . . . . . . . . .
142428
Triton III No. 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142419
YouWowMe Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
142455
142417
L
U X E M B O U R G
Dyamatosa Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 57.310.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013147947/12.
(130180662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Emotions Interior Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8025 Strassen, 34, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 167.937.
<i>Cession de parts socialesi>
Suivant la convention de cession de parts sociales du 3 octobre 2013, l'associé unique de la société EMOTIONS
INTERIOR DESIGN SARL est Monsieur Pascal HENNUY demeurant professionnellement au 241, Route de Longwy
L-1941 Luxembourg.
Suite aux cessions, les parts sociales seront dorénavant réparties comme suit:
Monsieur Pascal HENNUY demeurant professionnellement au 241, Route de Longwy
L-1941 Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EMOTIONS INTERIOR DESIGN SARLi>
Référence de publication: 2013147957/17.
(130180942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Novelis Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 19.358.
Les comptes annuels au 31/03/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 21/10/2013.
Benoit HAMAR
<i>Contrôleur Financieri>
Référence de publication: 2013147961/12.
(130180688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Indaba Boutique s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3931 Mondercange, 19, Op Feileschter.
R.C.S. Luxembourg B 138.029.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
<i>Pour Indaba - Boutique S.à r.l.
i>World Hopper S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013148091/13.
(130180873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142418
L
U X E M B O U R G
Henderson Global Investors Limited, Luxembourg Branch Office, Succursale d'une société de droit étran-
ger.
Adresse de la succursale: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 152.843.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la société mère de droit étranger ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148070/11.
(130181170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Triton III No. 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.939.
Les comptes annuels au 31 Mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton III No.16 S.à.r.l
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013148071/11.
(130181162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
High Wealth Investments International S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.687.
<i>Extrait des transferts de parts sociales intervenus en date du 21 octobre 2013i>
Suite aux transferts de parts sociales intervenus en date du 21 octobre 2013, le capital de la société High Wealth
Investments International S.à.r.l. se décompose comme suit:
Monsieur Jean-Pierre HIGUET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 parts.
Monsieur Clive GODFREY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 parts.
Monsieur Alain NOULLET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 parts.
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 parts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148072/17.
(130180989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
FR Solar Luxco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 136.974.
Suite au changement d'adresse de l'associé unique, FR IX Offshore AIV, L.P., le siège social de l'associé unique de la
société est:
190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013148036/15.
(130180973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142419
L
U X E M B O U R G
Gestion Fiera Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.910.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013148042/14.
(130181413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Glencoe Sky Dome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.366.
EXTRAIT
En date du 15 octobre 2013, l'associe unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Laurent Baucou, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 16 octobre 2013.
- Cédric Muenze, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant
B de la Société avec effet au 16 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148043/15.
(130180829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Green Mountains S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 163.761.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148046/12.
(130181254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
G.O. II - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 111.662.
Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2011 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg le 13 juin 2013, sous la référence L130095124 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148037/13.
(130181365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142420
L
U X E M B O U R G
Hena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 162.901.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148069/13.
(130180901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Hapelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 168.272.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associée unique en date du 11 octobre 2013:
1. La personne suivante a été nommée en tant que commissaire de la société, avec effet au 11 octobre 2013, jusqu'à
l'assemblée générale annuelle devant être tenue pour l'approbation des comptes 2012:
- DMS & Associés S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son adresse au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724,
Luxembourg et enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46 477.
2. Certifica Luxembourg S.à r.l. a été révoquée de son mandat de commissaire de la société, avec effet au 11 octobre
2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148066/18.
(130181363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Home Depot International Enterprises, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 177.860.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 17 juillet 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 16 août 2013.
Référence de publication: 2013148073/11.
(130181129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
"Europe Commerce Refractory S.à.r.l.", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 44, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 95.206.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour EUROPE COMMERCE REFRACTORY SARL
i>Signature
Référence de publication: 2013147962/12.
(130180912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142421
L
U X E M B O U R G
Morninglight Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.195.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 30 septembre 2013i>
1. Monsieur Choon Kiong TEE a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
2. Monsieur Robin ONG ENG JIN, administrateur de sociétés, né à Ipoh (Malaisie), le 27 janvier 1964, demeurant à
439960 Singapour, 14, Amber Gardens #08-04, a été nommé comme gérant de classe A pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Morninglight Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013148178/15.
(130180916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Menuiserie Thies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 146, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 170.214.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signatures
Référence de publication: 2013148171/11.
(130180708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 140.896.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148170/10.
(130181227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Lincoln Capital S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 144.422.
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 octobre 2013 a renouvellé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est Cederlux Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2019.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013148145/18.
(130180799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142422
L
U X E M B O U R G
Logistikpark Rhein-Main S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.524.
AUSZUG
Nach einer neuen Aufteilung des 09. September 2013 von 250 Gesellschaftsanteile wird fortan das Kapital wie folgt
aufgeteilt:
Alpha Industrial Holding S. à r. l., mit Gesesllschaftssitz, in L-1420 Luxemburg 1, avenue Gaston Diderich und einge-
tragen beim Handelsregister unter der Nummer B129732 Teilinhaber von 250 Anteile.
Logistikpark Hochrhein GmbH, mit Geschäftsanschrift Trottäckerstrasse 51, 79713 Bad Säckingen, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. unter HRB 708688, Teilinhaber von 250 Anteile.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 09. September 2013.
Herr Marcellino GRAF VON UND ZU HOENSBROECH
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2013148146/18.
(130180795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Lol School S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 61.600,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 167.384.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 07 octobre 2013i>
L'an deux mille treize (2013), le 07 octobre, à 08.00 heures, les actionnaires de la société anonyme LOL SCHOOL
S.A. sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg au siège social L-1420 Luxembourg, 119, avenue
Gaston Diderich et ont adoptés à l'unanimité la résolution suivante
- L'assemblée générale accepte à compter du 30 septembre 2013 la démission de Madame KLEIN Myriam en tant que
administrateur et administrateur-délégué en charge de la gestion quotidienne, employé privé, demeurant à L-3620 Kayl,
42b, rue Notre Dame.
Le président constate alors qu'aucun autre point ne figure à l'ordre du jour et déclare la présente séance levée à 08.30
heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148148/18.
(130181358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Interfrut Marketing Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 103.633.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 octobre 2013 a renouvelle les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Jean-Yves Nicolas
- Nicole Thommes
- Marc Koeune
- Andrea Dany
Le commissaire aux comptes est Cederlux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013148096/18.
(130180752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142423
L
U X E M B O U R G
Luxcartera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 133.734.
Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013148154/10.
(130181118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Luxembourg Corporation Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 37.974.
Une liste des fondés de pouvoirs de la Société Luxembourg Corporation Company S.A. en fonction au 15 Octobre
2013 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature
Référence de publication: 2013148155/12.
(130180839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Luxevents S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 4, ZAE Robert Steichen, rue Laangwiss.
R.C.S. Luxembourg B 50.742.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 21 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148156/10.
(130181199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Luxmétal Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3830 Schifflange, 9, rue des Fleurs.
R.C.S. Luxembourg B 70.454.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013148157/10.
(130180786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Mexx Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 116.511.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148174/12.
(130180665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142424
L
U X E M B O U R G
Manwin Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Manwin Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148187/13.
(130181301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Manwin Media Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Manwin Media S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148189/13.
(130181302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Maitagaria-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 55.002.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013148182/10.
(130181179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Methalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 134.602.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148203/9.
(130180773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Motor Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 70.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148212/9.
(130180855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142425
L
U X E M B O U R G
Monoks S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R.C.S. Luxembourg B 133.106.
Le bilan au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
MONOKS S.A.
Signature
Référence de publication: 2013148208/13.
(130181251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Mokatine SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 161.685.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L’agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2013148207/10.
(130180703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Miracles SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.315.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L’agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2013148206/10.
(130180704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Mercury International Consulting S.A., Société Anonyme,
(anc. BaC4 S.A.).
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 62.335.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013148202/10.
(130181443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Millesima 99 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 102.758.
Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de MILLESIMA 99 S.A.R.L., société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le
numéro B 102 758, a été dénoncé par son agent domiciliataire avec effet au 22 octobre 2013.
<i>Pour GODFREY HIGUET
Avocats / Un mandatairei>
Référence de publication: 2013148205/11.
(130180861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142426
L
U X E M B O U R G
Milestone Finance Company S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 12.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MILESTONE FINANCE COMPANY S.A., SPF
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013148204/12.
(130181039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Northern & Shell Property Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 142.599.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013148223/11.
(130181017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Novae Energies SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5481 Wormeldange, 69, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 147.772.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148228/9.
(130180909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
NEO Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 166.996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2013i>
Monsieur Pascal De Graeve, employé privé, né le 18 décembre 1969 à Arlon (B), demeurant à B-6741 VANCE, 8, rue
du Stade est nommé nouvel Administrateur de cat. B en remplacement de Monsieur Didier Scarcella, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2014
Certifié sincère et conforme
Neo Capital
Référence de publication: 2013148226/13.
(130180700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Outlet Mall Sub Group Holding No. 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 135.253.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148235/9.
(130180966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142427
L
U X E M B O U R G
Oban Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 114.219.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013148236/10.
(130181185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Oroluk Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 172.186.
Veuillez prendre note du changement de l'adresse de la société suivant:
Oroluk Investments S.à r.l.
59, Grand-rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
<i>Pour Oroluk Investments S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2013148234/15.
(130181062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Office Center Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 159.055.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148240/9.
(130180754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
P.S.S., Prévention.Sécurité.Santé, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 169.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013148262/10.
(130180728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
OLFI Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.358.110,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.806.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148246/10.
(130181221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142428
L
U X E M B O U R G
By Jeremy, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,00.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 180.918.
STATUTS
L'an deux mille treize, le deux octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jérémy BUCHET, maître coiffeur, né à Chambray-les-Tours, France, le 18 juillet 1986 (matricule
19860718874), demeurant à L-1912 Luxembourg, 104, rue du Grünewald.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «By Jeremy» (la «Société») qui sera
régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour hommes, dames et enfants.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
Elle pourra créer des filiales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra accomplir
toutes opérations généralement quelconques financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou in-
directement à son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies et prendre certaines participations dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui est de nature à favoriser
le développement de son entreprise.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatorze mille euros (14.000,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent
quarante euros (140,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. La durée de leurs mandats et leurs pouvoirs sont
définis dans l'acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la Société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.
142429
L
U X E M B O U R G
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 13. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan
et un compte de profits et pertes.
Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-
sitions légales.
<i>Souscription et Libérationi>
L'intégralité des cent (100) parts sociales a été souscrite par Monsieur Jérémy BUCHET, préqualifié.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de quatorze mille euros (14.000,-
EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille trois cents
euros (1.300,- EUR).
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale
extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
142430
L
U X E M B O U R G
Monsieur Jérémy BUCHET, maître coiffeur, né à Chambray-les-Tours, France, le 18 juillet 1986 (matricule
19860718874), demeurant à L-1912 Luxembourg, 104, rue du Grünewald.
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. Elle peut conférer des pouvoirs à
des tiers.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Buchet et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 octobre 2013. LAC/2013/46193. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145282/119.
(130178111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
Digital Services Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.879.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September.
Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of
Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
here represented by Mrs. Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Berlin, Germany on 24 September 2013.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services Holding I S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
142431
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
142432
L
U X E M B O U R G
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
142433
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
142434
L
U X E M B O U R G
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21 Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22. 6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2013.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-
tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR
12,500.-).
142435
L
U X E M B O U R G
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr. Alexander KUDLICH, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin; and
- Mr. Christian SENITZ, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr. Ulrich BINNINGER, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebenundzwanzigsten September.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Carlo Wersandt mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,
hier vertreten durch Frau Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 24. September 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services Holding I S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
142436
L
U X E M B O U R G
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
142437
L
U X E M B O U R G
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-
schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
142438
L
U X E M B O U R G
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung und wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Geschäftsführungsrats nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-
schrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
142439
L
U X E M B O U R G
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetzes von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
142440
L
U X E M B O U R G
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember
2013.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum
Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf tausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander KUDLICH, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin; und
- Herr Christian SENITZ, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannis-
strasse 20, D-10117 Berlin.
Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich BINNINGER, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: K. GAUZÈS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
octobre 2013. LAC/2013/44370. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145364/572.
(130177403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 123.201.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before Maître Leonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
142441
L
U X E M B O U R G
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Next Generation Aircraft Finance
S.à r.l. (en liquidation volontaire), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, with a share capital of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500;-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B
123.201 (the Company).
The Company was incorporated on 18 December 2006 pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing
in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 292 dated 2 March 2007. The articles of association have been amended for the last time by a notarial deed of
Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf, Grand Duchy of Luxembourg, dated 1
st
March 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1969 on 14 August 2013.
THERE APPEARED:
1) Amentum Lux S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incor-
porated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
125.579, hereby represented by Miss Rebecca Ballmann, employee, residing professionally at 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 23 September 2013;
2) Stichting Rocket Finance I, a Dutch foundation (stichting) duly incorporated and organised under the laws of The
Netherlands, having its registered office at 238, Herikerbergweg, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, and
registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34265864, hereby represented by Miss Rebecca
Ballmann, employee, residing professionally at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, by virtue of a proxy given
under private seal in Luxembourg on 23 September 2013; and
3) Stichting Rocket Finance II, a Dutch foundation (stichting) duly incorporated and organised under the laws of The
Netherlands, having its registered office at 238, Herikerbergweg, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, and
registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 34265867, hereby represented by Miss Rebecca
Ballmann, employee, residing professionally at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, by virtue of a proxy given
under private seal in Luxembourg on 23 September 2013.
(together the "Shareholders")
The said proxies, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That all of the one hundred and twenty-five (125) shares having a par value of one hundred Euros (EUR 100) each,
representing the entire subscribed share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500)
are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the
agenda;
II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Presentation of the liquidation auditor's report on the liquidator's report;
2. Approval of the liquidation auditor's report on the liquidator's report;
3. Discharge to the liquidator and to the auditor-to-the-liquidation;
4. Decision of the place where the Company's books will be deposited and kept for a period of five (5) years after the
closure of the liquidation; and
5. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken by the Shareholders:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to hear the report of the liquidation from the auditor of the liquidation on the report of the
liquidator.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve that the liquidation report which comes to the conclusion that the liquidation accounts
should be approved, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and by the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities. According to the conclusions
of the liquidation auditor, the Shareholders resolve unanimously to approve the liquidation accounts.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders decide unanimously to give full discharge to the liquidator and the liquidation auditor for the exercise
of their respective mandates.
142442
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to close the liquidation and state that the Company "Next Generation Aircraft
Finance S.à r.l." is dissolved.
The Shareholder resolves that the books and records of the dissolved company will be archived for a minimum period
of five (5) years after the closure of the liquidation at the following address:
L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
Nothing else being on the agenda the meeting was closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together
with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trentième jour du mois de septembre.
Pardevant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Next Generation Aircraft Finance
S.à r.l. (en liquidation volontaire), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, avec un capital social de douze mil cinq cent euros (EUR 12,500) et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.201 (la Société).
La Société a été constituée le 18 décembre 2006 en vertu d'un acte de Maître Bettingen, de résidence à Niederanven,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 292 du 2 mars 2007.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 1
er
mars 2013 par un acte de Maître Marc
Loesch, de résidence à Mondorf, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
ONT COMPARU
1) Amentum Lux S.à r.l., une société constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.579, ici représentée par Mademoiselle Rebecca Ball-
mann, employée privée, demeurant professionnellement à Luxemborg-Findel, aux termes d'une procuration donnée sous
seing privé le 23 septembre 2013;
2) Stichting Rocket Finance I, une fondation (stichting) constituée et régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège
social au 238, Herikerbergweg, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Pays-Bas, et immatriculée auprès de la Chambre de
Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34265864, ici représentée par Mademoiselle Rebecca Ballmann, employée
privée, demeurant professionnellement à Luxembourg-Findel, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé le
23 septembre 2013;
3) Stichting Rocket Finance II, une fondation (stichting) constituée et régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège
social au 238, Herikerbergweg, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Pays-Bas, et immatriculée auprès de la Chambre de
Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34265867, ici représentée par Mademoiselle Rebecca Ballmann, employée
privée, demeurant professionnellement à Luxemborg-Findel, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé le 23
septembre 2013.
(ensemble les Associés)
Lesdites procurations, après avoir signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et
par le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'intégralité des cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune,
représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de douze mil cinq cent euros (EUR 12,500),
sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme dûment constituée et apte
à valablement délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Présentation du rapport du commissaire à la liquidation de la Société sur le rapport du liquidateur;
142443
L
U X E M B O U R G
2. Approbation du rapport présenté par le commissaire à la liquidation de la Société sur le rapport du liquidateur;
3. Décharge au liquidateur de la Société et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats respectifs
pendant, et en relation avec, la liquidation de la Société;
4. Détermination du lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant les cinq (5) ans à
compter de la clôture de la liquidation; et
5. Divers.
III. Les Associés approuvent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'entendre le rapport du commissaire à la liquidation sur le rapport du liquidateur.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident que le rapport du commissaire à la liquidation, qui conclut que les comptes de liquidation de la
Société devraient être approuvés, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, devrait
être annexé au présent acte pour être enregistré ensemble avec celui-ci. Suite aux conclusions du rapport du commissaire
à la liquidation, les Associés décident d'accepter les comptes de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'accorder décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs
mandats respectifs pendant, et en relation avec, la liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de clôturer la liquidation et déclarent que la Société «Next Generation Aircraft Finance S.à r.l.»
est dissolue.
Les Associés décident que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant au moins
cinq (5) ans à compter de la clôture de la liquidation à l'adresse suivante:
L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
du présent acte sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: Ballmann, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 01 octobre 2013. Relation: LAC/2013/44466. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Référence de publication: 2013144994/156.
(130177210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Digital Services Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.880.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of September,
Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
142444
L
U X E M B O U R G
THERE APPEARED:
Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of
Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
here represented by Mrs. Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Berlin, Germany on 24 September 2013.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services Holding II S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
142445
L
U X E M B O U R G
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
142446
L
U X E M B O U R G
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
142447
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22. 6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
142448
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2013.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-
tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR
1,000.-).
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr. Alexander KUDLICH, born in Bonn, Germany, on 5 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,
D-10117 Berlin; and
- Mr. Christian SENITZ, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr. Ulrich BINNINGER, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am siebenundzwanzigsten September.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Carlo Wersandt mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
142449
L
U X E M B O U R G
Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,
hier vertreten durch Frau Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 24. September 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services Holding II S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12 500,-) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
142450
L
U X E M B O U R G
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
142451
L
U X E M B O U R G
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-
schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung und wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
142452
L
U X E M B O U R G
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Geschäftsführungsrats nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats – Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-
schrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr – Jahresabschluss - Gewinne – Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn-und Verlustrech-
nung.
142453
L
U X E M B O U R G
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden – Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetzes von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen – Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember
2013.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum
Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf tausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
142454
L
U X E M B O U R G
- Herr Alexander KUDLICH, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin; und
- Herr Christian SENITZ, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannis-
strasse 20, D-10117 Berlin.
Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich BINNINGER, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: K. GAUZÈS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
octobre 2013. LAC/2013/44371. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expedition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145365/572.
(130177431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
YouWowMe Europe S.A., Société Anonyme,
(anc. Heimsveldi).
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 137.040.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of September.
Before Maître Paul Decker, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Heimsveldi S.A.", a société anonyme with registered
office at Luxembourg, 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed
of the undersigned notary on February 15
th
, 2008, published in the Mémorial C number 888 of April 10
th
, 2008,
registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 137.040
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned
notary on December 18
th
, 2008, published in the Mémorial C, number 155 of January 23
rd
, 2009 (the "Company").
The meeting is declared presided by Mrs Géraldine NUCERA, notary clerk, residing in Luxembourg which also appoints
as secretary.
The meeting elected as scrutineer Ms Virginie PIERRU, notary clerk, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1 To change the name of the Company to "YouWowMe Europe S.A." and modification of the article 1, second para-
graph, of the Articles of Incorporation.
2 To amend the corporate object as to add the following wording: Provision of services to companies and private
individuals via internet and modification of article
3 of the Articles of Incorporation. 3 Miscellaneous.
(ii) The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares is
shown on an attendance-list, which, signed "ne varietur" by the proxyholder of the represented shareholders, by the
board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the proxyholder of the represented share-
holders, by the board of the meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
142455
L
U X E M B O U R G
(iv) The whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or repre-
sented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary. The present meeting, representing the whole corporate capital of the Company, is thus regularly
constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, each time unanimously, acknowledged the sole resolution:
<i>First resolution:i>
The general meeting changes the name of the Company to "YouWowMe Europe S.A.", and amends the article 1,
second paragraph, as follows:
" Art. 1. Form, Name. (Second paragraph). The Company will exist under the name of YouWowMe Europe S.A. ".
<i>Second resolution:i>
The general meeting changes the corporate object, adding a fifth paragraph to article 3 which shall read as follows:
" Art. 3. (Alinea 5). Provision of services to companies and private individuals via internet"
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at
one thousand euro (EUR 1,000.-).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-cinq septembre.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie l'assemblée extraordinaire des actionnaires de «Heimsveldi S.A.», une société anonyme ayant son siège
social au 8, rue Philippe II L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant en date du 18 février 2008, publié au Mémorial C sous le numéro 888 du 10 avril 2008,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 137.040.
Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire instrumentant en date du 18 décembre 2008, publié
au Mémorial C numéro 155 du 23 janvier 2009 (la "Société").
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Géraldine NUCERA, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg,
qui se désigne également comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Mlle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1 Modification du nom de la Société en "YouWowMe Europe S.A." et modification de l'article 1
er
, second alinéa, des
statuts de la Société.
2 Pour modifier l'objet social à ajouter le libellé suivant: Fourniture de services à des sociétés et à des personnes
physiques via internet et la modification de l'article 3 des statuts.
3 Divers.
(ii) Les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils dé-
tiennent, sont indiqués sur une liste de présence qui, signée «ne varietur» par le mandataire des actionnaires représentés,
par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui
à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par le mandataire des actionnaires représentés,
par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iv) L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, tous les actionnaires représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations. Cette assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la Société, est dès lors régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
142456
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale change le nom de la Société en "YouWowMe Europe S.A." et modifie, par conséquent, l'article
1
er
, second alinéa, des statuts de la Société, comme suit:
« Art. 1
er
. Forme, Dénomination. (Second alinéa). La Société adopte la dénomination de YouWowMe Europe S.A.»
<i>Seconde résolution:i>
L'assemblée générale modifie l'objet social, ajoutant un cinquième alinéa dans l'article 3 des statuts de la Société comme
suit:
« Art. 3. (5
ème
alinéa). Founitures de services à des sociétés et à des personnes physiques via internet»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (1.000,-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes com-
parants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: G.NUCERA, V.PIERRU, P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26/09/2013. Relation: LAC/2013/43613. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 17/10/2013.
Référence de publication: 2013145481/110.
(130178036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
OCM Njord Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.516.
In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of September.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OCM Njord Holdings S.à r.l., a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, Bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 176516, incorporated on April 8, 2013 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1298, page
62263, of June 1, 2013 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for
the last time on April 23, 2013 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1625, page 77994, of July 8, 2013.
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg OPPS IX S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 176362 and having a share capital amounting to EUR 12,500 (the OPPS
IX);
here represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
OPPS IX, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, has
requested the undersigned notary to record that:
142457
L
U X E M B O U R G
I. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
one hundred thousand (100,000) shares in registered form, without indication of a nominal value, all subscribed and fully
paid-up;
II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) represented by one hundred thousand (100,000) shares in registered form, without indication of a nominal value,
all subscribed and fully paid-up, to sixteen thousand nine hundred and forty-one Euro and twenty-five cents (EUR
16,941.25) by way of the issuance of thirty-five thousand five hundred and thirty (35,530) shares in registered form,
without indication of a nominal value;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above;
4. Subsequent amendment to the article 5.1. of the Articles;
5. Decrease of the share capital of the Company from its present amount of sixteen thousand nine hundred and forty-
one Euro and twenty-five cents (EUR 16,941.25) represented by one hundred thirty-five thousand five hundred and thirty
(135,530) shares in registered form, without indication of a nominal value, all subscribed and fully paid-up, to twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500) by way of cancellation of thirty-five thousand five hundred and thirty (35,530)
shares in registered form, without indication of a nominal value, held by OPPS IX;
6. Subsequent amendment to the article 5.1. of the Articles;
7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital increase and
decrease specified in items 2. and 5. above, with power and authority given to any manager of the Company, each acting
individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of (i) the thirty-five thousand five hundred and
thirty (35,530) newly issued shares and (ii) the cancellation of thirty-five thousand five hundred and thirty (35,530) shares,
in the register of shareholders of the Company; and
8. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, OPPS
IX considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated
to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500) represented by one hundred thousand (100,000) shares in registered form, without indication
of a nominal value, all subscribed and fully paid-up, to sixteen thousand nine hundred and forty-one Euro and twenty-five
cents (EUR 16,941.25) by way of the issuance of thirty-five thousand five hundred and thirty (35,530) shares in registered
form, without indication of a nominal value, and having the rights and obligations attached to them as set forth in the
Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The Meeting accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital increase above
as follows:
1. OCM Luxembourg OPPS VIIIb S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 164690 and having a share capital amounting to EUR 12,500
(OPPS VIIIb), represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to thirty-four thousand nine hundred and thirty (34,930) shares in registered form, without indication of a
nominal value, and to have paid them up in full by a contribution in cash in an aggregate amount of four thousand three
hundred and sixty-six Euro and twenty-five cents (EUR 4,366.25).
2. OCM Luxembourg OPPS IX (Parallel 2) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175641 and having a share capital amounting to
EUR 12,500 (OPPS IX Parallel 2), represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, by virtue of a proxy given under
private seal, declares to subscribe to six hundred (600) shares in registered form, without indication of a nominal value,
and to have paid them up in full by a contribution in cash in an aggregate amount of seventy-five Euro (EUR 75).
The aggregate amount of four thousand forty-four hundred and one Euro and twenty-five cents (EUR 4,441.25) is
forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by way of a
blocking certificate.
OPPS IX, OPPS VlIIb and OPPS IX Parallel 2, now representing the entire share capital of the Company and constituting
the Meeting, have unanimously taken the following resolutions:
142458
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:
" 5.1. The Company's corporate capital is fixed at sixteen thousand nine hundred and forty-one Euro and twenty-five
cents (EUR 16,941.25) represented by one hundred thirty-five thousand five hundred and thirty (135,530) shares in
registered form without indication of nominal value, all subscribed and fully paid-up."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company from its present amount of sixteen thousand nine
hundred and forty-one Euro and twenty-five cents (EUR 16,941.25) represented by one hundred thirty-five thousand five
hundred and thirty (135,530) shares in registered form, without indication of a nominal value, all subscribed and fully paid-
up, to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) by way of cancellation of thirty-five thousand five hundred and
thirty (35,530) shares in registered form, without indication of a nominal value, held by OPPS IX, by a repayment to OPPS
IX.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:
" 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
one hundred thousand (100,000) shares in registeredform without indication of nominal value, all subscribed andfully
paid-up."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital
increase and decrease specified under the second and the fourth resolutions above and to empower and authorize any
manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, with the registration of (i) the
thirty-five thousand five hundred and thirty (35,530) newly issued shares and (ii) the cancellation of thirty-five thousand
five hundred and thirty (35,530) shares, in the register of shareholders of the Company.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros
(1,500.-EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such proxyholder signed together with
the undersigned notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de OCM Njord Holdings S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176516, con-
stituée le 8 avril 2013 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1298, page 62263, du 1er juin 2013 (la
Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 23 avril 2013, suivant un acte de
Maître Jean Seckler, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1625, page 77994, du 8 juillet
2013.
A COMPARU:
OCM Luxembourg OPPS IX S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 176362 et dont le capital social s'élève à EUR 12.500 (OPPS IX);
ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
142459
L
U X E M B O U R G
OPPS IX, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société, a prié
le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Le capital social de la société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent
mille (100.000) parts sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement
libérées;
II. L'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
représenté par cent mille (100.000) parts sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominale, toutes
souscrites et entièrement libérées, à seize mille neuf cent quarante-et-un euros et vingt-cinq centimes (EUR 16.941,25)
par voie d'émission de trente-cinq mille cinq cent trente (35.530) parts sociales sous forme nominative, sans indication
de valeur nominale;
3. Souscription aux parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
4. Diminution du capital social de la Société de son montant actuel de seize mille neuf cent quarante-et-un euros et
vingt-cinq centimes (EUR 16.941,25) représenté par cent trente-cinq mille cinq cent trente (135.530) parts sociales sous
forme nominative, sans indication de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées, à douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) par voie d'annulation de trente-cinq mille cinq cent trente (35.530) parts sociales sous forme nomi-
native, sans indication de valeur nominale, détenues par OPPS IX;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation et la diminution du capital social
indiquées aux points 2. et 4. ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement (i) des parts sociales nouvellement émises
et (ii) de l'annulation de trente-cinq mille cinq cent trente (35.530) parts sociales, dans le registre des associés de la
Société;
6. Modification subséquente de l'article 5.1. des Statuts;
7. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500) représenté par cent mille (100.000) parts sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominale,
toutes souscrites et entièrement libérées, à seize mille neuf cent quarante-et-un euros et vingt-cinq centimes (EUR
16.941,25) par voie d'émission de trente-cinq mille cinq cent trente (35.530) parts sociales sous forme nominative, sans
indication de valeur nominale, et ayant les droits et obligations qui leur sont attachés tels que prévus par les Statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
L'Assemblée accepte et enregistre les souscriptions suivantes aux parts sociales et la libération intégrale de l'augmen-
tation du capital social ci-dessus comme suit:
1. OCM Luxembourg OPPS VIIIb S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 164690 et dont le capital social s'élève à EUR 12.500 (OPPS VIIIb), représentée par Maître Tulay
Sonmez, avocat à la cour, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à trente-quatre mille
neuf cent trente (34.930) parts sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominale, et de les libérer
entièrement par voie d'un apport en numéraire d'un montant total quatre mille trois cent soixante-six euros et vingt-
cinq centimes (EUR 4.366,25).
2. OCM Luxembourg OPPS IX (Parallel 2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 175641 et dont le capital social s'élève à EUR 12.500 (OPPS IX Parallel 2), représentée
par Maître Tulay Sonmez, avocat à la cour, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à six
cents (600) parts sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominale, et de les libérer entièrement par
voie d'un apport en numéraire d'un montant total soixante-quinze euros (EUR 75).
Le montant total de quatre mille quatre cent quarante-et-un euros et vingt-cinq centimes (EUR 4.441,25) est immé-
diatement à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant par un certificat de
blocage.
OPPS IX, OPPS VIIIB et OPPS IX Parallel 2, représentant désormais l'entièreté du capital social de la Société et
constituent l'Assemblée, ont adopté les résolutions suivantes:
142460
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société de son montant actuel de seize mille neuf cent quarante-
et-un euros et vingt-cinq centimes (EUR 16.941,25) représenté par cent trente-cinq mille cinq cent trente (135.530) parts
sociales sous forme nominative, sans indication de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées, à douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) par voie d'annulation de trente-cinq mille cinq cent trente (35.530) parts sociales
sous forme nominative, sans indication de valeur nominale, détenues par OPPS IX, par un paiement à OPPS IX de sa
participation.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation et la diminution
du capital social indiquées aux deuxième et troisième résolutions ci-dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant
de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement (i) des parts sociales
nouvellement émises et (ii) de l'annulation de trente-cinq mille cinq cent trente (35.530) parts sociales, dans le registre
des associés de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent mille
(100.000) parts sociales sous forme nominative sans indication de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement
libérées.»
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et
française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte original.
Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 septembre 2013. Relation: LAC/2013/44023. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145009/230.
(130176709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.957.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 9 octobre 2013 que:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. a été révoqué de son mandat de réviseur d'entreprises agréé chargé du contrôle des
comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach.
<i>Pour la Société
Un Géranti>
Référence de publication: 2013147845/16.
(130181389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
142461
L
U X E M B O U R G
Brasserie Fatiha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 43, rue du Fort Neipperg.
R.C.S. Luxembourg B 180.900.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Robert Weirig, demeurant professionnellement à L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht,
agissant en tant que mandataire de Madame Fatiha IDRISSI, née le 29 décembre 1962 à Agadir (Maroc), demeurant au
5, rue de la Fonderie, L-1531 Hollerich, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 septembre 2013.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée unipersonnelle, qu'elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront
associés par la suite et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-
mination de «BRASSERIE FATIHA S. à r. l.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restau-
ration à consommer sur place.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement
de son objet.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés ou leurs héritiers.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission de parts pour cause de mort, les associés se soumettent aux dispositions de l'article 189 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
De même, pour l'évaluation des parts sociales en cas de cession, les associés se soumettent à l'article 189 précité.
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés réunis en assemblée
générale, qui désignent leurs pouvoirs, et librement révocables par eux.
Le ou les gérants peut(vent) sous sa/leur responsabilité déléguer partie de ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés
de pouvoir.
Il peut être nommé un gérant technique.
La société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du ou des gérant(s) suivant les modalités déter-
minées lors de leur nomination.
142462
L
U X E M B O U R G
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. En cas de décès d'un
des associés, la société continuera d'exister soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants et les
héritiers légaux de l'associé décédé dûment agréés. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part
sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-
pation au capital social.
Art. 11. En cas de dissolution de la société la liquidation en sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par le ou les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.
Art. 12. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Disposition transitoire:i>
La première année sociale commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2013.
<i>Souscription et Libération:i>
Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites par la comparante Madame Fatiha IDRISSI, prénommée, et
libérées moyennant apport en nature consistant en:
- Un plasma LG;
- Un Home cinéma LG;
- Une caisse enregistreuse;
- Une machine à cigarettes;
- Une machine à glaçons;
- Un lave-vaisselle;
- Deux micro-ondes;
- Trois frigos;
- Un appareil de musique deux colonnes;
- Etagères pour les bouteilles;
- Une machine à café:
Cet apport en nature est évalué par l'associée unique à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR).
Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées en nature par l'associée unique de sorte que cet apport se
trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille euros (1.000,-EUR).
<i>Décisions de l'Associée Unique:i>
Et ensuite l'associée unique, représentée comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a pris les ré-
solutions suivantes:
a) Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
<i>Gérante technique:i>
Madame Leqdamra Habiba, née le 6 octobre 1949 à Rabat (Maroc), demeurant à 23, rue du Fort Neipperg, L-2230
Luxembourg.
<i>Gérante administrative:i>
Madame Fatiha Idrissi, prénommée, née le 29 décembre 1962 à Agadir (Maroc), demeurant au 5, rue de Fonderie,
L-1531 Hollerich.
142463
L
U X E M B O U R G
b) La société sera représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gérantes, avec pouvoir
de délégation réciproque.
c) Le siège social est fixé à L-2230 Luxembourg, 43, rue du Fort Neipperg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu celui-ci a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: R.WEIRIG, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 01/10/2013. Relation: LAC/2013/44420. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 16/10/2013.
Référence de publication: 2013145280/116.
(130177640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
Blackbird Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.400.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.744.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la société tenue en date du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2013 a Luxembourgi>
Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130
Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1
er
octobre 2013.
L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Aidan FOLEY, gérant de catégorie B de la Société, est la suivante: 8-10,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147847/14.
(130181048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Atoles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.327.
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 15 octobre 2013 que:
- La société Fiduciaire Internationale S.A. a cédé les 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans la société ATOLES
S.à.r.l. à Monsieur Vladimir Pintchouk demeurant professionnellement à Trident Chambers, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques.
Suite à ce transfert les parts sociales de la société ATOLES S.à.r.l. sont désormais détenues comme suit:
VLADIMIR PINTCHOUK.: 12.500 parts sociales
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2013147830/15.
(130180990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Malaga S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.527.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148162/10.
(130181206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
142464
Atoles S.à r.l.
BaC4 S.A.
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) IV S. à r.l.
Blackbird Energy S.à r.l.
Brasserie Fatiha S.à r.l.
By Jeremy
Digital Services Holding II S.à r.l.
Digital Services Holding I S.à r.l.
Dyamatosa Spf S.A.
Emotions Interior Design S.à r.l.
"Europe Commerce Refractory S.à.r.l."
FR Solar Luxco
Gestion Fiera Capital S.à r.l.
Glencoe Sky Dome S.à r.l.
G.O. II - Luxembourg One S.à r.l.
Green Mountains S.à r.l.
Hapelux S.A.
Heimsveldi
Hena S.à r.l.
Henderson Global Investors Limited, Luxembourg Branch Office
High Wealth Investments International S.à r.l.
Home Depot International Enterprises, S.à r.l.
Indaba Boutique s.à r.l.
Interfrut Marketing Corporation S.A.
Lincoln Capital S.A.
Logistikpark Rhein-Main S.à r.l.
Lol School S.A.
Luxcartera S.A.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Luxevents S.A.
Luxmétal Sàrl
Maitagaria-SPF
Malaga S.à r.l.
Manwin Holding Sàrl
Manwin Media Sàrl
Meif 3 Luxembourg A Holdings, S.à r.l.
Menuiserie Thies S.à r.l.
Mercury International Consulting S.A.
Methalux S.A.
Mexx Luxembourg S.à r.l.
Milestone Finance Company S.A., SPF
Millesima 99 S.à r.l.
Miracles SPF S.A.
Mokatine SPF S.A.
Monoks S.A.
Morninglight Investments S.à r.l.
Motor Lux S.A.
NEO Capital
Next Generation Aircraft Finance S.à.r.l.
Northern & Shell Property Luxembourg Sàrl
Novae Energies SA
Novelis Luxembourg S.A.
Oban Invest S.A.
OCM Njord Holdings S.à r.l.
Office Center Luxembourg S.à r.l.
OLFI Lux Holdings S.à r.l.
Oroluk Investments S.à r.l.
Outlet Mall Sub Group Holding No. 5 S.à r.l.
Prévention.Sécurité.Santé
Triton III No. 16 S.à r.l.
YouWowMe Europe S.A.