This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2880
15 novembre 2013
SOMMAIRE
Baco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138239
Bene Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138239
Besins Healthcare Luxembourg S.à r.l. . . .
138238
Brevan Howard Investment Fund . . . . . . . .
138238
BR Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
138239
CABRELUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138212
Cadogan Investments, S.A. . . . . . . . . . . . . .
138203
Café des Bons Amis de Gomes S.à r.l. . . . .
138213
Calendar Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
138225
Calyx Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
138213
Canna Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
138202
Capelle International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
138214
CapitalatWork Management Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138201
Carlo Schmitz Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138230
Cashnote Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138212
CCP II Berlin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138209
Cellgate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138212
CEPF Weisseritz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
138212
CFT Bourmicht S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138212
CGP Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
138225
Chartreuse et Mont Blanc GP S.à r.l. . . . .
138213
Chasselas Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138209
CN Batiment Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138209
Compass Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138214
Connector Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
138199
Constellation IV German Asset Light,
SCA-SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138215
Cross Falls Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . .
138214
Cross Falls Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . .
138213
Custom Auto Craft S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
138208
Dalkia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138230
Damode-MG S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
138231
Dansor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138231
David Brown Systems (Holdings) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138203
D.B. International Finance S.A. . . . . . . . . . .
138225
DDI A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138232
Delphina Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
138231
Deluco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138231
DHC Luxembourg IV S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
138226
Diajewel Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138214
Distress to Value S.A. -Société de Titrisa-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138225
Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138226
Dorel Hungary Kft., Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138230
Dune Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138226
M&G Chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138194
Nordstad Fashion S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
138240
Opportunity Properties Holding Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138240
SAACEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138238
Sagittaire Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
138236
Saposa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138237
SB Partners SIF SICAV S.A. . . . . . . . . . . . .
138237
SB Partners SIF SICAV S.A. . . . . . . . . . . . .
138237
Sciamani S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138233
SCOP Poland S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138232
SCOR ILS FUND S.A., SICAV-SIF . . . . . . .
138232
Son Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138234
Sopura Eastern Europe A.G. . . . . . . . . . . . .
138234
SSCP PADS PV S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
138234
SSCP Security Holding SCA . . . . . . . . . . . .
138233
St-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138233
Summit Partners PWS . . . . . . . . . . . . . . . . .
138237
Super-Max Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
138238
Super-Max Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
138235
138193
L
U X E M B O U R G
M&G Chemicals, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F.Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 174.890.
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) established
under Luxembourg law known as "M&G CHEMICALS", having its registered office in L-1855 Luxembourg, 37/A, Avenue
J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg), under section B No.
174890,
incorporated pursuant to a deed executed by undersigned notary dated 29
th
January 2013 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 713 dated 23
rd
March 2013.
The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed executed by the undersigned notary,
dated 8
th
July 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 2085 dated 28
th
August
2013.
with a current share capital of EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand Euro) divided into 250,000 (two hundred
fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, all fully subscribed and paid up (hereinafter referred
to as the "Company").
The meeting is chaired by Mr. Federico FRANZINA, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr. Paolo BARTOLUCCI, residing professionally in Luxembourg.
The general meeting appoints as scrutineer Mr. Massimo MARTINETTO, residing professionally in Luxembourg.
The shareholders present or represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been
recorded on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy holders of those represented, and
the members of the meeting declare to refer to this attendance list, as set up by the members of the bureau of the meeting.
The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the appearing parties and the acting notary, will remain
attached to the present deed with which it will be registered.
Will also remain attached to the present deed with which it will be registered the proxies given by the represented
shareholders to the present meeting, signed ne varietur by the appearing parties and the acting notary.
Then the Chairman declares and requests the notary to act:
I. - That as a result of the aforementioned attendance list all the shares representing the entire share capital are
represented at the present meeting, which is consequently duly constituted and may validly deliberate and decide on the
various items of the agenda.
II That the agenda of this meeting is as follows:
<i>Agendai>
1) Increase of the share capital by an amount of EUR 436,750,000.- (four hundred thirty six million seven hundred fifty
thousand Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 250,000.- (two hundred fifty thousand Euro) to EUR
437,000,000.- (four hundred thirty seven million Euro) by the creation and issuance of 436,750,000 (four hundred thirty
six million seven hundred fifty thousand) new shares of a par value of EUR 1.- (one Euro) each, having the same rights
and advantages as the existing shares and with a total share premium amounting to EUR 299,795,581.- (two hundred
ninety nine million seven hundred ninety five thousand five hundred eighty one Euro).
2) Subscription of the 436,750,000 (four hundred thirty six million seven hundred fifty thousand) new shares, by the
sole shareholder and paying-up in full of the shares newly issued and of the share premium amounting to EUR 299,795,581.-
(two hundred ninety nine million seven hundred ninety five thousand five hundred eighty one Euro), related to those new
shares by the contribution (in kind) of 85,104 corporate units of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each,
representing 100% of the corporate capital of the company existing under Luxembourg law named «MOSSI & GHISOLFI
INTERNATIONAL S.ar.l.» en abrege «M&G INTERNATIONAL S.ar.l.», having its registered office in L-1855 Luxembourg,
37/a avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 86.908, resulting from the merger between the companies both belonging
to the M&G Group «Gruppo M&G», «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A. en abrege M&G INTERNATIONAL
S.A.» and «CHEMTEX GLOBAL S.à r.l.», said contribution being evaluated at an amount of EUR 736,545,581.- (seven
hundred thirty six Million five hundred forty five thousand five hundred eighty one Euro).
3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association, to be read henceforth as
follows:
« Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 437,000,000.- (four hundred thirty seven million Euro)
divided into 437,000,000 (four hundred thirty seven million) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.».
138194
L
U X E M B O U R G
4) Powers to be granted to each director of the company in order to accomplish all deeds and sign and execute all
necessary documents, so that the shares contributed and mentioned sub. 2
nd
resolution, are at the free disposal of the
company M&G CHEMICALS; and in order to make the transfer effective wherever and towards any third party.
5) Miscellaneous.
The general meeting, after having acknowledged being validly constituted and approved the statements of the Chairman,
discussed the agenda.
After debate, the general meeting has taken unanimously and by separate vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the subscribed share capital by an amount of EUR 436,750,000.- (four hundred
thirty six million seven hundred fifty thousand Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 250,000.- (two
hundred fifty thousand Euro) to EUR 437,000,000.- (four hundred thirty seven million Euro) by the creation and issuance
of 436,750,000 (four hundred thirty six million seven hundred fifty thousand) new shares of a par value of EUR 1.- (one
Euro) each, having the same rights and advantages as the existing shares and with a total share premium amounting to
EUR 299,795,581.- (two hundred ninety nine million seven hundred ninety five thousand five hundred eighty one Euro).
<i>Second resolutioni>
Subscription and paying-up in full (100%) of the new issued shares by the sole shareholder, namely:
- M&G Finanziaria S.r.l., a company with limited liability (società a responsabilità limitata) organized under Italian law,
having its registered office at 11, Strada Vicinale Ribrocca, I-15057, Tortona (AL), Italy, registered with the «Registro
Imprese» (Companies Registrar) of Alessandria under number 02098590066 and with the R.E.A. («Registro Economico
Amministrativo») (Economical and Administrative Registrar) of Alessandria under number AL-226366, by the contribution
(in kind) of 85,104 corporate units of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each, representing 100% of the
corporate capital of the company existing under Luxembourg law named «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l.»
en abrégé «M&G INTERNATIONAL S.à r.l.», having its registered office in L-1855 Luxembourg, 37/a avenue J.F. Kennedy,
R.C.S. Luxembourg B 86.908, resulting from the merger (the "Merger") between the companies both belonging to the
M&G Group («Gruppo M&G»), «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A. en abrégé M&G INTERNATIONAL S.A.»
and «CHEMTEX GLOBAL S.à r.l.», said contribution being evaluated at an amount of EUR 736,545,581.- (seven hundred
thirty six million five hundred forty five thousand five hundred eighty one Euro).
Then Mr. Massimo MARTINETTO, prenamed, interveened, acting in his capacity as mandatory of the company M&G
Finanziaria S.r.l. prequalified, by virtue of a power of attorney given on 27
th
September 2013.
The subscriber, represented as stated above, declared to subscribe the 436,750,000 (four hundred thirty six million
seven hundred fifty thousand) new shares of a par value of EUR 1.- (one Euro) each, for a total amount of EUR
436,750,000.- (four hundred thirty six million seven hundred fifty thousand Euro),
with a share premium of a total amount of EUR 299,795,581.- (two hundred ninety nine million seven hundred ninety
five thousand five hundred eighty one Euro),
by the contribution (in kind) of 85,104 corporate units of a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each,
representing 100% of the corporate capital of the company existing under Luxembourg law named «MOSSI & GHISOLFI
INTERNATIONAL S.àr.l.» en abrégé «M&G INTERNATIONAL S.à r.l.», having its registered office in L-1855 Luxem-
bourg, 37/a avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 86.908, resulting from the merger (the "Merger") between the
companies both belonging to the M&G Group («Gruppo M&G»), «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A. en abrégé
M&G INTERNATIONAL S.A.» and «CHEMTEX GLOBAL S.à r.l.», said contribution being evaluated at an amount of EUR
736,545,581.- (seven hundred thirty six million five hundred forty five thousand five hundred eighty one Euro).
The general meeting representing the whole share capital of the Company, accepts unanimously the subscription of
436,750,000 (four hundred thirty six million seven hundred fifty thousand) new shares by the above-named subscriber.
The above-mentioned contribution has been detailed in the valuation report established priorly to the present deed
by the independent auditor, the société coopérative «PricewaterhouseCoopers», having its registered office at 400, route
d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg,
Said report established in accordance with article 26-1 of the law on commercial companies dated 10
th
August 1915,
as amended, ends as follows:
«Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the con-
tribution in kind does not correspond at least to the 436,750,000 (four hundred thirty six million seven hundred fifty
thousand) new shares of a par value of EUR 1.- (one Euro) each, with a the share premium amounting to EUR 299,795,581.-
(two hundred ninety nine million seven hundred ninety five thousand five hundred eighty one Euro), to be issued in
counterpart.".
Said report, dated 30
th
September 2013, will remain attached to the present deed with which it will be sealed and
filed.
The proof of the transfer of the corporate units of «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l.» en abrégé «M&G
INTERNATIONAL S.à r.l.» to the company «M&G CHEMICALS» has been given to the undersigned notary by means of
138195
L
U X E M B O U R G
a copy of the letter from the sole shareholder dated 23
rd
September 2013 received by the board of directors of M&G
CHEMICALS and expressing the will to «contribute» 100% of the corporate capital of «MOSSI & GHISOLFI INTERNA-
TIONAL S.àr.l.» en abrégé «M&G INTERNATIONAL S.à r.l.» (resulting from the Merger).
<i>Third resolutioni>
Further to the prior resolutions, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles
of association, to be read henceforth as follows:
« Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 437,000,000.- (four hundred thirty seven million Euro)
divided into 437,000,000 (four hundred thirty seven million) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to grant all powers to each director of the company in order to accomplish all deeds
and sign and execute all necessary documents, so that the corporate units contributed and mentioned sub. 2
nd
resolution,
are at the free disposal of the company M&G CHEMICALS; and in order to make the transfer effective wherever and
towards any third party.
<i>Statementi>
In accordance with Article 32-1 of the Companies Act as amended, the undersigned notary states that the conditions
required, as per article 26, are fulfilled.
<i>Closei>
There being no further items on the agenda, the Chairman declares the meeting closed.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this deed is estimated at approximately EUR 6.550.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party
the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the same appearing party and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date above written, at the beginning of this
document.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux-mil treize, le trente septembre.
Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée "M&G
CHEMICALS" ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 37/a, Avenue J.F. Kennedy, inscrite au R.C.S. à Luxembourg,
sous la Section B et le numéro 174.890,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 29 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n°713 du 23 mars 2013, page 34198.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire instrumentant, en date du 8 juillet 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2085 du 28 août 2013.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) représenté par 250.000
(deux cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et
libérées.
L'assemblée est présidée par Monsieur Federico FRANZINA, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paolo BARTOLUCCI, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Massimo MARTINETTO, résidant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux est porté
sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:
138196
L
U X E M B O U R G
I.- Que les 250.000 (deux cent cinquante mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 436.750.000,- (quatre cent trente-six millions
sept cent cinquante mille euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille
euros) à EUR 437.000.000,- (quatre cent trente-sept millions d'euros) par la création et l'émission de 436.750.000,- (quatre
cent trente-six millions sept cent cinquante mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et assorties d'une prime d'émission globale d'un
montant de EUR 299.795.581,- (deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent
quatre-vingt-et-un euros).
2) Souscription des 436.750.000,- (quatre cent trente-six millions sept cent cinquante mille) actions nouvelles par
l'actionnaire unique et libération intégrale des actions nouvellement émises et de la prime d'émission attachée à ces actions
par l'apport de 85.104 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, représentant 100% du
capital social de la société de droit luxembourgeois dénommée «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l.» en abrégé
«M&G INTERNATIONAL S.à r.l.», avec siège social à L-1855 Luxembourg, 37/a avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg
B 86.908, issue de la fusion entre les sociétés du Groupe M&G («Gruppo M&G»), «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIO-
NAL S.A. en abrégé M&G INTERNATIONAL S.A.» et «CHEMTEX GLOBAL S.à r.l.», cet apport étant évalué à un montant
de EUR 736.545.581,- (sept-cent trente-six millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-et-un euros).
3) Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 437.000.000,- (quatre cent trente-sept millions d'euros)
représenté par 437.000.000,- (quatre cent trente-sept millions) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro)
chacune.».
4) Pouvoirs à conférer à chaque administrateur de la société afin d'accomplir tous actes et signer tous documents
nécessaires en vue de mettre les actions apportées et mentionnées sub. 2., à la libre disposition de la société M&G
CHEMICALS, et de rendre le transfert effectif partout et vis-à-vis de toute tierce partie.
5) Divers.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé
l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 436.750.000,- (quatre cent trente-six
millions sept cent cinquante mille euros),
en vue de le porter de son montant actuel de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) à EUR 437.000.000,-
(quatre cent trente-sept millions d'euros),
par la création et l'émission de 436.750.000,- (quatre cent trente-six millions sept cent cinquante mille) actions nou-
velles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et assorties d'une prime d'émission globale d'un montant de EUR 299.795.581,- (deux cent quatre-vingt-dix-
neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-et-un euros).
<i>Deuxième résolutioni>
La souscription et la libération à concurrence du 100% des actions nouvellement émises sera faite par l'actionnaire
unique de la société à savoir:
- M&G Finanziaria S.r.l., une société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata) de droit italien, ayant son
siège social au 11, Strada Vicinale Ribrocca, I-15057, Tortona, Italie immatriculée auprès du «Registro Imprese» (Registre
des Entreprises) de Alessandria sous le numéro 02098590066 et au R.E.A. («Registro Economico Amministrativo») de
Alessandria sous le numéro AL-226366,
au moyen d'un apport en nature représentant au total 85.104 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,-
(mille euros) chacune, représentant 100% du capital social de la société de droit luxembourgeois dénommée «MOSSI &
GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l.» en abrégé «M&G INTERNATIONAL S.à r.l.», avec siège social à L-1855 Luxem-
bourg, 37/a avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 86.908, issue de la fusion (la «Fusion») entre les sociétés du Groupe
M&G («Gruppo M&G»), «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A. en abrégé M&G INTERNATIONAL S.A.» et
«CHEMTEX GLOBAL S.à r.l.», cet apport étant évalué à un montant de EUR 736.545.581,- (sept-cent trente-six millions
cinq cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-et-un euros).
Alors, est intervenu Monsieur Massimo MARTINETTO, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de la société
M&G Finanziaria S.r.l., prequalifiée, en vertu d'une procuration donnée le 27 septembre 2013.
138197
L
U X E M B O U R G
Lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 436.750.000,- (quatre cent trente-six
millions sept cent cinquante mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune pour un montant
total d'EUR 436.750.000,- (quatre cent trente-six millions sept cent cinquante mille euros)
assorties d'une prime d'émission globale d'un montant de EUR 299.795.581,- (deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions
sept cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-et-un euros),
moyennant apport de 85.104 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, représentant 100%
du capital social de la société de droit luxembourgeois dénommée «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l.» en
abrégé «M&G INTERNATIONAL S.à r.l.», avec siège social à L-1855 Luxembourg, 37/a avenue J.F. Kennedy, R.C.S.
Luxembourg B 86.908, issue de la fusion entre les sociétés du «Gruppo MG», «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL
S.A. en abrégé M&G INTERNATIONAL S.A.» et «CHEMTEX GLOBAL S.à r.l.», cet apport étant évalué à un montant
de EUR 736.545.581,- (sept-cent trente-six millions cinq cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-et-un d'euros).
L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 436.750.000,-
(quatre cent trente-six millions sept cent cinquante mille) actions nouvelles par le susdit souscripteur.
Le susdit apport a fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi préalablement aux présentes par le Réviseur d'Entreprises,
la société coopérative «PricewaterhouseCoopers», ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Lu-
xembourg,
lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, conclut comme suit:
«Sur base des vérifications que nous avons faites, nous n'avons relevé aucun élément qui puisse induire à croire que
la valeur globale de l'apport en nature ne correspond pas au moins aux 436.750.000,- (quatre cent trente-six millions sept
cent cinquante mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, assorties d'une prime
d'émission globale d'un montant de EUR 299.795.581,- (deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-
quinze mille cinq cent quatre-vingt-et-un euros), à émettre en contrepartie.».
Lequel rapport, daté du 30 septembre 2013, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux
formalités du timbre et de l'enregistrement.
La preuve du transfert des parts sociales de «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l.» en abrégé «M&G IN-
TERNATIONAL S.à r.l.» à la société «M&G CHEMICALS» a été soumise au notaire instrumentant par le biais d'une lettre
de l'actionnaire unique reçue par le conseil d'administration de M&G CHEMICALS exprimant la volonté d'«apporter»
100% du capital de «MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.àr.l. en abrégé M&G INTERNATIONAL S.à r.l.» (résultant
de la Fusion).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide, suite aux résolutions qui précédent, de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour
lui donner la nouvelle teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 437.000.000,- (quatre cent trente-sept millions d'euros)
représenté par 437.000.000,- (quatre cent trente-sept millions) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro)
chacune.».
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur de la société afin d'accomplir tous actes et
signer tous documents nécessaires en vue de mettre les parts apportées et mentionnées dans la première résolution, à
la libre disposition de la société anonyme M&G CHEMICALS, et de rendre le transfert effectif partout où cela s'avérerait
nécessaire vis-à-vis de tous tiers.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que
les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,
suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 6.550.-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en Anglais suivi d'une version Française. À la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre le
texte Anglais et le texte Français, la version Anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
138198
L
U X E M B O U R G
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du
notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. FRANZINA, P. BARTOLUCCI, M. MARTINETTO, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 01 octobre 2013. Relation: RED/2013/1600. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 04 octobre 2013.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013139183/283.
(130169888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Connector Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 27, rue d'Oradour.
R.C.S. Luxembourg B 180.699.
STATUTS
L'an deux mille treize, le sept octobre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Sebastiaan VAN DER WEERDEN, commerçant, né à Luxembourg le 25 avril 1971, demeurant à L-2266
Luxembourg, 27, rue d'Oradour,
ci-après dénommé «le comparant».
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:
"Connector Group S.à r.l.".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également
prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision de l'associé.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence commerciale, la prestation de services, la promotion et
l'organisation d'événements.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rappor-
tant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par
CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
138199
L
U X E M B O U R G
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.
A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille
treize (31.12.2013).
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique Monsieur Sebastiaan VAN DER WEERDEN, com-
merçant, né à Luxembourg le 25 avril 1971, demeurant à L-2266 Luxembourg, 27, rue d'Oradour, pré-qualifié.
L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Sebastiaan VAN DER WEERDEN, commerçant, né à Luxembourg le 25 avril 1971, demeurant à L-2266
Luxembourg, 27, rue d'Oradour.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-2266 Luxembourg, 27, rue d'Oradour.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.
Signé: VAN DER WEERDEN, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08/10/2013. Relation: EAC/2013/13029. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
138200
L
U X E M B O U R G
Esch-sur-Alzette, le 10/10/2013.
Référence de publication: 2013141842/95.
(130173527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CapitalatWork Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 162.281.
L'an deux mille treize, le dix-huit septembre,
par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réuni
en assemblée générale extraordinaire l'actionnaire unique de la société anonyme "CapitalatWork Management Com-
pany S.A.", ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 162.281, constituée suivant acte notarié en date du 12 juillet 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2205 du 19 septembre 2011, dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte notarié en date du 22 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 502 du 25 février 2012 (la «Société»).
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Benoît de Hults, Président du Conseil d'Ad-
ministration de la Société, demeurant professionnellement à Leudelange,
qui désigne comme secrétaire Madame Virginie Courteil, employée privée, demeurant professionnellement à Leude-
lange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Tesch, Président du Conseil d'Administration de Capita-
laAVork Foyer Group S.A., demeurant professionnellement à Leudelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de quatre cent mille euros (EUR 400.000.-) pour le
porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-), représenté par cinq cents (500) actions d'une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune, à neuf cent mille euros (EUR 900.000.-) par l'émission de quatre
cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune, contre paiement en espèces.
2. Souscription et libération.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.
4. Modification de l'article 16 des statuts de la Société.
5. Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions
qu'il détient est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire unique représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été para-
phée "ne varietur" par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-
vocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent mille euros (EUR
400.000.-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000.-), représenté par cinq cents
(500) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune, à neuf cent mille euros (EUR 900.000.-) par
l'émission de quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
Les quatre cents (400) actions nouvelles sont intégralement souscrites par l'actionnaire unique à savoir la société
«CapitalatWork Foyer Group S.A.», avec siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 78.769,
138201
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Monsieur François Tesch, prénommé, agissant en sa qualité de Président du Conseil d'Adminis-
tration de CapitalatWork Foyer Group S.A. et en vertu d'une délégation de pouvoirs du 12 septembre 2013,
pour un montant total de quatre cent mille euros (EUR 400.000.-) entièrement affectés au capital social de la Société.
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Toutes les quatre cents (400) actions sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quatre cent
mille euros (EUR 400.000.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, l assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital social. (premier alinéa). Le capital social est fixé à neuf cent mille euros (EUR 900.000.-) représenté
par neuf cents (900) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune."
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 16, alinéas 3, 4 et 13 des statuts de la Société afin de leur donner
désormais la teneur suivante.
" Art. 16. Procédure et Vote. (alinéas 3 et 4). Pour pouvoir être admis aux assemblées générales, les propriétaires
d'actions sont tenus de faire connaître au conseil d'administration au moins cinq jours à l'avance leur intention d'assister,
en personne ou par mandataire, à l'assemblée.
Tout actionnaire pourra se faire représenter à l'assemblée générale par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas
besoin d'être actionnaire.
(alinéa 13). L'assemblée générale désigne son président qui présidera l'assemblée."
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Leudelange, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: B. DE HULTS, V. COURTEIL, F. TESCH et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013. LAC/2013 /42814. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141825/87.
(130173588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Canna Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 104.357.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 avril 2013 que le mandat du conseil
de gérance a été renouvelé avec effet au 30 avril 2013 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013.
Par conséquent, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Mme. Myriam Deltenre, gérant classe A
- Mme. Isabelle Lapietra, gérant classe A
- M. Philippe Guyot, gérant classe B
- M. Patrice Gallasin gérant classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
138202
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013141853/21.
(130173199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Cadogan Investments, S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.671.
1) Pursuant to an extraordinary general meeting of shareholders dated October 10
th
, 2013, Mr. Franck Ruimy and
Mr. Antoine Lam-Chok have resigned from their function of director of the Company with immediate effect.
2) The Shareholders have decided to appoint Mr. Grégory Noyen, residing professionally at 6A Route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, as director of the Company with immediate effect and until the annual general meeting of share-
holders which will be held in 2015.
3) The Shareholders have decided to appoint Mr. Ely-Michel Ruimy, residing professionally 49 Grosvenor Street, W1K
3HP, London, United Kingdom as director of the Company with immediate effect and until the annual general meeting
of shareholders which will be held in 2015.
Traduction pour les besoins de l'Enregistrement
1) Suite à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 10 octobre 2013, il
résulte que M. Franck Ruimy et M. Antoine Lam-Chok ont démissionnés de leur mandat d'administrateur de la Société
avec effet immédiat.
2) Les actionnaires ont décidé de nommer M. Grégory Noyen, résident professionnellement à 6A Route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, comme administrateur de la Société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se
tenant en 2015.
3) Les actionnaires ont décidé de nommer M. Ely Michel Ruimy, résident professionnellement à 49 Grosvenor Street,
W1K 3HP, Londres, Royaume-Uni, comme administrateur de la Société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire se tenant en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013141848/27.
(130173818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
David Brown Systems (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 140.252.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of the month of August;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
An extraordinary general meeting (the "Unitholders Meeting") of the company David Brown Systems (Holdings) S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office (siège social) at 37, rue
d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
140252 (the "Company") was held.
The Unitholders Meeting was presided by Mr. Carmine REHO, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg (the "Chairman").
The Chairman appointed as Secretary Ms. Emma MASSICARD, jurist, residing professionally at 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
The Unitholders Meeting elected as Scrutineer Mr. Romain VIARD, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
The board of the Meeting then drew up the attendance list, which, after having been signed ne varietur by the holder
(s) of the powers of attorney representing the unitholders, will remain attached to the present minutes together with
said powers of attorney to be submitted together to the registration authorities.
The Chairman declared that:
I. According to the attendance list, members representing the full amount of the share capital were present or validly
represented at the Unitholders Meeting. The Unitholders Meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects
on the agenda.
138203
L
U X E M B O U R G
II. The agenda of the Unitholders Meeting was the following:
1) Approval of the repurchase by the Company of Seven Thousand Two Hundred and Sixty-Nine (7,269) own cor-
porate units divided into Seven Hundred and Twenty-Six (726) A to I corporate units and Seven Hundred and Thirty-
Five (735) J corporate units, each corporate unit with a nominal value of One Pound Sterling (GBP 1.-) (the "Repurchased
Units") from Appleby Nominees (Jersey) Limited, a company having its registered office at PO Box 2071, 13-14 Esplanade,
St Helier, Jersey, JE1 1BD, Channel Islands ("Appleby"), in consideration for an aggregate amount of Fifty-One Pounds
Sterling (GBP 51,000.-) (the "Repurchase Price") and subsequent decrease of the corporate capital of the Company by
an amount of Seven Thousand Two Hundred and Sixty-Nine Pounds Sterling (GBP 7,269.-) by cancellation of the Re-
purchased Units, so as to bring it from its present amount of Three Million One Hundred and Twenty-Five Thousand
Two Hundred and Seventy-Three Pounds Sterling (GBP 3,125,273.-) to an amount of Three Million One Hundred and
Eighteen Thousand and Four Pounds Sterling (GBP 3,118,004.-) represented by Three Hundred and Eighteen (318,000)
A to I corporate units and by Three Hundred Eighteen and Four (318,004) J corporate units with a nominal value of One
Pound Sterling (GBP 1.-) each and waiver by the unitholders of the Company other than Appleby of any right with respect
to the Repurchased Units and the capital decrease;
2) Approval of the increase of the corporate capital of the Company by an amount of One Hundred Fifty Four Thousand
Nine Hundred and Forty-Eight Pounds Sterling (GBP 154,948.-) to be paid up by way of a contribution in cash and a
contribution in kind as further detailed under item 3) of the present agenda so as to bring it from its current amount of
Three Million One Hundred and Eighteen and Four Pounds Sterling (GBP 3,118,004.-) to an amount of Three Million Two
Hundred and Seventy-Two Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Pounds Sterling (GBP 3,272,952.-) represented by
Three Hundred and Twenty-Seven Thousand Two Hundred and Eighty-One (327,281) A to I corporate units and by
Three Hundred and Twenty-Seven Thousand Four Hundred and Twenty-Three (327,423) J corporate units with a nominal
value of One Pound Sterling (GBP 1.-), by issuance of Fifteen Thousand Four Hundred and Ninety-Four (15,494) A to I
corporate units and by Fifteen Thousand Five Hundred and Two (15,502) J corporate units, each with a nominal value of
One Pound Sterling (GBP 1.-) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company;
3) Subscription and payment (i) by Appleby of 20,860 new corporate units represented by Two Thousand and Eighty-
Six (2,086) A to J corporate units in the Company, each with a nominal value of One Pound Sterling (GBP 1.-) and with
such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company in consideration for a contribution in
cash amounting to Twenty Thousand Eight Hundred and Sixty Pounds Sterling (GBP 20,860.-) together with a share
premium amounting to Fifty-Six Thousand Nine Hundred and Forty-Seven and Eighty Pence Pounds Sterling (GBP
56,947.80-) and (ii) by Clyde Blowers Capital S.a.r.l. a private limited liability company having its registered office at 37,
rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B. 141248 ("CBC"), of 134,088 new corporate units represented by Thirteen Thousand Four Hundred and Eight (13,408)
A to I corporate units and by Thirteen Thousand Four Hundred and Sixteen (13,416) J corporate units in the corporate
capital of the Company, each with a nominal value of One Pound Sterling (GBP 1.-) and with such rights and obligations
as set out in the articles of association of the Company in consideration for a contribution in kind consisting of Five Million
(5,000,000) interest free preferred equity certificates (the "IFPECs") held by CBC in the Company, having a nominal value
of One Pound Sterling (GBP 1.-) each, representing a share premium amounting to Four Million Eight Hundred Sixty Five
Thousand Nine Hundred and Twelve Pounds Sterling (GBP 4,865,912.-);
4) Subsequent amendment of Article 5, first paragraph of the articles of the Company;
5) Granting authorization to any one manager of the Company or any lawyer of the law firm Wildgen, Partners in Law,
to carry out any necessary or useful action, in the name and on behalf of the Company with sole signatory power, to
implement the resolutions to be taken on the basis of the present agenda;
6) Any other business.
The unitholders of the Company moved to the following resolutions unanimously:
<i>First resolutioni>
The unitholders of the Company resolved to approve the repurchase by the Company of the Repurchased Units from
Appleby in consideration for the Repurchase Price and subsequent decrease of the corporate capital of the Company by
an amount of Seven Thousand Two Hundred and Sixty-nine Pounds Sterling (GBP 7,269.-) by cancellation of the Repur-
chased Units so as to bring it from its present amount of Three Million One Hundred and Twenty-Five Thousand Two
Hundred and Seventy-Three Pounds Sterling (GBP 3,125,273.-) to an amount of Three Million One Hundred and Eighteen
Thousand and Four Pounds Sterling (GBP 3,118,004.-) represented by Three Hundred and Eighteen Thousand (318,000)
A to I corporate units and by Three Hundred and Eighteen Thousand and Four (318,004) J corporate units with a nominal
value of One Pound Sterling (GBP 1.-) each and waiver by the unitholders of the Company other than Appleby of any
right with respect to the Repurchased Units and the capital decrease.
<i>Second resolutioni>
The unitholders of the Company resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of One
Hundred and Fifty Four Thousand Nine Hundred and Forty-Eight Pounds Sterling (GBP 154,948.-) so as to bring it from
its amount after the cancellation referred to in the first resolution above of Three Million One Hundred and Eighteen
Thousand and Four Pounds Sterling (GBP 3,118,004.-) to an amount of Three Million Two Hundred and Seventy-Two
138204
L
U X E M B O U R G
Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Pounds Sterling (GBP 3,272,952.-) represented by Three Hundred and Twenty-
Seven Thousand Two Hundred and Eighty-One (327,281) A to I corporate units and by Three Hundred and Twenty-
Seven Thousand Four Hundred and Twenty-Three (327,423) J corporate units with a nominal value of One Pound Sterling
(GBP 1.-) each, by issuance of Fifteen Thousand Four Hundred and Ninety-Four (15,494) A to I corporate units and by
Fifteen Thousand Five Hundred and Two (15,502) J corporate units, each with a nominal value of One Pound Sterling
(GBP 1.-) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company.
<i>Subscription and Paymenti>
Further appeared Mr. Carmine REHO, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney of Appleby by virtue
of a power of attorney granted on August 27, 2013.
The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder and
the notary, to be submitted together with this deed to the registration authorities.
The person appearing declared to subscribe and to pay respectively in the name and on behalf of Appleby for Two
Thousand Eighty-Six (2,086) A to J corporate units in the Company, each with a nominal value of One Pound Sterling
(GBP 1.-) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company in consideration
for a contribution in cash amounting to Twenty Thousand Eight Hundred and Sixty Pounds Sterling (GBP 20,860.-)
together with a share premium amounting to Fifty-Six Thousand Nine Hundred Forty-Seven and Eighty Pence Pounds
Sterling (GBP 56,947.80-).
Further appeared said Mr. Carmine REHO, acting in his capacity as duly appointed attorney of CBC by virtue of a
power of attorney granted on August 27, 2013.
The said power of attorney will remain attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy
holder and the notary, to be submitted together with this deed to the registration authorities.
The person appearing declared to subscribe and to pay respectively in the name and on behalf of CBC Thirteen
Thousand Four Hundred and Eight (13,408) A to I corporate units and by Thirteen Thousand Four Hundred and Sixteen
(13,416) J corporate units in the corporate capital of the Company, each with a nominal value of One Pound Sterling
(GBP 1.-) and with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company in consideration
for a contribution in kind consisting of Five Million (5,000,000) interest free preferred equity certificates (the "IFPEC's")
held by CBC in the Company, having a nominal value of One Pound Sterling (GBP 1.-) each, representing a share premium
amounting to Four Million Eight Hundred and Sixty-Five Thousand Nine Hundred and Twelve Pounds Sterling (GBP
4,865,912.-). It results from the board meeting of the Company dated August 27, 2013 that the subscription and payment
by CBC is made by contribution of the IFPECs to the corporate capital of the Company.
The minutes of the said board meeting together with the IFPECs register of the Company reflecting the situation
before the present deed and are provided, as evidence, to the notary for his comfort.
Thereupon the Unitholders Meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to issue and allocate
the above listed corporate units to Appleby and CBC.
<i>Third resolutioni>
The unitholders of the Company resolved to amend article 5, paragraph 1 of the articles of association of the Company
so as to give it the following wording:
" Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at Three Million Two Hundred and Seventy-Two
Thousand Nine Hundred and Fifty-Two Pounds Sterling (GBP 3,272,952.-) represented by:
327,281 class A Corporate Units,
327,281 class B Corporate Units,
327,281 class C Corporate Units,
327,281 class D Corporate Units,
327,281 class E Corporate Units,
327,281 class F Corporate Units,
327,281 class G Corporate Units,
327,281 class H Corporate Units,
327,281 class I Corporate Units, and
327,423 class J Corporate Units,
each Corporate Unit having a nominal value of One Pound Sterling (GBP 1.-) with such rights and obligations as set
out in the articles of association of the Company."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to grant authorization to any manager of the Company or to any lawyer of the law firm Wildgen,
Partners in Law, Luxembourg, acting individually under his sole signature, in the name and on behalf of the Company, to
carry out any necessary or useful actions in relation to the present resolutions.
138205
L
U X E M B O U R G
<i>Costs - Valuationi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated
deed is estimated at three thousand nine hundred Euros.
For the purposes of the registration the amount of the capital decrease is valuated at EUR 8,462.17 and the amount
of the capital increase with share premium is valued at EUR 5,908,970.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the members of the board
appearing, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same persons
and in case of divergences between the English text and the French text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy-holders and the members of the board appearing, known to the un-
dersigned notary by names, surnames, civil statuses and residences, said persons signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le vingt-septième jour du mois d'août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de la société David Brown Systems
(Holdings) S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140252 (la «Société»).
L'Assemblée était présidée par Monsieur Carmine REHO, avocat, demeurant professionnellement au 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (le «Président»).
Le Président a nommé comme Secrétaire Mademoiselle Emma MASSICARD, juriste, demeurant professionnellement
au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
L'Assemblée a élu comme Scrutateur Monsieur Romain VIARD, avocat, demeurant professionnellement au 69, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée dressa la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les mandataires
représentant les associés, restera annexée au présent procès-verbal et aux procurations pour être soumis ensemble aux
autorités en charge de l'enregistrement.
Le Président a ensuite déclaré que:
I. Conformément à la liste de présence, les associés représentant l'intégralité du capital social sont présents ou dûment
représentés à l'Assemblée. L'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
II. La présente Assemblée a eu pour ordre du jour les points suivants:
1. Approbation du rachat par la Société de Sept Mille Deux Cent Soixante-Neuf (7.269) de ses parts sociales divisées
en Sept Cent Vingt-Six (726) parts sociales des catégories A à I et en Sept Cent Trente-Cinq (735) parts sociales de
catégorie J, ayant chacune une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) (les «Parts Rachetées») à Appleby Nominees
(Jersey) Limited, une société ayant son siège social à PO Box 2071, 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1BD, Channel
Islands ("Appleby"), en contrepartie d'un montant total de Cinquante et Un Mille (GBP 51.000,-) (le «Prix de Rachat») et
une réduction subséquente du capital social de la Société d'un montant de Sept Mille Deux Cent Soixante-Neuf (GBP
7.269,-) par l'annulation des Parts Rachetées, de manière à le porter de son montant actuel de Trois Millions Cent Vingt-
Cinq Mille Deux Cent Soixante-Treize Livres Sterling (GBP 3.125.273,-) à un montant de Trois Millions Cent Dix-Huit
Mille et Quatre Livres Sterling (GBP 3.118.004,-) représenté par Trois Cent Dix-Huit Mille (318.000) parts sociales des
catégories A à I et par Trois Cent Dix-Huit Mille et Quatre (318.004) parts sociales de la catégorie J ayant une valeur
nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) et renonciation des associés de la Société autres qu'Appleby de tout droit à
l'égard des Parts Rachetées et de la diminution du capital;
2. Approbation de l'augmentation de capital de la Société d'un montant de Cent Cinquante-Quatre Mille Neuf Cent
Quarante-Huit Livres Sterling (GBP 154.948,-) par un apport en numéraire et un apport en nature tels que détaillés au
point 3) du présent ordre du jour afin de le porter de son montant actuel de Trois Millions Cent Dix-Huit Mille et Quatre
Livres Sterling (GBP 3.118.004,-) à un montant de Trois Millions Deux Cent Soixante-Douze Mille Neuf Cent Cinquante-
Deux Livres Sterling (GBP 3.272.952,-) représenté par Trois Cent Vingt-Sept Mille Deux Cent Quatre-Vingt et Un
(327.281) parts sociales des catégories A à I et par Trois Cent Vingt-Sept Mille Quatre Cent Vingt-Trois (327.423) parts
sociales de la catégorie J, par l'émission de Quinze Mille Quatre Cent Quatre-Vingt-Quatorze (15.494) parts sociales des
catégories A à I et par Quinze Mille Cinq Cent Deux (15.502) parts sociales de catégorie J ayant chacune une valeur
nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) et avec les droits et obligations énoncés dans les statuts de la Société;
3. Souscription et libération (i) par Appleby de Vingt Mille Huit Cent Soixante (20.860) représenté par Deux Mille
Quatre-Vingt-Six (2.086) parts sociales des catégories A à J de la Société, ayant chacune une valeur nominale d'Une Livre
138206
L
U X E M B O U R G
Sterling (GBP 1,-) et avec les droits et obligations énoncés dans les statuts de la Société en contrepartie d'un apport en
numéraire s'élevant à Vingt Mille Huit Cent Soixante Livres Sterling (GBP 20.860,-) avec une prime d'émission de Cin-
quante-Six Mille Neuf Cent Quarante-Sept Livres Sterling et Quatre-Vingts Centimes de Livres Sterling (GBP 56.947,80)
et (ii) par Clyde Blowers Capital S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 37, rue d'Anvers,
L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule
B. 141248 («CBC»), de Cent Trente-Quatre Mille Quatre-Vingt-Huit (134.088) parts sociales représenté par Treize Mille
Quatre Cent Huit (13.408) parts sociales de catégories A à I et de Treize Mille Quatre Cent Seize (13.416) parts sociales
de catégorie J dans le capital social de la Société, ayant chacune une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) et
avec les droits et obligations énoncés dans les statuts de la Société en contrepartie d'un apport en nature consistant en
Cinq Millions (5.000.000) d'interest free preferred equity certificates («IFPECs») détenus par CBC dans la Société, ayant
une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1.-) chacune, représentant une prime d'émission qui s'élève à Quatre
Million Huit Cent Soixante-Cinq Mille Neuf Cent Douze Livres Sterling (GBP 4.865.912,-);
4. Amendements subséquents de l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société;
5. Autorisation à tout gérant de la Société ou tout mandataire de l'étude Wildgen, Partners in Law, d'accomplir toute
action nécessaire ou utile, au nom et pour le compte de la Société avec pouvoir de signature individuelle, pour mettre
en oeuvre les résolutions qui seront prises sur base de cet ordre du jour;
6. Divers.
Les associés de la Société ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés de la société ont unanimement décidé d'approuver le rachat par la Société des Parts Rachetées à Appleby
en contrepartie du Prix de Rachat et la réduction subséquente du capital social de la Société d'un montant de Sept Mille
Deux Cent Soixante-Neuf Livres Sterling (GBP 7.269.-) par l'annulation des Parts Rachetées pour porter le capital social
de son montant actuel de Trois Millions Cent Vingt-Cinq Mille Deux Cent Soixante-Treize Livres Sterling (GBP
3.125.273.-) à un montant de Trois Millions Cent Dix-Huit Mille et Quatre Livres Sterling (GBP 3.118.004,-) représenté
par Trois Cent Dix-Huit Mille (318.000) parts sociales des catégories A à I et par Trois Cent Dix-Huit Mille et Quatre
(318.004) parts sociales de la catégorie J chacune ayant une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) et signature
ne varietur par les mandataires représentant les associés et le notaire qui restera annexée au présent procès-verbal et
aux procurations pour être soumis ensemble aux autorités en charge de l'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés de la Société ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de Cent Cinquante-
Quatre Mille Neuf Cent Quarante-Huit Livres Sterling (GBP 154.948,-) pour le porter de son montant après l'annulation
telle que décrite dans la première résolution ci-dessus de Trois Millions Cent Dix-Huit Mille et Quatre Livres Sterling
(GBP 3.118.004,-) à un montant de Trois Millions Deux Cent Soixante-Douze Mille Neuf cent Cinquante-Deux Livres
Sterling (GBP 3.272.952,-) représenté par Trois Cent Vingt-Cinq Mille Deux Cent Quatre-Vingt-Un (325.281) parts
sociales des catégories A à I et par Trois Cent Vingt-Sept Mille Quatre Cent Vingt-Trois (327.423) parts sociales de la
catégorie J, ayant chacune une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) et avec les droits et obligations énoncés
dans les statuts de la Société.
<i>Souscription et Libérationi>
Comparu ensuite Monsieur Carmine REHO, préqualifié, agissant en qualité de mandataire dûment désigné par Appleby
en vertu d'une procuration sous seing privé octroyée le 27 août 2013.
Ladite procuration restera jointe au présent acte, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire,
pour être soumise en même temps que cet acte aux autorités d'enregistrement.
Le mandataire prénommé a déclaré souscrire et payer respectivement au nom et pour le compte d'Appleby à Deux
Mille Quatre-Vingt-Six (2.086) parts sociales des catégories A à J de la Société, ayant chacune une valeur nominale d'Une
Livre Sterling (GBP 1,-) et avec les droits et obligations énoncés dans les statuts de la Société en contrepartie d'un apport
en numéraire s'élevant à Vingt Mille Huit Cent Soixante Livres Sterling (GBP 20.860,-) avec une prime d'émission de
Cinquante-Quatre Mille Neuf Cent Quarante-Sept Livres Sterling et Quatre-Vingt Centimes de Livres (GBP 54.947,80).
Comparu ensuite ledit Monsieur Carmine REHO, agissant en qualité de mandataire dûment désigné par CBC en vertu
d'une procuration sous seing privé octroyée le 27 août 2013.
Le mandataire prénommé a déclaré souscrire et payer respectivement au nom et pour le compte de CBC Treize Mille
Quatre Cent Huit (13.408) parts sociales de catégories A à I et de treize Mille Quatre Cent Seize (13.416) parts sociales
de catégorie J dans le capital social de la Société, ayant chacune une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) et
avec les droits et obligations énoncés dans les statuts de la Société en contrepartie d'un apport en nature consistant en
Cinq Millions (5.000.000) d''interest free preferred equity certificates («IFPECs») détenus par CBC dans la Société, ayant
une valeur nominale d'Une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, représentant une prime d'émission qui s'élève à Quatre
Millions Huit Cent Soixante-Cinq Mille Neuf Cent Douze Livres Sterling (GBP 4.865.912,-). Il résulte du procès-verbal
du conseil de gérance daté du 27 août 2013 que la souscription et la libération par CBC est effectuée par l'apport d'IFPECs
au capital social de la Société.
138207
L
U X E M B O U R G
Le procès-verbal dudit conseil de gérance ainsi que du registre des IFPECs de la Société reflétant la situation précédant
le présent acte et sont fournis, au notaire pour son confort.
Sur ce, l'Assemblée des Associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et libérations et d'émettre et allouer les
parts sociales listées ci-dessus à Appleby et CBC.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés de la Société ont décidé de modifier l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société de manière
à lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital souscrit est fixé à Trois Millions Deux Cent Soixante-Douze Mille Neuf cent Cin-
quante-Deux Livres Sterling (GBP 3.272.952,-) représenté par:
327.281 parts sociales de classe A;
327.281 parts sociales de classe B;
327.281 parts sociales de classe C;
327.281 parts sociales de classe D;
327.281 parts sociales de classe E;
327.281 parts sociales de classe F;
327.281 parts sociales de classe G;
327.281 parts sociales de classe H;
327.281 parts sociales de classe I;
327.423 parts sociales de classe J;
chaque part sociale ayant une valeur nominale d'Une Livre sterling (GBP 1,-) et avec des droits et obligations tels que
définis dans les présent statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'autoriser tout dirigeant de la Société ou à tout mandataire de l'étude Wildgen, Partners in
Law, Luxembourg d'accomplir toute action nécessaire ou utile, au nom et pour le compte de la Société avec pouvoir de
signature individuelle, pour mettre en oeuvre les présentes résolutions.
<i>Frais - Evaluationi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé
à trois mille neuf cents euros.
Pour les besoins d'enregistrement, le montant total en euros de la réduction de capital est estimé à EUR 8.462,17 et
le montant total en euros de l'augmentation de capital avec la prime d'émission s'élève à EUR 5.908.970,-.
<i>Constati>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des membres du bureau comparant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi par la une traduction française; à la demande des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le document ayant été lu aux mandataires et membres du bureau comparants, connus du notaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. REHO, E. MASSICARD, R. VIARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2013 LAC/2013/39740. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Référence de publication: 2013141892/297.
(130173156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Custom Auto Craft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9408 Vianden, 7, Montée du Château.
R.C.S. Luxembourg B 90.550.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
138208
L
U X E M B O U R G
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2013141888/11.
(130173826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CN Batiment Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3336 Hellange, 6A, Wisestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 162.129.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013141879/11.
(130173390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Chasselas Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 133.626.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013141871/10.
(130173064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CCP II Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.620.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth of September.
Before Maitre Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole partner (the "Meeting") of "CCP II Berlin S.à r.l." (the "Company"),
a "Società à responsabilità limitée", established at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B
number 111.620, incorporated by deed of Maitre Joseph ELVINGER, notary, on October 3, 2005, published in the Lu-
xembourg Memorial C number 362 on February 18, 2006.
The Articles of Incorporation have been lastly amended pursuant to a deed of the undersigned notary on September
28, 2012, published in the Luxembourg Memorial C number 2620 on October 23, 2012.
The Meeting is presided by Mr Raymond THILL, "maitre en droit", with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKE, private employee, with professional address at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the sole partner present or represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be
registered with these minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 3,139 shares representing 100% of the capital of the Company (with an
amount of EUR 78,475.-) are present or duly represented so that the Meeting can validly decide on all the items of the
agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Curzon Capital Partners II S.à r.l. a "société à responsabilité limitée" with registered office at 16
Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, as liquidator (the "Liquidator");
138209
L
U X E M B O U R G
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
5. Miscellaneous.
IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liqui-
dation).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to appoint Curzon Capital Partners II S.à r.l.. a "société à responsabilité limitée" with registered
office at 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, R.C. S Luxembourg B No 109.746 as liquidator (The "Liquidator").
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxem-
bourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").
The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including
those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the sole partner.
The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or
several persons or entities.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on
behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required
for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-
ments of the liquidation proceeds to the sole partner of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their
respective mandates until today.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française
L'an deux mille treize, le vingt-six septembre.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (l'«Assemblée») de la société à responsabilité limitée
«CCP II Berlin S.à r.l.» (la «Société»), ayant son siège social au 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N° 111.620, constituée suivant acte reçu par le notaire
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 octobre 2005, publié au Mémorial C N° 362
du 18 février 2006.
Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 28
septembre 2012, publié au Mémorial C N° 2620 du 23 octobre 2012.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec adresse professionnelle
au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, avec adresse professionnelle au
74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'associé unique est présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
138210
L
U X E M B O U R G
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que 3,139 actions, représentant 100 % du capital social de la Société (d'un
montant de EUR 78.475,-), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Curzon Capital Partners II S.à r.l., Société à responsabilité limitée avec siège social au 16 Avenue
Pasteur, L-2310, Luxembourg, en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et
5. Divers.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volon-
taire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Curzon Capital Partners II S.à r.l.,, Société à responsabilité limitée avec siège social
au 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B No 109.746 en tant que liquidateur (le "Liquidateur").
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").
L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en
ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale de l'actionnaire
unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches
spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature
au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation
de la Société et la disposition de ses actifs.
L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances
sur le solde de liquidation à l'actionnaire unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à
ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Thill, M. Krecké, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2013. LAC/2013/44868. Reçu douze euros (12.- €)
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141861/130.
(130173795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
138211
L
U X E M B O U R G
Cashnote Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 154.956.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141859/10.
(130173134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Cellgate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 133.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CELLGATE SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013141863/11.
(130173821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CEPF Weisseritz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.325.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.255.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013141866/12.
(130173861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CFT Bourmicht S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R.C.S. Luxembourg B 164.934.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
CFT Bourmicht S.A.
Référence de publication: 2013141868/12.
(130173105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CABRELUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 40, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.830.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013141847/9.
(130173478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
138212
L
U X E M B O U R G
Calyx Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 79.877.
<i>Extrait de l’assemblée générale tenue en date du 27 septembre 2013:i>
Les actionnaires nomment administrateur de catégorie B, en remplacement de M. Nico Rollinger, Monsieur Kim Rol-
linger, né le 17 octobre 1983 à Luxembourg, demeurant professionnellement 33 rue de Bettembourg, L-3378 Livange,
pour une durée de deux ans.
Les actionnaires décident de nommer la société anonyme Compliance & Control, inscrite au R.C.S. de Luxembourg
sous le numéro B 172.482, ayant son siège au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg en remplacement de la société
anonyme PKF Weber & Bontemps au poste de commissaire, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2013. Son mandat prendra
fin lors de l'assemblée générale tenue en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013141852/18.
(130173638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Cross Falls Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: USD 250.000,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 89.243.
Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2011 de la société ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2013141845/12.
(130172940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Café des Bons Amis de Gomes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 120, rue Albert Unden.
R.C.S. Luxembourg B 97.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013141849/9.
(130172884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Chartreuse et Mont Blanc GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 142.634.
En date du 30 novembre 2011 l'associé unique de la Société, Macquarie International Investments Holdings L.P. & Cies
S.E.N.C., a changé sa dénomination et s'appelle désormais Macquarie Germany Holdings GmbH & Cies S.E.N.C..
En date du 27 septembre 2013 l'associé unique de la Société, Macquarie Germany Holdings GmbH & Cies S.E.N.C., a
cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales qu'il détient dans la Société à Macquarie Germany Holdings GmbH, avec siège
social à Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main (Allemagne), qui les acquiert.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141830/15.
(130173535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
138213
L
U X E M B O U R G
Cross Falls Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: USD 250.000,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 89.243.
Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2012 de la société ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2013141846/12.
(130173002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Capelle International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 102.421.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Tenue au siège social, le 8 octobre 2013i>
L'assemblée a pris acte de la démission du commissaire aux comptes actuels en date du 25 juillet 2013.
En conséquence, l'assemblée décide de nommer en son remplacement:
Monsieur Régis BUTRYN, demeurant professionnellement 36 Beetebuergerstrooss L-3333 Hellange
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015
Référence de publication: 2013141854/12.
(130173159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Compass Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 149.092.
Le Bilan au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société COMPASS RE S.A.
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013141841/11.
(130173476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Diajewel Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.851.
Les représentants permanents des administrateurs suivants de la société ont changé comme suit:
- Fides (Luxembourg) S.A., société anonyme, avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
immatriculée sous le numéro B 41469 avec le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, a pour représentant
permanent Monsieur Jorge Perez Lozano, né le 17 août 1973 à Mannheim, Allemagne, avec adresse professionnelle au
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Mutua (Luxembourg) S.A., société anonyme, avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
immatriculée sous le numéro B 41471 avec le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, a pour représentant
permanent Monsieur Patrick L.C. van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays Bas, avec adresse professionnelle au
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2013141922/19.
(130172943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
138214
L
U X E M B O U R G
Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 180.694.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Constellation IV German Asset Light, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly in-
corporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B179.317,
here represented by Mr Victorien Hémery, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Luxembourg on 27 September 2013; and
2. Constellation Flore Froehlich & Cie., a Swiss partnership incorporated under the Laws of Switzerland, with registered
office at Kantonsstrasse 77, CH-8807 Freienbach, Switzerland, registered with the trade register of the District of Schwyz
under number CH-130.2.016.409- 0.
here represented by Mr Victorien Hémery, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Freienbach on 27 September 2013.
The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the representative of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up the following articles of association of an
investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) under the form of a partnership
limited by shares (société en commandite par actions), qualifying as a specialised investment fund (fonds d'investissement
spécialisé - SIF) which they declare to establish as follows:
Chapter I. Definitions, Name, Registered office, Object, Duration
1. Definitions. In these articles of association (the Articles), the following shall have the respective meaning set out
below:
"1915 Law"
means the Luxembourg law of 10 August 1915, relating to commercial companies, as
amended;
“2007 Law”
means the Luxembourg law of 13 February 2007, relating to specialised investment funds,
as amended from time to time;
“Aggregate
Commitments”
means the aggregate amount of Commitments received by the General Partner from Sha-
reholders;
“Articles”
means these articles of association;
“Board”
means the board of managers of the General Partner;
“Business Day”
means a day on which banks are open for business in Luxembourg (other than a Saturday,
Sunday or public holiday);
“Capital Return”
means the entitlement of holders of Class A and Class B Shares to receive Distributions
equal to a capital return as set out in the Issuing Document;
“Carried Interest”
means the amounts distributed to the holders of Participating Shares as set out in the Issuing
Document;
“Class of Shares”
The share capital of the Fund is represented by four (4) classes (each a Class) of shares
(each a Share) namely the one (1) management share subscribed by the General Partner
in its capacity as managing general partner of the Fund with unlimited liability (the
Management Share), the Class A Shares, the Class B Shares and one thousand (1,000)
participating shares (the Participating Shares);
“Commitment(s)”
means the maximum amount (denominated in euro) that a prospective Shareholder has
committed to invest in the Fund by way of subscription for Shares pursuant to such
Shareholder’s Commitment Agreement;
“Commitment
Agreement”
means the agreement executed by each prospective Shareholder wishing to subscribe for
Shares in the Fund as foreseen in the Issuing Document;
“CSSF”
means the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the regulatory authority of
the Luxembourg financial sector;
138215
L
U X E M B O U R G
“Default Interest”
has the meaning ascribed to that term in Section 7.4 of the Articles;
“Defaulting Contribution” has the meaning ascribed to that term in Section 7.4 of the Articles;
“Defaulting Investor”
has the meaning ascribed to that term in Section 7.4. of the Articles;
“Distributions”
means proceeds received by the Fund and distributed to Shareholders as set out in the
Issuing Document;
“Drawdown”
means the request made by the General Partner to each Shareholder to pay to the Fund
whole or part of the remaining balance of the outstanding Commitment in exchange for
the issuance of Shares and, as appropriate, the issue of a Drawdown Notice;
“Drawdown Date”
means the date on which the General Partner will require Shareholders to subscribe for
Shares corresponding to the portion of their Commitment Drawdown;
“Drawdown Notice”
means the written notice (by post or e-mail) to be sent by the General Partner to each
Shareholder for them to subscribe for the number of Shares corresponding to the portion
of their Commitment Drawdown which should be sent not less than ten (10) Business
Days prior to the Drawdown Date;
“Final Closing”
means the final closing which shall take place no later than eighteen (18) months following
the Initial Closing;
“Fund”
means Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS, an investment company with
variable capital (société d’investissement à capital variable - SICAV) in the form of a
corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions - SCA)
organised as a specialised investment fund (fonds d’investissement spécialisé - SIF);
“Fund Documents”
means these Articles and the Issuing Document;
“General Meeting”
means any regularly constituted meeting of Shareholders of the Fund which shall represent
the entire body of Shareholders of the Fund;
“General Partner”
means Constellation IV German Asset Light, a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée), acting in its capacity as managing general partner (associé
gérant commandité) of the Fund;
“Initial Closing”
means the date of the initial closing of the Fund on a date to be determined at the discretion
of the General Partner;
“Issue Price”
means the issue price per Share determined in accordance with the Issuing Document;
”Luxembourg GAAP”
means Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles;
“Management Fee”
means the management fee payable to the General Partner pursuant to the Issuing
Document;
“Net Asset Value”
or “NAV”
means the net asset value of the Fund or, as the case may be, of a particular asset;
“Net Asset Value per
Share” or “NAV per
Share”
means, at any time, the NAV of the Fund as at that time divided by the number of Shares
on issue at that time;
Issuing Document
means the Issuing Document (document d’émission) prepared by the General Partner in
relation to the Fund, including its appendices;
“Ordinary Resolution”
means any resolution of a General Meeting adopted by Shareholders representing more
than fifty per cent. (50%) of the Shares present or represented and voting;
“Preferred Return”
means the entitlement of holders of Class A and Class B Shares to receive Distributions
equal to a preferred return as set out in the Issuing Document;
“Redemption Date”
has the meaning ascribed to that term in Section 9;
“Shareholder”
means any holder of Shares (including, as applicable, the General Partner) and whose liability
is limited to the amount of their Commitment to the Fund (with the exception of the
General Partner whose liability is unlimited);
“SIF”
means a specialised investment fund subject to the 2007 Law;
“Special Resolution”
means any resolution of a General Meeting taken by Shareholders representing more than
two-third (2/3rds) of the Shares issued and outstanding;
“Subsequent Closings”
means any closing subsequent to the Initial Closing but before the Final Closing, to be
determined at the discretion of the General Partner;
“Valuation Date”
means any day on which the Net Asset Value is calculated, which is to be determined at
least June 30 and December 3 as well as any other date determined by the General Partner;
“Well Informed Investor” any institutional investor, any professional investor and any investor who meets the
following conditions: (i) the investor has confirmed in writing that it adheres to the status
of “Well-Informed Investor”; and (ii) the investor invests a minimum of one hundred
138216
L
U X E M B O U R G
twenty-five thousand euro (EUR 125,000) in the Fund; or (iii) the investor has obtained an
assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an
investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC, or by a management company
within the meaning of Directive 2001/107/EC certifying such investor’s expertise,
experience and knowledge in adequately appraising an investment in the Fund.
2. Corporate Name. There is hereby established among the General Partner in its capacity as unlimited general ma-
naging partner (associé gérant commandité), the Shareholders and all persons who may become owners of the Shares, a
Luxembourg company under the corporate form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions),
qualifying as an investment company with variable capital - specialized investment fund (société d'investissement a capital
variable - fonds d'investissement specialise).
The Fund will exist under the corporate name of Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS.
3. Registered office. The registered office of the Fund is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
The General Partner is authorized to transfer the registered office of the Fund inside the municipality of Luxembourg
City.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a Special
Resolution.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Fund, the registered office of the Fund may be temporarily transferred
abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect on the
Fund's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg fund.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be taken by the General Partner.
4. Purpose. The main purpose of the Fund is to invest in securities of all kinds, undertakings for collective investment
as well as any other permissible assets, with a view of spreading investment risks and enabling its Investors to benefit
from the return on investment, in accordance with the 2007 Law.
The investment objectives and policies of the Fund shall be more fully described and be disclosed in the Issuing Do-
cument.
The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the 2007 Law.
5. Term. The Fund has a term of ten (10) years from the Initial Closing and may be extended by two (2) additional
one (1) year periods (the Term) upon a resolution of the General Meeting resolving by way of Special Resolution. Upon
the arrival of the Term, whether extended or not, the Fund will be automatically dissolved and will merely continue to
exist for the purpose of its orderly liquidation.
The Fund may also be dissolved in accordance with the provisions of these Articles and the Issuing Document.
Chapter II. Share Capital, Shares
6. Share capital. The initial share capital of the Fund at the time of incorporation is set at thirty one thousand euro
(EUR 31,000) divided into one (1) Management Share without par value, twenty-nine thousand nine hundred and ninety-
nine (29,999) Class A Shares without par value and one thousand (1,000) Participating Shares, without par value, the
Shares have been partly paid up upon issue.
The minimum share capital of the Fund shall be, as provided by the 2007 Law, one million two hundred and fifty
thousand euro (EUR 1,250,000) and must be reached within twelve (12) months after the date on which the Fund has
been authorized as a SIF.
Due to the fact that the Fund has a variable capital, the share capital of the Fund will be at all times equal to the value
of its net assets.
7. The offer of Shares.
7.1. Classes of Shares
The Fund will issue four (4) classes of Shares representing an interest in the Fund.
The General Partner has subscribed for one (1) Management Share. This Management Share may only be transferred
upon the termination of the General Partner as managing general partner of the Fund.
The Fund will issue Class A Shares and Class B Shares being classes of ordinary shares to the Shareholders in exchange
for their funded Commitments which grant them the right to Distributions, the Capital Return and to the Preferred
Return as set out in the Issuing Document.
The Fund has issued one thousand (1,000) Participating Shares to specific Shareholders, in accordance with the Issuing
Document, in exchange for their funded Commitments which grant them special rights to the Carried Interest.
7.2. Form of Shares
The Fund shall issue Shares in registered form only.
138217
L
U X E M B O U R G
A register of Shareholders will be maintained by the registrar agent of the Fund. Ownership of Shares will be established
by registration in the register of Shareholders. The Fund will recognize only one holder per share.
The inscription of the Shareholder's name in the register of Shareholders evidences their right of ownership on such
registered Shares. The Fund shall normally not issue certificates for such inscription.
The Fund shall consider the person in whose name the Shares are registered as the full owner of the Shares.
Fractional shares may be issued up to three (3) decimal places. Fractions of Shares shall carry rights in proportion to
the fraction of Shares they represent but shall carry no voting rights except to the extent the number of fractions held
by a Shareholder is so that it represents one (1) Share, in which case such Share confers a voting right.
Subject to the provisions of article 8 hereof, any transfer of registered Shares shall be entered into the register of
Shareholders.
Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Fund with an address to which all notices and
announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Fund may permit a notice to this effect to be entered
into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Fund,
or at such other address as may be so entered into by the Fund from time to time, until another address shall be provided
to the Fund by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of
Shareholders by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may be
set by the Fund from time to time.
Payments of Distributions, if any, will be made to Shareholders, in respect of registered Shares at their addresses
indicated in the register of Shareholders.
7.3. Restrictions to the Subscription for Shares
Shares are reserved for Well-informed Investors only and in accordance with the provisions of the Issuing Document.
The offering of the Shares may be restricted to specific categories of persons in certain jurisdictions in order to conform
to local law, customs or business practice or for fiscal or any other reason. It is the responsibility of any persons/entities
wishing to hold Shares to inform themselves of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant juris-
dictions.
The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued. The General Partner
may, in particular, decide that Shares shall only be issued during one or more offering periods.
The General Partner may fix a minimum subscription level as well as a minimum shareholding which any Shareholder
is required to comply with at any time as provided for in the Issuing Document.
7.4. Default provisions
Unless it is waived by the General Partner in its sole discretion, in the event that a Shareholder fails to pay to the Fund
the portion of its Commitment specified in a Drawdown Notice (the Defaulting Investor) on or before the Drawdown
Date, the amount outstanding shall bear interest as set out in the Issuing Document (Default Interest).
In such a case, further calls may be made upon the other Shareholders (up to but not exceeding their respective
undrawn Commitments and pro rata to their respective Commitments) in order to make good the shortfall.
If however, the Defaulting Investor fails to pay in full the outstanding amount and Default Interest accrued thereon
(the Defaulting Contribution), on or before the twentieth (20
th
) Business Day from the Drawdown Date, the General
Partner may (without prejudice to any other rights it may have), in its sole discretion, and without further notice, take
any of the measures as more fully described in the Issuing Document.
8. Transfer of Shares and Transfer restrictions. The transfer of Shares may normally be completed by delivery to the
General Partner, or its appointed agent, of an instrument of transfer in appropriate form. The transferee(s) will be required
to complete a Commitment Agreement, if he (they) is (are) a new Shareholder(s) in the Fund as the central administration
agent of the Fund may find necessary.
Any transferor shall in addition to its Shares, transfer the outstanding rights and obligations under its Commitment
Agreement (including, for avoidance of doubt the obligation to contribute any amount called pursuant to a Drawdown
Notice) so that the transferor is not a Shareholder once the transfer is completed.
No transfer of Shares may take place without (i) the prior approval of the General Partner in accordance with the
conditions determined in the Issuing Document which approval shall not be unreasonably withheld; (ii) the transferee
qualifying as a Well Informed Investor; and (iii) the transferee having duly completed all "know-your-customer" and "anti-
money laundering" processes to the satisfaction of the General Partner.
9. Redemption of Shares. No Shareholder may request the redemption of its Shares and no Shareholder may withdraw
from the Fund.
Notwithstanding the above, the shares subscribed by the founding shareholders (with the exception of the Management
Share) at the incorporation of the Company may be redeemed at the request of such founding shareholders at their
subscription price on or about the date on which shares are first issued to Well Informed Investors upon the terms of
the Issuing Document.
138218
L
U X E M B O U R G
The General Partner may, in its absolute discretion, decide to redeem all or some of the Shares in issue on a pro rata
basis of each Shareholder's holding in the Fund. Such redemption may be used in particular, but not exclusively, in lieu of
payment of Distributions.
Where such redemption is to be made, Shareholders shall be notified in writing, in accordance with the principle of
equal treatment of Shareholders, of the number of Shares to be redeemed, of the redemption price per Share and of the
date on which such Shares will be redeemed (the Redemption Date).
Shares will be redeemed at the Net Asset Value per Share as at the Valuation Date preceding the relevant Redemption
Date to the bank account designated by the Shareholder in its Commitment Agreement. No third party payment will be
made. Shares which have been redeemed will be cancelled with effect as of the Redemption Date.
No redemption of Shares may be made as a result of which the share capital of the Fund would fall below the minimum
share capital amount required by the 2007 Law.
The General Partner must process the redemption of any Shares held by a Shareholder who no longer qualifies as a
Well Informed Investor.
10. Calculation of the net asset value per share. For each Class of Shares, the Net Asset Value will be calculated in
Euro with respect to each Valuation Date by dividing the net assets attributable to such Class by the number of Shares
issued and in circulation in such Class.
The Net Asset Value will be expressed in euro (EUR). The value of all assets and liabilities not expressed in EUR will
be converted into EUR at the relevant rates of exchange prevailing on the relevant Valuation Date. If such rate of exchange
is not available, the rate of exchange will be determined with prudence and in good faith by or under procedures esta-
blished by the Fund.
In determining the Net Asset Value, income and expenditure are treated as accruing daily.
The Net Asset Value of the Fund will be equal to the difference between the gross assets and the liabilities of the Fund
in accordance with Luxembourg GAAP.
The Net Asset Value of the Fund shall be determined on a half year basis on the last day of June 30 and December 31.
11. In addition, the General Partner may at its own cost decide to undertake further valuations during the year to
confirm the Net Asset Value of a particular investment at the time of acquisition and the whole portfolio may be valued
at any time for the purposes of calculating the Net Asset Value.
12. Each valuation shall be conducted with prudence and in good faith and will be based on fair value (juste valeur).
13. The Net Asset Value will be determined as set out below:
a) The assets of the Fund shall include:
1. all cash in hand, receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
2. any interest of any kind or nature in any undertaking for collective investment or assimilated entity, without any
limitation as to its form or legal status, whether with or without legal personality;
3. all bills and notes payable on demand and any account due (including the proceeds of securities sold but not deli-
vered);
4. all securities, shares, bonds, time notes, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants and other
securities, money market instruments and similar assets owned or contracted for by the Fund;
5. all interest accrued on any interest-bearing assets, except to the extent that the same is included or reflected in the
principal amount of such assets;
6. all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Fund to the extent information thereon
is reasonably available to the Fund;
7. the liquidating value of all forward contracts and all call or put options in which the Fund has an open position; and
8. all other assets of any kind and nature.
b) The value of such assets shall be determined at fair value with due regard to the following principles:
1. the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless it is unlikely to be received in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount
as the General Partner may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
2. any transferable security and any money market instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other
organized market will be valued on the basis of the last known price, unless this price is not representative, in which case
the value of such asset will be determined on the basis of its fair value;
3. investments in private equity securities other than the securities mentioned above will be valued by the General
Partner which will take into account the guidelines and principles for valuation of portfolio companies set out by the
European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA);
4. the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock
exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on
138219
L
U X E M B O U R G
which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognized pricing service
approved by the General Partner. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market
instruments or derivatives as well as other permitted assets may be valued at a fair value at which it is expected that they
may be resold, as determined in good faith by and under the direction of the General Partner;
5. the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and
volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swap). Any adjustments required as a result
of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at
their market value. The Company shall only enter into swaps in connection with hedging activities;
6. the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded
on exchanges or on other recognized markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the
policies established by the General Partner on the basis of recognized financial models in the market and in a consistent
manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being
equal to the net unrealized profit/loss with respect to the relevant position. The Company shall only enter into derivatives
traded OTC in connection with hedging activities;
7. the value of any other assets of the Company will be determined on the basis of the acquisition price thereof including
all costs, fees and expenses connected with such acquisition or if such acquisition price is not representative, the value
of any other assets of the Company will be determined on the basis of their fair value.
c) The liabilities of the Fund shall include:
1. all loans, bills and accounts payable;
2. all accrued interest on loans (including accrued fees for commitment for such loans);
3. all known liabilities, present or future, including all matured contractual obligations for payment of money, including
the amount of any unpaid Distributions declared by the Fund;
4. an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from
time to time by the Fund, and other reserves (if any) authorised and approved by the Fund, as well as such amount (if
any) as the Fund may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Fund; and
5. all other liabilities of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg GAAP.
In determining the amount of such liabilities the Fund shall, with due regard to the expenses borne by the Fund out of
the fees it receives, if any, take into account all expenses payable by the Fund which shall include formation expenses,
fees, expenses, disbursements and out-of-pocket expenses payable to the depositary of the Fund, its correspondents, the
central administration agent of the Fund as well as any other agent appointed by the Fund, the remuneration of any officers
and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage and reasonable travelling costs in connection with
meetings of the Board and committee meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and expenses
involved in registering and maintaining the registration of the Fund with any governmental agencies or stock exchanges
in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, licensing fees for the use of the various indexes, reporting
and publishing expenses, including the cost of preparing, translating, printing, advertising and distributing the Fund Do-
cuments, further explanatory sales documents, periodical reports or registration statements, the costs of publishing the
NAV and any information relating to the fair value of the Fund, the costs of printing certificates, if any, and the costs of
any reports to Shareholders, the cost of convening and holding general meetings and committee meetings, all taxes, duties,
governmental and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, trans-
action fees, the cost of publishing the issue and redemption prices, interests, bank charges and brokerage, postage,
insurance, telephone and telex. The Fund may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature
based on an estimated amount for yearly or other periods.
d) For the purposes of the Net Asset Value computation:
1. Shares of the Fund to be redeemed shall be treated as existing and taken into account until immediately after the
time specified by the Board on the relevant Valuation Date and from such time and until paid by the Fund the price
therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;
2. Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the time specified by the General Partner
on the Valuation Date and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to be a
debt due to the Fund; and
3. all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the Net
Asset Value is calculated shall be converted on the basis of the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Date.
14. Temporary suspension of the net asset value. The General Partner may suspend the determination of the Net
Asset Value and hence suspend the redemption of Shares of the Fund in the following cases:
a) when the stock exchange(s) or market(s) that supplies/supply prices for a significant part of the assets are closed,
or in the event that transactions on such a market are suspended, or are subject to restrictions, or are impossible to
execute in volumes allowing the determination of fair prices;
b) when the information or calculation sources normally used to determine the value of assets are unavailable, or if
the value of an investment cannot be determined with the required speed and accuracy for any reason whatsoever;
138220
L
U X E M B O U R G
c) when exchange or capital transfer restrictions prevent the execution of transactions or if purchase or sale trans-
actions cannot be executed at normal rates;
d) when the political, economic, military or monetary environment, or an event of force majeure, prevent the Fund
from being able to manage normally its assets or its liabilities and prevent the determination of their value in a reasonable
manner;
e) upon the occurrence of a credit event in or default respect of any transaction or investment having as a consequence
that the value of that investment cannot be determined with sufficient accuracy;
f) when, for any other reason, the prices of any significant investments cannot be promptly or accurately ascertained;
and
g) when the Fund is in the process of establishing exchange parities in the context of a merger, a contribution of assets,
an asset or Share split or any other restructuring transaction.
The suspension of the calculation of the NAV shall be notified to the relevant persons through all means reasonably
available to the Fund, unless the General Partner is of the opinion that a notification is not necessary considering the
short period of the suspension.
Chapter III. Management
15. Determination of the General Partner. The General Partner is appointed as manager of the Fund and shall then
act as its managing general partner (associé gérant commandité).
The General Partner shall be personally, jointly and severally liable with the Fund for all liabilities which cannot be met
out of the assets of the Fund.
The limited partners (actionnaires commanditaires) shall not participate in the management of the Fund.
The General Partner may only be removed by way of a Special Resolution as set out in the Issuing Document. For the
avoidance of doubt, such decision to remove the General Partner shall not require the positive vote of the General
Partner.
16. Powers of the general partner and Removal as manager.
16.1. Powers of the General Partner
The General Partner is ultimately responsible for the administration and the management of the Fund and retains
ultimate decision making power and has exclusive authority with regard to any decision not specifically delegated or
attributed to another entity or service provider.
The Board shall have namely the specific powers provided for in the articles of association of the General Partner.
16.2. Removal of the General Partner as manager of the Fund
The General Partner may only be removed as the managing general partner of the Fund by the General Meeting
approving the removal with a Special Resolution, each time subject to the prior approval of the CSSF. A removal decision
may be made for cause only. The General Partner shall not have a veto right in respect of a removal resolution.
16.2.1. For cause removal
The removal for cause shall be subject to confirmation of the cause for removal by a final arbitration award. The forum
shall be Luxembourg and cause shall be construed in accordance with Luxembourg laws.
"Cause" shall exist upon the failure of the General Partner (such as the bankruptcy of the General Partner or in case
of incapacity of the General Partner to properly manage the Fund), the negligent behaviour, wilful misconduct, bad faith
or fraud resulting in a breach of a material term of the Issuing Document further causing a material loss to the Fund.
Upon confirmation of the final arbitration award, the General Partner will ipso facto be dismissed as the managing
general partner (associé gérant commandité) of the Fund and shall not be entitled to any further compensation.
If the General Partner is removed, the Participating Shares will be transferred at cost to the successive General Partner.
The replacing General Partner will hold a portion of the Participating Shares as trustee for the benefit of the removed
General Partner. The portion of Participating Shares so held by the replacing General Partner shall be the Carried Interest
entitlement of the removed General Partner which shall be determined as follows:
The removed General Partner will forfeit such percentage of its entitlement of the Carried Interest attached to the
Participating Shares, if any, according to the table shown in Section V. of the Issuing Document.
17. Representation of the fund. The Fund will be bound towards third parties by the sole signature of the General
Partner represented by its legal representatives or any other person to whom such power has been delegated by the
General Partner.
No Shareholder being a limited partner (actionnaires commanditaires) shall represent the Fund.
18. Liability of the General Partner and Shareholders. The General Partner shall be liable with the Fund for all debts
and losses which cannot be recovered on the Fund's assets.
The Shareholders (actionnaires commanditaires) shall refrain from acting on behalf of the Fund in any manner or
capacity whatsoever other than when exercising their rights as Shareholders in General Meetings in order to preserve
their limited liability status.
138221
L
U X E M B O U R G
19. Delegation of Powers to Agents of the General Partner. The General Partner may, at any time, appoint officers or
agents of the Fund as required for the affairs and management of the Fund, provided that the Shareholders (actionnaires
commanditaires) cannot act on behalf of the Fund without losing the benefit of their limited liability. The appointed officers
or agents shall be entrusted with the powers and duties conferred to them by the General Partner.
The General Partner will determine any such officers or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
20. Integrity and Conflict of interests.
20.1. Integrity
The General Partner shall act with honesty and uphold the highest ethical standards in all its conduct.
20.2. Conflicts of interests
Shareholders may have conflicting tax interests or other conflicting interests in connection with their participation in
the Fund. The conflicting interests of individual Shareholders may be related or triggered by the nature of the investments
made by the Fund, the structuring or acquisition of investments as well as by the timing of their transfer by the Fund,
knowing that with respect to the structuring of the investment, this will be, as the case may be, more beneficial for one
Shareholder than another, especially regarding the specific tax situations. When selecting and structuring the investments
of the Fund, the General Partner will consider the investment and tax objectives of the Fund as well as those of the
Shareholders as a whole and not in terms of investment, tax or other objectives of a particular Shareholder.
In addition, conflicts of interest between the Fund and, as appropriate, any person contributing to the activities of the
Fund or any person directly or indirectly related to the Fund may potentially occur. In accordance with article 42bis (2)
of the 2007 Law, the Fund has established an adequate system of risk management of such conflicts of interest in order
to prevent them from impairing the interests of the Shareholders. In case of a potential conflict of interest, the Fund will
safeguard the interests of the Shareholders.
Chapter IV. General Meeting of Shareholders
21. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Fund
shall represent the entire body of Shareholders of the Fund. The General Meeting shall deliberate only on the matters
which are not reserved to the General Partner by the Articles or by the applicable Luxembourg laws and regulations.
In accordance with Article 111 of the 1915 Law, and at the exclusion of what is provided under article 12 of these
Articles, no decision of the General Meeting will be validly taken without the prior approval of the General Partner.
22. Annual and other General Meetings. The annual General Meeting is held at the registered office of the Fund or at
any other address in Luxembourg as indicated in the convening notice on the 30 of June at 10.00 a.m. or if such a day is
not a Business Day, on the next following Business Day.
The General Partner may convene other General Meetings. Such meetings must be convened if Shareholders repre-
senting ten per cent. (10%) of the Fund's share capital so require.
Such other General Meetings will be held at such places and times as may be specified in the respective notices
convening the meeting.
Unless otherwise stipulated by applicable Luxembourg law and regulations or the Fund Documents, the decisions of
the General Meeting will be reached by way of a simple majority vote of the Shareholders present or represented and
voting.
23. Convening notice. The General Meeting is convened by the General Partner in compliance with the applicable
Luxembourg laws and regulations.
As all Shares are in registered form, notices to Shareholders are sent by registered mail by the central administration
agent of the Fund to all Shareholders, to their address indicated in the register of Shareholders, at least eight (8) Business
Days prior to the date of the meeting.
Such notice will indicate the time and place of such meeting and the conditions of admission thereto, will contain the
agenda and will refer to the requirements of applicable Luxembourg laws and regulations with regard to the necessary
quorum and majorities at such meeting. To the extent required by applicable Luxembourg laws and regulations, further
notices will be published in the Memorial and in one Luxembourg newspaper.
If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the Shareholders can waive all convening requirements and formalities.
24. Presence, Representation. Unless otherwise provided by applicable Luxembourg laws and regulations or by the
Articles, all Shareholders are entitled to attend, speak and vote at all General Meetings.
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as
his proxy another person who need not be a Shareholder himself.
25. Vote. At General Meetings each Shareholder has the right to one vote for each whole Share held.
In the case of a joint holding, only the first named Shareholder or the common representative appointed in this respect
and notified to the Fund may vote at a General Meeting.
138222
L
U X E M B O U R G
Unless otherwise provided by applicable Luxembourg laws and regulations or by the Articles, all resolutions of the
annual or ordinary General Meeting shall be taken by simple majority of votes of the Shareholders present or represented,
regardless of the proportion of the capital.
26. Proceedings. The General Meeting shall be chaired by a person designated by the meeting of Shareholders.
The chairman of the General Meeting shall appoint a secretary. The General Meeting shall elect one scrutineer to be
chosen from the Shareholders present or represented. They together form the office of the General Meeting.
27. Minutes. The minutes of the General Meeting shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and
the scrutineer.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits
28. Financial year. The Fund's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of
the same year.
The first financial year of the Fund shall begin upon the date hereof and shall end on December 31, 2013.
29. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Fund shall be examined by an independent auditor
(réviseur d'entreprises) appointed by the General Partner and remunerated by the Fund, who shall fulfil all duties pre-
scribed by the 2007 Law.
30. Distribution. The approval of the annual results and allocation of any Distributions shall be determined by the
annual General Meeting upon the discretionary proposal of the General Partner, in accordance with the Issuing Document.
Such allocation may include the creation or maintenance of reserve funds and provisions, and determination of the balance
to be carried forward.
The General Partner may at any time during the year decide to distribute interim dividends each time freely distributable
funds are available.
In no event will a Distribution be paid if, as a result thereof, the net assets of the Fund would fall below one million
two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000).
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
31. Causes of Dissolution.
31.1. Legal incapacity or inability to act of the General Partner
In accordance with the 2007 Law, the Fund shall be wound-up in the following circumstances:
a) After a period of 12 (twelve) months following the authorization of the Fund by the CSSF, if the share capital of the
Fund has not reached one million two hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000);
b) In the event of cessation by the depositary of the Fund of its duties, if it has not been replaces within two (2) months
by a suitably qualified entity;
c) upon the Net Asset Value of the Fund falling below one million two hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000)
before the end of the Term of the Fund.
31.2. Voluntary dissolution
At the proposal of the General Partner and unless otherwise provided by applicable Luxembourg laws and regulations
and the Articles, the Fund may be dissolved prior to the end of its term, if any, by a resolution of the Shareholders adopted
in the manner required to amend the Articles, and subject to the approval of the General Partner.
In particular, the General Partner shall submit to the General Meeting the dissolution of the Fund when all investments
of the Fund have been disposed of or liquidated.
31.3. Decrease of the share capital
Whenever the share capital falls below the two thirds of the minimum capital indicated in article 6 hereof, the question
of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the General Partner. The General Meeting
shall decide in accordance with the conditions provided in article 39(2) of the 2007 Law.
The question of dissolution of the Fund shall further be referred to the General Meeting whenever the share capital
falls below one fourth of the minimum capital set by article 6 hereof; in such event, the General Meeting shall decide in
accordance with the conditions provided in article 39(3) of the 2007 Law.
The meeting should be convened so that it is held within a period of forty (40) days from the discovery that the net
assets of the Fund have fallen below two thirds (2/3) or one fourth (1/4) of the legal minimum, as the case may be.
32. Liquidation. Upon the termination of the Fund, the assets of the Fund will be liquidated in an orderly manner and
the proceeds from the liquidation of investments will be distributed to the Shareholders in proportion to their holding
of Shares.
In the event of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators which can be the General
Partner, appointed by the General Meeting, pursuant to the 2007 Law and the Articles, and subject to the prior approval
of the CSSF. Amounts which have not been claimed by Shareholders at the close of the liquidation will be deposited in
138223
L
U X E M B O U R G
escrow with the Caisse de Consignations in Luxembourg. Should such amounts not be claimed within the prescription
period, then they may be forfeited.
Any appointed liquidator(s) shall be subject to full compliance with all the provisions of the Fund Documents.
Chapter VII. Final Provisions
33. Amendments of these Articles of Association. The Articles may from time to time be amended by the General
Meeting resolving by way of Special Resolution.
34. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the 2007 Law and the Issuing Document.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Fund and shall terminate on the December
31, 2013.
The first annual General Meeting shall be held on the 30 of June in 2014 in accordance with article 19 of the Articles.
<i>Subscriptioni>
The share capital has been subscribed as follows:
Subscriber
Share class
Subscribed
amount
Number
of shares
subscribed
Constellation IV German Asset Light, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Management Share
1 Euro
1
Constellation Flore Froehlich & Cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Class A Shares 29,999 Euro
29,999
Constellation Flore Froehlich & Cie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Participating Shares
1,000 Euro
1,000
The Fund has been incorporated with a share capital amounting to thirty one thousand euro (EUR 31,000) represented
by one (1) Management Share without par value, twenty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (29,999) Class A
Shares without par value and one thousand (1,000) Participating Shares, without par value, all subscribed and partly paid-
up. The amount of one thousand five hundred fifty euro (EUR 1,550), representing 5% of the share capital, is from now
on at the free disposal of the Fund, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Fund as a result
of the present deed amount approximately to two thousand two hundred euro (EUR 2.200.-).
<i>General meeting of the Shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Fund, the above-named persons, representing the entire subscribed capital
and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting of the
Shareholders of the Fund. Having first verified that it was regularly constituted, the meeting adopted the following reso-
lutions:
35. Resolutions. The incorporating shareholders representing the entire share capital of the Fund and considering
themselves as duly convened has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Partnership shall be at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg.
2. The independent auditor of the Fund shall be Ernst & Young S.A., a société anonyme, having its registered office at
7, rue Gabriel Lipmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, filed with the Luxem-
bourg Trade and Companies Registry under number B 47.771.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
parties, the present deed is worded in English.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with the notary the present
deed.
Signé: V. HÉMERY, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 02 octobre 2013. Relation: DIE/2013/12203. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): pd. RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Memorial C.
138224
L
U X E M B O U R G
Diekirch, le 09 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141843/559.
(130173035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
D.B. International Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 33.911.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 14 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 15 juillet 2013.
Référence de publication: 2013141889/11.
(130173499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
CGP Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 176.072.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 18 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 18 juillet 2013.
Référence de publication: 2013141870/11.
(130173419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Calendar Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.554.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Calendar Properties S.à r.l.
Rachel Hafedh
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013141820/13.
(130173684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Distress to Value S.A. -Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.523.
Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 25 septembre 2013 il a été décidé:
- de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle du 19-21 boulevard du Prince
Henri L-1724 Luxembourg vers le 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DISTRESS TO VALUE S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2013141899/14.
(130173542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
138225
L
U X E M B O U R G
Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.067.
Par résolutions signées en date du 18 juillet 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Fanny Him, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat.
2. Nomination de Gaël Sausy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141900/15.
(130173740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Dune Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 83.165.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 1
er
octobre 2013 que:
- le siège social de la Société a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, avec effet au 1
er
octobre 2013;
- M. Willem ADRIAANSE a été révoqué de ses fonctions d'Administrateur de catégorie B, avec effet immédiat;
- M. Olivier MAINGARD, né le 16 janvier 1950 à Biarritz (France), résident au 36, rue Auguste Liesch, L-1937 Lu-
xembourg, a été nommé aux fonctions d'Administrateur de catégorie B de la Société, avec effet immédiat. Son mandat
expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019;
- READ S.à r.l., avec siège social au 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été révoquée de son poste
de commissaire aux comptes, avec effet immédiat;
- M. Marco RIES, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé aux
fonctions de commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2012. Son mandat expirera à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019;
- M. Jean-Michel BEIGBEDER, Administrateur de catégorie A, demeurant au 11, rue Bonaparte, F-75006 Paris, et M.
Charles CARTHEW-YORSTOUN, Administrateur de catégorie B, demeurant au 5831, Sandhurst Lane, Apartment D,
USA - 75206 Dallas, ont été réélus pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013141929/25.
(130172896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
DHC Luxembourg IV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.328.575,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.012.
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "DHC Luxembourg IV S.àr.l." (the "Company"), a
société à responsabilité limitée with registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, being registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 121.012. and incorporated on 13 October
2006 by deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial")
number 2314 of 12 December 2006.
The articles of association of the Company were amended for the last time on 13 March 2013 by deed of Me Henri
Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial number 1212 of 23 May 2013.
The meeting was presided by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
138226
L
U X E M B O U R G
There was appointed as secretary and scrutineer Me Namik Ramic, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
A. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all:
- five thousand and seventy seven (5,077) Class B Shares,
- twenty thousand (20,000) Class H Shares,
- fifteen thousand one hundred and twenty (15,120) Class K Shares,
- two thousand and seven hundred (2,700) Class TL (CG) Shares,
- two thousand and seven hundred (2,700) Class TL (I) Shares,
- twenty four thousand eight hundred eighty seven (24,887) Class U Shares,
- fourteen thousand seven hundred and nine (14,709) Class Z Shares, and
- five hundred (500) Category X Shares,
being a total of eighty-five thousand six hundred ninety-three (85,693) shares in issue in the Company were represented
at the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so
that the meeting was validly constituted and able to validly decide on the items of the agenda.
B. The agenda of the meeting was as follows:
- Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of four hundred ten thousand six hundred twenty-
five Euro (EUR410,625), without payment to the shareholders of the Company, by the cancellation of sixteen thousand
four hundred twenty-five (16,425) Class U Shares; allocation of the share capital reduction to the share premium of the
Company;
- Increase of the issued share capital of the Company by (i) the issue of one million three hundred three thousand
eight hundred seventy-five (1,303,875) Class H Shares for a subscription price of twenty-five Euro (€25) per share (being
a total subscription price of thirty-two million five hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five Euro
(EUR32,596,875) upon the conversion of convertible claims at a conversion ratio of one to one and subscription in the
proportions set out hereafter:
Subscriber
Number
of Class
H Shares
subscribed
Subscription
price (EUR)
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377,051
9,426,275
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406,576
10,164,400
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,917
2,447,925
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351,088
8,777,200
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71,243
1,781,075
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,303,875
32,596,875
Acknowledgment of payment of the total subscription price of all new shares through conversion of the convertible
claims, allocation of an amount equal to the aggregate nominal value of the shares so issued to the issued share capital;
- consequential amendment of article 5.1 to read as follows:
5.1. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of thirty-four million three hundred twenty-eight
thousand five hundred seventy five euro (EUR34,328,575) divided into
- five thousand and seventy seven (5,077) Class B Shares,
- one million three hundred twenty-three thousand eight hundred seventy-five (I,323,875) Class HShares,
- fifteen thousand one hundred and twenty (15,120) Class K Shares,
- two thousand and seven hundred (2,700) Class TL (CG) Shares,
- two thousand and seven hundred (2,700) Class TL (I) Shares,
- eight thousand four hundred sixty-two (8,462) Class U Shares,
- fourteen thousand seven hundred and nine (14,709) Class Z Shares, and
- five hundred (500) Category X Shares,
each with a nominal value of twenty five Euro (€25).
Thereafter, the following resolutions were passed:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of four hundred ten thousand six hundred
twenty-five Euro (EUR410,625), without payment to the shareholders of the Company, by the cancellation of sixteen
138227
L
U X E M B O U R G
thousand four hundred twenty-five (16,425) Class U Shares and to allocate the share capital reduction amount to the
share premium of the Company.
It is resolved to increase the issued share capital of the Company and to issue ordinary shares as set forth below.
It is resolved to convert one million three hundred three thousand eight hundred seventy-five (1,303,875) convertible
claims into one million three hundred three thousand eight hundred seventy-five (1,303,875) Class H Shares for a total
subscription and issue price of thirty-two million five hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five Euro
(EUR32,596,875) and it was resolved to issue one million three hundred three thousand eight hundred seventy-five
(1,303,875) Class H Shares that were subscribed in the proportion set out in the agenda.
It is acknowledged and approved that the conversion of the convertible claims constitutes full payment of the sub-
scription price of the Class H shares.
As a result it was resolved to increase the issued share capital by thirty-two million five hundred ninety-six thousand
eight hundred seventy-five Euro (EUR32,596,875) to thirty-four million three hundred twenty-eight thousand five hundred
seventy five euro (EUR34,328,575).
Evidence of the conversion and hence full payment of the subscription price was shown to the undersigned notary.
It is resolved to allocate an amount of thirty-two million five hundred ninety-six thousand eight hundred seventy-five
Euro (EUR32,596,875) being equal to the aggregate nominal value of the Shares so issued to the issued share capital.
It is resolved to amend article 5.1 as set forth in the agenda.
There being no further items on the agenda, the meeting was thereupon closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present extraordinary general meeting are estimated at EUR 7,500.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing
parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le trentième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «DHC Luxembourg IV S.à r.l.» (la «Société»), une
société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.012 et constituée le 13 octobre 2006
suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro
2314 du 12 décembre 2006.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 13 mars 2013 suivant acte reçu de Me Henri Hellinckx,
précité, publié au Mémorial numéro 1212 du 23 mai 2013.
L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommée comme secrétaire et scrutateur Me Namik Ramic, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
A. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, figurent sur une liste de présence
signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au
présent acte afin d'être soumise aux formalités de l'enregistrement.
Il appert de ladite liste de présence que toutes les:
- cinq mille soixante-dix-sept (5.077) Parts Sociales de Classe B,
- vingt mille (20.000) Parts Sociales de Classe H,
- quinze mille cent vingt (15.120) Parts Sociales de Classe K,
- deux mille sept cents (2.700) Parts Sociales de Classe TL (CG),
- deux mille sept cents (2.700) Parts Sociales de Classe TL (I),
- vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (24.887) Part Sociales de Classe U,
- quatorze mille sept cent neuf (14.709) Parts Sociales de Classe Z, et
- cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie X,
soit un total de quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-treize (85.693) parts sociales émises dans la Société, étaient
représentées à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir eu préalablement connaissance de
l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée était régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer sur les points
portés à l'ordre du jour.
138228
L
U X E M B O U R G
B. L'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
- Réduction du capital social émis de la Société d'un montant de quatre cent dix mille six cent vingt-cinq euros (410.625
EUR), sans paiement aux associés de la Société, par l'annulation de seize mille quatre cent vingt-cinq (16.425) Parts Sociales
de Classe U; affectation de la réduction du capital social à la prime d'émission de la Société;
- Augmentation du capital social émis de la Société par (i) l'émission d'un million trois cent trois mille huit cent soixante-
quinze (1.303.875) Parts Sociales de Classe H pour un prix de souscription de vingt-cinq euros (25 €) par part sociale
(soit un prix total de souscription de trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze
euros (32.596.875 EUR) à la conversion de créances convertibles à un taux de conversion d'un à un et souscription dans
les proportions indiquées ci-dessous:
Souscripteur
Nombre
de Parts
Sociales
de Classe H
souscrites
Prix de
souscription
(EUR)
Doughty Hanson & Co IV Nominees One Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377.051
9.426.275
Doughty Hanson & Co IV Nominees Two Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406.576
10.164.400
Doughty Hanson & Co IV Nominees Three Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.917
2.447.925
Doughty Hanson & Co IV Nominees Four Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351.088
8.777.200
Officers Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.243
1.781.075
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.303.875
32.596.875
Reconnaissance du paiement du prix total de souscription de toutes les nouvelles parts sociales par la conversion des
créances convertibles, affectation d'un montant égal à la valeur nominale globale des parts sociales ainsi émises au capital
social émis;
- Modification en conséquence de l'article 5.1 afin qu'il ait la teneur suivante:
5.1. La Société a un capital social, émis et souscrit, intégralement libéré de trente-quatre millions trois cent vingt-huit
mille cinq cent soixante-quinze euros (34.328.575EUR) réparti en
- cinq mille soixante-dix-sept (5.077) Parts Sociales de Classe B,
- un million trois cent vingt-trois mille huit cent soixante-quinze (1.323.875) Parts Sociales de Classe H,
- quinze mille cent vingt (15.120) Parts Sociales de Classe K,
- deux mille sept cents (2.700) Parts Sociales de Classe TL (CG),
- deux mille sept cents (2.700) Parts Sociales de Classe TL (I),
- huit mille quatre cent soixante-deux (8.462) Parts Sociales de Classe U,
- quatorze mille sept cent neuf (14.709) Parts Sociales de Classe Z, et
- cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie X,
chacune d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 €).
À la suite de quoi, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Résolution uniquei>
Il a été décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de quatre cent dix mille six cent vingt-cinq
euros (410.625 EUR), sans paiement aux associés de la Société, par l'annulation de seize mille quatre cent vingt-cinq
(16.425) Parts Sociales de Classe U et d'affecter le montant de la réduction du capital social à la prime d'émission de la
Société.
Il a été décidé d'augmenter le capital social émis de la Société et d'émettre des parts sociales ordinaires tel qu'énoncé
ci-dessous.
Il a été décidé de convertir un million trois cent trois mille huit cent soixante-quinze (1.303.875) créances convertibles
en trois cent trois mille huit cent soixante-quinze (1.303.875) Parts Sociales de Classe H pour un prix total de souscription
et d'émission de trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze euros (32.596.875 EUR)
et il a été décidé d'émettre un million trois cent trois mille huit cent soixante-quinze (1.303.875) Parts Sociales de Classe
H qui ont été souscrites dans les proportions indiquées dans l'ordre du jour.
Il a été acquiescé et approuvé que la conversion des créances convertibles constitue le paiement intégral du prix de
souscription des Parts Sociales de Classe H.
Par conséquent, il a été décidé d'augmenter le capital social émis de trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-seize
mille huit cent soixante-quinze euros (32.596.875 EUR) pour l'établir à trente-quatre millions trois cent vingt-huit mille
cinq cent soixante-quinze euros (34.328.575 EUR).
Preuve de la conversion et donc du paiement intégral du prix de souscription a été montrée au notaire soussigné.
Il a été décidé d'affecter un montant de trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quinze
euros (32.596.875 EUR) équivalant à la valeur nominale globale des Parts Sociales ainsi émises au capital social émis.
138229
L
U X E M B O U R G
Il a été décidé de modifier l'article 5.1 tel qu'énoncé à l'ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
de la présente assemblée générale extraordinaire sont estimés à EUR 7.500,-
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes per-
sonnes comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, les membres du Bureau et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: T. HOSS, N. RAMIC et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2013. Relation: LAC/2013/44641. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 9 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141921/199.
(130172991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Carlo Schmitz Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 21, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 6.335.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter der Firma Carlo Schmitz S.à.r.l. Abge-i>
<i>halten am 24. September 2013 um 16.00 UHR in Merschi>
Die Versammlung ruft einstimmig Herr Bernd WEIRICH sowie Herr Eric GIGOT als Geschäftsführer der Gesellschaft
ab.
Herr Rainer MAYER wird als alleiniger Geschäftsführer bestätigt und kann die Gesellschaft nach aussen durch seine
alleinige Unterschrift verpflichten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, den 24. September 2013.
Für gleichlautende Ausfertigung
<i>Der Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2013141857/17.
(130173612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Dorel Hungary Kft., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 125.838.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 de Dorel Hungary Kft. ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Référence de publication: 2013141907/11.
(130173973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Dalkia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 18.830.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
138230
L
U X E M B O U R G
FIDUO
Référence de publication: 2013141910/10.
(130173231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Delphina Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 139.340.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
DELPHINA VENTURES S.A.
Référence de publication: 2013141919/11.
(130173025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Damode-MG S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.721.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013141911/11.
(130172960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Deluco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 170.857.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DELUCO
i>Signature
Référence de publication: 2013141920/11.
(130173072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Dansor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 156.193.
Il résulte de la lettre datée du 1
er
janvier 2013 que Monsieur Gilbert Muller a démissionné avec effet au 1
er
janvier
2013 de sa fonction de gérant de la Société
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2013.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013141913/14.
(130173113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
138231
L
U X E M B O U R G
DDI A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 153.684.
Ce dépôt remplace le dépôt enregistré à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg le 27.10.2011 sous la référence L110171587.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 24 octobre 2011i>
La durée du mandat de M. Georg Witt a été confirmée comme prenant fin lors de l’assemblée générale statutaire
devant se tenir en 2014.
La société PKF ABAX Audit a été révoquée de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société avec effet
immédiat.
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2014, la société Kohnen & Associés S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B
114.190, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, a été nommée commissaire aux comptes de
la Société.
Luxembourg, le 7 octobre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DDI A.G.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2013141917/21.
(130173668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SCOR ILS FUND S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 162.452.
<i>Extract of the minutes of the General Meeting dated 30 September 2013i>
Appointment of 2 new directors to Board of Directors until the next annual general meeting of the Company:
Mr. Fabrice ROSSARY (professionally residing at 5, avenue Kleber - F-75795 Paris Cédex -France).
Ms Michèle LACROIX (professionally residing at 5, avenue Kleber - F-75795 Paris Cédex -France).
Suit la traduction française
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale daté du 30 septembre 2013i>
Nomination de 2 nouveaux administrateurs au Conseil d'Administration jusqu'à la prochaine assemblée générale an-
nuelle de la société:
Mr. Fabrice ROSSARY (résidant professionnellement au 5, avenue Kleber - F-75795 Paris Cédex - France).
Ms Michèle LACROIX (résidant professionnellement au 5, avenue Kleber - F-75795 Paris Cédex - France).
<i>Pour SCOR ILS Fund S.A., SICAV-SIFi>
Référence de publication: 2013142459/19.
(130173308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SCOP Poland S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 101.812.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises le 30 septembre 2013i>
- le siège social de la société est transféré du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 - Luxembourg au 412F, Route d'Esch,
L-2086, Luxembourg, avec effet au 1
er
octobre 2013.
- Les personnes suivantes:
* M. Thierry Jacob, né le 7 juillet 1967 à Thionville (France), résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086
Luxembourg;
* M. Christian Mognol, né le 15 janvier 1962 à Esch-Sur-Alzette (Luxembourg), résidant professionnellement au 412F,
Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
138232
L
U X E M B O U R G
* M. Olivier Oudin, né le 19 octobre 1967 à Troyes (France), résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch,
L-2086 Luxembourg;
Sont nommés Gérants avec effet au 1
er
Octobre 2013 et pour une durée indéterminée en remplacement de M. Carlo
Schneider, M. Vincent Cormeau et M. Jean-Daniel Megret.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013142458/21.
(130172841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Sciamani S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 165.555.
Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 4 octobre 2013
que M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg, a été nommé à la fonction d’administrateur en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire, avec effet
immédiat.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013142457/14.
(130172956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SSCP Security Holding SCA, Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 70.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 137.111.
<i>Extrait des résolutions des associés de SSCP Security Holding S.C.A. prises au Luxembourg le 19 septembre 2013.i>
Les associés de SSCP Security Holding S.C.A. acceptent la démission de Madame Carol Wilson, née le 11 juillet 1954
à Irvine, Grande-Bretagne ayant son adresse professionelle au 11-15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH Jersey, en qualité
de membre du conseil de surveillance de la Société avec effet au 28 mars 2013.
Les associés acceptent la nomination de Monsieur Andreas Demmel, né le 11 avril 1969 à München, Allemagne ayant
son adresse professionelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duché de Luxembourg, en qualité
de membre du conseil de surveillance de la Société avec effet au 28 mars 2013.
Veuillez noter que l'adresse de Bolaji Adekunle Odunsi en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société a
changée au 2 Basil Street, Londres SW3 1AA, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2013.
Anke Jager.
Référence de publication: 2013142477/19.
(130173657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
St-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 59, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 98.643.
EXTRAIT
Il résulte d'une réunion de l'associée unique de la société ST-LUX S.à r.l, avec siège social à L-3450 Dudelange, 59, rue
du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.643, en date du 7
octobre 2013, que:
- Monsieur Fränk MANNES, maître-électricien, né Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1965, demeurant à L-5538 Remich, 5,
rue des Jardins,
a été nommé comme gérant supplémentaire de la société ST-LUX S.à r.l. pour une durée indéterminée.
- Le mandat de Monsieur Josua WUTZ en tant que gérant a été confirmé.
- Chaque gérant peut engager la société par sa signature individuelle.
138233
L
U X E M B O U R G
Echternach, le 8 octobre 2013.
Henri BECK
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013142478/19.
(130173094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SSCP PADS PV S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 174.608.
<i>Extrait des résolutions des associés de SSCP PADS PV S.C.A. prises au Luxembourg le 19 septembre 2013.i>
Les associés de SSCP PADS PV S.C.A. acceptent la démission de Madame Carol Anne Scott Wilson, née le 11 juillet
1954 à Irvine, Grande-Bretagne ayant son adresse professionelle au 11-15 Seaton Place, St. Helier, JE4 0QH Jersey, en
qualité de commissaire de la Société avec effet au 28 mars 2013.
Les associés acceptent la nomination de Monsieur Ganash Lokanathen, né le 05 juillet 1978 à Pahang, Malaisie ayant
son adresse professionelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duché de Luxembourg, en qualité
de commissaire de la Société avec effet au 28 mars 2013.
Veuillez noter que l'adresse de Monsieur Andreas Demmel en sa qualité de commissaire de la Société a changée au 7,
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2013.
Anke Jager.
Référence de publication: 2013142476/18.
(130173334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Sopura Eastern Europe A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.860.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 septembre 2013i>
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein une Présidente en la personne de Madame Monique GOPPIETERS. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2019.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Certifié sincère et conforme
SOPURA EASTERN EUROPE AG
M. COPPIETERS
<i>Administrateur-Délégué / Présidente du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013142474/17.
(130173340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Son Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers.
R.C.S. Luxembourg B 82.124.
<i>Auszug aus der ausserordentliche Versammlung vom 26. September 2013i>
Es geht aus einer außerordentliche Generalversammlung vom 26. September 2013, betreffend die Gesellschaft SON
GROUP S.A., mit Sitz zu L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer
B82.124:
Die Versammlung beschließt die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Komissars zu eneuern. Die Mandate
der Verwaltungsratsmitglieder und des Komissars enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr
2018 befindet.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 43933. Reçudouze euros 12,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
138234
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2013.
Référence de publication: 2013142473/19.
(130172901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Super-Max Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.969.
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before Us Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED
"Super-Max Malta Limited", a company incorporated under the laws of Malta, having its registered office at 60 Tigne
Towers, Tigne Street, Sliema SLM 3172, Malta, registered with the Register of Companies of Malta under number C 51177
(the "Sole Shareholder"),
here represented by Mrs Anita MAKARUKU, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given privately to her,
Which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered
with this deed.
The Sole Shareholder requests the notary to act that:
I. It is the Sole Shareholder of "SUPER-MAX LUXEMBOURG S.à r.l.", a limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with
a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), registered with the Luxembourg Trade Register,
section B number 154.969, incorporated by a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, in
replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated August 6
th
, 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2083 of October 5
th
, 2010.
The Articles of Association have been amended for the last time by deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER
notary residing in Luxembourg on March 7, 2012 published in the Memorial C number 2333 on September 19, 2012
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the General meeting and requests the undersigned notary to take
act of its following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the number of meetings of the Board of Managers to be held each year from
six (6) to four (4) at least.
The Sole Shareholder decides to amend subsequently the article 8.3 (i) as follows:
"The Board meets upon the request of any one "A" Manager and any one "B" Manager and, unless the "A" Managers
agree otherwise, at least four (4) Board meetings shall be held in each calendar year at the Company's registered office
(or, subject to Article 8.3(i), such other venue as is agreed by at least one "A" Manager and one "B" Manager)."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at nine hundred Euros
(EUR 900.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document. The document having been read to the proxy-holder, she signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le trente septembre
Par devant Nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
138235
L
U X E M B O U R G
«Super-Max Malta Limited», une société, constituée et régie selon les lois de Malte, ayant son siège social à 60 Tigne
Towers, Tigne Street, Sliema SLM 3172, Malte, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Malte sous le numéro C
51177 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Madame Anita MAKARUKU, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé, lui-délivrée,
Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le Notaire soussigné, sera enregistrée avec
le présent acte.
L'Associé Unique prie le notaire d'acter que:
I. Elle est l'Associé Unique de la société «SUPER-MAX LUXEMBOURG S.à r.l.», société à responsabilité limitée ayant
son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, avec un capital social
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section
B sous le numéro 154.969, constituée suivant acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg,
en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 août 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2083 du 5 octobre 2010.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 7 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2333 du 19 septembre 2012.
II. L'associé unique exerçant les pouvoir dévolus à l'assemblée générale a requis le notaire soussigné de prendre acte
des résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de modifier le nombre minimal de réunions du Conseil de Gérance par an pour le porter de
six (6) à quatre (4).
L'associé unique décide en conséquence de modifier l'article 8.3 (i) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«(i) Le Conseil se réunit sur demande d'un Gérant «A» et d'un Gérant «B» et, à moins que les Gérants «A» n'en
conviennent autrement, au moins quatre (4) réunions du Conseil seront tenues dans chaque année civile au siège social
de la Société (ou, sous réserve de l'article 8.3 (i), dans tout autre lieu convenu par au moins un Gérant «A» et un Gérant
«B»).»
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, coûts, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa
charge en raison du présent acte sont estimés à environ neuf cents euros (EUR 900,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le ou le comparant a requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi entre parties.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an mentionnés en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. MAKARUKU, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 2 octobre 2013. Relation: LAC/2013/44681. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2013142442/89.
(130173596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Sagittaire Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 160.751.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2013i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1
er
octobre 2013 que:
- Suite à la démission de Madame Audrey Martini de sa fonction d'Administrateur, est nommé, la société DMS Mana-
gement Services (Luxembourg) S.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B165956, ayant son siège social au 43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et ce, avec effet immédiat et jusqu'à
la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
138236
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 08/10/2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013142449/17.
(130173438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Saposa S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 1.012.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 148.521.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013142452/12.
(130172961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SB Partners SIF SICAV S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 167.693.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SB Partners SIF SICAV S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013142453/12.
(130173024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Summit Partners PWS, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 37.601,80.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 177.959.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 19 septembre 2013i>
Mme Robin Devereux demeurant professionnellement au 222 Berkeley Street, MA 02116 Boston, Etats-Unis d'Amé-
rique a été nommée gérante de classe A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013142441/13.
(130173749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SB Partners SIF SICAV S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 167.693.
<i>Extrait du Procès–Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 28 juin 2013i>
<i>Septième résolution:i>
L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de réduire, de 6 à 1 an, la durée du mandat du Réviseur d’Entreprises.
Par conséquent, il est décidé de ne pas renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers et de nommer en lieu et place
Grant Thornton Lux Audit S.A. 89A Pafebruch, L-8308 Capellen immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés
138237
L
U X E M B O U R G
de Luxembourg sous la section B et le numéro 43.298 jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se
tiendra en 2014 pour approuver les comptes de la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SB Partners SIF SICAV S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013142454/18.
(130173050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Super-Max Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.969.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°67416 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013142443/10.
(130173676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
SAACEL, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 105.119.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013142447/9.
(130173220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Brevan Howard Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 144.263.
Au 27 août 2013 l'adresse professionnelle de Madame Tracey McDermott et Monsieur Justin Egan, Administrateurs
de la Société, a changé.
A compter de ce jour Madame Tracey McDermott et Monsieur Justin Egan sont domiciliés à l'adresse ci-dessous
mentionnée:
European Bank & Business Center, Bâtiment B, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 octobre 2013.
BREVAN HOWARD INVESTMENT FUND
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2013142664/17.
(130174068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Besins Healthcare Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 150.711.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale de l'associée unique en date du 17 juillet 2013i>
1. M. Xavier DANDOY, administrateur de sociétés, né à Ottignies (Belgique), le 7 juin 1979, avec adresse au 25,
Chemin des Glaneurs, B-1325 Chaumont Gistoux (Belgique), a été nommé comme gérant de catégorie B pour une période
indéterminée.
2. Le nombre des gérants a été augmenté de 3 (trois) à 4 (quatre).
138238
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG SARL
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013142655/16.
(130174106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Bene Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 128.561.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 octobre 2013.i>
<i>Résolution:i>
L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de transférer le siège social de la Société du 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
L'Assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, le mandat des administrateurs Mme Hélène Mercier et M.
Vincent Thill.
L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
administrateur;
- Madame Audrey Petrini, employée privée, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
administrateur;
- Monsieur Denis Callonego, employé privé, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
administrateur.
Les mandats des nouveaux administrateurs auront échéance jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exer-
cice 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BENE INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2013142651/26.
(130173956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
BR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.525,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 112.133.
<i>Rectificatif concernant le dépôt n°L130132957 du 31/07/2013i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013142662/12.
(130174077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Baco Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4121 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Fondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 81.191.
Il résulte de deux contrats de cessions de parts sociales (du 13 septembre 2013 de la société à responsabilité limitée
BACO S.à r.l., société de droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 81.191) que Madame Anne WEBER, née le 6 juin 1950 à Schaerbeek (Belgique) et demeurant à L-4121 Esch-
sur-AIzette, 2 rue des Fondeurs, a cédé:
138239
L
U X E M B O U R G
- à Monsieur Yves FOUARGE, né le 9 janvier 1947 à Ixelles (Belgique) et demeurant à F-94440 Marolles-en-Brie, 16
rue des Maraîchers, 35 parts sociales de la société BACO S.à r.l.;
- à TEAM CONSULT, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B97.716 et sise au 24, rue de la Forêt Verte à L-7340 Heisdorf, 15 parts
sociales de la société BACO S.à r.l..
Après les cessions, ci-avant décrites, le capital social de la société BACO S.à r.l. se trouve réparti comme suit:
Monsieur Yves FOUARGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 parts
TEAM CONSULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Pour avis sincère et conforme
Bernard BOSQUEE
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013142644/24.
(130174155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
Nordstad Fashion S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 150.314.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013143685/9.
(130175292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Opportunity Properties Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 113.360.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
Il résulte d'une résolution de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 28 juin 2013 de renouveler le mandat
de l'administrateur de la Société, Monsieur Franck Ruimy, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels
au 31 décembre 2012.
Pour votre information, veuillez noter que Monsieur Franck Ruimy réside désormais professionnellement au 49,
Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Royaume Uni.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
It follows from a resolution of the sole shareholder of the Company dated 28 June 2013 that Mr Franck Ruimy, has
been renewed in its mandate as director of the Company until the general meeting approving the annual accounts as of
31 December 2012.
For your information, please note that Mr Franck Ruimy now resides professionally at 49, Grosvenor Street, W1K
3HP London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013143688/21.
(130175363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
138240
Baco Sàrl
Bene Investments S.A.
Besins Healthcare Luxembourg S.à r.l.
Brevan Howard Investment Fund
BR Luxembourg S.à r.l.
CABRELUX
Cadogan Investments, S.A.
Café des Bons Amis de Gomes S.à r.l.
Calendar Properties S.à r.l.
Calyx Immobilière S.A.
Canna Luxembourg S.à r.l.
Capelle International S.A.
CapitalatWork Management Company S.A.
Carlo Schmitz Sàrl
Cashnote Lux S.à r.l.
CCP II Berlin S.à r.l.
Cellgate S.à r.l.
CEPF Weisseritz S.à r.l.
CFT Bourmicht S.A.
CGP Investments S.à r.l.
Chartreuse et Mont Blanc GP S.à r.l.
Chasselas Finance S.A.
CN Batiment Sàrl
Compass Re S.A.
Connector Group S.à r.l.
Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS
Cross Falls Holding SPF S.A.
Cross Falls Holding SPF S.A.
Custom Auto Craft S.à r.l.
Dalkia S.A.
Damode-MG S.A., SPF
Dansor S.à r.l.
David Brown Systems (Holdings) S.à r.l.
D.B. International Finance S.A.
DDI A.G.
Delphina Ventures S.A.
Deluco
DHC Luxembourg IV S. à r.l.
Diajewel Finance S.A.
Distress to Value S.A. -Société de Titrisation
Distribution S.à r.l.
Dorel Hungary Kft., Luxembourg Branch
Dune Investment S.A.
M&G Chemicals
Nordstad Fashion S. à r.l.
Opportunity Properties Holding Luxembourg S.A.
SAACEL
Sagittaire Finance S.A.
Saposa S.à r.l.
SB Partners SIF SICAV S.A.
SB Partners SIF SICAV S.A.
Sciamani S.A.
SCOP Poland S.àr.l.
SCOR ILS FUND S.A., SICAV-SIF
Son Group S.A.
Sopura Eastern Europe A.G.
SSCP PADS PV S.C.A.
SSCP Security Holding SCA
St-Lux S.à r.l.
Summit Partners PWS
Super-Max Luxembourg S.à r.l.
Super-Max Luxembourg S.à r.l.