logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2801

8 novembre 2013

SOMMAIRE

Accon Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134446

ADB Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

134402

Algeco/Scotsman Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

134404

Alianza Iberian Private Equity (Luxem-

bourg-Six) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134410

Alianza Iberian Private Equity (Luxem-

bourg-Six) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134404

Allact S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134410

Alphacore International S.A.  . . . . . . . . . . . .

134412

Altura S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134406

Aqualan Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134411

Aqua-Rend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134412

Aqua-Rend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134406

Art et Beauté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134411

Arthel CO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134402

Astur Trading & Consulting S.à r.l.  . . . . . .

134444

Au Fil du Bois S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134411

Avvens Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

134416

BAUERE KOPERATIV, Société Coopéra-

tive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134414

BC Bowling S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134409

Beaugency Asset Management S.A. . . . . . .

134411

Bouquet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134409

BRE/Embassy Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

134413

BRE/Embassy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134413

BRE/Europe 5NQ S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

134413

BRE/Europe 5Q S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

134413

BRE/Everbright M6 Canada S.à r.l. . . . . . . .

134413

BRE/Insite Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

134413

BRE/Japan III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134415

BRE/Japan II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134416

BRE/Japan I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134414

BRE/Sakura I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134448

Broadband Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

134448

Car Classifieds Asia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

134417

CECEP Solar Energy (Luxembourg) Priva-

te Limited Company (S.à r.l.)  . . . . . . . . . .

134410

Cencan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134409

Centre Chretien-Social du Sud  . . . . . . . . . .

134408

Cidoval S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134408

Classifieds (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134427

Clemalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134416

Cofilux Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134412

Cold Waters Investments S.A.  . . . . . . . . . .

134406

ColorPortal Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

134408

Compagnie Financière de l'Union Euro-

péenne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134407

Concepta Senium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134408

Croisic Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134411

De Beers Holdings Luxembourg  . . . . . . . . .

134438

D & H Design Carrelage S. à r.l.  . . . . . . . . .

134448

Eberling Tennis Academie  . . . . . . . . . . . . . .

134405

Efficient Global Solution S.A. . . . . . . . . . . . .

134442

Elettra Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

134415

Engine Control Upgrade Software S.A.  . .

134442

Eurothea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134403

IGBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134440

Parkridge CER S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134448

Parque Principado S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

134402

Royal-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134404

Safrec S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134409

SOGETI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

134405

Spelec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134414

StayInvest GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134447

T & C International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

134415

The Before S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134403

Togo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134416

Trasys Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134407

Triumph Group Luxembourg Finance Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134407

134401

L

U X E M B O U R G

Parque Principado S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 180.448.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire des associés de la Société tenue le 27 septembre 2013 a décidé d'élire, avec effet à la

date de l'assemblé générale ordinaire des associés de la Société, Michael Edward Boundy, demeurant professionnellement
au 40 Broadway, Londres SW1H 0BT, Royaume Uni, et Martin Hubert, demeurant professionnellement au 2-4 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérants de la Société, pour un mandat de duré
indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé de cinq gérants comme il suit:
- Paul Lawrence;
- Michel Thill:
- David Andrew Fischel;
- Michael Edward Boundy; et
- Martin Hubert.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Parque Principado S.à r.l.

Référence de publication: 2013137546/22.
(130167425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Arthel CO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 108.267.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 30 juillet 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, après

avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Lex EIPPERS en son rapport oral et sur les conclusions écrites du Ministère
Public, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de

la société à responsabilité limitée ARTHEL CO s. à r.l., ayant eu son siège social à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 108 267, liquidation judiciaire prononcée par jugement
du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch en date du 24 juillet 2007.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur et a laissé les frais à charge de l'Etat.

Pour extrait conforme
Maître Daniel BAULISCH
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour
9, rue de l'Eau
L-9225 DIEKIRCH

Référence de publication: 2013137695/20.
(130167787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

ADB Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 176.823.

Les statuts coordonnés au 11 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013137731/12.
(130168386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134402

L

U X E M B O U R G

The Before S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 21, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 113.024.

<i>Procès verbal de l' assemblée générale extraordinaire de la société The Before S.à r.l., tenu au siège le 19 Août 2013

Il résulte de la liste de présence que les associés:
Monsieur SYNEGHEL Gilles, 5 rue du Moulin F-54470 PANNES
Monsieur HAMMADOU Xavier, 272 rue Gabriel Leroy F-54200 ECROUVES
Madame HAMMADOU Carine, 46 rue du Mi Foch F-54590 HUSSIGNY
Madame ZVEGUINZOVA Tatiana, 42 rue Paul Langevin F-54880 THILL
Mademoiselle RACH Audrey, 40 rue Jean d'Alembert F-54400 VILLERUPT
Sont présents et représentent l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire ont

pris les décisions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution

Madame ZVEGUINZOVA Tatiana cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire qui

accepte la pleine propriété les (15) parts sociales d'une valeur nominale de (100,00) euros chacune de la société à res-
ponsabilité limitée THE BEFORE SARL, avec siège social à L-3590 DUDELANGE 21 Place de l' Hôtel de Ville, société
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Aloyse BIEL de résidence à Esch sur Alzette en date du 12 décembre
2005 à Mademoiselle RACH Audrey, née le 18/01/1982 et demeurant au 40 rue Jean d'Alembert F-54400 VILLERUPT
pour l'euro symbolique.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statuaire ou autre

ne peut faire obstacle à la présente cession.

Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution

Madame COELHO FIGUEIRA PEDRO Maria Joao, née le 14/12/1976 et demeurant au 39 rue des Prés L-3671 KAYL

est nommée gérante technique en remplacement de Madame ZVEGUINZOVA Tatiana, démissionnaire.

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et de la gérante

administrative.

Signatures.

Référence de publication: 2013137711/33.
(130167923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Eurothea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 64.273.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le

<i>20 juin 2013 à 10.00 heures

Reconduction des mandats de Messieurs Henri Chibret, Jean-Frédéric Chibret, Reinald Loutsch et Mesdames Elise

Lethuilllier, en tant qu'Administrateurs.

Nomination de Madame Catherine Roux-Sevelle, née le 28 juillet 1960 à Paris et demeurant au 16, boulevard Emmanuel

Servais L-2535 Luxembourg.

Reconduction du mandat de H.R.T. Révision S.A. en tant que Commissaire aux Comptes, demeurant professionnel-

lement au 163 Rue du Kiem L-8030 Strassen et inscrit au RCS Luxembourg sous le numéro B51238, pour une durée de
six ans. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2013137702/21.
(130167684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

134403

L

U X E M B O U R G

Algeco/Scotsman Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.781.301,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.028.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des associés du 1 

<i>er

<i> octobre 2013

Les associés de la Société ont décidé comme suit:
- de nommer:
* Monsieur Mark BARTLETT, né le 28 août 1950 à Cumberland, Maryland, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 2638

Bulrush Lane, Naples, FL 34105, Etats-Unis d'Amérique en qualité de Gérant non exécutif de classe A de la Société et ce
avec effet au 1 

er

 octobre 2013 et pour une durée de 3 ans.

* Madame Martha BROOKS, née le 5 juin 1959 au Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 1775 South Ponce

de Leon Ave NE, GA 3030 Atlanta, Etats-Unis d'Amérique en qualité de Gérant non exécutif de classe A de la Société
et ce avec effet au 1 

er

 octobre 2013 et pour une durée de 3 ans.

* Monsieur Julian SEAWARD, né le 13 février 1956 à Plymouth, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au One

Stanhope Gate, W1K 1AF Londres, Royaume-Uni en qualité de Gérant de classe A de la Société et ce avec effet au 1

er

 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

Jean-Michel Clinquart
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013137718/23.
(130167869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Six) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 151.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013137740/11.
(130168366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Royal-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf.

R.C.S. Luxembourg B 97.083.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Jean-Claude WIRTH en son rapport oral et sur les conclusions écrites
du Ministère Public, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de

la société anonyme ROYAL-LUX S.A., ayant eu son siège social à L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 97083, liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal
d'Arrondissement de et à Diekirch en date du 13 janvier 2010.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur et a laissé les frais à charge de l'Etat.

Pour extrait conforme
Maître Daniel BAULISCH
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour
9, rue de l'Eau
L-9225 DIEKIRCH

Référence de publication: 2013137709/20.
(130167792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

134404

L

U X E M B O U R G

ETA, Eberling Tennis Academie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-7358 Lorentzweiler, 5, rue Jean-Pierre Glaesener.

R.C.S. Luxembourg B 180.450.

<i>Auszug aus den Statuten

Gesellschaftsbezeichnung: Eberling Tennis Academie ETA
Gesellschaftsform: Kommanditgesellschaft (Societe en commandite simple -SECS) KG
Gesellschaftszeck: Erteilung vom Tennisunterricht, Betreuung der Spieler, Durchführung der Sport Camps, Spielen der

Turniere

Gesellschaftssitz: L-7358 LORENTZWEILER 5, RUE Jean-Pierre Glaessener
Gründungsdatum: 20. September 2013
Dauer der Gesellschaft: Die Gesellschaft wird auf eine unbestimmte Zeit ab dem Tag seiner Entstehung gegründet.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am
einunddreißigsten  Dezember  jedes  Jahres.  Das  erste  Geschäftsjahr  beginnt  an  dem  Gründungstag  endet  am

einunddreißigsten Dezember 2013

Unbegrenzt haftende: Komplementärin Diana Eberling (43, Hauptstrasse, d-53578, Windhagen)
Solidarisch haftender: Kommanditist Mark Eberling (43, Hauptstrasse, d-53578, Windhagen)
Geschäftsführung: Diana Eberling. Sie haftet unbegrenzt und
solidarisch für sämtliche Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber:
den Gläubigern der Gesellschaft in Höhe des Gesellschaftsvermögens, zu welchem
das Privatvermögen der Gesellschafter hinzu gezählt wird;
den Steuerbehörden, wenn die Steuerschuld sich aus den Tätigkeiten des
Unternehmens ergibt (MwSt, kommunale Gewerbesteuer);
den anderen Gesellschaftern als solidarische Mitschuldner
Haftung gegenüber Dritten, Zinsen und Dividenden zu erstatten, wenn sie nicht von tatsächlichen Gewinnen, sondern

vom Gesellschaftskapital entnommen werden.

Lorentzweiler, den 20.09.2013.

Mark Eberling / Diana Eberling
<i>Komplementärin / Komanditist

Référence de publication: 2013137699/32.
(130167394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

SOGETI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.981.758,79.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 42.610.

Il résulte des décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 avril 2013 que:
Les actionnaires ont pris acte des démissions de MM Nicolas Dufourcq et Christian Gleyo de leurs mandats d'admi-

nistrateurs, et pour Monsieur Gleyo de son mandat d'administrateur délégué, à compter respectivement du 30 novembre
2012 et 31 décembre 2012 et décident à l'unanimité de nommer en remplacement et rétroactivement au 1 

er

 janvier

2013, pour un mandat qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014 (approbation des comptes
clos au 31/12/2013):

- Alain de Marcellus (nom complet de Martin du Tyrac de Marcellus), Administrateur, né le 28 octobre 1955 à Rennes

(France) et élisant domicile pour les besoins de son mandat, au siège social de la société;

- Hans van Waaijenburg, Administrateur, né le 25 décembre 1956 à Eindhoven (Pays-Bas) et élisant domicile pour les

besoins de son mandat, au siège social de la société.

Paris, le 22 avril 2013.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Hans van Waaijenburg

Référence de publication: 2013137710/22.
(130167530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

134405

L

U X E M B O U R G

Cold Waters Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 100.344.

En date du 20 septembre 2013 il a été convenu ce qui suit:
La démission de Mme Andrea Thielenhaus, administrateur de la société COLD WATERS INVESTMENTS S.A. est

acceptée, avec effet immédiat.

La démission de la société INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., administrateur de la société COLD WATERS IN-

VESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

La démission de M. Christoph Neilinger, administrateur de la société COLD WATERS INVESTMENTS S.A. est ac-

ceptée, avec effet immédiat.

La démission de la société AUTONOME DE REVISION. E955, commissaire aux comptes de la société COLD WATERS

INVESTMENTS S.A. est acceptée, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE TREVES S.C.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2013137696/20.
(130167340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Altura S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 177.834.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé de nommer comme gérants de catégorie A (i) M. Tomasz Blicharski, né le 28

août 1981 à Jedrzejow (Pologne), ayant son adresse professionnelle à Warsaw Financial Center, 29 

th

 Floor Ul. Emilii

Plater, 53 00-113 Varsovie, Pologne et (ii) Mme. Dominika Kozlowska, née le 07 juillet 1979 in Piaseczno (Pologne) ayant
son adresse professionnelle à Warsaw Financial Center, 29 

th

 Floor Ul. Emilii Plater, 53 00-113 Varsovie, Pologne.

Suite à ces nominations et à l'utilisation de catégories de gérants au sein de la Société, l'associé unique a décidé que

M. Matthijs Bogers and M. Julien François seraient des gérants de catégorie B.

Le tout avec effet en date du 30 septembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

<i>Pour Altura S.à r.l.

Référence de publication: 2013137722/19.
(130168017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Aqua-Rend, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 26.567.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

<i>Pour AQUA-REND
Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Fondé de pouvoir / -

Référence de publication: 2013137752/15.
(130168334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134406

L

U X E M B O U R G

Trasys Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 121.073.

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

Comme suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRASYS Luxembourg PSF S.A. tenue le 29

août 2011 et la réalisation de l'Apport d'une Branche d'Activités relative à l'apport de l'établissement stable luxembour-
geois de TRASYS S.A. dénommée TRASYS LUXEMBOURG, par TRASYS S.A. à TRASYS Luxembourg PSF S.A., le conseil
d'administration de la société anonyme de droit belge TRASYS SA., sise 7 avenue Ariane B-1200 BRUXELLES, a pris la
résolution de procéder à la fermeture de la succursale TRASYS LUXEMBOURG, conformément au point H «fermeture
de  l'Etablissement  Stable»  du  projet  déposé  le  13  juillet  2011  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
LUXEMBOURG sous la référence de publication 2011098127/312.

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

<i>Pour TRASYS LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2013137666/18.
(130167713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Triumph Group Luxembourg Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 180.409.

1. Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société datées du 23 septembre 2013 que la Société a enregistré

la démission de Mr. Jeffry Douglas Frisby du poste de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat en date du
22 septembre 2013 à minuit.

2. L'associé unique de la Société a décidé de nommer Mme Shella Gin Spagnolo, née le 6 août 1953 à Pennsylvanie,

États-Unis  d'Amérique,  résidant  professionnellement  à  899  Cassatt  Road,  Suite  210,  Berwyn,  PA  19312,  États-Unis
d'Amérique, gérant de catégorie A de la Société en date du 23 septembre 2013 et pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Mme Shella G. Spagnolo, gérant de classe A;
- Mr. Moshe David Kornblatt, gérant de classe A;
- Mr. Daniel Boone, gérant de classe B; et
- Mr. Christophe Laguerre, gérant de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137656/21.
(130167287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Compagnie Financière de l'Union Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 51.317.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01.10.2013.

<i>Pour: COMPAGNIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013137825/15.
(130167915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134407

L

U X E M B O U R G

Cidoval S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.425,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 175.673.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que, en date du 9 août 2013, tous les Associés de la société Cidoval S.à

r.l. ont cédé leurs parts sociales qu'ils détenaient à Pan European Ventures S.A.ayant son siège social au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le nouvel actionnariat s'établit donc comme suit:
- La société Pan European Ventures S.A. détient 2 375 000 parts sociales dans Cidoval S.à r.l.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013137799/15.
(130168028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Concepta Senium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 60.926.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013137826/10.
(130167802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Centre Chretien-Social du Sud, Société Coopérative.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 7.236.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

Référence de publication: 2013137798/10.
(130167993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

ColorPortal Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8366 Hagen, 35, rue Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 143.978.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 février 2013

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2017:

Monsieur Nicolas SPIETTE, administrateur délégué, demeurant à L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare
- Madame Anila BUSHI-BOUYER, administrateur, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal
- Monsieur Anton BATURIN, administrateur, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, Boulevard Royal
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2017:

- BDO Tax &amp; Accounting, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Luxembourg B 147571

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013137803/19.
(130168398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134408

L

U X E M B O U R G

Safrec S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 61.593.

EXTRAIT

Suite aux démissions de la société ANDREAS CAPITAL SUXESKEY S.A. (anc. "Suxeskey"), de Mme GOKKE Raymonde

et de Mr SEEN Albert, administrateurs, et de Mr NELLINGER Gerhard en tant que commissaire le 31/12/2012, il résulte
de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Larochette le 23 septembre 2013 que les personnes sui-
vantes ont été élues jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2015:

<i>Administrateurs:

- ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, société de droit luxembourgeoise, ayant son siège social à 10-12, rue

de Medernach, L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013;

- Monsieur SCHREUDERS Bastiaan Lodewijk Melchior, ayant son siège professionnel à 10-12, rue de Medernach,

L-7619 Larochette avec effet à partir du 20/12/2012;

- Monsieur ROTTEVEEL Joseph, demeurant professionnellement à 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette avec

effet à partir du 01/07/2013.

<i>Commissaire:

- ANDREAS AUDIT SERVICES, société de droit luxembourgeoise ayant son siège social à 10-12, rue de Medernach,

L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013

Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée

désigne  Monsieur  SCHREUDERS  Bastiaan  Lodewijk  Melchior,  10-12,  rue  de  Medernach,  L-7619  Larochette,  comme
représentant permanent de la société ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, inscrite au RCSL sous le numéro
B-179712.

En outre, l'Assemblée décide de rayer la fonction d'administrateur-délégué de ANDREAS CAPITAL SUXESKEY S.A.

(anc. "Suxeskey") et de Mr SEEN Albert avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137617/30.
(130167342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

BC Bowling S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Bouquet S.à r.l.).

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 53.208.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 1 

er

 octobre 2013.

Référence de publication: 2013137773/11.
(130168257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Cencan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 23.451.

Veuillez noter le changement d'adresse des administrateurs suivants:
Mr Bruce Alan Cleaver, avec adresse professionnelle au 17, Charterhouse Street, EC1N 6RA, Londres, Royaume-Uni
Mr Eric Caverhill, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
Mr Bernard Olivier, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137814/13.
(130168045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134409

L

U X E M B O U R G

Allact S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7430 Fischbach, 7, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.156.

<i>Assemblée générale extraordinaire en date du 17 août 2013

Les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont

pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Démission de l'administrateur Mr Vanstraelen.
2. Démission du Commissaire aux Comptes Mr De Ryck.
3. Nomination d'un nouveau administrateur, dont mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale tenue en 2019:
- Mr DE RYCK Guy, Cité de l'Usine 1, L-8450 Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg, né à Leuven, Belgique le 24

février 1958.

4. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes:
- Mr VANSTRAELEN Johny, Nieuwe Heidestraat 27, B-3500 Hasselt, Belgique, né à Hasselt, Belgique, le 28 janvier

1966.

5. Divers et remarques éventuelles: Néant

Dont acte, fait et passé à Luxembourg le 17 août 2013

Signatures.

Référence de publication: 2013137742/21.
(130168389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Six) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 151.238.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2013

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 septembre 2013 que:
- Suite à la démission de Monsieur Renaud Rivain de sa fonction d'Administrateur, est nommé, la société DMS Mana-

gement Services (Luxembourg) S.à r.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B165956, ayant son siège social au 43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et ce, avec effet immédiat et jusqu'à
la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02/10/2013.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013137741/17.
(130168367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 156.036.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 12 septembre 2013

1. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Mme Fanny AUENALLAH, administrateur de sociétés, née à Mers-el-Kebir (Algérie), le 16 décembre 1974, de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme
gérante de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

<i>Pour extrait sincère et conforme
Pour CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.)
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137812/16.
(130167766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134410

L

U X E M B O U R G

Croisic Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 165.840.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 12 juillet 2013

1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
2. Mme Virginie DECONINCK, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 11 octobre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
de classe A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Croisic SARL
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137804/16.
(130167927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Aqualan Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137754/9.
(130167956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Art et Beauté, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 137, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 140.783.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013137756/10.
(130168480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Au Fil du Bois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8212 Mamer, 7, rue de Bärendall.

R.C.S. Luxembourg B 171.649.

Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013137759/10.
(130168484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Beaugency Asset Management S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 45.317.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137774/9.
(130168416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134411

L

U X E M B O U R G

Alphacore International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 38.477.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les

informations inscrites auprès de celui-ci:

- que le siège social de la société Nationwide Management Services S.A., Administrateur, a été transféré avec effet au

16 décembre 2012 du 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage, L-1660 Luxembourg, au 12D, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

- que le siège social de la société Tyndall Management Services S.A., Administrateur, a été transféré avec effet au 16

décembre 2012 du 60, Grand-Rue, 1 

er

 étage, L-1660 Luxembourg, au 12D, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

- que l'adresse professionnelle de Madame Rika Mamdy, née le 4 novembre 1946, à Diksmuide, Belgique, représentant

permanent de Alpmann Holdings Limited, Nationwide Management Services S.A. et Tyndall Management Services S.A.,
est 12D, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

<i>Pour ALPHACORE INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2013137745/18.
(130167838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Aqua-Rend, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 26.567.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 3 juillet 2013

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Eric Nols et Vincent Planche ainsi que Madame Angélique Mandervelt, en qualité d'administra-

teurs, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,

2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour le terme d'un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

<i>Pour AQUA-REND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Valérie GLANE / Corinne ALEXANDRE
<i>Fondé de pouvoir / -

Référence de publication: 2013137753/19.
(130168341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Cofilux Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 172.342.

EXTRAIT

Suivant décision de l'actionnaire en date du 12 septembre 2013, deux administrateurs supplémentaires sont nommés,

à savoir:

- Madame Martine Bruwier, née à Verviers/Belgique, le 08.07.1970 et domiciliée professionnellement au 1, rue Bender,

L-1229 Luxembourg et

- Monsieur Benoît Compère, né à Liège/Belgique, le 15.07.1970 et domicilié professionnellement au 1, rue Bender,

L-1229 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2017.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013137824/17.
(130168013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134412

L

U X E M B O U R G

BRE/Embassy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.323.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137779/9.
(130167831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

BRE/Embassy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.577.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137780/9.
(130167830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

BRE/Europe 5NQ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.118.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137781/9.
(130167828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

BRE/Europe 5Q S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.602.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137782/9.
(130168142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

BRE/Everbright M6 Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 171.203.

Les comptes annuels au 31/12/2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137783/9.
(130168494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

BRE/Insite Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 140.836.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137784/9.
(130167832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134413

L

U X E M B O U R G

BRE/Japan I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.643.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137785/9.
(130167829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Spelec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal.

R.C.S. Luxembourg B 152.738.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés

<i>de la société Spelec S.à r.l. tenue au siège de la société en date du 9 septembre 2013

Tous les associés sont présents.
Les associés confirment:
- la cession de 50 parts sociales de Monsieur Christophe de FIERLANT DORMER, né le 19 juin 1970 à Uccle (Belgique)

et demeurant 21, Champ d'Al Vau à B-1380 OHAIN à Monsieur Christian VENTISETTE, né le 15 octobre 1962 à Bastia
(France) et demeurant 14, rue Bernard Haal à L-1711 LUXEMBOURG,

- acceptent la démission de Monsieur Christophe de FIERLANT DORMER de sa fonction de Gérant de la société

SPELEC SARL,

- acceptent la nomination de Monsieur Christian VENTISETTE à la fonction de Gérant de la société SPELEC SARL.
Les décisions ont été prises à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Signé en nom de SPELEC SARL
Christian VENTISETTE
<i>Gérant

Référence de publication: 2013137639/22.
(130167489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

BAUERE KOPERATIV, Société Coopérative, Société Coopérative.

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 95.424.

<i>Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Präsidenten
Herr Robert Feyder, Präsident der Bauere Koperativ, begrüßte alle Anwesenden zur zweiten diesjährigen General-

versammlung. Wie bereits im Vorfeld angekündigt ist der Zweck dieser Zusatzsitzung jene Punkte abzuhandeln, welche
wegen einer unzureichender Mitgliederpräsens in der Versammlung vom 21. März, nicht beschlossen werden konnten.

2. Statutenanpassungen
Im Hinblick auf die Ausweitung des Geschäftsfeldes der BAKO innerhalb der neuen Produktionsstätte in Hosingen ist

eine Anpassung der Statuten erforderlich. In dem Zusammenhang bietet sich die Möglichkeit einige weitere Punkte an die
aktuellen Erfordernisse anzupassen. Geschäftsführer der Bauere Koperativ, Herr Günter Mertes, verliest und erklärt im
Einzelnen die entsprechenden Textänderungen:

Art. 2. Zusatz: „Die Generalversammlung kann den Firmensitz innerhalb Luxemburgs verlegen mit einfacher Stim-

menmehrheit."

Art. 4.  Abänderung:  „Gegenstand  der  Genossenschaft  ist  der  An-  und  Verkauf  von  Produktionsmitteln,  landwirt-

schaftlichen Produkten und anderen Bedarfsgütern sowie die Produktion von Kraftfutter und Beratung ihrer Mitlieder
und Kunden."

Art. 6. Zusatz: „Die Mitgliedschaft endet: durch Nichtzahlung des Jahresbeitrages in zwei aufeinanderfolgenden Jahren."

Art. 11. Abänderung „20.000 LUF" auf „500€"

Art.16. Zusatz: „10. Die Verlegung des Geschäftssitzes"

134414

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Abänderung: „Die Mitgliedschaft im Vorstand ist begrenzt auf die Vollendung des 70. Lebensjahres"

Art. 30. Abänderung: „Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist begrenzt auf die Vollendung des 70. Lebensjahres"

Art. 34. Zusatz: „Stand des Gesellschaftskapital zum 31. Dezember 1996:1.699.500,- LUF."

Art. 35. Abänderung: „2.000LUF" auf „ 50€"
Den anwesenden Mitgliedern werden sämtliche Textanpassungen erläutert. Nach Rückfrage von Präsident FEYDER

Robert bestehen keine Einwände seitens der Anwesenden hinsichtlich der Statutenanpassungen, welche somit einstimmig
als gut und genehmigt befunden werden.

Référence de publication: 2013137772/32.
(130168158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

T &amp; C International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.183.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 22 août 2013

1. M. Xavier SOULARD a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. M. David GIANNETTI a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Mme Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née à Le Raincy (France), le 24 mai 1972, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
et présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

4. M. Franck BETH, administrateur de sociétés, né à Roubaix (France), le 6 mai 1974, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour T &amp; C INTERNATIONAL S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137649/20.
(130167695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

BRE/Japan III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.022.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137787/9.
(130167826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Elettra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 101.908.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la société en date du 28 juin 2013

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 28 juin 2013 que le siège social de

la Société a été transféré de son adresse actuelle, étant le 25 A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 15, rue du Fort
Bourbon, L-1249 Luxembourg avec effet au 30 septembre 2013.

Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Elettra Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013137864/16.
(130168374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134415

L

U X E M B O U R G

Avvens Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.876.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137761/10.
(130167784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Togo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 134.441.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire tenue extraordinairement en date du 19 septembre

<i>2013

1. Le siège de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1610

Luxembourg, 42-44, avenue de la gare.

2. Monsieur Hans DE GRAAF a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'adminis-

tration.

3. Madame Monique JUNCKER a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. Madame Valérie PECHON a démissionné de son mandat d'administrateur.
5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Togo S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013137653/20.
(130167716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

BRE/Japan II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.363.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137786/9.
(130167827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Clemalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.310.

Par résolutions écrites en date du 10 septembre 2013 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Alexandre Prost-Gargoz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg de son mandat de Gérant, avec effet au 31 mars 2013.

2. Nomination de Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137822/15.
(130168238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

134416

L

U X E M B O U R G

Car Classifieds Asia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 180.458.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of September,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register, under number B 177.038,

here represented by Mrs Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 6 September 2013, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 September 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Car Classifieds Asia S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

134417

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

134418

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, Removal and Term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

134419

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

134420

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Asia Internet Holding S.à r.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; and

- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

134421

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausenddreizehn, am sechzehnten September.
Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.038,

hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt

in Berlin, Deutschland, am 6. September 2013, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 5. September 2013.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Car Classifieds Asia S.à r.l. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art..

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

134422

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung  ist  nicht  erforderlich,  wenn  die  Anteile  Eltern,  Nachkommen  oder  dem/der  überlebenden  Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

134423

L

U X E M B O U R G

10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-

schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats  ist  nicht  erforderlich,  wenn  Zeit  und  Ort  in  einem  vorausgehenden  Beschluss  des  Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

134424

L

U X E M B O U R G

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres  Kommunikationsmittel  abgehalten  werden,  welches  es  allen  Teilnehmern  ermöglicht,  einander  durchgängig  zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist  gleichbedeutend  mit  einer  persönlichen  Teilnahme  an  einer  solchen  Sitzung  und  die  Sitzung  wird  als  am  Sitz  der
Gesellschaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer  der  Kategorie  B),  werden  Beschlüsse  des  Geschäftsführungsrats  nur  dann  wirksam  gefasst,  wenn  sie  von  der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungs-
rates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unter-

schrift  des  Einzelgeschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere  Geschäftsführer  hat,  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

134425

L

U X E M B O U R G

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung  stehen.  Der  ausschüttbare  Betrag  darf  nicht  die  Summe  der  seit  dem  Ende  des  vergangenen  Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember

2013.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Asia Internet Holding S.à r.l., vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

134426

L

U X E M B O U R G

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.200,-geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; und

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.

Gezeichnet: K. GAUZES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42902. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 30. September 2013.

Référence de publication: 2013137271/575.

(130167290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Classifieds (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 180.455.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of September,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register, under number B 177.038,

here represented by Mrs Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 6 September 2013, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 September 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

134427

L

U X E M B O U R G

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Classifieds (GP) S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

134428

L

U X E M B O U R G

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, Removal and Term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

134429

L

U X E M B O U R G

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced  manager  by  the  remaining  managers  until the  next meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

134430

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

134431

L

U X E M B O U R G

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Asia Internet Holding S.a r.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; and

- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausenddreizehn, am sechzehnten September,
Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.038,

hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht, ausge-

stellt in Berlin, Deutschland, am 6. September 2013, und, in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 5. September.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

134432

L

U X E M B O U R G

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Classifieds (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art..

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafter/Aktionär für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxembur-

gischen und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

134433

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung  ist  nicht  erforderlich,  wenn  die  Anteile  Eltern,  Nachkommen  oder  dem/der  überlebenden  Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

134434

L

U X E M B O U R G

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-

schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats  ist  nicht  erforderlich,  wenn  Zeit  und  Ort  in  einem  vorausgehenden  Beschluss  des  Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres  Kommunikationsmittel  abgehalten  werden,  welches  es  allen  Teilnehmern  ermöglicht,  einander  durchgängig  zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist  gleichbedeutend  mit  einer  persönlichen  Teilnahme  an  einer  solchen  Sitzung  und  die  Sitzung  wird  als  am  Sitz  der
Gesellschaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-

134435

L

U X E M B O U R G

führer  der  Kategorie  B),  werden  Beschlüsse  des  Geschäftsführungsrats  nur  dann  wirksam  gefasst,  wenn  sie  von  der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18 Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungs-
rates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unter-

schrift  des  Einzelgeschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere  Geschäftsführer  hat,  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

134436

L

U X E M B O U R G

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und Andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung  stehen.  Der  ausschüttbare  Betrag  darf  nicht  die  Summe  der  seit  dem  Ende  des  vergangenen  Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember

2013.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Asia Internet Holding S.à r.l., vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.200,-geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; und

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:

134437

L

U X E M B O U R G

- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.

Gezeichnet: K. GAUZES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42899. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 30. September 2013.

Référence de publication: 2013137277/579.
(130167284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

De Beers Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 178.777.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth of September before Maître Marc Loesch, notary, residing

in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

De Beers, a société anonyme with registered office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, registered with the

Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 78.985, (hereafter the “Sole Shareholder”),

here represented by Ms. Christelle Friio, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 18 September 2013.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of De Beers Holdings Luxembourg (hereafter the "Company"), a société

à responsabilité limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Lux-
embourg Trade and Companies' Register under section B, number 178.777, incorporated pursuant to a notarial deed
dated 16 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2200 of 9 

th

 September

2013.

The articles of incorporation have not yet been amended.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then requests the undersigned notary to record the following

resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of fifty thousand US

Dollars (USD 50,000.-) so as to raise it from its current amount of one fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) to one
hundred thousand US Dollars (USD 100,000.-) through the issue of fifty thousand (50,000) new shares with a par value
of one US Dollars (USD 1.-).

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared De Beers, a société anonyme, established under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 78.985, (hereafter the “Subscriber”),

represented by Ms. Christelle Friio, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 18 September, which proxy, by the proxyholder and the undersigned

notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The Subscriber declared to subscribe for fifty thousand (50,000) new shares with a nominal value of one US Dollar

(USD 1.-) per share, and to fully pay up in cash the new shares for a total amount of thirty million US Dollars (USD
30,000,000), out of which an amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) is allocated to the share capital of the

134438

L

U X E M B O U R G

Company, and the remaining amount i.e. twenty-nine million nine hundred fifty thousand US Dollars (USD 29,950,000.-)
to the share premium account of the Company.

The amount of thirty million US Dollar (USD 30,000,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the

Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The sole shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the thirty million new shares to

the above mentioned Subscriber.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is amended and

will henceforth read as follows:

"6.1 The Company’s issued capital is set at one hundred thousand dollars of the United States of America (USD

100,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares in registered form with a par value of one dollar of
the United States of America (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).

<i>Whereof

The present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-quatre septembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

De Beers, une société anonyme, avec siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 78.985, (ci-après « l’Associé Unique »),

ici représentée par Madame Christelle Friio, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 septembre 2013.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est le seul et unique associé de De Beers Holdings Luxembourg (ci-après la « Société »), une société

à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 178.777, constituée suivant acte notarié en date
du 16 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 2200 du 9 septembre 2013.

Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte des

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille US dollars (USD 50.000,-) pour

le porter de son montant actuel de cinquante mille US dollars (USD 50.000,-) à cent mille US dollars (USD 100.000,-)
par l’émission de cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’un US dollars (USD 1,-)

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu De Beers, une société anonyme, établie sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 48,

rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro
B 78.985, (ci-après le « Souscripteur »),

ici représentée par Madame Christelle Friio, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18

septembre 2013, ladite procuration, par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire cinquante mille (50.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’un US

dollars (USD 1,-), et les libérer intégralement en espèces, pour un montant total de trente millions d’US dollars (USD
30.000.000,-), dont un montant de cinquante mille US dollars (USD 50.000,-) est affecté au capital social de la Société et
le solde, i.e. vingt-neuf millions neuf cent cinquante mille d’US dollars (USD 29.950.000,-) sont affectés au compte de
prime d’émission.

134439

L

U X E M B O U R G

Le montant de trente millions d’US dollars (USD 30.000.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de

ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 6.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
"6.1 La Société a un capital émis de cent mille US dollars (USD 100.000,-), représenté par cent mille (100.000) parts

sociales, d’une valeur nominale d’un US dollars (USD 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libé-
rées."

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportées par la Société

comme résultat du présent acte sont estimés à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: C. Friio, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 26 septembre 2013. REM/2013/1692. — Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013136707/115.
(130166289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

IGBG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.

R.C.S. Luxembourg B 162.058.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of September. Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary

public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Investa Holding GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing

under the laws of Germany, having its registered office at 79-81 Mergenthalerallee, 65760 Eschborn, Germany, registered
with the commercial register of Frankfurt/Main, Germany, under number 53150 (the "Sole Shareholder"); represented
by Flora Gibert, Notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 2
September 2013. The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to enact the following declarations

and statements:

1. That the company IGBG, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, rue Rénert, L-2422 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (the "Register")
under the number B 162.058 (the "Company"), was incorporated according to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger,
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 7 July 2011, and its articles of association (the "Articles")
were published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2102, page 100855 dated 8 September 2011.
The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.

2. That the issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, fully subscribed by the Sole
Shareholder of the Company.

3. That the Company's activities have ceased; that the Sole Shareholder decides in the present general meeting to

proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company.

4. That the here represented Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity

requests the notary to authenticate its declaration that due to the close down of the liquidation all the liabilities towards
the Sole Shareholder of the Company have been fully and irrevocably renounced by itself today and that the liabilities

134440

L

U X E M B O U R G

toward third parties have been duly provisioned; furthermore the liquidator declares that with respect to eventual liabi-
lities of the Company presently unknown that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities;
that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

5. That the remaining net assets have been paid to the Sole Shareholder according to their booking value;
6. That the closing financial statement of the Company for the period from 1 January 2013 through 26 August 2013 is

approved.

7. That the dissolution of the Company is done and finalised;
8. That full discharge is granted to the Company's sole manager for his respective duties.
9. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office at 3,

rue Rénert, L-2422 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, where they will be kept in custody during a period of
five (5) years.

10. That Mr Thomas Haines, with power of substitution, is authorized in the name and on behalf of the Sole Shareholder

to file any tax declaration, notice to the Register and any other documents necessary or useful for the finalization of the
liquidation.

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary, by his

surnames, name, civil status and residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille treize, le quatre septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Investa Holding GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existant et orga-

nisée  sous  les  lois  de  l'Allemagne,  ayant  son  siège  social  au  79-81  Mergenthalerallee,  65760  Eschborn,  Allemagne,
immatriculée auprès du registre de commerce de Frankfurt/Main, Allemagne, sous le numéro 53150 (l'"Associé Unique"),

représentée par Flora Gibert, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d’une procu-

ration donnée sous seing privé le 2 septembre 2013.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et la partie comparante et le notaire

restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

Laquelle partie comparante, agissant des dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ses

déclarations et constatations:

1. Que la société IGBG, une société à responsabilité limitée existant et organisée sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le "Registre") sous le numéro B 162.058 (la "Société"),
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en date du 7 juillet 2011, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations le 8 septembre 2011, numéro 2102, page 100855. Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis
sa constitution.

2. Que le capital social souscrit de la Société est douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et versés par
l’Associé Unique de la Société.

3. Que l'activité de la Société ayant cessé, l’Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme Associé

Unique en assemblée générale extraordinaire modificative des Statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat;

4. Que l’Associé Unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instru-

mentant d'acter qu'il déclare que l'Associé Unique aujourd’hui à l’occasion de la dissolution a renoncé de façon définitive
et irrévocable à la totalité des ces créances envers la Société que tout le passif de la Société envers le tiers est réglé et
que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à
d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obli-
gation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

5. Que l'actif restant est réparti à l'Associé Unique selon sa valeur comptable de bilan;
6. Que le bilan de clôture de la Société pour la période du 1er janvier 2013 au 26 août 2013 est approuvé.
7. Que pourtant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

134441

L

U X E M B O U R G

8. Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la Société;
9. Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq (5) ans auprès du siège social de la Société

au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

10. Que M. Thomas Haines, avec pouvoir de substitution, est autorisé au nom et pour le compte de l’Associé Unique

de déposer toute déclaration fiscale, réquisition au registre de commerce et tout autre document nécessaire ou simple-
ment utile pour la finalisation de la liquidation.

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au

présent acte sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

(signé): F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 septembre 2013. Relation: LAC/2013/40634. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2013.
Référence de publication: 2013136851/112.
(130166529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

E.G.S. S.A., Efficient Global Solution S.A., Société Anonyme,

(anc. E.C.U.S. S.A., Engine Control Upgrade Software S.A.).

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 32.390.

L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre.
Pardevant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Engine Control Upgrade

Software S.A.» en abrégé: E.C.U.S. S.A. (2008 2214 551) avec siège social à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue;

constituée sous la dénomination de «CALCUL S.A.» suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de rési-

dence à Luxembourg, en date du 18 octobre 1989, publié au Mémorial C N0 101 du 29 mars 1990, page 4.819,

Les statuts ont été modifiés à plusieures reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 16 avril 2008, publié au Mémorial C N0 1560 du 25 juin 2008, page 74.846, RCS B32390,

La  séance  est  ouverte  à  14.00  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Bernard  DEDERICHS,  gérant  de  sociétés,

demeurant à B-4800 Verviers, 8, Avenue Léopold II

Le président choisit comme secrétaire Monsieur Fernand TOUSSAINT, administrateur, demeurant à L-9710 Clervaux,

17, Grand-Rue

et comme scrutateur Monsieur Christophe DODEMONT, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Embourg,

80/21, Voie de l'Ardenne.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarant se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L'intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la société de Engine Control Upgrade Software S.A. (en abrégé E.C.U.S.

S.A.) en Efficient Global Solution S.A. (en abrégé|E.G.S. S.A.)et modification afférente de l'article 1 des statuts.

2.- Modification de l'objet social et adaptation afférente de l'article 4 des statuts.

134442

L

U X E M B O U R G

3.- Démission du conseil d'administration avec décharge immédiate.
4.- Nomination d'un nouveau conseil d'administration pour une durée de six années.
5.-Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
6.-Divers
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la dénomination de la société de Engine Con-

trol Upgrade Software S.A. (en abrégé E.C.U.S. S.A.) en Efficient Global Solution S.A. (en abrégé E.G.S. S.A.) et de modifier
l'article premier des statuts afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de Efficient Global Solution S.A. (en abrégé
E.G.S. S.A.)»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'objet social et d'adapter l'article quarte (4)

des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet:
- tous travaux, études et conseils en matière d'isolation de bâtiments dans le sens le plus large, isolation thermique,

acoustique, isolation de sols, des murs, des toitures et tous travaux qui s'y rapporte directement ou indirectement;

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous produits et matériaux en rapport direct ou indirect avec l'iso-

lation;

-  d'agir  en  qualité  d'intermédiaire  auprès  de  sous-traitants  pour  des  gros  travaux  de  maçonnerie,  de  menuiserie,

d'électricité, et percevoir des commissions;

La société pourra faire des opérations mobilières, financières et de transport qui sont de nature à favoriser son objet

social. Elle peut s'intéresser dans toutes sociétés, associations, entreprises ayant un objet similaire ou susceptible de
favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer des fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de révoquer avec effet immédiat tous les membres du Conseil d'Admi-

nistration, c. à d.:

Monsieur Bernard DEDERICHS, prénommé;
Monsieur Jean-François RALET, administrateur de sociétés, demeurant à B-4900 Spa, 23, Avenue de la Corniche;
Monsieur Fernand TOUSSAINT, prénommé.
Pleine et entière décharge leur est donnée.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale nomme comme nouveau administrateur-délégué et administrateur pour une durée de six ans:
Monsieur Christophe DODEMONT, prénommé,
L'assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
1.- Monsieur Fernand TOUSSAINT, prénommé,
2.- Monsieur Olivier VINCK, gérant de sociétés, demeurant à B-1340 Ottignies, 8, avenue du Roi Albert.

<i>Cinquième et Dernière résolution

L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans à:
LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faïencerie; B25797.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité, commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 14.30 heures.

134443

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Clervaux, en l'étude du notaire instrumentant.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Dederichs, Toussaint, Dodémont, Vinck, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 23 septembre 2013. Relation: CLE/2013/998. Reçu soixante-quinze euros = 75,00.-€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Francis Kler.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de dépôt au Registre aux Firmes.

Clervaux, le 24 septembre 2013.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2013137182/96.
(130165233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2013.

Astur Trading &amp; Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 151.160.

DISSOLUTION

In the year two thousand thirteen, on the nineteenth day of September.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Eric Robert BUTCHER, consultant, born in Puebla, Mexico, on the 4 

th

 day of June, 1944, residing at 21-2A, Calle

Fernandez de la Hoz, E-28010 Madrid, Spain,

here represented by Mrs Céline Haeck, employee, residing professionally in Schuttrange,
by virtue of a proxy signed on the 18 

th

 of September, 2013.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company Astur Trading &amp; Consulting S.à r.l.", having its registered office in L-5367 Schuttrange, 64, rue

Principale, was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 18 

th

 day of January 2010, published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 571 on the 17 day of March, 2010.

- that the articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 28 

th

 day

of October, 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2774 of the 16 

th

 day of

December, 2010.

- that the capital of the company "Astur Trading &amp; Consulting S.à r.l." is fixed at twelve thousand five hundred euro

(12,500.- EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (1.-EUR) each, all subscribed
and fully paid-up.

- that the appearing party has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at the 17 

th

 day of September, 2013, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities

arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at the 17 

th

 day of September, 2013, being only one

information for all purposes;

- following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be arranged the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-5367 Schuttrange, 64,

rue Principale;

The undersigned notary, who knows and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

134444

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand EUROS (EUR 1,000.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day first above written.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Eric Robert BUTCHER, consultant, né le 4 juin 1944 à Puebla, Mexique, demeurant à 21-2A, Calle Fernandez

de la Hoz, E-28010 Madrid, Espagne,

ici représenté par Madame Céline Haeck, employée, demeurant professionnellement à Schuttrange,
en vertu d'une procuration accordée le 18 septembre 2013,
laquelle, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour

être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société Astur Trading &amp; Consulting S.à r.l., ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, Rue Principale, a

été constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 18 janvier 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 571 du 17 mars 2010;

- que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 octobre

2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2774 du 16 décembre 2010;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représenté par

douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1.-EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.;

- que la partie comparante est seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société;

- que l'associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 17 septembre 2013,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associé unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 17 septembre 2013 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales et/ ou du registre des associés;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-5367 Schuttrange,

64, rue Principale.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1,000.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Haeck, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42898. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

134445

L

U X E M B O U R G

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137206/101.
(130167580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

Accon Solutions, Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 68, Géidgerweeg.

R.C.S. Luxembourg B 133.161.

Im Jahre zweitausend und dreizehn, am vierundzwanzigsten Tag des Monats September.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Lu-

xemburg).

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft (société anonyme")

ACCON SOLUTIONS, mit Gesellschaftssitz in L-9980 Wilwerdange, 68, Géidgerweeg, und eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 133.161, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den
Notar, Maître Fernand UNSEN, mit damals dem Amtswohnsitz zu Diekirch, am 16. Oktober 2007, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2772 vom 30. November 2007 (die „Gesellschaft"). Die
Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird um 12.00 Uhr eröffnet und findet statt unter dem

Vorsitz von Herrn Jean-Claude LOUIS, Buchhalter, wohnhaft in B-4783 Sankt Vith, Wiesenbach, 16 (Belgien).

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Herr André

LOUIS, Student, wohnhaft in B-4783 Sankt Vith, Wiesenbach, 16 (Belgien).

Die  außerordentliche  Generalversammlung  der  Aktionäre  bestellt  zum  Stimmenzähler  Herr  Jean-Claude  LOUIS,

Buchhalter, wohnhaft in B-4783 Sankt Vith, Wiesenbach, 16 (Belgien).

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und diesbezügliche Neuverfassung des Artikels vier der Satzung.
2. Verschiedenes.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand

einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-
tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben
bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben

vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung der Aktionäre an-

wesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der außerordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen
sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, die das gesamte Gesellschaftskapital ver-

tritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Bes-

chlüsse gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu er-

weitern  und  diesbezüglich  Artikel  4  der  Satzung  wie  folgt  abzuändern,  um  demselben  folgenden  neuen  Wortlaut  zu
verleihen:

„ Art. 4. Zweck und Gegenstand der Gesellschaft sind; auf Rechnung Dritter, befasst mit:
- der Organisation der Buchhaltungsdienste und der betreffenden Beratung für Dritte;
- das Eröffnen, Führen, Zentralisieren und Schließen der Buchungen, die zum Erstellen der Konten geeignet sind;
- die Bestimmung der Ergebnisse und der Erstellung des Jahresabschlusses in der durch das Gesetz bestimmten Form;
- die Beratung in allen Steuerangelegenheiten, die Unterstützung der Steuerpflichtigen bei der Erfüllung ihrer Steuer-

verpflichtungen und der Vertretung von Steuerpflichtigen;

- die Lohnberechnungen erstellen, sowie alle Dienste eines Sozialsekretariats und der betreffenden Beratung für Dritte.

134446

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann sich in Form von Beiträgen beteiligen, sich mit anderen fusionieren, Anteile unterzeichnen und/

oder die Funktion der Geschäftsleitung übernehmen, sowie ein Mandat als Geschäftsführer oder Verwalter in anderen
juristischen Personen, Gesellschaften oder Zivilgesellschaften ausüben, insofern diese einen ähnlichen Zweck verfolgen.

Die Gesellschaft kann die Funktion des Liquidators in anderen Gesellschaften übernehmen.
Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen im Bezug auf bewegliche und un-

bewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringung, Anteilszeichnung, Verschmelzung oder auf jede Art und Weise

an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder
die  die  Ausdehnung und  Entwicklung  der gegründeten  Gesellschaft begünstigen können; sowie jede  andere  Tätigkeit
welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland ausüben."
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der

Aktionäre um 12.20 Uhr für geschlossen.

<i>Schätzung der kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf neunhundert Euro (EUR 900,-) geschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem die Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J.-C. Louis, A. Louis, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11612. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.

Diekirch, den 30. September 2013.

Référence de publication: 2013137209/81.
(130167297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

StayInvest GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 6, Grand rue.

R.C.S. Luxembourg B 175.060.

AUSZUG

Es geht aus einer Anteileabtretung vom 21. August 2013, betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "StayIn-

vest GmbH", mit Sitz zu L-6730 Grevenmacher, 6, Grand Rue, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B
175.060:

1) Siegfried Mauritzius BUSCH, Master of Business Administration, wohnhaft zu CH-6103 Schwarzenberg, Panora-

mastrasse 19,

Eigentümer von einhundert (100) Anteilen der vorgenannte Gesellschaft, erklärt andurch unter der gesetzlichen Ge-

währ Rechtens abzutreten an Norbert Karl HÖLZLE, Diplom Ingenieur, wohnhaft zu L-6758 Grevenmacher, 2a, rue
Victor Prost, hier anwesend und dies annehmend, fünfundfünzig (55) Anteile der vorgenannten Gesellschaft, zum Preise
von fünfhundertfünfzig Euro (550.- EUR).

2) Der Komparent Siegfried Mauritzius BUSCH, vorgenannt, erklärt andurch unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens

abzutreten an Stanislav SIMEONOV, IT Kaufmann, wohnhaft zu D-54290 Trier, Simeonstrasse 41, fünfundzwanzig (25)
Anteile der vorgenannten Gesellschaft, zum Preise von zweihundertfünfzig Euro (250,- EUR).

3) Der Komparent Siegfried Mauritzius BUSCH, vorgenannt, erklärt andurch unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens

abzutreten an Christina Clara MÜLLER, Administrative Assistant, wohnhaft zu D-54290 Trier, Simeonstrasse 41, hier
anwesend und dies annehmend, zwanzig (20) Anteile der vorgenannten Gesellschaft, zum Preise von zweihundert Euro
(200,- EUR).

4)  Die  Zessionare  werden  Eigentümer  der  ihnen  abgetretenen  Anteile  und  haben  Anrecht  auf  alle  Einkünfte  und

Gewinne, welche die ihnen abgetretenen Anteile erbringen von heute angerechnet. Die Zessionare werden in alle Rechte
und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen Anteilen anhaften.

134447

L

U X E M B O U R G

5) Christina Clara MÜLLER, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, um im Namen der Gesell-

schaft, gemäß Artikel 1690 des Code Civil, die genannten Abtretungen anzunehmen und sie entbindet die Zessionare von
einer diesbezüglichen Zustellung an die Gesellschaft. Weiterhin erklärt sie dass keine Opposition und kein Hindernis
bestehen, welche die Ausführung dieser Abtretungen aufhalten könnten.

6) Die Anteilinhaber, Norbert Karl HÖLZLE, Stanislav SIMEONOV, und Christina Clara MÜLLER, vorgenannt, geben

ihr Einverständnis zu den hiervor gemachten Abtretungen.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 août 2013. Relation: LAC/2013/39019. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.

Pour extrait conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137068/37.
(130166722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

Parkridge CER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 134.197.

EXTRAIT

1. La démission des gérants ci-dessous est acceptée avec effet immédiat au 10 Janvier 2012:
- Monsieur Benoît de Froidmont, demeurant au 370, route de Longwy, L - 1940 Luxembourg
- Monsieur Adrien Rollé, demeurant au 370, route de Longwy, L - 1940 Luxembourg

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013137544/13.
(130167750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2013.

BRE/Sakura I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.429.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137788/9.
(130167984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Broadband Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 614.456,25.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 146.370.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013137794/10.
(130168575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

D &amp; H Design Carrelage S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 57, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 92.694.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137838/9.
(130168375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

134448


Document Outline

Accon Solutions

ADB Luxembourg S.A.

Algeco/Scotsman Holding S.à r.l.

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Six) S.A.

Alianza Iberian Private Equity (Luxembourg-Six) S.A.

Allact S.A.

Alphacore International S.A.

Altura S.à r.l.

Aqualan Finance S.A.

Aqua-Rend

Aqua-Rend

Art et Beauté

Arthel CO S.à r.l.

Astur Trading &amp; Consulting S.à r.l.

Au Fil du Bois S.à r.l.

Avvens Luxembourg S.à r.l.

BAUERE KOPERATIV, Société Coopérative

BC Bowling S.à r.l.

Beaugency Asset Management S.A.

Bouquet S.à r.l.

BRE/Embassy Holding S.à r.l.

BRE/Embassy S.à r.l.

BRE/Europe 5NQ S.à r.l.

BRE/Europe 5Q S. à r.l.

BRE/Everbright M6 Canada S.à r.l.

BRE/Insite Holdings S.à r.l.

BRE/Japan III S.à r.l.

BRE/Japan II S.à r.l.

BRE/Japan I S.à r.l.

BRE/Sakura I S.à r.l.

Broadband Investments S.à r.l.

Car Classifieds Asia S.à r.l.

CECEP Solar Energy (Luxembourg) Private Limited Company (S.à r.l.)

Cencan S.A.

Centre Chretien-Social du Sud

Cidoval S.à r.l.

Classifieds (GP) S.à r.l.

Clemalux S.à r.l.

Cofilux Conseil

Cold Waters Investments S.A.

ColorPortal Europe S.A.

Compagnie Financière de l'Union Européenne S.A.

Concepta Senium S.A.

Croisic Sàrl

De Beers Holdings Luxembourg

D &amp; H Design Carrelage S. à r.l.

Eberling Tennis Academie

Efficient Global Solution S.A.

Elettra Holdings S.à r.l.

Engine Control Upgrade Software S.A.

Eurothea S.A.

IGBG

Parkridge CER S.à r.l.

Parque Principado S.à r.l.

Royal-Lux S.A.

Safrec S.A., SPF

SOGETI Luxembourg S.A.

Spelec S.à r.l.

StayInvest GmbH

T &amp; C International S.A.

The Before S.àr.l.

Togo S.A.

Trasys Luxembourg

Triumph Group Luxembourg Finance Sàrl