This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2749
5 novembre 2013
SOMMAIRE
Accenture SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131908
Airfreight Development Worldwide S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131906
Almack II Unleveraged SA . . . . . . . . . . . . . .
131952
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l. . . . .
131910
Arelux France S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131910
Batiwal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131915
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131947
Bridgepoint Europe II Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131914
BYR Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131914
Cerigo Développement Un S.à r.l. . . . . . . .
131921
CNH Industrial Finance Europe S.A. . . . . .
131908
Codeca S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131910
Cube Infrastructure Fund . . . . . . . . . . . . . . .
131914
Cytolnat International S.A. . . . . . . . . . . . . .
131928
Darlington S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131916
Daumont Development S.A. . . . . . . . . . . . .
131917
D & D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131915
Delight s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131918
Denovo S.A., société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131913
Donner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131916
Dufry Finances SNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131917
ECSA S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131922
Elia Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131922
Elliot Promotions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131919
EnCo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131920
EnCo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131918
European Camping Distributors S.à r.l. . .
131918
European Casino Operators S.à r.l. . . . . . .
131919
European Marketing Group (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131906
European News Promotions S.à r.l. . . . . . .
131920
European Opticians 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
131923
European Opticians S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
131921
European Packaging S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
131924
European Private Equity Portfolio S.A., SI-
CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131918
European Recreational Vehicles S.à r.l. . .
131924
European Vehicle Inspections S.à r.l. . . . . .
131925
E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A. . . . . . . . .
131917
FedEx Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
131922
FINANCIAL BIS Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
131923
Financière de Titrisation S.A. . . . . . . . . . . .
131923
Finorma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131926
Fisch Fund Services AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
131909
Galilehorn Asset Management S.à r.l. . . . .
131925
General Electric International Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131920
Genpact Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
131926
Gérances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131926
Gerona Securitization S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
131927
GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131945
Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131928
I.F.G. International Food Group S.A. . . . .
131906
ING Lease Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
131907
ING Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131907
JPMorgan Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131907
Marino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131906
Meigerhorn Bulle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
131952
M & M Ballooning s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
131946
Partners Group Direct Mezzanine 2013
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131937
Partners Group Global Real Estate 2013
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131928
Radiant Fund S.C.A. SICAV FIS . . . . . . . . .
131927
REF IV Associates (Caymans) L.P. Child
Wear CIV S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131927
Rovabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131908
TMCRIGHT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131913
UBS (Lux) Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
131912
131905
L
U X E M B O U R G
Airfreight Development Worldwide S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 92, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 100.302.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>26 novembre 2013i> à 10.00 heures au siège de la société à
Senningerberg, 92 rue du Golf, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31 décembre 2012;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2013152266/832/18.
EMG (Luxembourg) S.A., European Marketing Group (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 16.575.
L'extrait du recueil des signatures autorisées au 1
er
septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013146049/10.
(130178760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
I.F.G. International Food Group S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 151.644.
We hereby give you notice of an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company that will be held in front of a Notary on <i>13th November 2013i> at 11.00 a.m. (local
time) at the registered office of the Company at which the following Agenda will be considered:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the Company's share capital by a maximum of € 3.000.000.- to raise it from € 100.000.000.- to a
maximum of € 103.000.000.- by the creation and issue of a maximum of 30.000 new shares with a nominal value
of € 100.- each.
Subscription and paying up by cash.
2. Subsequent amendments of Article 3 of the Company's Articles of Incorporation.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2013148422/17.
Marino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 56.112.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136249/9.
(130166149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
131906
L
U X E M B O U R G
JPMorgan Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.478.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Funds (the "Company") will be held on Wednesday, <i>20 November 2013i>
at 15:00 CET, at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Reports of the Auditors and the Board of Directors for the accounting year ended June 30,
2013.
2. Adoption of the Financial Statements for the accounting year ended June 30, 2013.
3. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended June 30,
2013.
4. Approval of Directors' Fees.
5. Re-election of Mr Iain Saunders, Mr Jacques Elvinger, Mr Jean Frijns, Mr Berndt May, Mr John Li and Mr Peter
Schwicht to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders adopting the
Financial Statements for the accounting year ending on June 30, 2014.
6. Re-election of PricewaterhouseCoopers Société coopérative to serve as Auditors of the Company until the Annual
General Meeting of Shareholders, adopting the Financial Statements for the accounting year ending on June 30,
2014.
7. Allocation of the results as per the Audited Annual Report for the accounting year ended June 30, 2013.
8. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>VOTINGi>
Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>VOTING ARRANGEMENTSi>
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. A form
of Proxy for voting is available at www.jpmorganassetmanagement.com/extra.Completed Forms of Proxy must be re-
ceived by no later than the close of business in Luxembourg on Monday, 18 November 2013 at the Registered Office of
the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2013152267/755/34.
ING Lease Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 31.049.
L'extrait du recueil des signatures autorisées au 1
er
septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013146155/10.
(130178769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
ING Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 6.041.
L’extrait du recueil des signatures autorisées d’octobre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013148093/10.
(130180917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.
131907
L
U X E M B O U R G
CNH Industrial Finance Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.849.
Les statuts coordonnés au 14 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013146612/11.
(130178895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.
Rovabo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1482 Luxembourg, 15, rue Charlotte Engels.
R.C.S. Luxembourg B 145.360.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2660 du 24 octobre 2013, page 127642, de la
mention du dépôt au Registre de commerce et des sociétés des comptes 2012 de la société Rovabo:
au lieu de:
"Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.",
lire:
"Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg."
Référence de publication: 2013152256/13.
Accenture SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.874.
The shareholders of Accenture SCA, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions)
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.874, with registered and principal
executive offices at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (“Accenture SCA”), are cordially invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>November 15, 2013i> , at 12:00 noon, local time, at the offices of Allen & Overy Luxembourg at
33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (the “Annual General Meeting”) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of (i) the report on the annual accounts issued by Accenture plc, the general partner of Accenture
SCA, and (ii) the report of the external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of Accenture SCA for the year ended
August 31, 2013;
2. Approval of (i) the balance sheet, (ii) the profit and loss accounts and (iii) the notes to the accounts of Accenture
SCA as of and for the year ended August 31, 2013;
3. Allocation of the results of Accenture SCA as of and for the year ended August 31, 2013, declaration of a cash
dividend in a per share amount of USD $0.93 to each holder of a Class I common share of Accenture SCA of
record as of October 8, 2013 and authorization to the general partner of Accenture SCA to determine any appli-
cable terms in respect of the payment of the dividend;
4. Authorization and granting of power to the general partner of Accenture SCA to pay up to EUR 700 million taken
from the distributable reserves of Accenture SCA as interim dividends between November 15, 2013 and November
14, 2014 in accordance with the last paragraph of article 19 of Accenture SCA's articles of association;
5. Discharge of the duties of the general partner of Accenture SCA in connection with the year ended August 31,
2013;
6. Re-appointment of KPMG S.à r.l. as the external auditor of Accenture SCA on a stand-alone basis for the year
ending August 31, 2014, subject to the approval by the Audit Committee of the general partner of Accenture SCA
of the engagement of KPMG S.à r.l. as the external auditor of Accenture SCA, in satisfaction of the Luxembourg
law requirement that Accenture SCA's shareholders appoint a supervisory board or external auditor of Accenture
SCA's annual accounts; and
7. Re-appointment of KPMG LLP as the independent auditor of Accenture SCA on a consolidated basis with its
subsidiaries for the year ending August 31, 2014, subject to the approval by the Audit Committee of the general
partner of Accenture SCA of the engagement of KPMG LLP as the independent auditor of Accenture SCA.
131908
L
U X E M B O U R G
Shareholders may obtain, free of charge, copies of (a) the stand-alone (i) balance sheet, (ii) profit and loss accounts
and (iii) notes to the accounts of Accenture SCA for the year ended August 31, 2013, (b) the list of securities held by
Accenture SCA, (c) the list of shareholders, if any, who have not fully paid up their shares with an indication of the number
of shares and their contact details, (d) the report of the general partner of Accenture SCA, (e) the report of the external
auditor of Accenture SCA and (f) the consolidated accounts of Accenture SCA by (i) making a written request to Ac-
centure plc c/o Accenture, 161 N. Clark Street, Chicago, IL 60601, United States of America, Attention: Secretary or (ii)
at Accenture SCA's registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 in Luxembourg.
The general partner of Accenture SCA has fixed 11:59 p.m., local time in Luxembourg on October 8, 2013 as the
record date for the determination of shareholders entitled to vote at the Annual General Meeting. This means that only
those persons who were registered holders in Luxembourg of Accenture SCA Class I common shares at such time on
that date will be entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.
Dated: October 17, 2013.
ACCENTURE plc
<i>acting as general partner of Accenture SCAi>
Référence de publication: 2013148424/5499/49.
Fisch Fund Services AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 51.063.
Im Jahre zweitausenddreizehn, am dreizehnten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,
Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft FISCH FUND
SERVICES AG (die „Gesellschaft"), mit Sitz in L-1470 Luxemburg, 69, route d'Esch, die gegründet wurde gemäß notarieller
Urkunde vom 17. Mai 1995, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 268 am 16. Juni 1995
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 22. August 2012 durch Urkunde, aufgenommen
durch Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, geändert, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 2502
vom 09. Oktober 2012.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Solange Wolter, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.
Die Vorsitzende ernennt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Régis Galiotto, Pri-
vatbeamter, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterzeichnet. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger
Urkunde ne varietur paraphiert, beigebogen und mitformalisiert.
II.- Sämtliche elftausend (11.000) Aktien der Gesellschaft sind durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte ver-
treten, demnach ist die Versammlung ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1. Verlegung des Sitzes von 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg nach 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg und
Abänderung von Artikel drei der Satzung.
2. Verschiedenes
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftssitz von 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg nach 5, rue Heien-
haff, L-1736 Senningerberg zu verlegen und beschließt den ersten Satz in Artikel drei der Satzung wie folgt umzuändern:
„ Art. 3. Erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven.
Nachdem zum Tagesordnungspunkt „2. Verschiedenes" keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt die
Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die außerordentliche Gesellschafterversamm-
lung.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben diese mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
131909
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: S. WOLTER, R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43023. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 2. Oktober 2013.
Référence de publication: 2013139034/48.
(130169483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Codeca S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 35.129.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 99 Septembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2013136021/10.
(130166127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 153.267.
Arelux France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 160.433.
PROJET COMMUN DE FUSION SIMPLIFIEE
CONVENU ENTRE
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale
Capital social: EUR 50.000,00
R.C.S. Luxembourg B 153.267
ET
ARELUX FRANCE S.à r.l.
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale
Capital social: EUR 12.500,00
R.C.S. Luxembourg B 160.433
L'an deux mille treize, le 24 octobre,
1 Le conseil de gérance de AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, dont le siège social est sis à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.267,
et
2 Le conseil de gérance de ARELUX FRANCE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
dont le siège social est sis à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.433,
conformément aux articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après la Loi), conviennent par les présentes du projet commun de fusion:
1. Sociétés fusionnantes.
1.1 Société absorbante
131910
L
U X E M B O U R G
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social
est sis à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.267, constituée par acte notarié passé devant Me Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 2010 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
Luxembourg n° 1427 du 13 juillet 2010 (la Société absorbante).
Les statuts de la Société absorbante ont été modifiés la dernière fois par acte passé devant Me Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 2010 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du Luxembourg n° 742 du 16 avril 2011.
Le capital social émis de la Société absorbante s'élève à cette date à cinquante mille euro (EUR 50,000.-), réparti en
cinquante mille (50,000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (les Actions de la Société absorbante).
Toutes les Actions de la Société absorbante sont entièrement libérées.
1.2 Société absorbée:
ARELUX FRANCE S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis à
L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 160.443, constituée par acte notarié passé devant Me Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 15 avril 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
Luxembourg n°1497 du 7 juillet 2011 (la Société absorbée).
Le capital social émis de la Société absorbante s'élève à cette date à douze mille cinq cent euro (EUR 12,500.-), réparti
en douze mille cinq cent (12,500) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (les Actions de la Société
absorbée).
Toutes les Actions de la Société absorbée sont entièrement libérées.
1.3 Actionnariat de la Société absorbante et de la Société absorbée
AOG Real Estate B.V., une besloten vennootschap met beperkte aansprakeijkheid régie par les lois des Pays-Bas, ayant
son siège social à Hoge Mosten 62, NL-4822 NH Breda, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce des Pays Bas sous le
numéro 24487609, est seul actionnaire de la Société absorbante.
La Société absorbante est seul actionnaire de la Société absorbée.
2. Type de fusion. La Société absorbée fusionnera avec la Société absorbante par voie de fusion par absorption, la
Société absorbante absorbant la Société absorbée, et sans liquidation de la Société absorbée (ci-après la Fusion) confor-
mément (i) aux dispositions de la Section XIV de la Loi et (ii) aux conditions stipulées dans le présent projet commun de
fusion ((i) et (ii) étant conjointement appelées ci-après les Conditions de fusion).
A l'entrée en vigueur de la Fusion, tous les actifs et passifs de la Société absorbée, de même que ses droits et obligations
(dans la mesure où de tels actifs, passifs, droits et devoirs existent à la Date d'entrée en vigueur, comme défini ci-dessous),
seront transférés à la Société absorbante en vertu de la Loi, la Société absorbée cessera d'exister.
Sur le plan comptable, l'actif et le passif de la Société absorbée seront évalués à leur valeur de marché (fair market
value) au 30 septembre 2013.
Aucune part sociale ne sera nouvellement émise par la Société absorbante ou échangée contre quelconque part sociale
de la Société absorbée. Aucun expert tel que visé à l'article 266 de la Loi n'a été élu et les dispositions de l'article 265 de
la Loi ne sont pas applicables.
3. Date d'entrée en vigueur. La Fusion deviendra effective vis-à-vis de tiers à la date de publication:
- de l'acte notarié enregistrant les résolutions de l'actionnaire unique de la Société absorbante, et
- de l'acte notarié enregistrant les résolutions de l'actionnaire unique de la Société absorbée,
et approuvant la décision de fusion conformément aux conditions exposées dans le présent projet de Fusion (ci-après
la Date d'entrée en vigueur) et selon les dispositions de l'Article 9 de la Loi.
4. Date de prise d'effet de la fusion d'un point de vue comptable. D'un point de vue comptable, les opérations de la
Société absorbée seront considérées effectuées pour le compte de la Société absorbante à partir du 1
er
octobre 2013.
5. Incidence de la fusion sur l'emploi. Comme ni la Société absorbée ni la Société absorbante n'ont de personnel salarié,
la Fusion n'aura pas d'incidence sur l'emploi.
6. Incidence juridique. D'un point de vue juridique, les activités de la Société absorbée seront poursuivies par la Société
absorbante.
Sous réserve des conditions contractuelles existantes, les conventions contractuelles conclues par tout tiers avec la
Société absorbée ou la Société absorbante respectivement, ou conclues entre ces deux dernières, demeureront inchan-
gées et garderont leur plein effet dans le chef de la Société absorbante, en tant que société absorbante.
A partir de la Date d'entrée en vigueur, de par la loi et en vertu des présentes Conditions de fusion, toutes les
obligations contractuelles existantes et exécutoires vis-à-vis de la Société absorbée à la date de la Fusion, seront trans-
férées à la Société absorbante. La Société absorbante sera responsable des droits et obligations qu'elle aura acquis.
131911
L
U X E M B O U R G
7. Droits octroyés par la Société absorbante aux actionnaires de la Société absorbée qui disposent de droits spéciaux
et aux détenteurs de titres autres que des actions. Ni la Société absorbante, ni la Société absorbée n'ont émis d'actions
ou autres titres octroyant des droits spéciaux à leurs détenteurs.
8. Avantages spéciaux. Aucun avantage spécial n'a été ou ne sera accordé dans le cadre de la Fusion aux membres des
conseils de gérance de la Société absorbée et de la Société absorbante, aux réviseurs d'entreprise de la Société absorbée
et de la Société absorbante, à d'autres experts ou conseillers de la Société absorbée et de la Société absorbante, ni
généralement à aucune autre personne.
9. Incidence de la fusion sur les droits des créanciers. Les créanciers de la Société absorbée deviendront créanciers
de la Société absorbante.
Conformément à l'Article 268 de la Loi, les créanciers des Sociétés fusionnantes dont les créances sont antérieures à
la date de publication dans le Mémorial des actes d'enregistrement de la Fusion visés par l'Article 273 de la Loi, pourront,
nonobstant toute convention contraire, introduire dans un délai de deux (2) mois et auprès du juge présidant la chambre
du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matières commerciales une demande en référé afin d'ob-
tenir des garanties appropriées pour toute dette échue ou non échue, dans le cas où la Fusion rendrait une telle protection
nécessaire.
10. Dépôt et Publication. Le projet de Fusion sera déposé auprès du Registre de Commerce et des Société de Lu-
xembourg.
Le projet de Fusion sera déposé au siège de chacune des sociétés fusionnantes.
Le projet de Fusion sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations un mois au moins avant la date
de l'assemblée générale appelée à approuver la projet de Fusion.
11. Documents disponibles aux sièges des sociétés fusionnantes. Les documents suivants seront disponibles aux ac-
tionnaires respectifs de la Société absorbée et de la Société absorbante aux sièges sociaux des sociétés fusionnantes au
moins un (1) mois avant la date à laquelle l'actionnaire unique de chacune des Sociétés fusionnantes est appelé à approuver
la décision de Fusion envisagée au présent projet de Fusion:
- le présent projet de Fusion;
- les comptes annuels des sociétés qui fusionnent pour les trois derniers exercices (si applicable);
- un état comptable pour chacune des sociétés qui fusionnent arrêté à une date qui n'est pas antérieure au premier
jour du troisième mois précédant la date du projet de Fusion.
AOG REAL ESTATE LUXEMBOURG S.A R.L.
Alex van Zeeland / Gert Triest
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie B
i>ARELUX FRANCE S.À R.L.
Alex van Zeeland / Gert Triest
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2013150321/126.
(130184053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.
UBS (Lux) Equity Fund, Fonds Commun de Placement.
<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Subfondsi>
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Navigator (EUR)
Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (nachfolgend der "Verwaltungsrat"), der Verwal-
tungsgesellschaft von UBS (Lux) Equity Fund, möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass er die Auflösung des Subfonds
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Navigator (EUR) (der "Subfonds") gemäss den Bestimmungen des Verwaltungs-
reglements und des Verkaufsprospekts von UBS (Lux) Equity Fund mit Wirkung zum 5. November 2013 (das "Datum
des Inkrafttretens") beschlossen hat.
Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass das Nettovermögen des Subfonds auf einen Wert gefallen ist, der nicht
ausreicht, um eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Daher ist er der Auffassung, dass die Auflösung
des Subfonds im besten Interesse der Anteilinhaber ist.
Seit dem Annahmeschluss des 30. September 2013 werden keine Neuzeichnungen oder Umtauschvorgänge in Anteile
des Subfonds sowie seit dem Annahmeschluss des gestrigen Tages keine Rücknahmen mehr akzeptiert.
Anteilinhaber, die am Datum des Inkrafttretens Anteile des Subfonds halten, erhalten den ihnen zustehenden Anteil
am Liquidationserlös nach Abschluss der Liquidation des Subfonds gemäss den luxemburgischen Gesetzen und Bestim-
mungen. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet
werden können, werden bei der "Caisse de Consignation" in Luxemburg hinterlegt.
131912
L
U X E M B O U R G
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Beteiligung an Investmentfonds der Besteuerung unterliegen kann. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, sofern Sie aufgrund dieser Auflösung steuerliche Fragen haben.
Luxemburg, den 5. November 2013.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2013152268/755/23.
TMCRIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 56, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 177.765.
<i>Extrait du procès-verbal d'assemblée générale de la SàRL TMCRIGHT (B177765)i>
L'an Deux Mille Treize 30 août à 10 heures, l'assemblée générale des actionnaires de la SàRL TMCRight au capital de
12500 EUR s'est tenue en son siège social 56 route d'Arlon L-8310 Capellen, en assemblée générale extraordinaire, sur
convocation conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts.
Sont présents les associés suivants, représentant chacun 25% des parts sociales:
1) Monsieur Yuksel Gul, né à Kelkit, Turquie, le 5 septembre 1974 et demeurant au 21 Rue de la Chapelle à F-57600
Forbach, France
2) Monsieur Yucel Gul, né à Kelkit, Turquie, le 1
er
octobre 1975 et demeurant au 21 Rue de la Chapelle à F-57600
Forbach, France
3) Monsieur Konstantin Beda, né à Kustanai, Kazakhstan et demeurant au 80 Koenigstrasse D-67655 Kaiserslautern,
Allemagne
4) Monsieur Ercan Calik, né à Istanbul le 8 mars 1972 et demeurant à Hakimiiyeti Milliye Cad., Vedat Kancal Is Mrkz,
No 158 Kat: 2 No: 49A, 4672 Üsküdar/Istanbul est représenté par Monsieur Yuksel Gul
L'assemblée est présidée par Monsieur Yucel Gul, associé-gérant, disposant des pouvoirs les plus étendus pour engager
la société par sa seule signature, dans les limites des statuts.
Les associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- La fin du mandat de gérance de monsieur Yucel Gul avec effet immédiat
- La nomination de monsieur Konstantin Beda au poste de gérant avec effet immédiat
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10:30.
Yucel GuI / Konstantin Beda
<i>Le président de la séance / Le gérant nommé
i>Yuksel Gul / Ercan Calik
<i>Les associési>
Référence de publication: 2013135835/31.
(130164401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Denovo S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 18.912.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42, rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société DENOVO S.A., société de gestion de patrimoine familial, société anonyme: Monsieur
Giacomo DI BARI, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
<i>Pour: DENOVO S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2013136726/19.
(130166912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.
131913
L
U X E M B O U R G
Cube Infrastructure Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécia-
lisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.234.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 25 mars 2013i>
En date du 25 mars 2013, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission au 7 mars 2013, de Monsieur Luc-Emmanuel Auberger en qualité d'Administrateur,
- de coopter en date du 25 mars 2013, Monsieur Pierre Fourrier, 33, rue La Fayette, 75009 Paris, France, en qualité
d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013, en remplacement de Monsieur Luc-Em-
manuel Auberger, démissionnaire.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Cube Infrastructure Fund
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2013136009/18.
(130165916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
BYR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.446.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 28 août 2013 («l'Assemblée Générale») a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Sylvain FERAUD, Président, avec adresse professionnelle, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Margherita BALERNA BOMMARTINI, Administrateur, avec adresse professionnelle, Via L.Zuccoli 19,
CH-6900 Lugano, Suisse;
- Monsieur Arnaud BOUTEILLER, Administrateur, avec adresse professionnelle, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg.
- Monsieur Curt Linus SLUYTER, Administrateur, avec adresse professionnelle, 44 Carrera, Medellin, Colombie.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2014.
L'Assemblée Générale du 28 Août 2013 a renouvelé le mandat du réviseur d'entreprise:
- Deloitte S.àr.L., réviseur d'entreprise, 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2014.
<i>Pour BYR SICAVi>
Référence de publication: 2013135984/20.
(130165745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Bridgepoint Europe II Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 79.098.
<i>Extrait des résolutions des associés de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- Les associés ont accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR
12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- Les associés ont nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
131914
L
U X E M B O U R G
- Michaël Goosse;
- Davy Beaucé;
- Paul Gunner; et
- Charles Barter.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013135977/27.
(130166028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Batiwal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7257 Walferdange, 1-3, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 144.741.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 août 2013, de révoquer Monsieur Régis
NOEL de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat et de nommer en son remplaçant la société
Fiduciaie FIDUWAL S.A R.L., ayant son siège social au 1-3,Millewee, L-7257 Helmsange, comme commissaire aux comptes,
jusqu'à l'issue de assemblée générale qui se tiendra en 2014.
Suite à la démission de Monsieur Wei ZHANG, administrateur de société, et de Monsieur Nico ROLLINGER, admi-
nistrateur de société, de leurs mandats d'administrateur en date du 25 août 2013, le conseil d'administration a décidé de
nommer en leur remplacement, Monsieur Thomas HUESTER, avec adresse professionnelle au 1-3, Millewee, L-7257
Helmsange et Monsieur Jean-Claude SCHERER, demeurant au 229, rue des Romains, L-8041 Bertrange, comme admi-
nistrateurs, jusqu'à l'issue de assemblée générale qui se tiendra en 2014.
Monsieur Nico ROLLINGER, administrateur de société, démission également de son mandat d'administrateur-délégué
en date du 25 août 2013.
En conséquence de la résolution qui précède, le Conseil d'administration de la Société est désormais composé comme
suit:
- Monsieur Jean-Jacques SCHERER,
- Monsieur Thomas HUESTER,
- Monsieur Jean-Claude SCHERER,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Helmsange, le 20 septembre 2012.
Référence de publication: 2013135956/26.
(130166175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
D & D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6990 Hostert, 10, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 58.696.
L'an deux mille treize, le trois septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Dany KALAC, employé privé, né à Zadar (Croatie), le 03 novembre 1952, demeurant à L-1131 Luxembourg,
20, rue Antoine.
Lequel comparant déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée "D&D, S.à r.l.", avec siège social à L-6990 Hostert, 10, rue Principale, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 58.696, (ci-après dénommée la
"Société"), a été constituée par acte reçu par le notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, en date du 24 mars
1997, publié au Mémorial C numéro 364 du 9 juillet 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître
Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial C, numéro 919 du
8 septembre 2003.
2.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq euros (25,-EUR) chacune.
- Que le comparant est le seul et unique associé de ladite société et qu'il s'est réuni en assemblée générale extraor-
dinaire et a pris les résolutions suivantes:
131915
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement et de mettre en liquidation la société "D&D, S.à r.l.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge à la gérante de la société pour l'exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée désigne Monsieur Dany KALAC, employé privé, né à Zadar (Croatie), le 03 novembre 1952 demeurant
à L-1131 Luxembourg, 20, rue Antoine, comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la
loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette auto-
risation est normalement requise.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme
de neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Dany KALAC, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2013. Relation GRE/2013/3643. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
POUR EXPEDITION CONFORME
Junglinster, le 26 septembre 2013.
Référence de publication: 2013136029/45.
(130165743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Donner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 167.540.
Constituée par devant Me Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 2012, acte publié
au Mémorial C no 1058
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Donner S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013136032/14.
(130165445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Darlington S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 136.659.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2013 que, le mandat des organes sociaux
étant venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) Administrateursi>
- Monsieur Claude GEIBEN, avocat, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
131916
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
<i>b) Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Jérôme DOMANGE, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2018.
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2013136038/24.
(130165795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Daumont Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 146.916.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136039/10.
(130165971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Dufry Finances SNC, Société en nom collectif.
Capital social: USD 2.660.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 172.090.
EXTRAIT
Par résolution écrite du conseil de gérance en date du 30 août 2013, le conseil de gérance a décidé d'adopter la
résolution suivante:
- le siège social de la société a été transféré de 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, avec effet au 1
er
septembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2013136035/17.
(130165719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 118.389.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnairesi>
En date du 12 septembre 2013, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé comme suit:
- de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Johan MANSVELT, résidant professionnellement au 24,
Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, Eric VANDERKERKEN résidant professionnellement au 22-24, rives de Clausen,
L-2165 Luxembourg et Massimo LONGONI, résidant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg avec
effet immédiat. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 dé-
cembre 2013.
- de renouveler le mandat de Monsieur Marcel STEPHANY en tant que commissaire aux comptes de la Société avec
effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre
2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131917
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013136050/21.
(130165548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Delight s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 59.471.
Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136040/10.
(130166072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
EnCo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 148.840.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013136055/13.
(130165734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Private Equity Portfolio S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 132.420.
Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Juli 2013 geht hervor, dass
- Herr Dr. Gerhard Opitz, geboren am 24.10.1948 in Belzig (Deutschland), Geschäftsadresse Bockenheimer Lands-
trasse 10 in 60323 Frankfurt am Main (Deutschland) zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wird. Sein Mandat endet mit
der Generalversammlung im Jahr 2014, die den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 verabschiedet.
Luxemburg, den 27.09.2013.
Monika Anell / Andreas Diendorf.
Référence de publication: 2013136059/13.
(130166024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Camping Distributors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.899.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
131918
L
U X E M B O U R G
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick
Street, W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136072/27.
(130166037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Elliot Promotions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 443, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 169.418.
EXTRAIT
Les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, 443, rue de Neudorf en date du 3 septembre 2012 et ont pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
- Ratifient la démission des administrateurs A, Messieurs Mile Jovanovic et Philippe Aulner
- Nomment en tant que administrateur A, Messieurs Jean-Marc Kieffer demeurant 1, rue Mathias Goergen L-8028
Strassen et Daniel Hein demeurant 21, rue de Verdun F-57480 Kirsch-les-Sierck
Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2012.
Pour extrait conforme
Camille Koener / Philippe Aulner / Mile Jovanovic
<i>Le président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2013136054/18.
(130165998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Casino Operators S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 111.794.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick
Street, W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
131919
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136073/27.
(130166045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
EnCo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.296.875,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 148.840.
<i>Extrait du projet commun de fusion transfrontalière prenant effet au 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2013i>
En vertu du projet commun de fusion transfrontalière prenant effet au 1
er
juillet 2013, les parts sociales de la Société
ont été transférées comme suit:
- 90.375 parts sociales détenues dans la Société par Columbus Prime sp.z o.o., ayant son siege social au 18, Targowa
St, PL-25-520 Kielce, Pologne ont été transférées à Barcocapital Investment Limited, ayant son siège social au 15, Agios
Pavlos Street, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nicosia, Chypre.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013136056/18.
(130165824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
General Electric International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 62.841.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence
à Mondorf, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 21
mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 21 juin 2013.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2013136124/14.
(130165694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European News Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 101.757.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
131920
L
U X E M B O U R G
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick
Street, W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136074/27.
(130166025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Cerigo Développement Un S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 147.852.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 26 Septembre 2013 que:
- Madame Joy Bainville a démissionné de sa fonction en tant que gérant de type A de la Société avec effet au 26
Septembre 2013.
- Monsieur Dwight Cupit, né le 09 Mai 1969 né à Sydney en Australie et résident professionnellement au 81 Michelin
House, Fulham Road, SW3 6RD au Royaume-Uni, est nommé en tant que gérant de type A de la Société avec effet au
26 Septembre 2013.
Par conséquent le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- Olivier Dorier, Gérant B
- Stewart Kam Cheong, Gérant B
- Dwight Cupit, Gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 27 Septembre 2013.
Référence de publication: 2013135995/21.
(130166185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Opticians S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 114.902.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick
Street, W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
131921
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136075/27.
(130165383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
FedEx Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.468.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence
à Mondorf, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23
mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 juin 2013.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2013136086/14.
(130165698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Elia Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 86.097.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2013 tenue au siège social de la société 74, ruei>
<i>de Merl. L-2146i>
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Résolution 1: Révocation du mandat de Monsieur Jan Gesquière en tant qu'administrateur et président de la Sociétéi>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de révoquer, rétroactivement au 05 septembre, le mandat de Monsieur Jan
Gesquière en tant qu'administrateur et président de la Société.
<i>Résolution 2: Nomination de Madame Lieve Kerckhof en tant qu'administrateur de la Sociétéi>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Madame Lieve Kerckhof, demeurant professionnellement au 20,
boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, en tant qu'administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Jan
Gesquière.
Son mandat prend effet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 20 septembre 2013 pour se
terminer immédiatement après l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014 relative à l'exercice clôturé au 31 dé-
cembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013136067/23.
(130165685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
ECSA S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R.C.S. Luxembourg B 32.194.
EXTRAIT
Suite aux démissions de la société ANDREAS CAPITAL SUXESKEY S.A. (anc. "Suxeskey") le 15/08/2013, de Mme.
GOKKE Raymonde le 01/07/2013 et de Mr SEEN Albert le 20/12/2012, jusqu'alors administrateurs, et de AUTONOME
DE REVISION S.A, le 15/08/2013 en tant que commissaire, il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordi-
nairement à Larochette le 23 septembre 2013 que les personnes suivantes ont été élues jusqu'à l'assemblée qui se tiendra
en 2014:
<i>Administrateurs:i>
- ANDREAS MANAGEMENT SERVICES Sàrl, société de droit luxembourgeoise, ayant son siége social à 10-12, rue
de Medernach, L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013;
131922
L
U X E M B O U R G
- Monsieur SCHREUDERS Bastiaan Lodewijk Melchior, ayant son siége professionnel à 1012, rue de Medernach, L-7619
Larochette avec effet à partir du 20/12/2012;
- Monsieur ROTTEVEEL Joseph, demeurant professionnellement à 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette avec
effet à partir du 01/07/2013.
<i>Commissaire:i>
- ANDREAS AUDIT SERVICES, société de droit luxembourgeoise ayant son siége social à 10-12, rue de Medernach,
L-7619 Larochette avec effet à partir du 15/08/2013
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l' Assemblée
désigne Monsieur SCHREUDERS Bastiaan Lodewijk Melchior, 10-12, rue de Medernach, L-7619 Larochette, comme
représentant permanent
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Référence de publication: 2013136061/28.
(130165481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
FINANCIAL BIS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 154.187.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Financial Bis SPF S.A.
Société anonyme de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2013136095/13.
(130166059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Financière de Titrisation S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 121.770.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINANCIERE DE TITRISATION S.A.
Référence de publication: 2013136097/10.
(130166160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Opticians 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.161.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse;
- Davy Beaucé;
131923
L
U X E M B O U R G
- Paul Gunner; et
- Charles Barter.
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Europe III Investments S.à r.l., est désormais au 2 avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, me des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136076/29.
(130165384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Packaging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.012.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 88.435.
<i>Extrait des résolutions des associés de la Société en date du 25 septembre 2013i>
- Les associés ont accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR
12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- Les associés ont nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 25 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
L'adresse de l'associé de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick Street,
W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136077/27.
(130166101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Recreational Vehicles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 100.441.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
131924
L
U X E M B O U R G
- Davy Beaucé.
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick
Street, W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136078/27.
(130166047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
European Vehicle Inspections S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 112.051.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
L'adresse de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est désormais au 30 Warwick
Street, W1B 5AL Londres, Royaume-Uni et son numéro d'enregistrement est le 03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35,rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136079/27.
(130166058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Galilehorn Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 22.250,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 111.049.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
Il résulte d'une résolution de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 29 avril 2013 de renouveler le mandat
du réviseur d'entreprise agréé de la Société, Mazars Luxembourg, une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant
son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B-159.962, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre
2012.
A titre informatif, veuillez noter que Messieurs Ely Michel Ruimy et Franck Ruimy, gérants de la Société, résident
désormais professionnellement au 49 Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Grande Bretagne.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
It follows from a resolution of the sole shareholder of the Company dated 29 April 2013 that Mazars Luxembourg, a
public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Trade and
Companies Register of Luxembourg under number B-159.962, has been renewed in its mandate as external auditor
131925
L
U X E M B O U R G
("réviseur d'entreprise agréé") of the Company until the general meeting approving the annual accounts as of 31 December
2012.
For your information, please note that Mr. Ely Michel Ruimy and Mr. Franck Ruimy, managers of the Company, now
reside professionally at 49 Grosvenor Street, W1K 3HP London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136106/26.
(130165581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Finorma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 142.104.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné
comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'admi-
nistration de la société FINORMA S.A., société anonyme: Madame Nathalie LETT, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Yves BIEWER.
Luxembourg, le 26.09 2013.
<i>Pour: FINORMA S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Johanna Tenebay / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2013136099/18.
(130165491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Gérances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8838 Wahl, 38, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 145.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136105/10.
(130166135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Genpact Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 28.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 131.149.
<i>Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique prise en date du 16 septembre 2013i>
La nomination de Monsieur Gianni Giacomelli, né le 6 décembre 1969 à Florence, Italie, avec adresse professionnelle
au 1155 Avenue of the Americas, 4
th
Floor, New York 10036, Etats Unis, en tant que gérant de catégorie A est approuvée.
Son mandat prendra effet à compter du 16 septembre 2013 pour une durée indéterminée.
Le Conseil de Gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:
<i>Gérants de catégorie Ai>
- Lucinda FULL
- HeatherWHITE
- Gianni GIACOMELLI
<i>Gérants de catégorie Bi>
- Harald CHARBON
- Marc LIMPENS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
131926
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Genpact Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2013136108/25.
(130165739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Gerona Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.388.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 23 septembre 2013i>
En date du 23 septembre 2013, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter les démissions de Geneviève Blauen-Arendt, Alexandra Fantuz et Philip Godley en tant que gérants de la
Société avec effet au 23 septembre 2013;
- de nommer ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au
13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Lu-
xembourg sous le numéro B103336, ayant un capital social de 12,500.- EUR, en tant que gérant de la Société avec effet
au 23 septembre 2013 et pour une durée illimitée;
- de transférer le siège social de la Société du 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, avec effet au 23 septembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013136109/22.
(130165703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Radiant Fund S.C.A. SICAV FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 159.100.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26.09.2013.
<i>Pour: RADIANT FUND S.C.A. SICAV-FIS
i>Fonds d'Investissement Spécialisé - Société en Commandite par Actions
Experta Luxembourg
Société anonyme
Nathalie Lett / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2013136339/16.
(130165550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
REF IV Associates (Caymans) L.P. Child Wear CIV S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 11.100.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.137.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2013136341/10.
(130165797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
131927
L
U X E M B O U R G
Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.449.
1) Suite au changement d'adresse du siège social de l'associé unique, veuillez noter la nouvelle adresse comme suit:
Goodrich Luxembourg S.C.S., dont le siège social est désormais 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2) Par résolutions signées en date du 19 septembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Démission du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013: Monsieur Mark Bole
- Nomination du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:
Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, né le 21 mars 1973 à Bangkok, Thailande, ayant son adresse professionnelle
à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Christiaan Frederik van Arkel
<i>Gérant de Classe Ai>
Référence de publication: 2013136111/20.
(130166056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Cytolnat International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 85.880.
VERSION CORRIGEE des documents déposés antérieurement
Sous le n°L130143471
REMPLACE la 1
ère
version
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013136028/13.
(130165776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Partners Group Global Real Estate 2013 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 180.399.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the on the seventeenth day of September.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. Partners Group Management III S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with its registered
office at 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, represented by Ms Solange Wolter, professionally residing in Lu-
xembourg, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29 August 2013; and
2. Partners Group Finance EUR IC Limited, Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, GY1 6BD Guernsey, represented
by represented by Ms Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
prenamed, pursuant to a proxy dated 3 September 2013.
The proxies signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
association of a société en commandite par actions which they form between themselves (the "Articles"):
Art. 1. Establishment. There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares hereafter issued,
a corporation in the form of a société en commandite par actions with variable capital qualifying as investment company
131928
L
U X E M B O U R G
in risk capital under the law of 15
th
June 2004, as amended (the "2004 Law") under the name of "Partners Group Global
Real Estate 2013 S.C.A., SICAR" (the "Corporation").
Art. 2. Term. The Corporation is established for a period expiring on 31
st
December 2026, provided that the Cor-
poration by Shareholder Resolution (according to the term defined hereafter) taken under the conditions for amendments
of these Articles may be dissolved prior to this date or continued for up to 3 (three) additional one-year periods.
Art. 3. Purpose.
(a) The object of the Corporation is to invest directly or indirectly in real estate assets and other instruments with
similar characteristics worldwide as determined by the Manager, representing risk capital within the meaning of article 1
of the 2004 Law, in order to provide its Investors with the benefit of the result of the management of its assets in
consideration of the risk which they incur.
(b) The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development
and accomplishment of its purpose including (i) to borrow in any form and (ii) to grant guarantees by way of mortgage,
charge, pledge, assignment of a security interest or otherwise in all or any of its assets including Remaining Commitments
(including for the avoidance of doubt any of the claims) of the Corporation to secure the obligations of the Corporation
towards its Shareholders or third parties each time to the full extent permitted by the 2004 Law, provided that the other
provisions of these Articles will be complied with.
(c) The Corporation may not undertake any other investment activities except for holding short-term bank deposits,
cash and cash equivalents, high quality short-term money market mutual funds and borrowing of funds pursuant to Article
13 (c).
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand-
Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established in Luxembourg by resolution of the Manager. If and
to the extent permitted by law, the Manager may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg.
Art. 5. Share Capital.
(a) The share capital of the Corporation shall be represented by Shares without nominal value and shall at all times be
equal to the Corporation's total net assets.
(b) The Corporation is incorporated with a share capital of thirty-three thousand Euro (EUR 33,000).
(c) The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Corporation or to any other duly authorized
person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares issued.
(d) The share capital of the Corporation shall be represented by the following classes of Shares:
(i) Ordinary Shares issued to Investors, generally for a subscription price of one thousand Euros (EUR 1,000); and
(ii) Manager Shares issued to the Manager, generally for a subscription price of one Euro cent (EUR 0.01).
(e) No preferential subscription rights are granted.
(f) The Manager may fully or partially return to Shareholders the amounts paid in connection with the subscription of
Shares, provided that such amounts may be recallable at times and under the conditions determined by the Manager.
(g) The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder are referred to as "Contributions".
(h) The Manager will determine the dates of the share offerings of the Corporation for the admission of additional
Investors (each a "Share Offering"), and may hold further Share Offerings over a period of eighteen months following the
initial Share Offering. The Share Offering period may, in the discretion of the Manager, be extended by up to 12 months.
(i) The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
(j) The minimum capital, as defined in the 2004 Law, which must be achieved within twelve months after the date on
which the Corporation has been authorised as a société d'investissement en capital à risque under Luxembourg law, shall
be one million Euros (EUR 1,000,000).
Art. 6. The Manager.
(a) The "associé-gérant-commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation
organised under the laws of Luxembourg (the "Manager").
(b) The Manager is jointly and severally liable for all liabilities to third parties which cannot be met out of the assets
of the Corporation. The Manager shall not be liable on its own assets for the payment of (i) any distributions to Share-
holders or (ii) the return of Contributions to Investors.
Art. 7. Liability of Investors.
(a) The Investors are not permitted to act on behalf of the Corporation in any manner or capacity other than by
exercising their rights at Shareholder meetings.
(b) The Investors shall be solely liable for payment to the Corporation of (i) the subscription price on any Ordinary
Shares and any Remaining Commitment (according to the term defined hereafter), (ii) the return of distributions, (iii), if
131929
L
U X E M B O U R G
applicable, an Entry Charge (according to the term defined hereafter) and (iv) its obligation to pay withholding tax amounts
where applicable.
Art. 8. Share Register.
(a) All issued Shares of the Corporation shall be recorded in the Shareholder register (the "Register"). The Register
shall contain the name of each Shareholder, their residence, registered office or elected domicile, the number and class
of Shares held, the amount paid in on the Shares, and the banking account details of the Shareholders.
(b) Until notices to the contrary have been received by the Corporation, it may treat the information contained in the
Register as accurate and up-to-date and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and
announcements and the inscribed banking account details for the making of any payments.
(c) The Manager will appoint an entity responsible for the maintenance of the Register.
(d) Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Corporation
of a completed transfer form together with evidence that the purchaser has assumed all obligations in connection with
the Remaining Commitment relating to the respective Interest and such other documentation as the Corporation may
require.
(e) Investors may transfer fully paid Ordinary Shares to Eligible Investors (according to the term defined hereafter).
Their Remaining Commitment (according to the term defined hereafter) may be transferred to the extent the transferee
is (i) creditworthy, as determined by the Manager, and (ii) eligible in accordance with the provisions of the 2004 Law.
To the extent that, and as long as, a respective Interest is part of a German insurance company's or a German pension
fund's "committed asset" ("Sicherungsvermögen") as defined in Sec. 66 of the German Insurance Supervisory Act, as may
be amended from time to time ("Versicherungsaufsichtsgesetz") or "other committed asset" ("Sonstiges gebundenes
Vermögen" as defined in Sec. 54 para 1 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended from
time to time), such Interest shall not be disposed of without the prior written consent of the trustee ("Treuhänder")
appointed in accordance with Sec. 70 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended from time to time,
or by the trustee's authorized deputy.
However, notwithstanding the above, any Interest that is directly or indirectly held by a German insurance company
or a German pension fund and that is part of their committed assets is freely transferable and such transfer will not require
the approval of the Manager provided the transferee is an Eligible Investor and executes the necessary documentation.
Upon the transfer of any Interest that is directly or indirectly held by a Shareholder that is a German insurance company
or German pension fund, the transferee shall accept and become solely responsible for all liabilities and obligations relating
to such Interest held and the transferor shall be released from and shall have no further liability in respect of the Cor-
poration.
(f) Fractions of Shares may be issued up to three decimal places.
(g) Shares will only be issued as registered securities.
(h) Shares will be available in book-entry form. No certificates will be issued.
Art. 9. Commitment.
(a) Investors will irrevocably undertake to subscribe for Ordinary Shares in an amount as set out in the Subscription
Agreement (each a "Commitment").
(b) The minimum Commitment to the Corporation by an Investor will be ten million Euro (EUR 10,000,000) although
the Manager reserves the right to admit Investors with lower Commitments.
(c) The Commitment made by each Investor will be payable in instalments by subscribing for additional Shares in the
Corporation. Prior to each Contribution, the Manager will issue a drawdown notice advising Investors of the portion of
their Commitment required to be contributed to the Corporation and the corresponding number of Shares that will be
issued, whereupon such amount shall be payable within ten (10) calendar days, in cash denominated in Euro, and the
relevant number of Shares shall be issued to Investors on a pro-rata basis (each such event of drawing down capital being
a "Drawdown").
(d) Drawdowns will be made in proportion to the Commitment of each Investor, as needed to satisfy the capital
requirements of the Corporation's investments, to permit the payment of fees and expenses and any other obligations
of the Corporation and to maintain a reserve for the operating expenses of the Corporation.
Art. 10. Eligible Investor.
(a) The Manager on behalf of the Corporation may, at its discretion, restrict or prevent the ownership of Shares in
the Corporation by any person, firm or corporate body.
(b) Only Eligible Investors are permitted to hold an Interest in the Corporation.
(c) The Manager may, at its discretion, delay the acceptance of any application for an Interest until such time as sufficient
documentation has been provided verifying that the applicant qualifies as an Eligible Investor.
(d) If the Corporation determines that an Investor is not an Eligible Investor, or is in breach of its obligations, repre-
sentations or warranties or fails to make such representations or warranties or fails to deliver information (for example
131930
L
U X E M B O U R G
as required under the United States Foreign Account Tax Compliance Act of 2010 or similar law)as the Manager may
require, the Manager may:
A. require/cause such Investor or Ordinary Shareholder to sell all or part of its Interest at a price determined in
accordance with the following provisions:
(i) the Corporation shall serve a notice (the "Purchase Notice") upon the Investor, specifying the Interest to be pur-
chased as aforesaid, the price to be paid for such Interest (the "Purchase Price"), and the place at which the Purchase
Price in respect of such Interest is payable. Any such notice may be served upon such Investor by posting the same in a
prepaid registered envelope addressed to such Investor at its last address known to or appearing in the Register. Imme-
diately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Investor shall cease to be the owner
of the Interest specified in such notice and its name shall be removed as to the respective Shares in the Register;
(ii) the Purchase Price of the Interest shall be an amount equal to 75% of the market value of the Investor's Interest,
such value being determined by the Manager obtaining price quote(s) within the market;
(iii) payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Interest, except during periods of exchange
restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
Purchase Notice) for payment to such owner. Upon deposit of such price as aforesaid the person specified in such
Purchase Notice shall have no further interest in the Corporation, or any claim against the Corporation or its assets in
respect thereof, except the right to receive the price so deposited (without interest) from such bank.
B. redeem Ordinary Shares from such Investor Shareholders in accordance with provisions of Article 17.
(e) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated
in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true
ownership of any Shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any Purchase Notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith.
(f) In addition to any liability under applicable law, each Investor who does not qualify as an Eligible Investor, and who
holds an Interest, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the Manager, the other Investors and Ordinary
Shareholders and the Corporation's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such
holding in circumstances where the relevant Investor had furnished misleading or untrue documentation or had made
misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the
Corporation of its loss of such status.
Art. 11. Annual General Meeting.
(a) The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Friday of the month of June at 6.00 p.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in Luxem-
bourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the preceding bank business day.
(b) Other Shareholder meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective meeting
notices.
Art. 12. Shareholder Meetings.
(a) All Shareholder meetings shall be presided over by the Manager.
(b) Any duly convened Shareholder meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest
power to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.
(c) A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by:
(i) appointing another person as its proxy in writing, or
(ii) providing written confirmation to the Manager instructing the manner in which it elects to vote on respective
agenda points provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the
relevant Shareholder, (2) the indication of the Shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda
as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the
agenda. The original voting bulletins must be received by the Corporation 24 hours before the relevant Shareholder
meeting.
(d) Each Manager Share and each Ordinary Share carries one vote at all Shareholder meetings.
(e) All Shares will vote as one class unless otherwise required by law or provided in these Articles.
(f) Except as otherwise required by law or provided in these Articles, resolutions at a Shareholder meeting (a "Sha-
reholder Resolution") shall require the approval of:
(i) a simple majority of the votes cast by the Shareholders present or represented, and
(ii) the Manager.
(g) Any resolution at a Shareholder meeting deciding that the Corporation will no longer qualify as investment company
in risk capital under the 2004 Law will need to be passed by a unanimous vote of all Shareholders and the Manager and
requires prior approval by the Luxembourg supervisory authority.
131931
L
U X E M B O U R G
(h) The Manager shall provide at least 8 days prior notice of any Shareholder meeting as required under Luxembourg
law.
(i) The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
Shareholder meeting.
(j) Votes cast as used in these Articles shall not include votes attaching to Shares in respect of which a Shareholder
has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.
(k) The Manager is obliged to convene a Shareholder meeting so that it is held within a period of one month if
Shareholders representing 10% of the Corporation's capital require so in writing with an indication of the agenda.
Art. 13. Manager Powers.
(a) The Manager has the broadest power to perform all acts of administration and disposition of the Corporation and
to investigate, pursue and conclude transactions. All powers that are not reserved by law or these Articles to the general
meeting of Shareholders are within the powers of the Manager.
(b) The Manager shall determine the investment policy and the borrowing policy of the Corporation, subject to the
restrictions established by (i) Luxembourg law, (ii) regulatory authorities, and (iii) these Articles.
(c) The Manager is authorized to borrow on behalf of the Corporation. The Manager shall only utilize borrowings in
accordance with applicable laws and regulations and subject to rates commercially available for such borrowing.
(i) Subject to Article 13(c)(ii) below, the Manager shall not cause the Corporation to undertake borrowing (at any one
time) in an amount which exceeds the higher of (i) 10% of the aggregate Commitments; or (ii) the lesser of 25% of the
aggregate Commitments and 100% of Remaining Commitments, unless otherwise unanimously advised by the Advisory
Board; provided that prior to the final Share Offering, the Manager acting on behalf of the Corporation may borrow in
any form(at any one time) up to the higher of (i) 50 million Euros, or (ii) 100% of Remaining Commitments.
(ii) To the extent there are Shareholders who are subject to the German Insurance Supervisory Act provisions, then
the Manager shall not, after the final Share Offering, cause the Corporation to undertake any borrowing except for short-
term borrowing (i.e. up to one year) in an amount that exceeds 10% of the net asset value of the Corporation.
(d) Pursuant to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009
and (EU) No 1095/2010, the Manager has designated Partners Group (UK) Ltd as its external "Alternative Investment
Fund Manager"; and the Manager may also appoint service providers or administrative agents as permitted by applicable
rules and regulations. The Manager may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their
services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Corporation.
(e) The Manager may establish an advisory board ("Advisory Board") that will be responsible certain matters referred
to it by the Manager such as risk management and conflicts of interest.
(f) The Manager may at any time decide to proceed to the listing of the Ordinary Shares of the Corporation on any
stock exchange or market. Should the Manager proceed with a listing, the Prospectus will be updated.
Art. 14. Due Authorisation. The Corporation shall be bound by the joint signatures of any duly authorised directors
or officers of the Manager or by the signature of any other persons to whom authority shall have been delegated by the
Manager.
Art. 15. Exculpation & Indemnification.
(a) No Indemnified Party (as defined below) shall be liable to the Corporation or any Investor for any act or omission
taken or suffered by such Indemnified Party in the reasonable belief that such act or omission is or is not, contrary to the
best interests of the Corporation and is within the scope of authority granted to such Indemnified Party, provided that
such acts or omissions do not constitute gross negligence or a material violation of such Indemnified Party's obligations
to the Corporation.
(b) To the fullest extent permitted by law, the Corporation shall indemnify and hold harmless the Manager or its
affiliates, and any of their respective employees, officers, directors, agents, controlling persons or representatives (each
an "Indemnified Party") from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including
amounts paid in satisfaction of judgments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs
and expenses of investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unk-
nown, liquidated or unliquidated (collectively "Losses"), that are incurred by any Indemnified Party and arise out of or are
related to the affairs or activities of the Corporation, including acting as a director of a target company, or the performance
by such Indemnified Party of any of its responsibilities hereunder or otherwise in connection with being or having been
a director or officer of the Corporation; provided that an Indemnified Party shall not be entitled to indemnification
hereunder to the extent it is determined by any court or governmental body of competent jurisdiction that such Losses
resulted directly from the Indemnified Party's gross negligence, wilful misconduct, or material breach of a material term
of the Articles provided that such right of indemnification shall be reinstated in the event of such determination being
reversed (Losses shall also include all costs and expenses incurred by the Indemnified Party in connection with obtaining
a reversal of such determination).
131932
L
U X E M B O U R G
(c) The right of any Indemnified Party to the indemnification provided herein shall be cumulative of, and in addition to,
any and all rights to which such Indemnified Party may otherwise be entitled by contract or as a matter of law or equity
and shall extend to such Indemnified Party's successors, assigns and legal representatives.
(d) Any Indemnified Party shall first seek to recover under any other indemnity or any insurance policies by which
such Indemnified Party is indemnified or covered, as the case may be, but only to the extent that the indemnitor with
respect to such indemnity or the insurer with respect to such insurance policy provides (or acknowledges its obligation
to provide) such indemnity or coverage, as the case may be, on a timely basis. To the extent an Indemnified Party is
indemnified pursuant to this Article 15 and subsequently recovers an amount in relation to the same matter from such
indemnitor or insurer then such Indemnified Party shall account to the Corporation for the amount so recovered after
deduction of all costs and expenses incurred in procuring recovery and all taxes thereon. The Indemnified Party shall
obtain the written consent of the Manager prior to entering into any compromise or settlement which would result in
an obligation of the Corporation to indemnify such Indemnified Party.
Art. 16. Contribution and Recontribution Obligations.
(a) The Corporation may require Investors to (i) make Contributions, and/or (ii) recontribute to the Corporation
amounts up to 50% of the aggregate distributions previously made to them less any amounts they have re-contributed
to the Corporation, in order to satisfy indemnification or any other obligations of the Corporation.
(b) All of the foregoing contribution or recontribution obligations shall continue until the liquidation of the Corpora-
tion. The Corporation may make provision in order to satisfy indemnification or other obligations of the Corporation
after the liquidation of the Corporation.
Art. 17. Share Redemption and Defaulting Investors.
(a) No redemption of Shares may be requested by the Shareholders.
(b) A redemption of Shares at the discretion of the Manager shall in particular be possible:
(i) in respect of the Shares issued in connection with the incorporation of the Corporation;
(ii) for the purpose of temporarily returning to Investors a portion of the capital paid in connection with any Share
Offering or Drawdown;
(iii) for the purpose of distributing proceeds from investments;
(iv) in the situations detailed in Article 10(d).
(c) Shares will generally be redeemed for:
(i) the respective subscription price in relation to redemptions as set out in Article 17(b)(i) and (ii);
(ii) the latest reported Net Asset Value (according to the term defined thereafter) in relation to redemptions as set
out in Article 17(b (iii);
(iii) 75% of the market value of Ordinary Shares, such value being determined by the Manager obtaining prices quote
(s) within the market, to be redeemed in relation to redemptions set out in Article 17(b)(iv).
(d) The Manager shall retain flexibility in using the respective subscription price or the latest reported Net Asset Value,
if deemed necessary and taking into account the interests of the Investors/ Shareholders.
(e) Redeemed Shares will be cancelled by the Corporation.
(f) If at any time:
(i) any representation made by an Investor to the Corporation in connection with the acquisition of Ordinary Shares
by such Investor is determined by the Manager not to be true and correct in any respect; or
(ii) an Investor does not fulfil its obligations towards the Corporation and in particular where such Investor has
committed to subscribe for further Ordinary Shares and fails to honour its commitment to make further Contributions
within the timeframe required,
then the Manager has the authority in the absence of curing of the above defaults within a reasonable time period
determined by the Manager to (A) suspend or terminate the pecuniary rights attached to all or part of the Ordinary
Shares previously subscribed and paid for by the defaulting Investor, or (B) cause the sale and transfer to a new Investor
of the Interest held by the defaulting Investor for a price equal to the Purchase Price as detailed in Article 10, or (C)
reduce the Commitment of the defaulting Investor, or (D) withdraw the defaulting Investor's right to make Contributions
or (E) apply any combination of the above or such other measure as it deems appropriate.
(g) Each Investor expressly acknowledges the strict default provisions in these Articles and that it has been accepted
as an Investor in the Corporation in reliance upon its agreement to the provisions of these Articles, and that where an
Investor fails to fulfil its obligations to the Corporation set out in Article 17(f)(ii) then the Manager may have no other
option than to terminate a defaulting Investor's pecuniary rights in connection with its Ordinary Shares.
Art. 18. Net Asset Value of Shares.
(a) The net asset value of Ordinary Shares in the Corporation (the "Net Asset Value") shall be determined on each
Valuation Day (according to the term defined hereafter)in accordance with this Article 18.
(b) The Net Asset Value in accordance with fair valuation methods shall be expressed as a per share figure and shall
be determined by:
131933
L
U X E M B O U R G
(i) first, establishing the value of assets less the liabilities of the Corporation (including any adjustments as considered
by the Corporation to be necessary or prudent);
(ii) second, allocating the portion of assets and liabilities to Ordinary Shares according to the aggregate Contributions
of Ordinary Shares, adjusted as necessary to take into consideration any additional fees or distributions to which Ordinary
Shares may be entitled; and
(iii) finally, dividing the total assets and liabilities allocated to Ordinary Shares by the total number of Ordinary Shares
on the Valuation Day.
(c) The valuation of the Corporation's assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted
valuation principles in compliance with article 5 (3) of the 2004 Law:
(i) liquid assets shall be valued at their face value with interest accrued;
(ii) investments in target funds shall be valued according to the most recent valuation report received from the general
partners of the target funds adjusted for net capital activity; and
(iii) other investments and other property and assets of the Corporation shall be valued according to the applicable
accounting principles as set out in the Prospectus.
(d) The Manager or one of its affiliates is responsible for the valuation of the Corporation's investments, which will be
valued according to International Financial Reporting Standards.
(e) The Net Asset Value for Ordinary Shares will be made available to Shareholders at the registered office of the
Corporation within a period of time following the relevant Valuation Day as disclosed in the Prospectus.
(f) The determination of the Net Asset Value may be suspended during any period if, in the reasonable opinion of the
Manager, a fair valuation of the assets of the Corporation is not practical for reasons beyond the control of the Corpo-
ration.
Art. 19. Accounting Year and Auditors.
(a) The accounting year of the Corporation shall begin on 1
st
January and shall terminate on the 31
st
December of
the same year, with the exception of the first accounting year which shall begin on the date of the incorporation of the
Corporation and shall terminate on the 31
st
December 2014.
(b) The annual general meeting of Shareholders shall appoint independent auditors.
(c) Accounting of the Corporation shall be based on the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (Lux
GAAP).
Art. 20. Distributions.
(a) The results allocated to Ordinary Shares shall be distributed in accordance with the provisions of these Articles.
(b) Within the limits provided by law distributions of results and capital may be made at the discretion of the Manager.
(c) The Manager shall apply the following distribution policies:
(i) Distributable proceeds derived from investments will be distributed by the Manager from time to time, provided
that the Manager may retain reasonable amounts to pay or provide reserves for expenses and other obligations of the
Corporation, including fees payable to the Manager or for re-investment purposes; and
(ii) The Corporation may receive proceeds from the Corporation's investments in the form of marketable securities.
The Manager will seek to sell such securities and distribute the net cash proceeds; Shareholders will bear any associated
market risk and related costs incurred during the disposition process.
(iii) The Manager shall not distribute securities to Shareholders other than at the time of dissolution of the Corporation
or with the approval of a simple majority of the votes cast with respect to Ordinary Shares in issue.
(d) Distributions of proceeds derived from (i) direct investments and (ii) secondary investments (each, a "Class") will
be made first to Investors in proportion to their Commitments and subsequently to the Manager (as holder of Manager
Shares) as an incentive allocation ("Incentive Allocation") in the following order of priority:
(i) first, 100% shall be distributed to Shareholders until the aggregate distributions derived from the relevant Class
under this paragraph (i) equal the Shareholders' aggregate Contributions in respect of the relevant Class (the "Relevant
Contributions"), plus an amount sufficient to provide the Shareholders, in aggregate, with a preferred rate of return of
8% per annum on the cash flows relating to such Class (the "Preferred Return"), such cash flows being comprised of the
Relevant Contributions and distributions relating to such Class;
(ii) second, 100% shall be paid to the Manager as an Incentive Allocation until such time as the Manager has received
the Specified Percentage of the sum of the distributed Preferred Return and the Incentive Allocation payments made
under this clause (ii) (full catch up);
(iii) third, provided that the Manager has received the Specified Percentage under clause (ii), then (a) 100% minus the
Specified Percentage shall be distributed to the Shareholders and (b) the Specified Percentage shall be paid to the Manager
as an additional Incentive Allocation;
(e) The "Specified Percentage" shall equal 15% for direct investments and 10% for secondary investments. Relevant
Contributions shall include Contributions in respect of the Investment Fees associated with the relevant Class of Invest-
ments.
131934
L
U X E M B O U R G
(f) For the purpose of the Incentive Allocation and the Clawback provisions, calculations shall be based on the dates
when (i) Contributions are made by the Company in respect of the relevant Investments, (ii) the Investment Fees in
respect of the relevant Investments are payable to the Manager and (iii) proceeds derived from the relevant Investments
are received by the Company. All calculations shall be based on the currency in which the respective investment is made,
to ensure that any Incentive Allocation is based on the performance of the relevant investment rather than on currency
fluctuations. Accordingly, it is possible that an Incentive Allocation may not be received by the Manager even though
Shareholders receive significant returns from a particular investment due to changes in currency valuations. Similarly, the
Manager may receive an Incentive Allocation where no profit, on a Euro basis, is realized by the Shareholders. The Manager
may waive, reduce or defer payment of any Incentive Allocation in respect of a given Shareholder or otherwise, and for
purposes of this section, any in-kind distribution shall be treated as if such distribution was made in cash in an amount
equal to the fair value of such in-kind distribution as of the date of such distribution.
(g) Distributions made to Shareholders are subject to recall to satisfy the obligations of the Corporation. Accordingly,
the Shareholders may be required to recontribute such amounts to the Corporation.
(h) In connection with the winding-up of the Corporation (i) the Manager will calculate the Clawback Amount (if any)
in respect of each Class and where any Clawback Amount is outstanding then the Manager shall pay such amount to the
Corporation prior to the final distribution, and (ii) the Corporation shall pay the Manager an amount (if any) as necessary
for the Manager to have received 15% of the Incentive Basis for each Class, provided that no payment shall be made to
the Manager that creates a Clawback Amount.
(i) The "Clawback Amount" is the higher of (i) the Preferred Return Shortfall, and (ii) the positive amount, if any,
required for the Shareholders, in aggregate, to have received cumulative distributions equal to the Shareholder Threshold,
provided that the Clawback Amount in no event shall exceed the aggregate Incentive Allocation payments received by
the Manager with respect to the relevant Class, less any tax paid or payable by the Manager in relation thereto and not
refunded to the Manager. For the purposes of this section:
(j) The "Preferred Return Shortfall" is defined as an amount, if any, required to provide the Shareholders with the
Preferred Return.
(k) The "Incentive Basis" is defined as the positive difference, if any, between (i) the distributions made that are derived
from the relevant Class and (ii) Relevant Contributions.
(l) The "Shareholder Threshold" means the sum of (i) the Relevant Contributions of the Shareholders, and (ii) (100%
minus the Specified Percentage) multiplied by the Incentive Basis.
Art. 21. Liquidation.
(a) In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed at a Shareholder meeting effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their remuneration.
(b) The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to Shareholders pursuant to the rules set
forth in Article 20.
(c) The net proceeds may be distributed in kind.
Art. 22. Amendment to Articles. Subject to the prior approval by the Luxembourg supervisory authority, these Articles
may be amended from time to time by Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and
the following related articles) and article 67-1 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended,
("1915 Law"). In addition, any proposed amendment to these Articles will become valid and effective only if separately
approved by a simple majority of the Ordinary Shares in issue.
Art. 23. Governing Regulation. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the
1915 Law and the 2004 Law.
Art. 24. Definitions. These definitions form an integral part of the Articles.
Eligible Investors Pursuant to article 2 of the 2004 Law, either a) professional or institutional investors, or b) other
investors who confirm in writing that they adhere to the status of well-informed investors and are fully aware of the risks
and rewards of this type of investment within the meaning of the 2004 Law and who either invest or are committed to
invest a minimum of 125,000 Euro in the Corporation or have been subject to an assessment made by a credit institution
within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a
management company within the meaning of Directive 2009/65/EC certifying such investor's expertise, experience and
knowledge in adequately appraising an investment in risk capital or c) a person taking part in the management of the
Corporation.
A U.S. Person is prohibited from acquiring Shares in the Corporation.
Entry Charge A charge which may be levied on an Investor admitted to the Corporation subsequent to the initial share
offering.
Interest An Investor's interest in the Corporation being its rights and obligations in connection with any Ordinary
Shares held and its related Remaining Commitment.
131935
L
U X E M B O U R G
Investor(s) The investors who have acquired or have committed to acquire Ordinary Shares in accordance with a
Subscription Agreement. For the avoidance of doubt, any affiliate of the Manager who has acquired or has committed to
acquire Ordinary Shares shall be deemed an Investor.
Manager Share A share issued by the Corporation that has been subscribed to by the Manager.
Ordinary Share A share issued by the Corporation that has been subscribed to by an Investor.
Ordinary Shareholder The holder of Ordinary Shares.
Prospectus The most up-to-date version of the prospectus of the Corporation published in accordance with the 2004
Law.
Remaining Commitments The excess of (i) an Investor's Commitment over (ii) the aggregate amount of such Investor's
Contributions (net of Contributions refunded pursuant to Article 17 (b)(ii)).
Shares The Ordinary Shares and the Manager Shares.
Shareholders The holders of Ordinary Shares and Manager Shares.
Subscription Agreement The agreement the Corporation entered into with each of the Investors in connection with
the commitment to subscribe for a certain number of Ordinary Shares.
U.S. Person Shall have the meaning ascribed in Regulation S, as amended from time to time, of the United States
Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or as in any other Regulation or act which shall come into force
within the United States of America and which shall in the future replace Regulation S or the 1933 Act.
Valuation Day The last day of each month.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Corporation as a result of its organisation are estimated at approximately
EUR 3,000.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereinafter:
Subscribed
capital
Paid-in
amount
Number of shares
1) Partners Group Management III S.à r.l., prenamed . . . . . EUR 31,000 EUR 31,000 3,100,000 Manager Shares
2) Partners Group Management III S.à r.l., prenamed . . . . .
EUR 1,000
EUR 1,000
1 Ordinary Share
3) Partners Group Finance EUR IC Limited, prenamed . . .
EUR 1,000
EUR 1,000
1 Ordinary Share
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 33,000 EUR 33,000
Evidence of the above payment has been given to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first accounting year of the Corporation shall begin on the date of its incorporation and end on 31
st
December
2014.
2. Exceptionally the first annual general meeting of the shareholders of the Corporation will be held on the first
Thursday of the month of March 2015 at 4.00 p.m. (Luxembourg time).
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26, 26-3 and 26-5 of the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>General Meeting of shareholdersi>
The above named persons representing the entire subscribed capital and considering themselves as validly convened,
have immediately proceeded to hold a general meeting of shareholders which resolved as follows:
I. The following company is elected as independent auditor «réviseur d'entreprises agréé»:
PricewaterhouseCoopers, société-cooperative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The mandate shall lapse on the date of the annual general meeting in 2015.
II. The registered office of the Corporation is fixed at 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above named person, this
deed is worded in English only.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, Christian name,
civil status and residence, said appearing person signed together with us, the notary, this original deed.
131936
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: S. WOLTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42907. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den 27. September 2013.
Référence de publication: 2013136298/478.
(130165926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Partners Group Direct Mezzanine 2013 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme
d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 180.471.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of September.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. Partners Group Management III S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with its registered
office at 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, represented by Ms Solange Wolter, professionally residing in Lu-
xembourg,101, rue Cents, L-1319 Luxembourg pursuant to a proxy dated 29 August 2013; and
2. Partners Group Finance EUR IC Limited, Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, GY1 6BD Guernsey, represented
by Ms Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg, 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, prenamed, pursuant
to a proxy dated 3 September 2013.
The proxies signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
association of a société en commandite par actions which they form between themselves (the "Articles"):
Art. 1. Establishment. There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares hereafter issued,
a corporation in the form of a société en commandite par actions with variable capital qualifying as investment company
in risk capital under the law of 15
th
June 2004, as amended, (the "2004 Law") under the name of "Partners Group Direct
Mezzanine 2013 S.C.A., SICAR" (the "Corporation").
Art. 2. Term. The Corporation is established for a period expiring on 31
st
December 2026, provided that the Cor-
poration by Shareholder Resolution (according to the term defined hereafter) taken under the conditions for amendments
of these Articles may be dissolved prior to this date or continued for up to 3 (three) additional one-year periods.
Art. 3. Purpose.
(a) The object of the Corporation is to make mezzanine investments on a global basis, investments with similar cha-
racteristics, and/ or investments into any other assets as permitted, representing risk capital within the meaning of article
1 of the 2004 Law, in order to provide its Shareholders with the benefit of the result of the management of its assets in
consideration of the risk which they incur.
(b) The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development
and accomplishment of its purpose including (i) to borrow in any form and (ii) to grant guarantees by way of mortgage,
charge, pledge, assignment of a security interest or otherwise in all or any of its assets including Remaining Commitments
(including for the avoidance of doubt any of the claims) of the Corporation to secure the obligations of the Corporation
towards its Shareholders or third parties each time to the full extent permitted by the 2004 Law, provided that the other
provisions of these Articles will be complied with.
(c) The Corporation may not undertake any other investment activities except for holding short-term bank deposits,
cash and cash equivalents, short-term money market mutual funds and borrowing of funds pursuant to Article 13 (c).
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand-
Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established in Luxembourg by resolution of the Manager. If and
to the extent permitted by law, the Manager may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg.
131937
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Share Capital.
(a) The share capital of the Corporation shall be represented by Shares without nominal value and shall at all times be
equal to the Corporation's total net assets.
(b) The Corporation is incorporated with a share capital of thirty-three thousand Euro (EUR 33,000.-).
(c) The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Corporation or to any other duly authorized
person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares issued.
(d) The share capital of the Corporation shall be represented by the following classes of Shares:
(i) Ordinary Shares, issued generally for a subscription price of one thousand Euro (EUR 1,000); and
(ii) Manager Shares issued to the Manager, generally for a subscription price of one Euro cent (EUR 0.01).
(e) No preferential subscription rights are granted.
(f) The Manager may fully or partially return to Investors the amounts paid in connection with the subscription of
Shares, provided that such amounts may be recallable at times and under the conditions determined by the Manager.
(g) The total amounts contributed to the Corporation by an Investor are referred to as "Contributions".
(h) The Manager will determine the dates of the share offerings of the Corporation for the admission of additional
Investors (each a "Share Offering"), and may hold further Share Offerings over a period of eighteen months following the
initial Share Offering. The Share Offering period may, in the discretion of the Manager, be extended by up to 12 months.
(i) The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,
drawdowns and payments upon drawdown.
(j) The minimum capital, as defined in the 2004 Law, which must be achieved within twelve months after the date on
which the Corporation has been authorised as a société d'investissement en capital à risque under Luxembourg law, shall
be one million Euro (EUR 1,000,000).
Art. 6. The Manager.
(a) The "associé-gérant-commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management III S.à r.l., a corporation
organised under the laws of Luxembourg (the "Manager").
(b) The Manager is jointly and severally liable for all liabilities to third parties which cannot be met out of the assets
of the Corporation. The Manager shall not be liable on its own assets for the payment of (i) any distributions to Share-
holders or (ii) the return of Contributions to Investors.
Art. 7. Liability of Investors / Ordinary Shareholders.
(a) The Shareholders are not permitted to act on behalf of the Corporation in any manner or capacity other than by
exercising their rights at Shareholder meetings.
(b) The Investors shall be solely liable for payment to the Corporation of (i) the subscription price on any Ordinary
Shares and any Remaining Commitment (according to the term defined hereafter), (ii) the return of distributions, (iii), if
applicable, an Entry Charge (according to the term defined hereafter) and (iv) its obligation to pay withholding tax amounts
where applicable.
Art. 8. Share Register.
(a) All issued Shares of the Corporation shall be recorded in the Shareholder register (the "Register"). The Register
shall contain the name of each Shareholder, their residence, registered office or elected domicile, the number and class
of Shares held, and the banking account details of the Shareholders.
(b) Until notices to the contrary have been received by the Corporation, it may treat the information contained in the
Register as accurate and up-to-date and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and
announcements and the inscribed banking account details for the making of any payments.
(c) The Manager will appoint an entity responsible for the maintenance of the Register.
(d) Ordinary Shares are freely transferable to Eligible Investors. Remaining Commitments (according to the term
defined hereafter) may be transferred to the extent the transferee is (i) creditworthy, as determined by the Manager, and
(ii) eligible in accordance with the provisions of the 2004 Law.
To the extent that, and as long as, an Interest/Ordinary Shares are part of a German insurance company's or a German
pension fund's "committed asset" ("Sicherungsvermögen") as defined in Sec. 66 of the German Insurance Supervisory Act,
as may be amended from time to time ("Versicherungsaufsichtsgesetz") or "other committed asset" ("Sonstiges gebun-
denes Vermögen" as defined in Sec. 54 para 1 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended
from time to time), such Interest/Ordinary Shares shall not be disposed of without the prior written consent of the
trustee ("Treuhänder") appointed in accordance with Sec. 70 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amen-
ded from time to time, or by the trustee's authorized deputy.
However, notwithstanding the above, any Interest/Ordinary Shares that are directly or indirectly held by a German
insurance company or a German pension fund and that are part of their committed assets are freely transferable and such
transfer will not require the approval of the Manager. Upon the transfer of any Interest/Ordinary Shares that is directly
or indirectly held by a Shareholder that is a German insurance company or German pension fund, the transferee shall
131938
L
U X E M B O U R G
accept and become solely responsible for all liabilities and obligations relating to such Interest/Ordinary Shares held and
the transferor shall be released from and shall have no further liability in respect of the Corporation.
(e) Fractions of Shares may be issued up to three decimal places.
(f) Shares will only be issued as registered securities.
(g) Shares will be available in book-entry form. No certificates will be issued.
Art. 9. Commitment.
(a) Investors will undertake to subscribe for Ordinary Shares in an amount as set out in the Subscription Agreement
(each a "Commitment").
(b) The minimum Commitment to the Corporation by an Investor will be ten million Euro (EUR 10,000,000) although
the Manager reserves the right to admit Investors with lower Commitments.
(c) The Commitment made by each Investor will be payable in instalments by subscribing for additional Shares in the
Corporation. Prior to each Contribution, the Manager will issue a drawdown notice advising Investors of the portion of
their Commitment required to be contributed to the Corporation and the corresponding number of Shares that will be
issued, whereupon such amount shall be payable within ten (10) calendar days, in cash denominated in EUR, and the
relevant number of Shares shall be issued to Investors on a pro-rata basis (each such event of drawing down capital being
a "Drawdown").
(d) Drawdowns will be made in proportion to the Commitment of each Investor, as needed to satisfy the capital
requirements of the Corporation's investments, to permit the payment of fees and expenses and any other obligations
of the Corporation and to maintain a reserve for the operating expenses of the Corporation.
Art. 10. Eligible Investor.
(a) The Manager on behalf of the Corporation may, at its discretion, restrict or prevent the ownership of Shares in
the Corporation by any person, firm or corporate body.
(b) Only Eligible Investors are permitted to hold Ordinary Shares in the Corporation.
(c) The Manager may, at its discretion, delay the acceptance of any applicant and therefore the acceptance of any
subscription agreement until such time as sufficient documentation has been provided on the Eligible Investor status of
the applicant.
(d) If the Corporation determines that an Investor is no longer an Eligible Investor or an Ordinary Shareholder (or, if
the context so requires, the beneficial owner of the relevant Ordinary Shares) is not or no longer an Eligible Investor, or
if the Investor/Ordinary Shareholder is in breach of its obligations, representations or warranties or fails to make such
representations and warranties or fails to deliver information (for example as required under the United States Foreign
Account Tax Compliance Act of 2010 or similar law) as the Manager may require, the Manager may:
A). require/cause such Investor or Ordinary Shareholder to sell all or part of its Interest/Ordinary Shares at a price
determined in accordance with the following provisions:
(i) the Corporation shall serve a notice (the "Purchase Notice") upon the Investor, specifying the Interest/Ordinary
Share to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such Interest/Ordinary Share (the "Purchase Price"), and the
place at which the Purchase Price in respect of such Interest/Ordinary Share is payable. Any such notice may be served
upon such Investor/Ordinary Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such In-
vestor/Ordinary Shareholder at its last address known to or appearing in the Register;
(ii) the Purchase Price of the Interest/Ordinary Share shall be an amount equal to 75% of the market value of the
Investor's Interest/Ordinary Share, such value being determined by the Manager obtaining price quote(s) within the
market;
(iii) payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Interest/Ordinary Share, except during periods
of exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified
in the Purchase Notice) for payment to such owner. Upon deposit of such price as aforesaid the person specified in such
Purchase Notice shall have no further interest in the Corporation, or any claim against the Corporation or its assets in
respect thereof, except the right to receive the price so deposited (without interest) from such bank or
B). redeem Ordinary Shares from such Investor / Ordinary Shareholders in accordance with the provisions of Article
17.
(e) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated
in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Ordinary Shares by any person or that the
true ownership of any Ordinary Shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any Purchase
Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith.
(f) In addition to any liability under applicable law, each Investor / Ordinary Shareholder who does not qualify as an
Eligible Investor, and who holds an Interest/Ordinary Share, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the
Manager, the other Investors and Ordinary Shareholders and the Corporation's agents for any damages, losses and
expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant Investor / Ordinary Share-
holder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully
establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the Corporation of its loss of such status.
131939
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Annual General Meeting.
(a) The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at
the registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Friday of the month of June at 5.30 p.m. (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in Luxem-
bourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the preceding bank business day.
(b) Other Shareholder meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective meeting
notices.
Art. 12. Shareholder Meetings.
(a) All Shareholder meetings shall be presided over by the Manager.
(b) Any duly convened Shareholder meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest
power to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.
(c) A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by:
(i) appointing another person as its proxy in writing, or
(ii) providing written confirmation to the Manager instructing the manner in which it elects to vote on respective
agenda points provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the
relevant Shareholder, (2) the indication of the Shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda
as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the
agenda. The original voting bulletins must be received by the Corporation 24 hours before the relevant Shareholder
meeting.
(d) Each Manager Share and each Ordinary Share carries one vote at all Shareholder meetings.
(e) All Shares will vote as one class unless otherwise required by law or provided in these Articles.
(f) Except as otherwise required by law or provided in these Articles, resolutions at a Shareholder meeting (a "Sha-
reholder Resolution") shall require the approval of:
(i) a simple majority of the votes cast by the Shareholders present or represented, and
(ii) the Manager.
(g) Any resolution at a Shareholder meeting deciding that the Corporation will no longer qualify as investment company
in risk capital under the 2004 Law will need to be passed by a unanimous vote of all Shareholders and the Manager and
requires prior approval by the Luxembourg supervisory authority.
(h) The Manager shall provide at least 8 days prior notice of any Shareholder meeting as required under Luxembourg
law.
(i) The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any
Shareholder meeting.
(j) Votes cast as used in these Articles shall not include votes attaching to Shares in respect of which a Shareholder
has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.
(k) The Manager is obliged to convene a Shareholder meeting so that it is held within a period of one month if
Shareholders representing 10% of the Corporation's capital require so in writing with an indication of the agenda.
Art. 13. Manager Powers.
(a) The Manager has the broadest power to perform all acts of administration and disposition of the Corporation and
to investigate, pursue and conclude transactions. The Manager may at any time decide to proceed to the listing of the
Ordinary Shares of the Corporation on any stock exchange or market. All powers that are not reserved by law or these
Articles to the general meeting of Shareholders are within the powers of the Manager.
(b) The Manager shall determine the investment policy and the borrowing policy of the Corporation, subject to the
restrictions established by (i) Luxembourg law, (ii) regulatory authorities, and (iii) these Articles.
(c) The Manager is authorized to borrow on behalf of the Corporation. The Manager shall only utilize borrowings in
accordance with applicable laws and regulations and subject to rates commercially available for such borrowing.
(i) Subject to Article 13(c)(ii) below, the Manager shall not cause the Corporation to undertake borrowing (at any one
time) in an amount which exceeds 50% of the aggregate Commitments unless unanimously advised by the Advisory Board;
provided that prior to the final Share Offering, the Manager acting on behalf of the Corporation may borrow in any form
(at any one time) up to the higher of (i) 50 million Euro, or (ii) 100% of Remaining Commitments.
(ii) To the extent there are Shareholders who are subject to the German Insurance Supervisory Act provisions, then
the Manager shall not, after the final Share Offering, cause the Corporation to undertake any borrowing except for short-
term borrowing (i.e. up to one year) in an amount that exceeds 10% of the net asset value of the Corporation.
(d) Pursuant to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009
and (EU) No 1095/2010, the Manager has designated Partners Group (UK) Ltd as its external "Alternative Investment
Fund Manager"; and the Manager may also appoint service providers or administrative agents as permitted by applicable
131940
L
U X E M B O U R G
rules and regulations. The Manager may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their
services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Corporation.
(e) The Manager may establish an advisory board ("Advisory Board") that will be responsible for certain matters
referred to it by the Manager such as risk management and conflicts of interest.
Art. 14. Due Authorisation. The Corporation shall be bound by the joint signatures of any duly authorised directors
or officers of the Manager or by the signature of any other persons to whom authority shall have been delegated by the
Manager.
Art. 15. Exculpation & Indemnification.
(a) No Indemnified Party (as defined below) shall be liable to the Corporation or any Investor / Shareholder for any
act or omission taken or suffered by such Indemnified Party in the reasonable belief that such act or omission is or is not,
contrary to the best interests of the Corporation and is within the scope of authority granted to such Indemnified Party,
provided that such acts or omissions do not constitute gross negligence or a material violation of such Indemnified Party's
obligations to the Corporation.
(b) To the fullest extent permitted by law, the Corporation shall indemnify and hold harmless the Manager or its
affiliates, and any of their respective employees, officers, directors, agents, controlling persons or representatives (each
an "Indemnified Party") from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including
amounts paid in satisfaction of judgments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs
and expenses of investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unk-
nown, liquidated or unliquidated (collectively "Losses"), that are incurred by any Indemnified Party and arise out of or are
related to the affairs or activities of the Corporation, including acting as a director of a target company, or the performance
by such Indemnified Party of any of its responsibilities hereunder or otherwise in connection with being or having been
a director or officer of the Corporation; provided that an Indemnified Party shall not be entitled to indemnification
hereunder to the extent it is determined by any court or governmental body of competent jurisdiction that such Losses
resulted directly from the Indemnified Party's gross negligence, wilful misconduct, or material breach of a material term
of the Articles provided that such right of indemnification shall be reinstated in the event of such determination being
reversed (Losses shall also include all costs and expenses incurred by the Indemnified Party in connection with obtaining
a reversal of such determination).
(c) The right of any Indemnified Party to the indemnification provided herein shall be cumulative of, and in addition to,
any and all rights to which such Indemnified Party may otherwise be entitled by contract or as a matter of law or equity
and shall extend to such Indemnified Party's successors, assigns and legal representatives.
(d) Any Indemnified Party shall first seek to recover under any other indemnity or any insurance policies by which
such Indemnified Party is indemnified or covered, as the case may be, but only to the extent that the indemnitor with
respect to such indemnity or the insurer with respect to such insurance policy provides (or acknowledges its obligation
to provide) such indemnity or coverage, as the case may be, on a timely basis. To the extent an Indemnified Party is
indemnified pursuant to this Article 15 and subsequently recovers an amount in relation to the same matter from such
indemnitor or insurer then such Indemnified Party shall account to the Corporation for the amount so recovered after
deduction of all costs and expenses incurred in procuring recovery and all taxes thereon. The Indemnified Party shall
obtain the written consent of the Manager prior to entering into any compromise or settlement which would result in
an obligation of the Corporation to indemnify such Indemnified Party.
Art. 16. Contribution and Recontribution Obligations.
(a) The Corporation may require Investors to (i) make Contributions, and/or (ii) recontribute to the Corporation
amounts up to 50% of the aggregate distributions previously made to them less any amounts they have recontributed to
the Corporation, in order to satisfy indemnification or any other obligations of the Corporation.
(b) The obligations of the Investors to re-contribute amounts previously distributed to them shall continue and survive
until the earlier of (i) the third anniversary of the date of the relevant distribution was made, or (ii) the liquidation of the
Corporation provided that, if at the end of any such period there are any actions, proceedings or investigations then
pending, the Manager shall notify the Corporation and the Shareholders in writing at such time, and in such cases the
Investors' re-contribution obligations shall survive with respect to any obligations of the Corporation that arise out of
or relate to such action, proceeding or investigation (or any related action, proceeding or investigation based upon the
same or a similar claim) until the date that such action, proceeding or investigation is finally resolved.
Art. 17. Share Redemption and Defaulting Investors.
(a) No redemption of Shares may be requested by the Shareholders.
(b) A redemption of Shares at the discretion of the Manager shall in particular be possible:
(i) in respect of the Shares issued in connection with the incorporation of the Corporation;
(ii) for the purpose of temporarily returning to Investors a portion of the capital paid in connection with any Share
Offering or Drawdown;
(iii) for the purpose of distributing proceeds from investments to Shareholders / Investors; and
(iv) in the situations detailed in Article 10 (d)
131941
L
U X E M B O U R G
(c) Shares will generally be redeemed for:
(i) the respective subscription price in relation to redemptions as set out in Article 17(b)(i) and (ii);
(ii) the latest reported Net Asset Value (according to the term defined hereafter) in relation to redemptions as set
out in Article 17(b) (iii);
(iii) 75% of the market value of Ordinary Shares, such value being determined by the Manager obtaining price quote
(s) within the market, to be redeemed in relation to redemptions set out in Article 17(b) (iv).
(d) The Manager shall retain flexibility in using the respective subscription price or the latest reported Net Asset Value,
if deemed necessary and taking into account the interests of the Investors/Shareholders.
(e) Redeemed Shares will be cancelled by the Corporation.
(f) If at any time:
(i) any representation made by an Investor to the Corporation in connection with the acquisition of Ordinary Shares
by such Investor is determined by the Manager not to be true and correct in any respect; or
(ii) an Investor does not fulfil its obligations towards the Corporation and in particular where such Investor has
committed to subscribe for further Ordinary Shares and fails to honour its commitment to make further Contributions
within the timeframe required,
then the Manager has the authority in the absence of curing of the above defaults within a reasonable time period
determined by the Manager to (A) suspend or terminate the pecuniary rights attached to all or part of the Ordinary
Shares previously subscribed and paid for by the defaulting Investor, or (B) cause the sale and transfer to a new Investor
of the Interest held by the defaulting Investor for a price equal to the Purchase Price as detailed in Article 10, or (C)
reduce the Commitment of the defaulting Investor, or (D) withdraw the defaulting Investor's right to make Contributions
or (E) apply any combination of the above or such other measure as it deems appropriate.
Art. 18. Net Asset Value of Shares.
(a) The net asset value of Ordinary Shares in the Corporation (the "Net Asset Value") shall be determined on each
Valuation Day (according to the term defined hereafter) in accordance with this Article 18.
(b) The Net Asset Value in accordance with fair valuation methods shall be expressed as a per share figure and shall
be determined by:
(i) first, establishing the value of assets less the liabilities of the Corporation (including any adjustments as considered
by the Corporation to be necessary or prudent);
(ii) second, allocating the portion of assets and liabilities to Ordinary Shares according to the aggregate Contributions
of Ordinary Shares, adjusted as necessary to take into consideration any additional fees or distributions to which Ordinary
Shares may be entitled; and
(iii) finally, dividing the total assets and liabilities allocated to Ordinary Shares by the total number of Ordinary Shares
on the Valuation Day.
(c) The valuation of the Corporation's assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted
valuation principles in compliance with article 5 (3) of the 2004 Law:
(i) liquid assets shall be valued at their face value with interest accrued;
(ii) investments in target funds shall be valued according to the most recent valuation report received from the general
partners of the target funds adjusted for net capital activity; and
(iii) other investments and other property and assets of the Corporation shall be valued according to the applicable
accounting principles as set out in the Prospectus.
(d) The Manager, or one of its affiliates, is responsible for the valuation of the Corporation's investments, which will
be valued according to International Financial Reporting Standards.
(e) The Net Asset Value for Ordinary Shares will be made available to Shareholders at the registered office of the
Corporation within a period of time following the relevant Valuation Day as set out in the Prospectus.
(f) The determination of the Net Asset Value may be suspended during any period if, in the reasonable opinion of the
Manager, a fair valuation of the assets of the Corporation is not practical for reasons beyond the control of the Corpo-
ration.
Art. 19. Accounting Year and Auditors.
(a) The accounting year of the Corporation shall begin on 1
st
January and shall terminate on the 31
st
December of
the same year, with the exception of the first accounting year which shall begin on the date of the incorporation of the
Corporation and shall terminate on the 31
st
December 2014.
(b) The annual general meeting of Shareholders shall appoint independent auditors.
(c) Accounting of the Corporation shall be based on the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (Lux
GAAP).
Art. 20. Distributions.
(a) The results allocated to Ordinary Shares shall be distributed in accordance with the provisions of these Articles.
131942
L
U X E M B O U R G
(b) Within the limits provided by law, distributions of results and capital may be made at the discretion of the Manager.
(c) The Manager shall apply the following distribution policies:
(i) Proceeds derived from investments will be distributed by the Manager from time to time, provided that the Manager
may retain reasonable amounts to pay or provide reserves for expenses and other obligations of the Corporation, in-
cluding fees payable to the Manager or for re-investment purposes; and
(ii) The Corporation may receive proceeds from the Corporation's investments in the form of marketable securities.
The Manager will seek to sell such securities and distribute the net cash proceeds; Shareholders will bear any associated
market risk and related costs incurred during the disposition process.
(iii) The Manager shall not distribute securities to Shareholders other than at the time of dissolution of the Corporation
or with the approval of a simple majority of the votes cast with respect to Ordinary Shares in issue.
(d) Distributions of proceeds will be made first to the Shareholders in each case in proportion to their holding and
subsequently to the Manager (as holder of Manager Shares) as an incentive allocation ("Incentive Allocation") in the
following order of priority:
(i) first, 100% shall be distributed to Shareholders until the aggregate distributions made under this paragraph (i) equal
the Shareholders' aggregate Contributions (the "Relevant Contributions"), plus an amount sufficient to provide the Sha-
reholders, in aggregate, with a preferred return of 8% per annum on the cash flows relating to the Corporation (the
"Preferred Return"), such cash flows being comprised of the Relevant Contributions and distributions made to Share-
holders;
(ii) second, 100% shall be paid to the Manager as an Incentive Allocation until such time as the Manager has received
15% of the sum of the distributed Preferred Return and the Incentive Allocation payments made under this clause (ii)
(full catch-up);
(iii) third, provided that the Manager has received the amount under clause (ii), then 85% shall be distributed to the
Shareholders and 15% shall be paid to the Manager as an additional Incentive Allocation;
(iv) The Manager may waive, reduce or defer payment of any Incentive Allocation in respect of a given Shareholder
or otherwise, and for purposes of this section, any in-kind distribution shall be treated as if such distribution was made
in cash in an amount equal to the fair value of such in-kind distribution as of the date of such distribution.
(v) Distributions made to Shareholders are subject to recall to satisfy the obligations of the Corporation. Accordingly,
the Investors may be required to re-contribute such amounts to the Corporation.
(vi) In connection with the winding-up of the Corporation (i) the Manager will calculate the Clawback Amount (if any)
and where any Clawback Amount is outstanding then the Manager shall pay such amount to the Corporation prior to
the final distribution, and (ii) the Corporation shall pay the Manager an amount (if any) as necessary for the Manager to
have received 15% of the Incentive Basis, provided that no payment shall be made to the Manager that creates a Clawback
Amount.
(1) The "Clawback Amount" is the higher of (i) the Preferred Return Shortfall, and (ii) the positive amount, if any,
required for the Shareholders, in aggregate, to have received cumulative distributions equal to the Shareholder Threshold,
provided that the Clawback Amount in no event shall exceed the aggregate Incentive Allocation payments received by
the Manager, less any tax paid or payable by the Manager in relation thereto and not refunded to the Manager. For the
purposes of this section:
(2) The "Preferred Return Shortfall" is defined as an amount, if any, required to provide the Shareholders with the
Preferred Return.
(3) The "Incentive Basis" is defined as the positive difference, if any, between the distributions made to and Relevant
Contributions received from the Shareholders.
(4) The "Shareholder Threshold" means the sum of (i) the Contributions of the Shareholders, and (ii) 85% multiplied
by the Incentive Basis.
Art. 21. Liquidation.
(a) In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed at a Shareholder meeting effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their remuneration.
(b) The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to Shareholders pursuant to the rules set
forth in Article 20.
(c) The net proceeds may be distributed in kind.
Art. 22. Amendment to Articles. Subject to the prior approval by the Luxembourg supervisory authority, these Articles
may be amended from time to time by Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and
the following related articles) and article 67-1 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended,
("1915 Law"). In addition, any proposed amendment to these Articles will become valid and effective only if separately
approved by a simple majority of the Ordinary Shares in issue.
131943
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Governing Regulation. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the
1915 Law and the 2004 Law.
Art. 24. Definitions. These definitions form an integral part of the Articles.
Corporation Currency Euro
Eligible Investors Pursuant to article 2 of the 2004 Law, either a) professional or institutional investors, or b) other
investors who confirm in writing that they adhere to the status of well-informed investors and are fully aware of the risks
and rewards of this type of investment within the meaning of the 2004 Law and who either invest or are committed to
invest a minimum of 125,000 EUR in the Corporation or have been subject to an assessment made by a credit institution
within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a
management company within the meaning of Directive 2009/65/EC certifying such investor's expertise, experience and
knowledge in adequately appraising an investment in risk capital or c) a person taking part in the management of the
Corporation.
A U.S. Person is prohibited from acquiring Shares in the Corporation.
Entry Charge A charge which may be levied on an Investor admitted to the Corporation subsequent to the initial share
offering.
Interest An Investor's interest in the Corporation being its rights and obligations in connection with any Ordinary
Shares held and its related Remaining Commitment.
Investor(s) The investors who have committed to acquire Ordinary Shares in accordance with a Subscription Agree-
ment. For the avoidance of doubt, any affiliate of the Manager who has committed to acquire Ordinary Shares shall be
deemed an Investor.
Manager Share A share issued by the Corporation that has been subscribed to by the Manager.
Ordinary Share A share issued by the Corporation that has been subscribed to by an Investor or has been acquired
by an Eligible Investor.
Ordinary Shareholder The holder of Ordinary Shares.
Prospectus The most up-to-date version of the prospectus of the Corporation published in accordance with the 2004
Law.
Remaining Commitments The excess of (i) a Shareholder's Commitment over (ii) the aggregate amount of such Sha-
reholder's Contributions (net of Contributions refunded to the Shareholders pursuant to Article 17(b)(ii)).
Shares The Ordinary Shares and the Manager Shares.
Shareholders The holders of Ordinary Shares and Manager Shares.
Subscription Agreement The agreement the Corporation entered into with each of the Investors in connection with
the commitment to subscribe for a certain number of Ordinary Shares.
U.S. Person Shall have the meaning ascribed in Regulation S, as amended from time to time, of the United States
Securities Act of 1933, as amended (the "1933 Act") or as in any other Regulation or act which shall come into force
within the United States of America and which shall in the future replace Regulation S or the 1933 Act.
Valuation Day The last day of each month.
<i>Expensesi>
The expenses which shall be borne by the Corporation as a result of its organisation are estimated at approximately
EUR 3,000.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereinafter:
Subscribed
capital
Paid-in
amount
Number of shares
1) Partners Group Management III S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . EUR 31,000 EUR 31,000 3,100,000 General
Partner Shares
2) Partners Group Management III S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . .
EUR 1,000
EUR 1,000
1 Ordinary Share
3) Partners Group Finance EUR IC Limited, prenamed . . . . . . . . . .
EUR 1,000
EUR 1,000
1 Ordinary Share
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 33,000 EUR 33,000
Evidence of the above payment has been given to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first accounting year of the Corporation shall begin on the date of its incorporation and end on 31
st
December
2014.
2. Exceptionally the first annual general meeting of the shareholders of the Corporation will be held on the first
Thursday of the month of March 2015 at 3.00 p.m.
131944
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26, 26-3 and 26-5 of the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named persons representing the entire subscribed capital and considering themselves as validly convened,
have immediately proceeded to hold a general meeting of shareholders which resolved as follows:
I. The following company is elected as independent auditor:
PricewaterhouseCoopers, société-cooperative, Réviseur d'entreprises agréé, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The mandate shall lapse on the date of the annual general meeting in 2015.
II. The registered office of the Corporation is fixed at 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above named person, this
deed is worded in English only.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, Christian name,
civil status and residence, said appearing person signed together with us, the notary, this original deed.
Gezeichnet: S. WOLTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42884. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den 30. September 2013.
Référence de publication: 2013137547/465.
(130167732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2013.
GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg, Groupement d'Intérêt Economique.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg C 13.
L'an deux mille treize, le dix-huit octobre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des membres du Groupement d'Intérêt Economique GIE DE Gestion
IMMOBILIERE DU KIRCHBERG, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 6 juin 1997,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 525 du 25 septembre 1997. Les statuts en ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date 30 août 2013, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les membres présents ou représentés sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le
secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des membres représentés resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que tous les membres sont présentes ou représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Modification de l'article 4 alinéa 1 pour lui donner la teneur suivante:
131945
L
U X E M B O U R G
«Les membres du groupement sont:
- La société anonyme AUCHAN IMMOBILIER DE KIRCHBERG S.A., avec siège social à L-2721 Luxembourg, 5, rue
Alphonse Weicker (R.C.S. Luxembourg B 50178);
- la société anonyme GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., avec siège social à L-2721 Luxembourg, 5, rue
Alphonse Weicker (R.C.S. Luxembourg B 50172).»
2.- Modification de l'article 8 alinéa 1 pour lui donner la teneur suivante: «Le conseil de gérance se réunit, sur la
convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige. Il doit être
convoqué chaque fois qu'un gérant au moins le demande.»
3.- Modification de l'article 10 alinéa 2 qui aura désormais la teneur suivante:
«Envers les tiers, le groupement est valablement représenté par la signature de l'un quelconque de ses gérants étant
précisé qu'à titre de règle interne, (i) tout gérant concluant seul un engagement au nom et pour le compte du groupement
devra en informer dans les meilleurs délais le(s) autre(s) gérant(s) et (ii) tout engagement excédant le budget annuel arrêté
par le conseil de gérance devra être signé conjointement par les gérants. Le budget annuel du groupement et ses modi-
fications devront être adoptées à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés du conseil de gérance.»
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 4 alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Les membres du
groupement sont:
- La société anonyme AUCHAN IMMOBILIER DE KIRCHBERG S.A., avec siège social à L-2721 Luxembourg, 5, rue
Alphonse Weicker (R.C.S. Luxembourg B 50178);
- la société anonyme GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., avec siège social à L-2721 Luxembourg, 5, rue
Alphonse Weicker (R.C.S. Luxembourg B 50172).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 8 alinéa 1 pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil de gérance se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que
l'intérêt du groupement l'exige. Il doit être convoqué chaque fois qu'un gérant au moins le demande.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 10 alinéa 2 qui aura désormais la teneur suivante:
«Envers les tiers, le groupement est valablement représenté par la signature de l'un quelconque de ses gérants étant
précisé qu'à titre de règle interne, (i) tout gérant concluant seul un engagement au nom et pour le compte du groupement
devra en informer dans les meilleurs délais le(s) autre(s) gérant(s) et (ii) tout engagement excédant le budget annuel arrêté
par le conseil de gérance devra être signé conjointement par les gérants. Le budget annuel du groupement et ses modi-
fications devront être adoptées à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés du conseil de gérance.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2013. Relation: LAC/2013/47482. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 24 octobre 2013.
Référence de publication: 2013148693/73.
(130182135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.
M & M Ballooning s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7652 Heffingen, 26, Stenkel.
R.C.S. Luxembourg B 75.478.
DISSOLUTION
L'an deux mille treize, le trois septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
131946
L
U X E M B O U R G
A COMPARU:
Madame Brigitte dite Micky KIRCHEN, secrétaire de direction, née à Luxembourg, le 12 septembre 1965, demeurant
à L-7652 Heffingen, 26, Stenkel.
Laquelle comparante déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée " M & M Ballooning S.à r.l.", avec siège social à L-7652 Heffingen, 26, Stenkel,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75.478, (ci-après dénommée
la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch,
le 14 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 582 du 16 août 2000.
2.- Que le capital social est fixé à 18.592,01,- EUR (dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et un cent),
représenté par 75 (soixante-quinze) parts sociales, sans désignation de la valeur nominale.
3.- Que la comparante est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- Que la comparante, agissant comme associée unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat.
5.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter
et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.
6.- Que la comparante déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société dissoute.
7.- Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué à la section 6.
8.- Que la comparante déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs
à l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.
9.- Que décharge est donnée à la gérante unique de la Société.
10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien
siège social de la Société à L-7652 Heffingen, 26, Stenkel.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de cet acte, est dès lors évalué à 750,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Micky KIRCHEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2013. Relation GRE/2013/3644. Reçu soixante-quinze euros 75,00.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 26 septembre 2013.
Référence de publication: 2013136232/45.
(130165653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.026.042,97.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 146.948.
FUSIONSPROJEKT
Im Jahre zweitausenddreizehn, am dreissigsten des Monats Oktober.
vor Maître Martine SCHAEFFER, Notar, niedergelassen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ERSCHIENEN:
1) Reinhard Mohn GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend unter den Gesetzen
Deutschlands und mit eingetragenem Gesellschaftssitz in der Carl-Bertelsmann Straße 270, D-33335 Gütersloh, Nord-
rhein-Westfalen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter der Nummer HRB 3101.
Das Stammkapital von 19.497.000,00 Euro ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Bertelsmann SE & Co KGaA
( die "Reinhard Mohn GmbH" oder die "Übernehmende Gesellschaft");
hier vertreten durch Gianpiero SADDI, Notarschreiber, wohnhaft beruflich in Luxemburg, handelnd als Bevollmäch-
tigter des Geschäftsführungsrates der Reinhard Mohn GmbH (der "RM Verwaltungsrat"), gemäß einer Vollmacht vom 29.
Oktober 2013 (die "RM Vollmacht");
131947
L
U X E M B O U R G
und
2) BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend
unter den Gesetzen Luxemburgs und mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Lu-
xembourg, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 146948, gegründet durch notarielle Urkunde der Maître Martine Schaeffer, zu dieser Zeit in Luxemburg
niedergelassene Notarin, am 30. Juni 2009, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations) am 27. Juli 2009, Nummer 1443. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Februar 2013 geändert, gemäß
notarieller Urkunde des Maître Joseph Elvinger, zu dieser Zeit in Luxembourg niedergelassener Notar, veröffentlicht im
Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) am 6. Mai 2013, Nummer 1071 (die "BMG
RM Investments Luxembourg S.à r.l." oder die "Übernommene Gesellschaft");
hier vertreten durch Gianpiero SADDI, vorbenannt, handelnd als Bevollmächtigter des Geschäftsführungsrates der
BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. (der "BMG Geschäftsführungsrat"), gemäß Beschluss des BMG Geschäftsfüh-
rungsrates vom 30. Oktober 2013 (der "BMG Beschluss");
Nachfolgend werden der RM Vollmacht und der BMG Beschluss gemeinsam als die "Vollmachten" bezeichnet.
Die besagten Vollmachten, vom Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar mit
ne varietur paraphiert, werden zum Zwecke der gleichzeitigen Einreichung bei den Registerbehörden mit der vorliegenden
Urkunde als Anhang verbunden bleiben.
Die erschienenen Parteien, hier in den vorgenannten Funktionen handelnd, haben den unterzeichnenden Notar um
die Beurkundung des Nachfolgenden ersucht:
<i>Gemeinsamer Verschmelzungsplan der Reinhard Mohn GmbH und der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l.i>
<i>Präambeli>
Im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh ist unter HRB 3101 die Reinhard Mohn GmbH, eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz und Hauptverwaltung in Gütersloh, eingetragen. Das Stammkapital von
19.497.000,00 Euro ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Bertelsmann SE & Co. KGaA mit dem Sitz in
Gütersloh, Amtsgericht Gütersloh, HRB 9194.
Im R.C.S. Luxemburg ist unter der Nr. B 146 948 die BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., eine société à res-
ponsabilité limitée, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Sitz und Hauptverwal-
tung im Großherzogtum Luxemburg eingetragen. Das gesamte Kapital von 4.026.042,97 Euro ist eingeteilt in 402.604.297
Anteile zu je 0,01 Euro. Sämtliche Anteile werden von der Aufnehmenden Gesellschaft als alleinige Gesellschafterin ge-
halten. Die Einlagen sind vollständig eingezahlt.
Die übertragende BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. ist ausweislich der Angaben in dieser Präambel eine
verschmelzungsfähige Kapitalgesellschaft im Sinne des Artikels 257 i.V.m. Artikel 2 des Luxemburger Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in geänderter Fassung (das „Luxemburger Handelsgesetzbuch"). Die aufneh-
mende Reinhard Mohn GmbH ist ausweislich der Angaben in dieser Präambel eine verschmelzungsfähige Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 122b deutsches Umwandlungsgesetz („UmwG").
Die Parteien beabsichtigen, die BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. als übertragende Gesellschaft auf die Reinhard
Mohn GmbH als aufnehmende Gesellschaft nach den Vorschriften der §§ 122a ff. deutsches UmwG und §§ 278 ff. des
Luxemburger Handelsgesetzbuches zu verschmelzen. Die übernehmende Gesellschaft behält ihren Satzungssitz in der
Bundesrepublik Deutschland bei. Da die aufnehmende Gesellschaft Inhaberin sämtlicher Anteile der übertragenden Ge-
sellschaft ist, entfallen im Verschmelzungsplan die Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 deutsches UmwG (vgl. §
122c Abs. 3 deutsches UmwG) sowie Artikel 278 i.V.m. Artikel 261 (2) b, c, d des Luxemburger Handelsgesetzbuches.
Eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. zu diesem Versch-
melzungsplan ist gemäß § 122g Abs. 2 deutsches UmwG sowie Artikel 279 Abs. 2 des Luxemburger Handelsgesetzbuches
entbehrlich, da die Reinhard Mohn GmbH die alleinige Gesellschafterin der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. ist.
Eine Prüfung der Verschmelzung ist gemäß § 122f Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 deutsches UmwG und Artikel 278
i.V.m. Artikel 266 des Luxemburger Handelsgesetzbuches nicht erforderlich und wird daher nicht durchgeführt.
Mit der nachstehenden Verschmelzung überträgt die BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. im Wege der Gesam-
trechtsnachfolge ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gem. § 122a
Abs. 2 und § 3 Abs. 1 Nr. 2 deutsches UmwG sowie Artikel 278 i.V.m. Artikel 274 Abs. 1 a und c des Luxemburger
Handelsgesetzbuches grenzüberschreitend auf die Reinhard Mohn GmbH (Verschmelzung durch Aufnahme).
§1. Rechtsform, Firma und Sitz. Die BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. ist eine société à responsabilité limitée,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit dem Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Die Reinhard Mohn GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit dem Sitz in Gütersloh,
Deutschland.
§2. Keine Gewährung einer Gegenleistung. Für die Übertragung des Vermögens der BMG RM Investments Luxembourg
S.à r.l. werden keine Geschäftsanteile der Reinhard Mohn GmbH als Gegenleistung gewährt, da die Reinhard Mohn GmbH
die alleinige Gesellschafterin der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. ist. Gemäß § 122a i.V.m. § 54 Abs. Satz 1 Nr.
131948
L
U X E M B O U R G
1 deutsches UmwG darf die Reinhard Mohn GmbH ihr Stammkapital zur Durchführung der grenzüberschreitenden
Verschmelzung nicht erhöhen. Eine Anteilsgewährung scheidet überdies nach § 122a i.V.m. § 20 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1
deutsches UmwG und Artikel 278 des Luxemburger Handelsgesetzbuches aus.
§3. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigten, Verfahren zu Beteiligung der Arbeitneh-
mer. Die übertragende Gesellschaft und die aufnehmende Gesellschaft haben keine Arbeitnehmer. Keine der am
Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften unterliegt der Mitbestimmung. Rechtspositionen von Arbeitnehmern
werden durch die Verschmelzung also nicht berührt. Ein Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren nach dem Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) ist somit nicht durchzufüh-
ren.
§4. Verschmelzungsstichtag. Die Übernahme des Vermögens der übertragenden Gesellschaft erfolgt im Innenverhältnis
mit Wirkung zum Ablauf des 30. Juni 2013, 24:00 Uhr. Vom Beginn des 01. Juli 2013, 00:00 Uhr (Verschmelzungsstichtag),
an gelten alle Handlungen und Geschäfte der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung und Risiko der übernehmenden
Gesellschaft vorgenommen. Im Verhältnis zu Dritten wird die Verschmelzung am Tag der Eintragung der Verschmelzung
im Handelsregister der übernehmenden Reinhard Mohn GmbH wirksam.
§5. Besondere Rechte und Vorteile. Besondere Rechte oder Vorteile einzelner Anteilsinhaber der am Verschmel-
zungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder einzelner Inhaber anderer Wertpapiere als Aktien oder besonderer Rechte
im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 deutsches UmwG werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind
auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen. Auch werden weder der auf-
nehmenden Gesellschaft selber noch anderen Personen Sonderrechte und andere Rechte gemäß Artikel 261 Abs. 2 f des
Luxemburger Handelsgesetzbuches gewährt. Bei der übertragenden Gesellschaft bestehen keine Sonderrechte im Sinne
der vorbezeichneten Vorschriften.
§6. Besondere Vorteile. Besondere Rechte oder Vorteile im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 deutsches UmwG bzw.
Artikel 261 Abs. 2 g des Luxemburger Handelsgesetzbuches werden weder einem Mitglied eines Vertretungs- oder
Aufsichtsorgans der am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften, noch dem Abschlussprüfer oder sonstigen
Prüfern gewährt. Es sind keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen. Mit dem
Wirksamwerden der grenzüberschreitenden Verschmelzung erlischt die Organstellung der bisherigen Geschäftsführer,
der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l.
§7. Satzung der aufnehmenden Gesellschaft. Die im Zeitpunkt dieses Verschmelzungsplanes gültige Satzung der Rein-
hard Mohn GmbH ist diesem Verschmelzungsplan entsprechend § 122 c Nr. 9 deutsches UmwG und Artikel 261 Abs. 4
a des Luxemburger Handelsgesetzbuches als Anlage 1 beigefügt. Sie entspricht dem letzten zum Register eingereichten
und mit einer Notarbestätigung versehenen Wortlaut der Satzung.
§8. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens. Das Aktiv- und Passivvermögen der BMG RM Investments
Luxembourg S.à r.l., das durch die grenzüberschreitende Verschmelzung auf die Reinhard Mohn GmbH übergeht, wird
für handelsbilanzielle Zwecke zu den in der handelsrechtlichen Schlussbilanz der BMG RM Investments Luxembourg S.à
r.l. jeweils angesetzten Buchwerten in der Reinhard Mohn GmbH fortgeführt. Sowohl für deutsche als auch für luxem-
burgische steuerliche Zwecke werden die in der steuerlichen Schlussbilanz der BMG RM Investments Luxembourg S.à
r.l. angesetzten steuerlichen Buchwerte von der Reinhard Mohn GmbH fortgeführt.
§9. Stichtag der Bilanzen. Der Verschmelzung wird die Zwischenbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni
2013 als Schlussbilanz zugrunde gelegt.
Eine Gewährung von Geschäftsanteilen und eine damit verbundene Bestimmung des Umtauschverhältnisses finden
nicht statt. Bilanzstichtag sowohl der übertragenden BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. als auch der überneh-
menden Reinhard Mohn GmbH ist der 31. Dezember eines jeden Jahres. Die aufnehmende Gesellschaft wird das von ihr
mit Wirksamwerden der Verschmelzung übernommene Vermögen der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l. erst-
mals in ihrer Bilanz zum 31. Dezember 2013 ausweisen. Der letzte Bilanzstichtag der Reinhard Mohn GmbH war der 31.
Dezember 2012.
§10. Kosten, Steuern, Gebühren. Alle mit diesem Plan und seiner Ausführung verbundenen Kosten, Steuern und Ge-
bühren einschließlich des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafter der Reinhard Mohn GmbH Zustimmungsbeschlüsse
trägt die aufnehmende Gesellschaft. Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, tragen die Kosten dieses Vertrages
die am Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften zu gleichen Teilen; alle übrigen Kosten trägt die jeweils betrof-
fene Gesellschaft alleine.
§11. Sonstiges, Schlussbestimmungen. Die Bücher und Aufzeichnungen der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l.
werden für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum am eingetragenen Sitz der Reinhard Mohn GmbH aufbewahrt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages bzw. Plans unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, soll
dies auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss haben. In diesem Fall ist eine solche Bestimmung zu
vereinbaren, die der mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zielsetzung entspricht oder
ihnen möglichst nahe kommt. Gleiches gilt im Falle einer Lücke.
131949
L
U X E M B O U R G
Der unterzeichnende Notar zertifiziert hiermit die Existenz und Rechtmäßigkeit des Zusammenschlussvorhabens und
aller Handlungen, Dokumente und Formalitäten, die den Verschmelzenden Gesellschaften kraft Gesetzes obliegen.
Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxemburg ausgefertigt.
An dem Tage, der zu Beginn dieses Dokuments genannt wurde.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, der dem Notar mit Vor- und Nachnamen,
Familienstand sowie Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, unterzeichnete der genannte Bevollmächtigte der erschie-
nenen Parteien zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2013. LAC/2013/49664. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
Suit l'annexe:
Begl. Kopie
GESELLSCHAFTSVERTRAG
§1. Firma und Sitz. Die Firma der Gesellschaft lautet:
Reinhard Mohn GmbH.
Sitz der Gesellschaft ist Gütersloh.
§2. Gegenstand. Gegenstand des Unternehmens ist der Verlag, die Herstellung und der Vertrieb von Druck-, Schall-
platten-, Phono- und sonstigen Erzeugnissen des Verlags-, Film- und Schallplattensektors, sowie die Verrichtung von
Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder Beteiligungen an solchen
erwerben. Die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland ist zulässig.
§3. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.
Der Zeitraum bis zum 31.12.2000 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.
Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung jedes Geschäftsjahres aufzustellen.
§4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt EUR 19.497.000,-- (in Worten: Euro neunzehnmillionen-vierhundertsie-
benundneunzigtausend) und ist wie folgt eingeteilt:
I. EUR 2.807.000,--
II. EUR 2.305.930,--
III. EUR 511.300,--
IV. EUR 230.090,--
V. EUR 127.830,--
VI. EUR 76.700,--
VII. EUR 76.700,--
VIII. EUR 25.570,--
IX. EUR 25.570,--
X. EUR 25.570,--
XI. EUR 153.390,--
XII. EUR 51.130,--
XIII. EUR 51.130,--
XIV. EUR 520,--
XV. EUR 46.020,--
XVI. EUR 520,--
XVII. EUR 520,--
XVIII. EUR 515.900,--
XIX. EUR 468.860,--
XX. EUR 10.230,--
XXI. EUR 3.226.770,--
XXII. EUR 161.570,--
XXIII. EUR 70.050,--
XXIV. EUR 400.350,--
XXV. EUR 6.347.690,--
XXVI. EUR 178.450,--
XXVII. EUR 1.022.590,--
131950
L
U X E M B O U R G
XXVIII. EUR 511.300,--
XXIX. EUR 20.460,--
XXX. EUR 520,--
XXXI. EUR 4.610,--
XXXII. EUR 260,--
XXXIII. EUR 25.310,--
XXXIV. EUR 5.120,--
XXXV. EUR 5.120,--
XXXVI. EUR 2.500,--
XXXVII. EUR 500,--
XXXVIII. EUR 1.000,--
XXXIX. EUR 100,--
XL. EUR 100,--
XLI. EUR 150,--
XLII. EUR 1.000,--
XLIII. EUR 1.000,--
Die Stammeinlagen sind voll erbracht.
§5. Geschäftsführer und Vertretung.
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer ge-
meinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, werden Beschlüsse der Geschäftsführung, wenn die Gesellschafterver-
sammlung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Gesellschafterversammlung kann einen Ge-
schäftsführer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellen und ihm Sonderrechte innerhalb der Geschäftsführung
zuweisen. Das Widerspruchsrecht einzelner Geschäftsführer kann ausgeschlossen werden.
(3) Die Gesellschafterversammlung oder die Geschäftsführer können eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
erlassen, in der einzelnen Geschäftsführern Einzelgeschäftsführung erteilt wird, für die Gesellschaft insgesamt oder für
einzelne Geschäftsbereiche.
(4) Die Gesellschafterversammlung kann einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungs-
befugnis erteilen und/oder sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
§6. Abtretung. Zur Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen, ganz oder teilweise, ist die Zustimmung aller
Gesellschafter erforderlich.
§7. Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung ist durch die Geschäftsführung einzuberufen, wenn
eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich ist oder wenn ein Gesellschafter es verlangt.
§8. Gewinnverwendung. Die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jahresüberschuss zzgl. eines Gewinnvortrages und
abzüglich eines Verlustvortrages, soweit der sich ergebende Betrag nicht nach dem Gesetz oder durch einen Mehrheits-
beschluss der Gesellschafterversammlung in Gewinnrücklagen eingestellt wird oder als zusätzlicher Aufwand aufgrund
des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses von der Verteilung unter die Gesellschafter ausgeschlossen Ist.
§9. Sonstiges. Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.
Urkundenrolle Nr. 284 für das Jahr 2009
Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG bescheinige ich, dass der vorstehende Wortlaut des Gesellschaftsvertrags der
<i>Reinhard Mohn GmbHi>
die durch meine Urkunde Nr. 283/2009 vom 29. Mai 2009 geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags enthält
und dass diese mit der in jener Urkunde enthaltenen Vereinbarung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages übe-
reinstimmt.
Ferner bescheinige ich aufgrund der gleichen Vorschrift, dass die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim
Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.
Demnach hat der Gesellschaftsvertrag nach Eintragung der vereinbarten Änderung im Handelsregister den vorste-
henden Wortlaut.
Gütersloh, den 29. Mai 2009.
Dr. Merklinghaus
<i>Notari>
Diese Bescheinigung ergeht gemäß § 47 Abs. 1 KostO gebührenfrei.
131951
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2013. LAC/2013/49664. Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013151604/245.
(130186705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.
Almack II Unleveraged SA, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.734.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 24 septembre 2013 que:
- Les démissions de Monsieur Peter Dickinson, Monsieur Carl Andrew Pollard et Monsieur Fernand Heim de leur
fonctions d'administrateur de la Société, ont été acceptées avec effet au 24 septembre 2013.
- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, France, avec adresse professionnelle au 51 avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Monsieur John Wisemann, né le 22 aout 1971 à Jersey, Jersey, avec adresse
professionnelle au 13, Castle street, St Helier, JE4 5UT Jersey, ont été nommés administrateurs de la Société avec effet
au 24 septembre 2013, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2018.
- Les mandats des administrateurs suivants étant venus à l'échéance, l'actionnaire unique a décidé de les ré - élire avec
effet rétroactif au 24 avril 2013 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2018.
* Monsieur Philip Godley, né le 21 mars 1974 à Sheffield, Jersey, ayant son adresse professionnelle au 51 avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
* Madame Geneviève Blauen - Arendt, née le 28 septembre 1962 à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle
au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
* Monsieur Marc Schmit, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, Luxembourg ayant son adresse professionnelle au 231 Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013135885/28.
(130165816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Meigerhorn Bulle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 82.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 110.319.
A titre informatif, veuillez noter que le siège social du gérant unique de la Société, LDV Management II S.à r.l., se situe
désormais au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Veuillez noter également que le siège social de l'associé MEIGERHORN PROPERTIES S.à r.l se situe désormais au 6A,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
For your information, please note that the registered office of the sole manager of the Company, LDV Management
II S.à r.l., is now at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Please, note also that the registered office of the shareholder MEIGERHORN PROPERTIES S.à r.l. is now at 6A, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136240/18.
(130165887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
131952
Accenture SCA
Airfreight Development Worldwide S.A.
Almack II Unleveraged SA
AOG Real Estate Luxembourg S.à r.l.
Arelux France S.à r.l.
Batiwal S.A.
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l.
Bridgepoint Europe II Investments S.à r.l.
BYR Sicav
Cerigo Développement Un S.à r.l.
CNH Industrial Finance Europe S.A.
Codeca S.à.r.l.
Cube Infrastructure Fund
Cytolnat International S.A.
Darlington S.A.
Daumont Development S.A.
D & D S.à r.l.
Delight s.à r.l.
Denovo S.A., société de gestion de patrimoine familial
Donner S.à r.l.
Dufry Finances SNC
ECSA S.A., SPF
Elia Re S.A.
Elliot Promotions S.A.
EnCo S.àr.l.
EnCo S.àr.l.
European Camping Distributors S.à r.l.
European Casino Operators S.à r.l.
European Marketing Group (Luxembourg) S.A.
European News Promotions S.à r.l.
European Opticians 2 S.à r.l.
European Opticians S.àr.l.
European Packaging S.à r.l.
European Private Equity Portfolio S.A., SICAR
European Recreational Vehicles S.à r.l.
European Vehicle Inspections S.à r.l.
E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A.
FedEx Luxembourg S. à r.l.
FINANCIAL BIS Spf S.A.
Financière de Titrisation S.A.
Finorma S.A.
Fisch Fund Services AG
Galilehorn Asset Management S.à r.l.
General Electric International Holdings S.à r.l.
Genpact Luxembourg S.à r.l.
Gérances S.A.
Gerona Securitization S.à r.l.
GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg
Goodrich Aftermarket (Singapore) S.à r.l.
I.F.G. International Food Group S.A.
ING Lease Luxembourg
ING Luxembourg
JPMorgan Funds
Marino S.A.
Meigerhorn Bulle S.à r.l.
M & M Ballooning s.àr.l.
Partners Group Direct Mezzanine 2013 S.C.A., SICAR
Partners Group Global Real Estate 2013 S.C.A., SICAR
Radiant Fund S.C.A. SICAV FIS
REF IV Associates (Caymans) L.P. Child Wear CIV S.C.S.
Rovabo
TMCRIGHT, S.à r.l.
UBS (Lux) Equity Fund