logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2743

4 novembre 2013

SOMMAIRE

Beechy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131654

Buvette Piscine de Dudelange S.à r.l.  . . . .

131618

Carraig Mor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131642

Caspian Luxembourg Company S.à r.l. . . .

131618

DBAG Investment I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

131630

DBAG Investment I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

131642

Energy Investments Lux S.A. . . . . . . . . . . . .

131664

EPG Investment Partners  . . . . . . . . . . . . . . .

131618

Etech Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .

131629

Expertise Informatique Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131629

Formes Contemporaines S.A.  . . . . . . . . . . .

131629

Galathee S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131625

GARANT-MÖBEL Holding International

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131624

GB Aero Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

131621

Geninvest Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131622

Global Paints S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131622

Global Paints S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131621

Globe All Investment SA  . . . . . . . . . . . . . . .

131620

Gottex Partners (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

131628

Goudal Gestion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131620

GP ManCo Holding PE S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

131620

GPR Aerospace Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

131619

Grabory S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131628

Grace Lodge Care II Holding S.à r.l.  . . . . .

131657

Grand Hôtel Billia Holding S.A.  . . . . . . . . .

131621

Green Basil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131622

Groupe Aldelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131619

Haarslev Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

131619

Haneda Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

131627

Harmonia Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

131624

Hary Putz Promotions . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131623

Haydn S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131624

Heraldic LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131624

Heraldic LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131654

Heraldic MidCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131622

Hotel Investors I, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131646

H.P. Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131619

Humphrey Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131618

ICH Property Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

131627

Iecorp S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131625

IFICOM Financial Company S.A.  . . . . . . . .

131626

Ifigenia S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131625

Ilsole S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131623

Imbrazo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131626

Immobilière Maritime Méditérranéenne

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131621

Immo du Nord S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131623

Immonew S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131624

Immo Sud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131622

Immo Sud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131623

In Art We Trust - Artfund Investments SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131626

InterFact S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131651

International Omnia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

131627

International Transfert Consulting S.A.  . .

131627

Ipron Capital SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131625

Ipron Capital SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131626

Jupiter Immo 69 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131628

Kompass Wohnen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

131664

Luxembourg Residential Properties Loan

Finance 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131629

OI-Incentive 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131620

Piscine de Remich S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

131618

RAIFFEISEN Luxembourg Ré  . . . . . . . . . . .

131650

SDT Securitisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

131641

Starting 2008 Investment S.à r.l. . . . . . . . . .

131641

Sunflower Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131663

131617

L

U X E M B O U R G

Buvette Piscine de Dudelange S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Piscine de Remich S.à r.l.).

Siège social: L-3653 Kayl, 3, rue de Kahlebierg.

R.C.S. Luxembourg B 147.337.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013133945/10.
(130163395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Caspian Luxembourg Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 163.363.

EXTRAIT

Suite à un déménagement,
- Monsieur Christophe Gaul, gérant de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure

désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

-  Madame  Constance  Collette,  gérant  de  la  société  susmentionnée,  née  le  21  juin  1976  à  Luxembourg,  demeure

désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

- Caspian Luxembourg Holdings S.à r.l., associé unique de la société susmentionnée enregistré auprès du registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163360 a désormais son siège social à l'adresse suivante: 7,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2013133951/21.
(130162907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

EPG Investment Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 162.295.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013134072/11.
(130162940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Humphrey Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.205.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HUMPHREY INVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013134169/12.
(130163446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131618

L

U X E M B O U R G

Haarslev Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 647.381.120,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 166.797.

Les comptes annuels pour la période du 6 février 2012 à 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013134154/11.
(130163258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

H.P. Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 1, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 152.351.

Siège social:
Le siège social de la société est tranféré avec effet immédiat à l'adresse suivante:
1, rue Prince Jean
L-9052 ETTELBRÜCK

<i>Associés / Gérant

Il est à noter que l'adresse de l'associé et gérant de la société, Monsieur Hary Putz, est la suivante:
10 Boulevard G-D Charlotte
L-9024 ETTELBRÜCK

Itzig, le 24 septembre 2013.

Pour extrait conforme et sincère

Référence de publication: 2013134152/17.
(130163711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Groupe Aldelia, Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 150.644.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013134150/10.
(130162961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

GPR Aerospace Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 173.383.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 26 août 2013

1. M. David CATALA a démissionné de son mandat de gérant A.
2.  Mme  Mounira  MEZIADI,  administrateur  de  sociétés,  née  à  Thionville  (France),  le  12  novembre  1979,  résidant

professionnellement au 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée comme gérante
A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GPR Aerospace Holdings S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013134146/16.
(130163208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131619

L

U X E M B O U R G

Goudal Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 45, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 109.632.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 24/09/2013.

Référence de publication: 2013134143/10.
(130163481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

GP ManCo Holding PE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 179.232.

EXTRAIT

Suite à des transferts de parts entre parties en date du 16 septembre 2013, Holding PE, une société par actions

simplifiées régie sous les lois de France, ayant son siège social 20, place Vendôme, F-75001 Paris, a transféré des parts
sociales qu'elle détenait dans la Société de la manière suivante:

- 4000 parts sociales à Thibault Basquin, demeurant Domaine de Pierre Lue, 98, route d'Herbeville, F-78580 Maule;
- 4000 parts sociales à Martin Kessi, demeurant Sonnenstrasse 3, CH-6300 Zug;
- 4000 parts sociales à Jennifer Ferrand, demeurant 3 rue Victor Ferrant, L-1517 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GP ManCo Holding PE S.à r.l.

Référence de publication: 2013134145/17.
(130163772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Globe All Investment SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 156.296.

L'Assemblée Générale a été informé du décès de Monsieur Christian COLLIGNON (né à Habay la Vieille, Belgique,

le 22 février 1949) survenu le 19 janvier 2013, Messieurs les administrateurs ont décidé de mettre à jour les informations
publiées au Registre de Commerce et des Sociétés en le rayant du poste d'administrateur de la société

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 5 juillet 2013.

Référence de publication: 2013134136/13.
(130163322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

OI-Incentive 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 178.706.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013134348/14.
(130163602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131620

L

U X E M B O U R G

Grand Hôtel Billia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.170.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013134147/10.
(130163393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Global Paints S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 118.865.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134135/10.
(130163618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

GB Aero Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 162.860.

EXTRAIT

En date du 24 septembre 2013, l'associé unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Jacques de Patoul, en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013.
- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu

nouveau gérant B de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134130/15.
(130163664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immobilière Maritime Méditérranéenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 118.240.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 20 septembre 2013, que

la liquidation de la société, décidée en date du 27 juin 2013, a été clôturée et que Immobilière Maritime Méditerranéenne
S.A, société anonyme a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour
une période de cinq ans au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

<i>Pour: Immobilière Maritime Méditérranéenne S.A.
Société anonyme liquidée
<i>Pour le Liquidateur: GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013134188/19.
(130163583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131621

L

U X E M B O U R G

Heraldic MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.295.

Les statuts coordonnés au 27 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013134162/11.
(130163447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Global Paints S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 118.865.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134134/10.
(130163005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Geninvest Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.344.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013134132/10.
(130163383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Green Basil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 108.441.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 24 septembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013134149/11.
(130163299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immo Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 94.894.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2013.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2013134185/12.
(130162992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131622

L

U X E M B O U R G

Immo Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 94.894.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2013.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2013134186/12.
(130162993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immo du Nord S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 61, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.732.

<i>Rectificatif du dépôt n° L130132703 déposé le 31/07/2013

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 24/09/2013.

Référence de publication: 2013134183/11.
(130163604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Ilsole S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 165.940.

Les comptes annuels au 30.06.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12.09.13.

<i>Pour: ILSOLE S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013134180/15.
(130162931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Hary Putz Promotions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 1, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 139.789.

<i>Associés / Gérants:

1) Il est à noter que l'adresse du gérant de la société, Monsieur Hary PUTZ est la suivante:
10 Boulevard G-D Charlotte
L-9024 ETTELBRÜCK
3) Il est à noter que l'adresse de l'associé HP PARTICIPATIONS Sàrl est la suivante:
1, rue Prince Jean
L-9052 ETTELBRÜCK

Itzig, le 24 septembre 2013.

Pour extrait conforme et sincère

Référence de publication: 2013134165/16.
(130163727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131623

L

U X E M B O U R G

Haydn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Patrice Gallasin.

Référence de publication: 2013134158/10.
(130163400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Heraldic LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.294.

Les statuts coordonnés au 27 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013134159/11.
(130163351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

GARANT-MÖBEL Holding International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 42, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 165.352.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013134129/10.
(130163487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Harmonia Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 167.923.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013134156/10.
(130163004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immonew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 171.133.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique en date du 12/08/2013

L'associé unique prend la résolution suivante.
Le siège social de la société est transféré du 54 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 51-53 rue de Merl, L-2146

Luxembourg avec effet au 23 septembre 2013.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 12/08/2013.

Référence de publication: 2013134190/13.
(130162948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131624

L

U X E M B O U R G

Ifigenia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 108.755.

<i>Extrait de la résolution de l'associée unique

En date du 16 septembre 2013, l'Associée Unique de la société décide:
- de nommer Nicolas Hamel, Avocat, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L - 1142 Luxembourg,

comme nouveau Gérant de la société en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann.

Le nouveau Gérant est nommé pour une durée indéterminée.
Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit: Madame Véronique Wauthier et Messieurs Didier Schön-

berger et Nicolas Hamel.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013134179/16.
(130162945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Iecorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 136.665.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Septembre 2013 à 15 H

La Société IECORP SARL a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de reconduire le mandat du gérant pour une durée illimitée. Il s'agit donc de reconduire Mr Philippe

Raymond CORVISIER, demeurant 6 Impasse des Vosges F-54 500 VANDOEUVRE au fonction de gérant.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 23/09/2013.

Mr Philippe Raymond CORVISIER / Mme C. SIMON / Mme A. VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2013134177/18.
(130163156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Galathee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 100.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013134128/10.
(130163389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Ipron Capital SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134174/10.
(130163428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131625

L

U X E M B O U R G

Ipron Capital SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134175/10.
(130163716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

In Art We Trust - Artfund Investments SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 151.184.

En date du 23 septembre 2013, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur de la société In Art We Trust Artfund

Investments SIF ayant son siège social à 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 151184

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Pour extrait conforme
Monsieur Riccardo MORALDI

En date du 14 Juin 2013, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur de la société ANCHORAGE VENTURE LAB

S.A., ayant son siège social à 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 99225.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 Juillet 2013.

Référence de publication: 2013134170/17.
(130163710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Imbrazo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 177.097.

<i>Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 23

<i>Septembre 2013

<i>Décisions:

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:
- de nommer aux fonctions d'administrateur A Madame Julia Josette BRAIN, née le 25 décembre 1962 à Victoria

(Seychelles), demeurant au 3E, Route de Gimel a CH-1185 Mont-sur-Rolle, jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires
qui se tiendra en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013134181/17.
(130163686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 154.548.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2013134178/10.
(130163381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131626

L

U X E M B O U R G

ICH Property Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 109.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2013134176/10.
(130163649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

International Transfert Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 167.863.

Par décision du Conseil d'Administration prise par voie circulaire, Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Giuliano BIDOLI, démis-
sionnaire, avec effet au 20 septembre 2013.

Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.

Luxembourg, le 23.09.2013.

<i>Pour: INTERNATIONAL TRANSFER CONSULTING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2013134200/17.
(130163096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

International Omnia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.110.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013134199/10.
(130163392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Haneda Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 160.512.

EXTRAIT

Par résolution écrite du gérant unique en date du 24 septembre 2013, le gérant unique a décidé d'adopter la résolution

suivante:

- le siège social de la société a été transféré de 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg à 7, rue Robert Stümper,

L-2557 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2013134155/17.
(130163521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131627

L

U X E M B O U R G

Gottex Partners (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 286.400,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.017.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de Gottex Partners (Luxembourg) S.à r.l. le 1 

<i>er

<i> septembre 2013

Le conseil de gérance de Gottex Partners (Luxembourg) S.à r.l. a décidé de transférer le siège social de la Société du

12, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre

2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

<i>Pour Gottex Partners (Luxembourg) S.à r.l.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2013134123/17.
(130163724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Grabory S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 9.535.960,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 115.756.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 30 août 2013:
1. que la démission de M. Christophe Ponticello en tant que gérant de classe B est acceptée avec effet au 30 août 2013;
2. que la démission de M. Simon Henin en tant que gérant de classe B est acceptée avec effet au 30 août 2013;
3. que la démission de IPES Director (Guernsey) Limited en tant que gérant de classe A est acceptée avec effet au 30

août 2013;

4. que M. Mario COHN avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée

nouveau gérant de classe A avec effet au 30 août 2013 et ce pour une durée indéterminée;

5. que M. Giovanni LA FORGIA avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est

nommée nouveau gérant de classe B avec effet au 30 août 2013 et ce pour une durée indéterminée;

6. que le siège social de la société est transféré du 124, boulevard de la Pétrusse, L- 2330 Luxembourg au 15, Rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 30 août 2013.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134124/22.
(130163697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Jupiter Immo 69 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 112.269.

Il résulte d’un procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire en date du 3 sep-

tembre 2013 que M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, né le 2 avril 1973 à Villers-Semeuse (France), avec adresse
professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé, avec effet immédiat, au poste d’admi-
nistrateur de la Société, en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire.

Sa co-optation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.

Référence de publication: 2013134213/15.
(130163731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131628

L

U X E M B O U R G

Expertise Informatique Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 80.630.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EXPERTISE INFORMATIQUE LUXEMBOURG SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013134086/11.
(130162965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Etech Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 164.448.

Il résulte, d'une part, du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 17

septembre 2013 que M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire,
avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017.

Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.
Il résulte, d'autre part, d'un autre procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la même date que M.

Marc SCHMIT a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013134074/16.
(130163606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Formes Contemporaines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 126A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 11.991.

<i>Dépôt rectificatif du bilan 2011 qui a été déposé le 03 juillet 2013 avec comme numéro de référence de dépôt L130109481

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013134112/10.
(130163738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Luxembourg Residential Properties Loan Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.035.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites de l'associée unique de la Société du 23 septembre 2013 que Monsieur William J.

FOX a démissionné avec effet au 18 septembre 2013 de son mandat de gérant de la Société.

Partant, le conseil de gérance de la Société est composé dorénavant comme suit:
- John Samuel KEEN
- Daniel EHRMANN
- Ray O'GRADY
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2013134263/17.
(130162876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

131629

L

U X E M B O U R G

DBAG Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 180.696.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

DBAG Holding I S.à r.l., a société à responsabilité limitée having an issued capital of EUR 12,500.-, with its registered

office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of registration
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

represented by Ms Monica Morsch, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 30 September 2013; such proxy, signed by the proxyholder and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “DBAG Investment I S.à r.l.”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the Municipality of Niederanven.
The registered office may be transferred to any other place within the Municipality of Niederanven by a resolution of

the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which
are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

131630

L

U X E M B O U R G

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,

suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.

Chapter III. - Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or

class B Managers (the “Class B Managers”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

131631

L

U X E M B O U R G

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means

of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The

131632

L

U X E M B O U R G

foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the

number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. - Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first day of the month of June.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in

131633

L

U X E M B O U R G

writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. - Financial Year, Financial Statements, Distribution of Profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. - Applicable Law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have

been subscribed and the nominal value of these shares has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholders

Subscribed

capital

Number

of

ordinary

shares

Amount

paid-in

DBAG Holding I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-

12,500

EUR 12,500.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-

12,500

EUR 12,500.-

131634

L

U X E M B O U R G

The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal

of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR
1,400.-).

<i>Transitory Provision

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2013.

<i>Shareholders' Resolutions

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Lu-

xembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint

the following for an unlimited duration:

- James Bermingham, lawyer, born in Sheffield, United Kingdom, on 19 December 1972, professionally residing at 7,

rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Anke Jager, manager, born in Salzgitter, Germany, on 22 April 1968, professionally residing at 7, rue Lou Hemmer,

L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing

party, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg-Findel, on the day referred to at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed, together with the undersigned notary, this
original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und dreizehn, am dreißigsten September.
Vor  dem  unterzeichnenden  Notar,  Maître  Marc  Loesch,  mit  dem  Amtssitz  in  Mondorf-les-Bains,  Großherzogtum

Luxemburg.

Ist erschienen:

DBAG Holding I S.à r.l., eine société à responsabilité limitée mit einem Grundkapital in Höhe von EUR 12.500, -, mit

Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxemburg-Findel, Großherzogtum Luxemburg die sich zur Zeit in der Anmeldung
beim Luxemburger Firmen- und Handelsregister befindet,

vertreten durch Frau Monica Morsch, Privatebeamtin, wohnhaft in Luxembourg,
kraft der privatschriftlichen am 30. September 2013 erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet

wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „DBAG Investment I S.à r.l.“ firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Gemeinde Niederanven haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der

Gemeinde Niederanven verlegt werden.

131635

L

U X E M B O U R G

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-

weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse

politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt.  Die  genannten  vorübergehenden  Maßnahmen  sind  von  der  Geschäftsführung  zu  beschließen  und  den  hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von

Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreu-
ung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-

terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die  Gesellschaft  kann  auch  in  Immobilien,  geistiges  Eigentum  oder  jegliche  andere  bewegliche  oder  unbewegliche

Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder

ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Generell  kann  die  Gesellschaft  jede  kommerzielle,  industrielle  oder  finanzielle  Tätigkeit  ausführen,  welche  für  die

Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500,-), und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf das alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an Nicht¬Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser an-
genommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

131636

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Tod, Aussetzung von Bürgerrechten, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die

Handlungsunfähigkeit, der Tod, die Aussetzung von Bürgerrechten, der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleich-
barer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. - Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-

ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)

gegründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)

„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle

Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, gebun-
den.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen

Schriftführer  benennen, welcher  selbst kein Geschäftsführer  sein muss  und für die  Protokollführung der  Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-

rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit

der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.

Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-

führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner

amtierenden Mitglieder, wobei im Falle der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäfts-

131637

L

U X E M B O U R G

führer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein
muss.

Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-

schäftsführungsrates gefasst.

Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung

oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die

(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-

bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder

irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  persönlich  an  einer  solchen  Gesellschaft  oder  einem  solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft oder einem Unternehmen in Beziehung steht, mit der beziehungsweise dem die Gesellschaft vertrag-
liche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder
andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter

ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in

131638

L

U X E M B O U R G

Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.

Kapitel IV. - Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am ersten Tag des Monats Juni abge-
halten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-

halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.

Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die

Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-

und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu

von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-

versammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde zur Änderung der Satzung

oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind,
unterliegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals reprä-
sentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-

schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

131639

L

U X E M B O U R G

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-

winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung be-
rechtigt.

Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-

henden  Bestimmungen,  können  die  Geschäftsführer  eine  Abschlagsdividende  an  die  Gesellschafter  auszahlen.  Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst

werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-

stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der
zuletzt geltenden Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert

Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

Gezeichnetes

Kapital

Anzahl

Stammanteile

Eingezahlter

Betrag

DBAG Holding I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-

12.500

EUR 12.500,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-

12.500

EUR 12.500,-

131640

L

U X E M B O U R G

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Zeitpunkt an

zur Verfügung. Nachweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Maßgaben
von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung,
erfüllt wurden.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

des Jahres 2013.

<i>Gesellschafterbeschlüsse

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou

Hemmer, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit

als Geschäftsführer ernannt:

- James Bermingham, Anwalt, geboren in Sheffield, Vereinigtes Königreich, am 19. Dezember 1972, mit beruflicher

Adresse in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg; und

- Anke Jager, Geschäftsführerin, geboren in Salzgitter, Deutschland, am 22. April 1968 mit beruflicher Adresse in 7,

rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembour-Findel, Großherzogtum Luxemburg.

Der  unterzeichnende  Notar,  der  Englisch  spricht  und  versteht,  erklärt,  dass  vorliegende  Urkunde  auf  Antrag  des

Vollmachtnehmers der oben genannten Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf
Antrag desselben Vollmachtnehmers und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text
gilt der englische Text.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Findel, am eingangs erwähnten Datum.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Vollmachtnehmer vorgelesen worden ist, hat derselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar
unterzeichnet.

Signé: M. Morsch, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 2 octobre 2013. REM/2013/1730. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141915/636.
(130173326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

SDT Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013135039/9.
(130164242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Starting 2008 Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.690.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013135030/9.
(130164428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

131641

L

U X E M B O U R G

DBAG Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 180.696.

AUSZUG

Laut  Beschluss  des  alleinigen  Gesellschafters  vom  3.  Oktober  2013,  wird  Herr  Andreas  Demmel,  mit  beruflicher

Anschrift in L-1748 Luxemburg-Findel, 7, rue Lou Hemmer mit sofortiger Wirkung und auf unbegrenzte Zeit zum Ge-
schäftsführer der Gesellschaft ernannt.

DBAG Investment I S.àr.l

Référence de publication: 2013141916/12.
(130173326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Carraig Mor, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 21.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 108.899.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of September.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Carraig Mor, a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 108.899 (the Company).

THERE APPEARED:

- Carraig Investments, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws

of Luxembourg, having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 107.747 (Shareholder 1); and

- Carraig Beag, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 108.805 (Shareholder 2).

Shareholder 1 and Shareholder 2 are together referred to as the Shareholders and individually as Shareholder.
The Shareholders are represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional

address is at Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 17 September 2013.

Which proxy, after signature "ne varietur" by the representative of the relevant Shareholder and the undersigned

notary, each power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That they are the Company's sole shareholders and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate

on the items on the agenda, as set out below;

II. That the Company was incorporated on June 14 

th

 , 2005, pursuant to a deed drawn up by Maître Gérard Lecuit,

a notary resident in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial)
number 1108 of October 27, 2005.

The Company's articles of association (the Articles) have since been amended on August 13, 2010 pursuant to a deed

drawn up by Maître Joseph Elvinger, a notary resident in Luxembourg, published in the Mémorial under number 2249
page 107929 on October 21, 2010;

III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening formalities;
2. Amendment of article 7 of the Articles;
3. Amendment of article 8 of the Articles;
4. Creation of two classes of managers, i.e. class A managers and class B managers;
5. As a consequence of the above amendments of the Articles, reclassification of the current managers of the Company

as class A or Class B managers of the Company; and

6. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

131642

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholders declare that he has full knowledge of the items on the agenda and waive the requirement for con-

vening formalities.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 7 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole partner or, as

the case may be, the partners, which sets the term of their office. The managers need not be partners. If several managers
are appointed, they shall constitute the board of managers. The sole partner or, as the case may be, the partners may
decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B
managers. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

7.2. The managers may be removed at any time ad nutum (without cause)."

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 8 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

Art. 8. Board of managers.
8.1 Powers of the board of managers
8.1.1 All powers not expressly reserved to the sole member or to the general meeting of the members by the Law of

the articles of incorporation fall within the competence of the board of managers or of the sole manager, who has all
powers to carry out and approve all acts and operations necessary useful to realise the corporate object.

8.1.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents, member or not, by the

board of managers.

8.2 Procedure
8.2.1 The board of managers shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice,

which in principle shall be in Luxembourg.

8.2.2 Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in

advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

8.2.3 No notice is required if all members of the board of managers are present or represented and each of them

states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either
before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places
indicated in a schedule previously adopted by the board of managers.

8.2.4 A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any meeting of the

board of managers.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

8.2.5 The board of managers may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented.

Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided
that if the partners have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. The resolutions of the board of managers
shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the
managers present or represented.

8.2.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference, or by

any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each
other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

8.2.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held

meeting of the board of managers, and shall bear the date of the last signature.

8.3 Representation
8.3.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager

and any class B manager.

8.3.2 The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the board of managers."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to create two classes of managers, i.e. class A managers and class B managers with effect as

from the date of the present deed.

131643

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to reclassify the following managers:
- as class A managers of the Company with effect as from 18 September 2013 and for an indefinite period of time:
* Mr Gregor Dalrymple, born on 16 May 1960, in Edinburgh, United Kingdom, whose addresse is at 3, Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg; and

* Ms Clare Jenner, born on on 25 May 1974 in Kingston, United Kingdom, whose address is at 3, Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

- as class B managers of the Company with effect as from 18 September 2013 and for an indefinite period of time:
* Mr Emile Habayeb, born on 18 January 1955 in Beirut, Lebanon, whose address is at 111, Poseidonos Avenue GR -

16610 Glyfada, Greece; and

* Mr Tawfiq Afif Hasan Awwad, born on 25 September 1966 in Kuwait, Kuwait, whose address is at 111, Poseidonos

Avenue GR - 16610 Glyfada, Greece.

<i>Estimate of Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed

is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

Whereof this notarial deed is drawn up in Esch/Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Shareholders' authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour de septembre,
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Carraig Mor, une société à respon-

sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 20, Rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.899 (la
Société).

ONT COMPARU:

- Carraig Investments, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 107.747 (l'Associé 1); et

- Carraig Beag, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social à 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 108.805 (l'Associé 2).

L'Associé 1 et l'Associé 2 sont ci-après dénommés conjointement les Associés, et individuellement un Associé.
Les Associés sont représentés par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse

professionnelle à Esch/Alzette, en vertu de deux procurations donnée à Luxembourg le 17 septembre 2013.

Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de l'Associé en question et le notaire instrumentant, chaque

procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Qu'ils sont les seuls associés de la Société et que l'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer

sur les points de l'ordre du jour reproduits ci-après;

II. Que la Société a été constituée le 14 juin 2005, suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial)
numéro 1108 du 27 octobre 2005. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 13 août 2010, suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mé-
morial numéro 2249 page 107929 du 21 octobre 2010;

III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 7 des Statuts;
3. Modification de l'article 8 des Statuts;
4. Création de deux classes de gérants, i.e. gérants de classe A et gérants de classe B;

131644

L

U X E M B O U R G

5. Suite aux modifications des Statuts ci-dessus, reclassification des gérants actuels de la Société en gérants de classe

A ou de classe B; et

6. Divers.
IV. Que les Associés prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour et renoncent aux formalités de convocation.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 7 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'associé unique ou, selon le cas,

des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance. L'associé unique ou, selon le cas, les associés,

peut/peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un
ou plusieurs gérants de classe B.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment ad natum (sans motif).»

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 8 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Conseil de gérance.
8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
8.1.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le

cas) par la Loi ou les présents Status sont de la competénce du conseil de gérance, qui a tous les pouvoirs pour effectuer
et approuver tous les actes et opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

8.1.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le ou les gérants.

8.2 Procédure
8.2.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, sera au Luxembourg.

8.2.2 Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-

quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront
mentionnées dans la convocation à la réunion.

8.2.3 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et si

chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer
à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
conseil de gérance.

8.2.4 Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du conseil de

gérance.

8.2.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés, à la condition qu'un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs
gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions
du conseil de gérance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

8.2.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou visio-conférence ou par tout

autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.

8.2.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient

été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

Art. 8.3. Représentation.
8.3.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de

classe A et d'un gérant de classe B.

131645

L

U X E M B O U R G

8.3.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le conseil de gérance.»

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de créer deux catégories différents de gérants, i.e. gérants de classe A et gérants de classe B,

avec effet à compter de la date du présent acte.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de reclassifier les gérants suivants:
- comme gérants de classe A de la Société avec effet à compter du 18 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Gregor Dalrymple, né le 16 mai 1960, à Edinburgh, Royaume-Uni, dont l'adresse est au 3, Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

* Madame Clare Jenner, née le 25 mai 1974, à Kingston, Royaume-Uni, dont l'adresse est au 3, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- comme gérants de classe B de la Société avec effet à compter du 18 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Emile Habayeb, né le 18 janvier 1955, à Beirut, Liban, dont l'adresse est au 111, Poseidonos Avenue GR -

16610 Glyfada, Grèce; et

* Monsieur Tawfiq Afif Hasan Awwad, né le 25 septembre 1966, à Koweït, Koweït, dont l'adresse est au 111, Posei-

donos Avenue GR - 16610 Glyfada, Grèce.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte

s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande des Associés, le présent acte est rédigé

en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des Associés.
Signé: Conde, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12157. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013133950/237.
(130163179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Hotel Investors I, Inc., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.496.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of August,
Before Us Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), acting in repla-

cement of his colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), who last
named shall remain depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of Hotel Investors I, Inc., a société à responsabilité limitée (private limited

liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD
20,000 and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register)
under number B 157.496 (the "Company").

There appeared:

HI Holdings Cyprus Limited, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of Cyprus, with

registered office at 4, Riga Feraiou, bâtiment Omega Court, 1 

st

 floor, CY-3095 Limassol, Cyprus and registered with the

Registrar of Companies of Cyprus under number 158701 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

131646

L

U X E M B O U R G

The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-

tration.

The 20,000 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

<i>Agenda

1. Creation of two different types of managers, namely the type A and B managers;
2. Subsequent amendment to the articles 11, 12 and 13 of the articles of association of the Company to reflect the

reorganization of the management;

3. Appointment of Mrs. Marjorie Allo as type A manager and Mr. Brian Karaba and Mr. Stephen M. Sokal as type B

managers of the Company; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to reorganize the management of the Company by creating two different types of managers, namely the

type A and B managers.

In the framework of the management reorganization, it is resolved to (i) grant a joint power of signature of at least

one type A manager and one type B manager binding the Company toward thirds parties, (ii) establish a quorum of at
least one type A manager and one type B manager present or represented for the meetings of the board of managers
and (iii) submit the decisions of the board of managers to the affirmative vote of the majority of the managers including
the affirmative vote of at least one type A manager and one type B manager.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution it is resolved to amend the articles 11, 12 and 13 of the articles of

association of the Company to read as follows:

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where

more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among

its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

131647

L

U X E M B O U R G

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means, initiated from the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear
each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or represented by proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented by proxyholder including
the affirmative vote of at least one type A manager and at least one type B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies

or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers."

<i>Third resolution

It is resolved to acknowledge the resignation of Mr. Lawrence C. Somma as manager of the Company.
It is further resolved to approve the appointments of:
- Mrs. Marjorie ALLO, born on November 19, 1967, in Paris, France, and residing professionally at 2-4, rue Eugène

Ruppert,  L-2453  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  is  appointed  as  type  A  manager  of  the  Company  with
immediate effect for an undetermined duration;

- Mr. Brian KARABA, born on January 22, 1981, in Niskayuna, New York, United States of America, and residing

professionally at 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, United States of America, is appointed as type B manager
of the Company with immediate effect for an undetermined duration in replacement of Mr. Lawrence C. Somma; and

- Mr. Stephen M. SOKAL, born on February 2, 1951, in Miami Beach, Florida, United States of America, and residing

professionally at 71, South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, United States of America, is appointed as type B manager
of the Company with immediate effect for an undetermined duration.

Pursuant to this resolution, the board of managers of the Company shall be composed of Mrs. Marjorie Allo as type

A manager and Mr. Brian Karaba and Mr. Stephen M. Sokal as type B managers.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 900.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trentième jour d'août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg) agissant

en remplacement de son confrère Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxem-
bourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société Hotel Investors I, Inc., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 USD, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.496 (la «Société»).

A comparu:

HI Holdings Cyprus Limited, une société dûment constituée en vertu des lois de Chypre, ayant son siège social à 4,

Riga Feraiou, bâtiment Omega Cour, 1 

er

 étage, CY-3095 Limassol, Chypre, et étant immatriculée au Registre des Sociétés

de Chypre sous le numéro 158701 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec

ce dernier.

131648

L

U X E M B O U R G

Les 20.000 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que

l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalable-
ment informé.

L'Associé Unique représenté par son mandataire prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Création de deux catégories différentes de gérants, à savoir les gérants de catégorie A et B;
2. Modification subséquente des articles 11, 12 et 13 des statuts de la Société en vue de refléter la réorganisation de

la gérance;

3. Nomination de Mme Marjorie Allo en tant que gérante de catégorie A et de M. Brian Karaba et M. Stephen M. Sokal

en tant que gérants de catégorie B de la Société; et

4. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé de réorganiser la gérance de la Société en créant deux catégories différentes de gérants, à savoir les

gérants de catégories A et B.

Dans le cadre de la réorganisation de la gérance, il est décidé de (i) octroyer un pouvoir de signature conjoint d'au

moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B liant la Société à l'égard des tiers, (ii) établir un quorum d'au
moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B présent ou représenté pour les réunions du conseil de gérance
et (iii) soumettre les décisions du conseil de gérance au vote favorable de la majorité des gérants incluant le vote favorable
d'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier les articles 11, 12 et 13 des statuts de la Société

comme suit:

« Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas

où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société, le cas échéant. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même
manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société, le cas échéant.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou ces Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée

de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par le consentement de chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication approprié, s'ils sont initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant
à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation
est réputée équivalente à une participation physique.

131649

L

U X E M B O U R G

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue à toutes fins utiles, si au commencement de celle-ci, au moins

un gérant de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B sont présents en personne ou représentés par un man-
dataire.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion du conseil

de gérance de la Société valablement tenue, par un vote favorable de la majorité des gérants présents ou représentés par
un mandataire incluant le vote favorable d'au moins un gérant de catégorie A et d'au moins un gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.»

<i>Troisième résolution

Il est décidé de reconnaître la démission de M. Lawrence C. Somma en tant que gérant de la Société.
Il est en outre décidé d'approuver la nomination de:
- Mme Marjorie ALLO, née le 19 novembre 1967, à Paris, France, avec son adresse professionnelle au 2-4, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommée gérante de catégorie A de la Société, avec
effet immédiat pour une durée indéterminée;

- M. Brian KARABA, né le 22 janvier 1981, à Niskayuna, New York, Etats-Unis d'Amérique, avec son adresse profes-

sionnelle au 71, South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, Etats-Unis d'Amérique, est nommé gérant de catégorie B
de la Société, avec effet immédiat pour une durée indéterminée en remplacement de M. Lawrence C. Somma; et

- M. Stephen M. SOKAL, né le 2 février 1951, à Miami Beach, Floride, Etats-Unis d'Amérique, avec son adresse pro-

fessionnelle au 71, South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, Etats-Unis d'Amérique, est nommé gérant de catégorie
B de la Société, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Suite à cette résolution, le conseil de gérance de la Société sera composé de Mme Marjorie Allo en tant que gérante

de catégorie A et M. Brian Karaba et M. Stephen M. Sokal en tant que gérants de catégorie B.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 900,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes repré-

sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Joseph ELVINGER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2013. Relation GRE/2013/3636. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2013134163/222.
(130163696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

RAIFFEISEN Luxembourg Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 171.427.

<i>Extrait du procès verbal de la 3 

<i>e

<i> réunion du conseil d'administration tenue en date du 29 juillet 2013 à 11 heures au 4, rue Léon

<i>Laval, L-3372 Leudelange

<i>Résolution 7: Changement d'adresse du siège social

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, soit à l'adresse

du siège administratif de la société en accord avec l'article 2 des statuts de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013135001/15.
(130163957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

131650

L

U X E M B O U R G

InterFact S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.031.000,00.

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 82.163.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of the month of September,
before us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Advent Mach S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg (the "RCS") under number B 89.855 and having a share capital of
five hundred and thirty-five thousand seven hundred and seventy-five Euro (€ 535,775) and represented by Me Ana
BRAMAO, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 17 September 2013 which
shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities after having been signed by the
proxyholder and the undersigned notary,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of InterFact S.A.R.L. (the "Company"), a société à responsabilité

limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of Maître Martine Decker, notary, then
residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg of 3 May 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") of 5 December 2001, number 1113, registered with the RCS under number B 82.163 and
having a share capital of eight hundred and twenty-six thousand seven hundred Euro (€ 826,700).

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary,

on the date hereof, not yet published in the Mémorial.

The appearing party declared and requested the notary to state that:
1. The Sole Shareholder holds all the thirty-three thousand sixty-eight (33,068) shares in issue in the Company so that

decisions can validly be taken by the Sole Shareholder on all items on the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are the following:

<i>Agenda

A. Increase of the issued share capital of the Company from an amount of eight hundred and twenty-six thousand

seven hundred Euro (€826,700) to an amount of one million thirty-one thousand Euro (€ 1,031,000) by the creation and
issue of eight thousand one hundred and seventy-two (8,172) new shares without any nominal value for a total subscription
price of two million forty-three thousand Euro (€ 2,043,000) (the "Subscription Price"); subscription for the new shares
and payment of the Subscription Price by Advent Mach S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg (the "RCS") under
number B 89.855 and having a share capital of 535,775 Euro being the sole shareholder of the Company (the "Sole
Shareholder") through the contribution in kind of a receivable of an aggregate amount (principal and interest included)
of two million forty-three thousand Euro (€ 2,043,000) held by the Sole Shareholder against the Company (the "Recei-
vable") and approval of the valuation thereof; allocation of an amount of two hundred four thousand three hundred Euro
(€204,300) to the share capital of the Company and allocation of the remainder, being one million eight hundred and
thirty-eight thousand seven hundred Euro (€ 1,838,700) to the share premium of the Company;

B. Subject to the approval of item A, consequential amendment of the first indent of article 5 of the articles of association

of the Company to reflect the above increase of the share capital of the Company.

After having duly considered the above, the Sole Shareholder resolved as follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from an amount of eight hundred

and twenty-six thousand seven hundred Euro (€ 826,700) to an amount of one million thirty-one thousand Euro (€
1,031,000) by the creation and issue of eight thousand one hundred and seventy-two (8,172) new shares without any
nominal value.

The new shares were entirely subscribed for the Subscription Price and paid-up in full by the Sole Shareholder, through

the contribution in kind of a definite, due and payable receivable of an aggregate amount (principal and interest included)
of two million and forty-three thousand Euro (€ 2,043,000) held by the Sole Shareholder against the Company (the
"Contribution in Kind").

The Contribution in Kind has been further described and valued by the board of managers of the Company pursuant

to a valuation report dated 17 September 2013. The conclusion of this report is as follows:

131651

L

U X E M B O U R G

"The board of managers of the Company is of the opinion that the Contribution in Kind as described above, as offered

by Advent Mach in consideration for the issue of 8,172 shares in the Company without any nominal value, is equal to an
aggregate total amount of EUR 2,043,000 which corresponds at least to the aggregate par value (and premium) of the
shares to be issued by the Company, and that, accordingly, the Company may issue 8,172 new shares, allocate an amount
of EUR 204,300 to the share capital of the Company and an amount of EUR 1,838,700 to the share premium account of
the Company'"

The Sole Shareholder approved the above valuation of the Contribution in Kind at an aggregate amount of two million

and forty-three thousand Euro (€ 2,043,000).

The Sole Shareholder decided to allocate an amount of two hundred and four thousand three hundred Euro (€ 204,300)

to the share capital of the Company and to allocate the remainder, being one million eight hundred and thirty-eight
thousand seven hundred Euro (€ 1,838,700) to the share premium account of the Company.

Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Contribution in Kind and the transfer of the Contribution in

Kind described hereabove to the Company was given to the undersigned notary.

The Sole Shareholder, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exist no impediments to

the free disposal of the Contribution in Kind and that the receivable with respect to the Contribution in Kind is a definite,
due and payable receivable of the Sole Shareholder

<i>Second resolution

Consequently to the first resolution, the Sole Shareholder resolved to amend the first indent of article 5 of the articles

of association of the Company to reflect the above increase of the share capital of the Company approved by the above
resolutions as follows:

Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is set at one million thirty-one thousand Euro (€ 1,031,000), repre-

sented by forty-one thousand two-hundred and forty (41,240) units without any nominal value'".

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at two thousand seven hundred Euro (€ 2,700).

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing party,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of discrepancies
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxyholder known to the notary by name, first name, civil

status and residence, the appearing party's proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-septième jour du mois de septembre,
par-devant nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Advent Mach S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 15,

rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 89.855 et dont le capital social est de cinq cent trente-cinq mille
sept cent soixante-quinze euros (535.775 €), et représentée par Me Ana BRAMAO, maître en droit, résidant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d' une procuration datée du 17 septembre 2013, laquelle restera annexée au
présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement après avoir été signée par le mandataire
et le notaire soussigné,

étant l'associé unique Associé Unique») d'InterFact S.A.R.L. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, dont le siège social est situé au 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée le 3 mai 2001 suivant acte reçu de Maître Martine Decker, notaire alors de résidence à Wiltz, Grand-Duché
de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 5 décembre 2001, numéro
1113, et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 82.163 et dont le capital social s'élève à huit cent vingt-six mille
sept cents euros (826.700 €).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, ce jour, suivant acte reçu du notaire soussigné, non

encore publié au Mémorial.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
3. L'Associé Unique détient la totalité des trente-trois mille soixante-huit (33.068) parts sociales émises de la Société,

de sorte que l'Associé Unique peut valablement prendre des décisions sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

4. Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

131652

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

A. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de huit cent vingt-six mille sept cents euros (826.700

€) à un montant d'un million trente et un mille euros (1.031.000€) par la création et l'émission de huit mille cent soixante-
douze (8.172) nouvelles parts sociales sans valeur nominale pour un prix total de souscription de deux millions quarante-
trois mille euros (2.043.000 €) (le «Prix de Souscription»); souscription aux nouvelles parts sociales et paiement du Prix
de Souscription par Advent Mach S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social
est situé au 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 89.855 et dont le capital social s'élève à 535.775
euros, étant l'associé unique de la Société Associé Unique»), par l'apport en nature d'une créance d'un montant total
(principal et intérêts inclus) de deux millions quarante-trois mille euros (2.043.000 €) détenue par l'Associé Unique à
l'encontre de la Société (la «Créance») et approbation de l'évaluation de celle-ci; affectation d'un montant de deux cent
quatre mille trois cents euros (204.300 €) au capital social de la Société et affectation du solde, soit un million huit cent
trente-huit mille sept cents euros (1.838.700 €), au compte de prime d'émission de la Société;

B. Sous réserve de l'approbation du point A., modification en conséquence du premier alinéa de l'article 5 des statuts

de la Société afin de refléter l'augmentation ci-dessus du capital social de la Société.

Après avoir dûment considéré ce qui précède, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société pour le porter d'un montant de huit cent

vingt-six mille sept cents euros (826.700 €) à un montant d'un million trente et un mille euros (1.031.000 €) par la création
et l'émission de huit mille cent soixante-douze (8.172) nouvelles parts sociales sans valeur nominale.

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites au Prix de Souscription et intégralement libérées par

l'Associé Unique, par l'apport en nature d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant total (principal et intérêts
inclus) de deux millions quarante-trois mille euros (2.043.000 €) détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société
Apport en Nature»).

L'Apport en Nature a fait l'objet d'une description plus détaillée et d'une évaluation par le conseil de gérance de la

Société en vertu d'un rapport d'évaluation daté du 17 septembre 2013. La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Le conseil de gérance de la Société est d'avis que l'Apport en Nature tel que décrit ci-dessus, tel que proposé par

Advent Mach en contrepartie de l'émission de 8.172 parts sociales dans la Société sans valeur nominale, est égal à un
montant total de 2.043.000 EUR, ce qui correspond au moins à la valeur nominale totale (et la prime) des parts sociales
devant être émises par la Société, et que, par conséquent, la Société peut émettre 8.172 nouvelles parts sociales, affecter
un montant de 204.300 EUR au capital social de la Société ainsi qu'un montant de 1.838.700 EUR au compte de prime
d'émission de la Société».

L'Associé Unique a approuvé l'évaluation ci-dessus de l'Apport en Nature à un montant total de deux millions quarante-

trois mille euros (2.043.000 €).

L'Associé Unique a décidé d'affecter un montant de deux cent quatre mille trois cents euros (204.300 €) au capital

social de la Société et d'affecter le solde, soit un million huit cent trente-huit mille sept cents euros (1.838.700 €), au
compte de prime d'émission de la Société.

La preuve par l'Associé Unique de la propriété de l'Apport en Nature ainsi que du transfert de l'Apport en Nature

décrit ci-dessus à la Société a été donnée au notaire soussigné.

L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment autorisé, déclare qu'il n'existe aucune res-

triction quant au libre transfert de l'Apport en Nature et que la créance quant à l'Apport en Nature est une créance
certaine, liquide et exigible de l'Associé Unique.

<i>Seconde résolution

Consécutivement à la première résolution, l' Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article

5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation ci-dessus du capital social de la Société approuvée par la réso-
lution ci-avant comme suit:

« Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à un million trente et un mille euros (1.031.000 €), représenté par

quarante et un mille deux cent quarante (41.240) parts sociales sans valeur nominale.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelle que forme que ce soit, qui incomberont à la Société sont

estimés à deux mille sept cents euros (2.700 €).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

131653

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par

nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Bramao, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42450. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134172/175.
(130163623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Heraldic LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Beechy S.à r.l.).

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.294.

Ce document remplace celui annexé au dépôt L130161956 du 20 septembre 2013
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of August,
before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement

of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, the latter
remaining depositary of the present deed,

there appeared:

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share

capital of twelve thousand five hundred euro and twenty-one cent (EUR 12,500.21) with registered office at 26-28, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 143926 (the "Shareholder"),

hereby represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 27 

th

 August 2013.

The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of

Beechy S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of notary Marc Loesch, residing in Mondorf-les-Bains, of 29
November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 129 of 18 January 2013 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173.294 (the "Company"). The
articles of incorporation have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To change the Company's corporate name from "Beechy S.à r.l." into "Heraldic LuxCo S.à r.l.".
2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro cent (EUR 0.01) so as to raise it from

its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand five hundred euro and one
cent (EUR 12,500.01).

3 To issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges

as the existing shares.

4 To accept subscription for the new share, with payment of a share premium in a total amount of four million three

hundred and ninety-four thousand three hundred and sixty-four euro and forty-three cent (EUR 4,394,364.43) by the
sole shareholder and to accept full payment in kind.

5 To amend the first paragraph of article 5 and the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the

Company, in order to reflect the capital increase.

6 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to change the Company's corporate name from "Beechy S.à r.l." into "Heraldic LuxCo S.à

r.l."

131654

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro cent (EUR

0.01) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand
five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01).

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the

same rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value of

one euro cent (EUR 0.01), together with the payment of a share premium of four million three hundred ninety-four
thousand three hundred sixty-four euro and forty-three cent (EUR 4,394,364.43) and to make payment in full for such
new share by a contribution in kind consisting of a receivable held by the Shareholder against the Company (the "Con-
tribution").

The Contribution represents a value in an aggregate amount of four million three hundred ninety-four thousand three

hundred sixty-four euro and forty-four cent (EUR 4,394,364.44).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.
The Shareholder declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there

subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation
and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to
perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Con-

tribution is described and valued (the "Report").

The conclusions of the Report read as follows:
"Based on our the valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution in

Kind which corresponds at least in number and nominal value to the one new share, with a nominal value of one euro
cent (EUR 0.01), to be issued with a share premium in an aggregate amount of four million three hundred and ninety-
four thousand three hundred and sixty-four euro and forty-three cent (EUR 4,394,364.43)."

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one (1) new share according to

the above mentioned subscription.

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to amend the third paragraph of the article 1 and the first paragraph of article 5 of the

articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraphs will from now on
read as follows:

« Art. 1. Form, Name. The Company will exist under the name of "Heraldic LuxCo S.à r.l.".

Art. 5. Issued Capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro and one

cent (EUR 12,500.01) divided into one million two hundred fifty thousand one (1,250,001) shares with a nominal value
of one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up".

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at four thousand euro (EUR 4,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in
case of inconsistencies between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, who is known to the notary by his

or her surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-sept août,
par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Marc

Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier
nommé restera dépositaire du présent acte.

131655

L

U X E M B O U R G

A comparu:

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant un capital

social de douze mille cinq cents euros et vingt et un centimes (EUR 12.500.21), avec siège social au 26-28, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 143926 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Manfred Müller, demeurant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 27 août 2013.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Beechy S.à r.l., une

société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), dont le siège social est au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte du notaire Marc Loesch, de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 29 novembre 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 129 du 18 janvier 2013 et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.294 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été
modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Modification de la dénomination sociale de la Société de «Beechy S.à r.l.» en «Heraldic LuxCo S.à r.l.».
2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0,01) pour le porter de son

montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR
12.500,01).

3 Émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes

droits et privilèges que les parts sociales existantes.

4 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant

total de quatre millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-quatre euros et quarante-trois centimes
(EUR 4.394.364,43) par l'Associé à libérer intégralement par un apport en nature.

5 Modification du premier alinéa de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société, afin de

refléter l'augmentation de capital.

6 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de «Beechy S.à r.l.» en «Heraldic LuxCo S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0.01) pour le

porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cents euros et un centime
(EUR 12.500,01).

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01),

ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à une (1) part sociale nouvelle d'une valeur no-

minale d'un centime d'euros (EUR 0,01), ensemble avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre
millions  trois  cent  quatre-vingt-quatorze  mille  trois  cent  soixante-quatre  euros  et  quarante-trois  centimes  (EUR
4.394.364,43) et libérer intégralement cette part sociale souscrite par un apport en nature consistant en une créance
détenue par l'Associé contre la Société (l' «Apport»).

L'Apport représente un montant total de quatre millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-

quatre euros et quarante-quatre centimes (EUR 4.394.364,44).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.
L'Associé a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au

libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifi-
cations, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le

«Rapport»).

131656

L

U X E M B O U R G

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:
«Sur base de notre méthode d'évaluation, nous n'avons pas d'observation à mentionner sur la valeur de l'Apport en

nature qui correspond au moins en nombre et valeur nominale à une part sociale nouvelle, d'une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01), à émettre avec une prime d'émission d'un montant total de quatre millions trois cent quatre-
vingt-quatorze mille trois cent soixante-quatre euros et quarante-trois centimes (EUR 4.394.364,43).»

<i>Quatrième résolution

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre la part sociale nouvelle conformément

à la souscription ci-dessus mentionnée.

<i>Cinquième résolution

L'Associé a décidé de modifier le troisième alinéa de l'article 1 et le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société

pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  La Société adopte la dénomination «Heraldic LuxCo S.à r.l.».»

« Art. 5. Capital émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros et un centime (EUR 12.500,01)

divisé en un million deux cent cinquante mille et une (1.250.001) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à quatre mille cents euros (EUR 4.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande au même
mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante ci-avant, connu du notaire

instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Müller, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 29 août 2013. REM/2013/1537. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): L. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134160/182.
(130163412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Grace Lodge Care II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 18.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 180.319.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the ninth of September.
Before  Us  Maître  Marc  LOESCH,  notary  residing  in  Mondorf-les-Bains,  acting  in  replacement  of  Maître  Martine

SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent and who will remain the
depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

UK Carehomes Holdings S.à r.l., a limited liability company with registered office at L-2310 Luxembourg, 6, avenue

Pasteur and in the course of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, here represented by
Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given in Luxembourg on September 9 

th

 , 2013.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

131657

L

U X E M B O U R G

Art. 1. There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Grace Lodge Care II Holding S.à r.l." (the
Company).

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets, including without

limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may borrow in any form and issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts,

warrants and any kind of debt or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings
and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly

connected with its purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at eighteen thousand British Pounds (GBP 18,000) represented

by eighteen thousand (18,000) shares having a nominal value of one British Pound (GBP 1) per each share.

Art. 6. The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 13 of these articles of association.

Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).

Art. 10.  The  death,  suspension  of  civil  rights,  insolvency  or  bankruptcy  of  the  sole  shareholder  or  of  one  of  the

shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 11 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration
(if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

131658

L

U X E M B O U R G

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented,
and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of
managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or

telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at
the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain
attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

Art. 12. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 13. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.

Art. 14. The Company's year starts on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 15. Each year, with reference to December 31 

st

 , the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits is at the free disposal of the shareholder's general meeting. The manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 17. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All the eighteen thousand (18,000) shares have been subscribed by UK Carehomes Holdings S.à r.l., prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of eighteen thousand British Pounds (GBP

18,000) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31 

st

 , 2013.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

131659

L

U X E M B O U R G

The amount of eighteen thousand British Pounds (GBP 18,000) corresponds to the amount of twenty-one thousand

two hundred seventy-four Euro and fifteen Eurocent (EUR 21,274.15).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two (2). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited

period of time:

- Mr Emmanuel Mougeolle, director, born in Epinal, France, on July 3 

rd

 , 1977, residing professionally at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg; and

- Mrs Géraldine Schmit, director, born in Messancy (Belgium) on November 12 

th

 , 1969, residing professionally at 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2) The registered office is established in L-2310 Luxembourg, 6 avenue Pasteur.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le neuf septembre.
Par-devant Nous, Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, agissant en remplacement de Maître

Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera le dépo-
sitaire de la présente minute.

A COMPARU:

UK Carehomes Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 6, avenue

Pasteur, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, ici représentée par Monsieur
Gianpiero SADDI, employé privé, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 septembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie

comparante et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la

suite une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Grace Lodge Care II Holding S.à r.l." (ci-après, la
Société).

Art. 2. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indi-

rectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit,
l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, par échange ou toute
autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
son portefeuille.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses
avoirs.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de titres, obligations, bons

de caisse, certificats, parts bénéficiaires et warrants ainsi que et toute sorte d'instruments de dette ou de capital. La
Société peut prêter des fonds, y compris ceux issus du produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières à ses filiales,
à des sociétés affiliées ainsi qu'à toute autre société.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

131660

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de dix-huit mille Livres Sterling (18.000.- GBP) représenté

par dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Livre Sterling (1.- GBP) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 13 des présents statuts.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de

gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle
il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents
ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des
compétences du conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa
rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de
gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion
de s'entendre mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion.
Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société
et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un
président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

131661

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 14. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les dix-huit mille (18.000) parts sociales ont été souscrites UK Carehomes Holdings S.à r.l., préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de dix-huit mille Livres

Sterling (18.000.- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

La somme de dix-huit mille Livres Sterling (18.000,- GBP) correspond à la somme de vingt et un mille deux cent

soixante-quatorze Euros et quinze Centimes d'Euro (EUR 21.274,15).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique préqualifié représentant la totalité du capital souscrit

a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont nommés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Mr Emmanuel Mougeolle, gérant de Sociétés, né à Epinal, France, le 3 juillet 1977, demeurant professionnellement à

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

- Madame Géraldine Schmit, gérant de Sociétés, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, résidant profes-

sionnellement à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Loesch.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 septembre 2013. LAC/2013/42005. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

131662

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013134125/294.
(130163573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Sunflower Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 124.443.

L'an deux mille treize, le huit juillet,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

SUNFLOWER HOLDINGS (CAYMAN), L.P., une limited partnership de droit des Iles Cayman, avec siège social à C/

O WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, immatriculée
auprès du Registre des Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 18956 (ci-après l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Fabienne Cattini, avec adresse professionnelle à L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou

Hemmer,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1 

er

 juillet 2013.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de Sunflower Holdings (Luxembourg) S.à r.l., en liquidation (ci-après la «Société»),

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, inscrite auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 124.443, constituée suivant acte
notarié en date du 22 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 679 du 23 avril
2007.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 27 février 2007, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1001 du 30 mai 2007.

La Société a été mise en liquidation suivant acte notarié en date du 22 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 881 du 13 avril 2013.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a

ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 9A, rue

Gabriel Lippmann vers L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

<i>Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier, dans ses versions anglaise et française la 1 

ère

phrase de l'article 2.1. des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxem-

bourg."

Version française:

« 2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution:

L'Associé Unique décide de modifier avec effet immédiat l'adresse de son siège social ainsi que celle du liquidateur et

de la fixer à la nouvelle adresse, savoir Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, P.O.
Box 309, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Findel, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: F. Cattini, M. Loesch.

131663

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Remich, le 11 juillet 2013. REM/2013/1237. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 24 septembre 2013.

.

Référence de publication: 2013134447/52.
(130163552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Kompass Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.663.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'associé Westfalen Gründstucks- und

Immobilien GmbH &amp; Co. KG et aussi du changement de nom du registre et du numéro d'immatriculation:

Lüdinghauser Straße 23
59387 Ascheberg, Allemagne
Nom du registre: Registre Commercial du Tribunal local de Coesfeld
Numéro d'immatriculation: HRA 6878
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Stijn Curfs
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013134887/18.
(130164258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Energy Investments Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 57.675.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 juillet 2013 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de M. Joseph WINANDY, Administrateur et de

M. Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur en remplacement de M. Joseph

EL GAMMAL:

M. Koen LOZIE
Domicilié au 61, Grand-Rue
L-8510 Redange-sur-Attert
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouvel Administrateur en remplacement de COSAFIN

S.A.:

JALYNE S.A., Société Anonyme,
Ayant son siège social au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg
Représentée par M. Jacques BONNIER
1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2013.

Copie certifiée conforme
ENERGY INVESTMENTS LUX S.A.
- / JALYNE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013134729/29.
(130163966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

131664


Document Outline

Beechy S.à r.l.

Buvette Piscine de Dudelange S.à r.l.

Carraig Mor

Caspian Luxembourg Company S.à r.l.

DBAG Investment I S.à r.l.

DBAG Investment I S.à r.l.

Energy Investments Lux S.A.

EPG Investment Partners

Etech Investissements S.A.

Expertise Informatique Luxembourg S.à r.l.

Formes Contemporaines S.A.

Galathee S.A.

GARANT-MÖBEL Holding International S.A.

GB Aero Holding S.à r.l.

Geninvest Group S.A.

Global Paints S.A.

Global Paints S.A.

Globe All Investment SA

Gottex Partners (Luxembourg) S.à r.l.

Goudal Gestion S.à r.l.

GP ManCo Holding PE S.à r.l.

GPR Aerospace Holdings S.à r.l.

Grabory S.à r.l.

Grace Lodge Care II Holding S.à r.l.

Grand Hôtel Billia Holding S.A.

Green Basil S.A.

Groupe Aldelia

Haarslev Holding S.à r.l.

Haneda Holding S.à r.l.

Harmonia Investments S.à r.l.

Hary Putz Promotions

Haydn S.à r.l.

Heraldic LuxCo S.à r.l.

Heraldic LuxCo S.à r.l.

Heraldic MidCo S.à r.l.

Hotel Investors I, Inc.

H.P. Participations

Humphrey Invest S.A.

ICH Property Holding S.A.

Iecorp S.à r.l.

IFICOM Financial Company S.A.

Ifigenia S. à r.l.

Ilsole S.A. SPF

Imbrazo S.A.

Immobilière Maritime Méditérranéenne S.A.

Immo du Nord S.A.

Immonew S.à r.l.

Immo Sud S.A.

Immo Sud S.A.

In Art We Trust - Artfund Investments SIF

InterFact S.à.r.l.

International Omnia S.A.

International Transfert Consulting S.A.

Ipron Capital SPF S.A.

Ipron Capital SPF S.A.

Jupiter Immo 69 S.A.

Kompass Wohnen S.à r.l.

Luxembourg Residential Properties Loan Finance 2 S.à r.l.

OI-Incentive 2 S.A.

Piscine de Remich S.à r.l.

RAIFFEISEN Luxembourg Ré

SDT Securitisation S.A.

Starting 2008 Investment S.à r.l.

Sunflower Holdings (Luxembourg) S.à r.l.