This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2635
22 octobre 2013
SOMMAIRE
1-Days, S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126434
7ème Quai Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
126434
CEREP Tour Air 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126441
CEREP Valmy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126441
China Furnitures Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126469
Clairvaux Invest SPF - S.A. . . . . . . . . . . . . . .
126441
CLS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
126436
Coachman S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126442
COFRA Treasury Services S.A. . . . . . . . . . .
126442
Continental Finance Group S.A. . . . . . . . . .
126442
Dalinvest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126480
Delphinus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126436
Delphinus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126435
Delphinus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126436
Espace Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126440
Europ Estate & Property Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126441
Eurosoft Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126441
Golden Ring Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
126437
GT Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126435
Hannover Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126437
Hasa Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126438
Heidenkampsweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126435
Hoche Partners Real Estate S.A. . . . . . . . .
126438
Holstein Retail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126435
Hopetoun Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
126437
Hosting-Garage Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126434
Hupah Investor Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
126470
Hydra Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126455
Imprimerie Gérard Klopp S.à r.l. . . . . . . . .
126434
International Programs Development S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126438
Jardine Schindler (Pacific) S.à r.l. . . . . . . . .
126435
J&B Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126439
Jenebe International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126436
KANDAHAR (Springfield) S.à r.l. . . . . . . . .
126439
LFPE S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126439
Life-Cap Brokerage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126480
Luxemburg Capital Value . . . . . . . . . . . . . . .
126439
Meetings, Translations & Incentives Servi-
ces S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126440
Men Sana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126440
M-INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126440
Mobey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126443
Modesta Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
126437
MPRGEFI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126440
MTI Luxco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126462
Nandrin Galet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126443
Nettoservice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126444
Neuhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126443
North & South Airlogistics . . . . . . . . . . . . . .
126443
OB Partnership GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
126444
OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2)
Blocker S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126442
Oportet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126444
Paragon Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
126443
Phoenix Funding (Luxembourg) S.à r.l. . .
126438
Presidential Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
126439
RedWall Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
126444
Saigon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126469
S.C.I. Sitego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126477
T.D.S. Technologies, Development & Sup-
port Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126480
Victoria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126474
W2007 Parallel Bora S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126445
Xeops Consulting (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126445
Yeasty Minds S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126434
126433
L
U X E M B O U R G
Yeasty Minds S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 58.232.
<i>Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013i>
Transfert du siège social avec effet au 1
er
septembre 2013
- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125140/11.
(130152047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
1-Days, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 9, rue Ferdinand Nothomb.
R.C.S. Luxembourg B 144.860.
Le Bilan au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013125144/10.
(130151678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
7ème Quai Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 67.972.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour 7 i>
<i>èmei>
<i> QUAI LUXEMBOURG S.A.i>
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013125145/11.
(130152072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Imprimerie Gérard Klopp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Ellange, 34, Zone d'Activités Economiques Le Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 71.669.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/09/2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013125369/12.
(130152623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Hosting-Garage Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1C, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 113.839.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013125360/10.
(130152590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
126434
L
U X E M B O U R G
Heidenkampsweg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 119.043.
Les comptes annuels au 30 Novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Heidenkampsweg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2013125341/10.
(130152657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Holstein Retail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 134.370.
Les comptes annuels au 30 Novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Holstein Retail S.A.i>
Référence de publication: 2013125346/10.
(130152655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
GT Global S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 175.823.
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg que le siège social de GT GLOBAL
S.A. a été transféré avec effet au 28 février 2013 à l’adresse suivante:
L-2210 Luxembourg, 38 boulevard Napoléon 1
er
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2013.
<i>Pour GT GLOBAL S.A.i>
Référence de publication: 2013125335/13.
(130152814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Delphinus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 39.430.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELPHINUS SARL
Référence de publication: 2013125256/10.
(130152670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Jardine Schindler (Pacific) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.001,00.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 179.690.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125380/11.
(130152355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
126435
L
U X E M B O U R G
Delphinus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 39.430.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELPHINUS SARL
Référence de publication: 2013125254/10.
(130152668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Delphinus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 39.430.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELPHINUS SARL
Référence de publication: 2013125255/10.
(130152669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
CLS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.200.000,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 110.163.
EXTRAIT
En date du 29 août 2013, l’Associé unique a pris la résolution suivante:
- Monsieur Claes-Johan Geijer, avec adresse privée au 31, rue Frantz Clement à L-1345 Luxembourg, est élu nouveau
gérant de la société avec effet au 29 août 2013, et ce pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 29 août 2013.
Pour extrait conforme
Anders Lindbergh
Référence de publication: 2013125236/15.
(130152252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Jenebe International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.737.600,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 80.602.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 1 i>
<i>eri>
<i> aout 2013i>
Il résulte des décisions prises par les Associés en date du 1
er
août 2013 que:
- Monsieur Michel van Krimpen en tant que gérant de classe B, employé privé, avec adresse professionnelle au 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg a démissionné de son poste de gérant B de la société, avec date effective au 1
er
août 2013.
- Monsieur Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Lu-
xembourg a été élu au poste de gérant B de la société avec date effective au 1
er
août 2013 pour durée indéterminé.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013125381/19.
(130152242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
126436
L
U X E M B O U R G
Golden Ring Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 108.588.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Septembre 2013.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2013125333/13.
(130152821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Hopetoun Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 90.453.
EXTRAIT
En date 30 août 2013, l'associé unique de la société approuvé la résolution suivante:
- La démission de Monsieur Freddy de Petter en tant que gérant A est acceptée avec effet au1
er
septembre 2013.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125347/13.
(130152452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Hannover Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 123.239.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013125352/12.
(130152257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Modesta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 127.589.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 26 août 2013i>
1. Monsieur Donovan ANDRE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Monsieur Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 23 décembre 1985, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MODESTA INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013125440/16.
(130152626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
126437
L
U X E M B O U R G
Hasa Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 85.041.
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 30 août 2013, le contrat de domiciliation
conclu avec la société sous rubrique 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 août 2013.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Rits / Alan Botfield
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2013125353/13.
(130152500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Hoche Partners Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 159.702.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 3 septembre 2013i>
L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Laurent Kind, Administrateur de sociétés, né le 28 novembre 1971
à Luxembourg, résidant professionnellement à L – 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie en tant qu’Adminis-
trateur et Administrateur délégué de la Société avec effet immédiat pour une durée de six ans.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013125358/13.
(130152511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
INTER-PRO-DE. S.A., International Programs Development S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.250,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 41.569.
<i>Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013i>
Transfert du siège social avec effet au 1
er
septembre 2013
- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125374/12.
(130152277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Phoenix Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.917.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
Le siège social de l'associé unique Phoenix Funding (Cayman) L.P., a changé et doit désormais se lire comme suit: 190,
Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Îles Caïmans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Phoenix Funding (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013125469/16.
(130152492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
126438
L
U X E M B O U R G
KANDAHAR (Springfield) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 139.222.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
M. Gérald Stevens
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013125391/12.
(130152272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
LFPE S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 125.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LFPE S.C.A. SICAR
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2013125408/12.
(130152372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Luxemburg Capital Value, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.590.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125420/10.
(130152304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Presidential Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R.C.S. Luxembourg B 22.569.
Les comptes annuels au 01.01.2012 au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125486/10.
(130152619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
J&B Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 32A, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 122.966.
Le bilan et l’annexe légale de l’exercice au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125379/10.
(130152377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
126439
L
U X E M B O U R G
M-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8028 Strassen, 24, rue Mathias Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 89.704.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour M-INVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013125421/11.
(130152303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Meetings, Translations & Incentives Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8015 Strassen, 3, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 53.661.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013125429/10.
(130152722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Men Sana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7636 Ernzen, 17, Montée de Ernzen.
R.C.S. Luxembourg B 94.397.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013125431/11.
(130152649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
MPRGEFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 165.374.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 2013 que:
- Monsieur Roberto DE LUCA et Madame Orietta RIMI ont démissionné de leur fonction de gérant.
- Monsieur Alessandro GASPARINI, employé privé, né à Milan (Italie) le 26 juin 1972 et domicilié via A. Volta 16,
CH-6830 CHIASSO a été nommé à la fonction de gérant.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013125442/13.
(130152426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Espace Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4410 Soleuvre, 2, Zone Um Woeller.
R.C.S. Luxembourg B 89.087.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125816/9.
(130152875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
126440
L
U X E M B O U R G
CEREP Valmy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 100.332.
EXTRAIT
Il apparait que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais
professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125750/13.
(130152957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Clairvaux Invest SPF - S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 161.473.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 5 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125754/10.
(130153057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
CEREP Tour Air 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.520.
EXTRAIT
Il apparait que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais
professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125748/13.
(130152913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Europ Estate & Property Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 45, rue St. Vincent.
R.C.S. Luxembourg B 103.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125821/9.
(130153417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Eurosoft Consulting S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-8308 Capellen, 89A, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 126.094.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125823/9.
(130152990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
126441
L
U X E M B O U R G
COFRA Treasury Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 39.234.
EXTRAIT
L'adresse professionnelle de Monsieur John Drury, administrateur, a été modifiée comme suit en date du 12 Août
2013:
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Michelin House, 81 Fulham Road, 3
ème
étage, London SW3 6RD, Angleterre.
Référence de publication: 2013125759/12.
(130153219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Continental Finance Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 64.751.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale annuelle qui s'est tenue au siège social de la Société à Luxembourg le 22 juillet 2013, a pris les
résolutions suivantes:
- Le mandat du réviseur d'entreprises de la Société - PricewaterhouseCoopers S.à r.l. - est reconduit à l'unanimité à
compter de ce jour et viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014.
- L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Jennifer JAMES en date du 28 janvier 2013 comme administrateur
de la Société et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2013.
Référence de publication: 2013125767/16.
(130152981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Coachman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9190 Vichten, 52D, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 92.325.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013125757/10.
(130153364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.054.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 5 août 2013 que:
- La démission de Mr. Pedro URQUIDI, gérant de la Société, a été acceptée avec effet immédiat;
- Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, résidant professionnellement
au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni, a été nommée gérant de la Société avec effet immédiat et ce
pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Référence de publication: 2013126031/16.
(130153321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
126442
L
U X E M B O U R G
Mobey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 161.979.
Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La société
Mobey S.A.
Référence de publication: 2013126001/11.
(130153389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Nandrin Galet, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, Site Hoyer.
R.C.S. Luxembourg B 145.275.
EXTRAIT
Le gérant a décidé de transférer le siège social de la succursale de l’adresse : Zone Industrielle – Site Hoyer à 8287
KEHLEN:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 2 septembre 2013.
Référence de publication: 2013126016/12.
(130153185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Neuhaus, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 61, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 152.036.
Le Bilan au 31 décembre 2012 de la société de droit étranger a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013126020/10.
(130153033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
North & South Airlogistics, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.774.
Le bilan au 30/06/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013126023/10.
(130153278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Paragon Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 616.209,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.036.
Les comptes annuels pour la période du 7 février 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2013.
Référence de publication: 2013126042/11.
(130153512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
126443
L
U X E M B O U R G
Nettoservice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 4, Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 11.739.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de la société mère Meyers S.A., ayant son siège social au 2, rue de
Breedewues, L-1259 Senningerberg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 43.564,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Référence de publication: 2013126019/12.
(130153599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Oportet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 171.339.
EXTRAIT
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que The Oportet Trust est actuellement géré par un deuxième trustee:
- La société Z-OPT Administration Ltd., ayant son siège social au 19 Kathleen Road, London SW11 2JR, UK, Company
House n. 08489769.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013126024/13.
(130153378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
OB Partnership GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 153.283.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 31 août 2013i>
<i>Dépôt à réctifier L130151235 déposé le 02/09/2013i>
Il en résulte dudit procès-verbal que:
L'Assemblée Générale remplace Monsieur Robert Heros en tant que Gérant par l'AGENCE IMMO HÉROS S.à r.l,
ayant son siège social au 15, Avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-3441 Dudelange. La durée du mandat débute au 31
août 2013 pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013126028/16.
(130153633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
RedWall Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 158.852.
Der Jahresabschluss vom 1. Januar 2013 bis 29. Mai 2013 (Clôture de liquidation) wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. September 2013.
<i>Für RedWall Management S.à r.l., en liquidation volontaire
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2013126077/13.
(130153108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
126444
L
U X E M B O U R G
W2007 Parallel Bora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.834,13.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 130.278.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 09 aout 2013, a décidé d'accepter:
- la démission de Maxime Nino en qualité de gérant de la Société avec effet au 9 août 2013.
- la nomination avec effet au 09 août 2013 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de GS
Lux Management Services Sarl, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88045
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 9 août 2013, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- GS Lux Management Services Sarl, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Marielle STIJGER
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013123907/23.
(130150257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.
Xeops Consulting (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 179.891.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of August.
Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Mr. Eric FERMAUD, born in Paris, France, on September 25, 1949, having his professional address at 6, rue Jean
Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr. Mihály KUDRJÁVCEV, born in Moscow, Russia, on September 18, 1973, having his professional address at 6, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Dr Klaus RICHTER, born in Bad Lauterberg im Harz, Germany, on March 4, 1953, having his professional address at
6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The appearing parties have requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a
private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Xeops Consulting (Luxembourg) S.à r.l." (the Company). The Company
is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
126445
L
U X E M B O U R G
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the provision, in Luxembourg or abroad, for any companies or enterprises or public
entity in any form whatsoever, of commercial services of Business Consulting including Strategy Consulting, Organization/
Operation Management, Project Management, Change Management, Human Resources as well as Other services com-
plementary to consulting: development and integration, training, Engineering consulting, executive selection and recruit-
ment and the interim management.
The company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property
rights of any nature or origin.
3.2. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities or legal
consulting without having obtained the requisite authorization.
3.3. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favors or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty thousand Euros (EUR 30,000), represented by twenty-two thousand five hundred
(22,500) A shares and seven thousand five hundred (7,500) B shares in registered form, having a nominal value of one
Euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
6.2. Each Share carry one (1) voting right.
6.3. The shares are freely transferable between shareholders.
6.4. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.5. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the corporate capital. In aforesaid three-quarters
majority, the holders of at least three-quarters of A shares must always be represented.
6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need to be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and
one or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
126446
L
U X E M B O U R G
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in
principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that
if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favor of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two class A Manager or
any class A manager and any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general
meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twelve (12), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
126447
L
U X E M B O U R G
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) Any increase in a shareholder's commitment to the Company and the Articles may only be amended with the
consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved within six (6) months following the end of the
relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (12), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend. If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the
financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually
earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realize
the Company's assets and pay its liabilities.
126448
L
U X E M B O U R G
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2014 and the first annual general meeting will be held before February 19, 2015.
<i>Subscription and Paymenti>
1. Eric FERMAUD subscribes for seven thousand five hundred (7500) A shares in registered form, having a nominal
value of one Euro each and two thousand five hundred (2500) B shares in registered form, having a nominal value of one
Euro each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of ten thousand Euro
2. Mihály KUDRJÁVCEV subscribes for seven thousand five hundred (7500) A shares in registered form, having a
nominal value of one Euro each and two thousand five hundred (2500) B shares in registered form, having a nominal value
of one Euro each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of ten thousand Euro
3. Dr Klaus RICHTER subscribes for seven thousand five hundred (7500) A shares in registered form, having a nominal
value of one Euro each and two thousand five hundred (2500) B shares in registered form, having a nominal value of one
Euro each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of ten thousand Euro
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of EUR 30,000 (thirty thousand Euros) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation and first location are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1) The following persons are appointed as class A manager of the Company for an undetermined period:
- Mr. Eric FERMAUD, born in Paris, France on September 25, 1949 and having his professional address at 6, rue Jean
Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr. Mihály KUDRJÁVCEV, born in Moscow, Russia on September 18, 1973 and having his professional address at 6,
rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
2) The following person is appointed as class B manager of the Company for an undetermined period:
- Dr Klaus RICHTER, born in Bad Lauterberg im Harz, Germany, on March 4, 1953, having his professional address at
6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg Grand Duchy of Lu-
xembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
126449
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung
Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunzehnten August..
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
ERSCHIENEN:
- Eric FERMAUD, geboren in Paris, Frankreich, am 25. September 1949, mit der Geschäftsadresse in 6, rue Jean
Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Mihály KUDRJÁVCEV, geboren in Moskau, Russland, am 18. September 1973, mit der Geschäftsadresse in 6, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
- Dr Klaus RICHTER, geboren in Bad Lauterberg in Harz, Germany, am 4. März 1953, mit der Geschäftsadresse in 6,
rue Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Die Erschienenen haben den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
I. Name - Sitz - Unternehmensgegenstand - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet "Xeops Consulting (Luxembourg) S.à r.l." (die Gesellschaft). Die
Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen
des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
geänderten Fassung (das Gesetz) und der vorliegenden Satzung (die Satzung).
Art. 2. Sitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann mittels eines
Beschlusses der Geschäftsführung innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der Sitz kann mittels eines Beschlusses
der Gesellschafter an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden entsprechend der für
die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen.
2.2. Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können kraft eines Beschlusses der Geschäftsführung
im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gegründet werden. Falls die Geschäftsführung feststellt, dass außerge-
wöhnliche politische oder kriegerische Entwicklungen eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen und dass diese
Entwicklungen oder Umstände die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die problemlose Kom-
munikation zwischen dem Büro am Geschäftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, dann kann der Sitz
vorübergehend in das Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Beendigung der besagten Entwicklungen oder Um-
stände. Solche vorübergehenden Maßnahmen bewirken nicht eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft, die
ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Unternehmensgegenstand.
3.1. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung kommerzieller Dienstleistungen in Luxemburg und im Ausland,
für Gesellschaften, Unternehmen, Körperschaften, Anstalten oder andere juristische Personen privaten oder öffentlichen
Rechts in jeglicher Form, im Bereich der Unternehmensberatung einschließlich Strategieberatung, Organisationsmanage-
ment/Betriebsführung, Projektmanagement, Change Management, Personalwesen sowie sonstige ergänzende Beratungs-
leistungen: Entwicklung und Integration, Training, Engineering Consulting, Auswahl und Suche von Führungskräften und
InterimManagement.
Die Gesellschaft kann in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentportfolios oder sonstiger geistiger Eigentums-
rechte jeder Art oder Herkunft investieren.
3.2. Um Zweifel zu vermeiden, die Gesellschaft darf keine gesetzlich regulierten Finanzsektortätigkeiten oder Rechts-
beratungsleistungen ohne die dafür erforderliche Genehmigung erbringen.
3.3. Die Gesellschaft darf jegliche kommerzielle, finanzielle oder industrielle Handlungen sowie jegliche Transaktionen
im Bezug auf Immobilien oder bewegliche Wirtschaftsgüter ausführen, die, direkt oder indirekt, dem Unternehmensge-
genstand förderlich sind oder sich auf diesen beziehen.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch Todesfall, Aufhebung der Bürgerrechte, Arbeitsunfähigkeit, Insolvenz,
Konkurs oder einen ähnlichen Vorfall, der einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.
II. Kapital - Beteiligungen
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital beträgt dreißigtausend Euro (EUR 30,000), davon zweiundzwanzigtausendfünfhundert (22,500)
als A Anteile und siebentausendfünfhundert (7.500) als B Anteile in registrierter Form zu je einem Nominalwert von
einem Euro (EUR 1).
126450
L
U X E M B O U R G
5.2. Das Stammkapital kann einmalig oder mehrmalig durch Beschluss der Gesellschafter erhöht oder gesenkt werden,
im Einklang mit den für die Änderung dieser Satzung vorgeschriebenen Bedingungen.
Art. 6. Anteile.
6.1. Die Anteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Inhaber je Aktie an.
6.2. Alle Anteile haben ein (1) Stimmrecht.
6.3. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
6.4. Falls die Gesellschaft über einen einzigen Gesellschafter verfügt, dann sind die Anteile frei auf Dritte übertragbar.
6.5. Falls die Gesellschaft über mehr als einen Gesellschafter verfügt, dann bedarf der Übertrag der Anteile (unter
Lebenden) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals halten.
In vorgenannte Dreiviertelmehrheit müssen die Inhaber von A Aktien die wenigstens drei Viertel dieser A Anteile halten,
immer vorhanden sein.
6.6. Ein Anteilübertrag ist für die Gesellschaft oder Dritte nur verbindlich nach Benachrichtigung oder Einwilligung der
Gesellschaft im Einklang mit Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs (Code Civil).
6.7. Am Sitz der Gesellschaft ist ein Register der Gesellschafter aufzubewahren, das von jedem Gesellschafter auf
Anfrage eingesehen werden kann.
6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile einziehen, vorausgesetzt:
(i) sie verfügt über ausreichende Rücklagen für diesen Zweck; oder
(ii) die Einziehung resultiert aus einer Senkung des Stammkapitals der Gesellschaft.
III. Management - Repräsentation
Art. 7. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer.
7.1. Die Leitung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die kraft eines Beschlusses der
Gesellschafter bestellt werden, mit dem zugleich die Amtszeit festgelegt wird. Die Geschäftsführer müssen Gesellschafter
sein.
7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung, durch einen Beschluss der Gesellschafter ab-
berufen werden.
Art. 8. Geschäftsführung. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so stellen sie die Geschäftsführung dar.
Die Gesellschafter können über die Bestellung zweier Klassen von Geschäftsführern entscheiden, d.h. einen oder
mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B.
8.1. Befugnisse der Geschäftsführung
(i) Alle Befugnisse, die kraft des Gesetzes oder der Satzung nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind,
fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung, die für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Handlungen
und Tätigkeiten im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft bevollmächtigt ist.
(ii) Die Geschäftsführung kann für bestimmte Angelegenheiten spezielle oder eingeschränkte Vollmachten an einen
oder mehrere Vertreter erteilen.
8.2. Verfahrensweisen
(i) Die Geschäftsführung versammelt sich auf Verlangen von mindestens zwei (2) der Geschäftsführer und zwar an dem
in der Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort, der sich in der Regel in Luxemburg befindet.
(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung über eine Versammlung der Geschäftsführung ist mindestens vierundzwanzig (24)
Stunden vorab an alle Geschäftsführer zu übermitteln, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall, wann die Art und
die Umstände desgleichen in der Bekanntmachung anzuführen sind.
(iii) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung anwesend oder vertreten
sind und erklären, vollste Kenntnis über die Tagesordnung der Versammlung zu besitzen. Ein Geschäftsführer kann ebenso
auf die Bekanntmachung einer Versammlung verzichten, entweder vor oder nach der Versammlung. Gesonderte schrift-
liche Bekanntmachungen sind nicht für jene Versammlungen erforderlich, die zu den Zeiten und an den Orten abgehalten
werden, die bereits in einem seitens der Geschäftsführung angenommenen Plan angegeben wurden.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vertretungsvollmacht für eine Versammlung der
Geschäftsführung erteilen.
(v) Die Geschäftsführung kann sich nur dann rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung müssen rechtskräftig anhand einer Stimmmehrheit der
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen werden, vorausgesetzt dass, falls die Gesellschafter einen
oder mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B bestellt haben, min-
destens einer (1) der Geschäftsführer der Klasse A und einer (1) der Geschäftsführer der Klasse B seine Stimme zu
Gunsten des Beschlusses abgibt. Über die Beschlüsse der Geschäftsführung ist Protokoll zu führen, das seitens des Ver-
sammlungsvorsitzenden unterzeichnet wird oder, falls kein Versammlungsvorsitzender ernannt wurde, seitens aller
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
126451
L
U X E M B O U R G
(vi) Jeder Geschäftsführer kann an einer Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon- oder Videokonferenz
sowie mittels sonstiger Kommunikationsmittel teilnehmen, die allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, sich ge-
genseitig zu identifizieren, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Eine derartige Teilnahme wird als gleichwertig
zu einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung betrachtet.
(vii) Beschlüsse der Geschäftsführung, die seitens aller Geschäftsführer im Umlaufverfahren unterzeichnet sind (Um-
laufbeschlüsse der Geschäftsführung) sind rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen
und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst wären und tragen das Datum der letzten Unterschrift.
8.3. Repräsentation
(i) Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zweier Ge-
schäftsführer der Klasse A oder eines Geschäftsführers der Klasse A und eines Geschäftsführers der Klasse B verpflichtet.
(ii) Die Gesellschaft ist ebenso gegenüber Dritten durch die Unterschrift einer Person(en), der spezielle Vollmachten
seitens der Geschäftsführung abgeordnet wurden, verpflichtet.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer. Erfolgt die Leitung der Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer, so sind
alle Bezugnahmen in der Satzung zu der Geschäftsführung, den Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer als Bezug-
nahmen zu dem alleinigen Geschäftsführer - falls zutreffend - zu verstehen.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind nicht persönlich für Verpflichtungen haftbar zu machen,
die sie aufgrund ihres Amtes im Namen der Gesellschaft rechtgültig eingegangen sind, unter der Voraussetzung, dass diese
Verpflichtungen im Einklang mit der Satzung und dem Gesetz stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Gesellschafterversammlungen und Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Sofern Beschlüsse nicht entsprechend Artikel 11.1. (ii) gefasst werden, sind Gesellschafterbeschlüsse in Gesell-
schafterversammlungen zu fassen (jeweils eine Gesellschafterversammlung).
(ii) Wenn die Anzahl der Gesellschafter nicht mehr als zwölf (12) beträgt, können die Gesellschafterbeschlüsse in
schriftlicher Form gefasst werden (Schriftlicher Gesellschafterbeschluss).
(iii) Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zu einer (1) Stimme.
11.2. Bekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Stimmverfahren
(i) Die Gesellschafter können seitens der Geschäftsführung zu Gesellschafterversammlungen einberufen werden. Die
Geschäftsführung muss eine Gesellschafterversammlung einberufen, in Folge des Verlangens von einer Zahl von Gesell-
schaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals repräsentieren.
(ii) Die schriftliche Bekanntmachung einer Gesellschafterversammlung ist an alle Gesellschafter mindestens acht (8)
Tage vor dem Versammlungstag zu geben, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall, wann die Art und die Umstände
desgleichen in der Bekanntmachung anzuführen sind.
(iii) Wenn Beschlüsse in schriftlicher Form gefasst werden sollen, so muss die Geschäftsführung den Text eines solchen
Beschlusses an alle Gesellschafter übermitteln. Die Gesellschafter sollen in schriftlicher Form abstimmen und innerhalb
der seitens der Geschäftsführung gesetzten Frist ihre getroffene Entscheidung an die Gesellschaft zurück übermitteln.
Jeder Geschäftsführer ist dazu berechtigt, die Stimmen auszuzählen.
(iv) Gesellschafterversammlungen sind an dem Ort und zu der Zeit abzuhalten, die in den Bekanntmachungen angeführt
sind.
(v) Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und über die
Tagesordnung der Gesellschafterversammlung informiert betrachten, kann diese ohne vorherige Bekanntmachung abge-
halten werden.
(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person (die kein Gesellschafter sein muss) eine schriftliche Vertretungs-
vollmacht für eine Gesellschafterversammlung erteilen.
(vii) Die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse sind von einer Zahl von Gesellschaftern zu
verabschieden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten. Falls diese Mehrheit bei der ersten Gesellschafterver-
sammlung nicht erlangt wird, so sind die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung
einzuberufen, in welcher der Beschluss durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen ist, unabhängig von dem
Verhältnis des repräsentierten Stammkapitals.
(viii) Jede Erhöhung der Verpflichtung der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft und jede Änderung der Satzung
kann nur durch Zustimmung der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter erfolgen, die mindestens drei Viertel des
Stammkapitals halten.
(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter.
(x) Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse werden unter Einhaltung der oben dargelegten Beschlussfähigkeits- und Mehr-
heitsvoraussetzungen gefasst und tragen das Datum der letzten Unterschrift, die vor Ablauf des seitens der Geschäfts-
führung gesetzten Frist eingegangen ist.
126452
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Alleinige Gesellschafter. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) reduziert ist:
(i) übt der alleinige Gesellschafter sämtliche Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung per Gesetz gewährt
werden;
(ii) ist jede Bezugnahme in der Satzung zu den Gesellschaftern, der Gesellschafterversammlung oder den Schriftlichen
Gesellschafterbeschlüssen gegebenenfalls als Bezugnahme zu dem alleinigen Gesellschafter oder dem Beschluss des allei-
nigen Gesellschafters zu verstehen; und
(iii) sind die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters zu protokollieren oder schriftlich abzufassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 13. Geschäftsjahr und Feststellung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.
13.2. Die Geschäftsführung hat jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung aufzustellen, gemeinsam mit
einem Bestandsverzeichnis des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, mit einem zusammenfassenden
Anhang der Verpflichtungen der Gesellschaft und der Verbindlichkeiten seitens der Geschäftsführer und Gesellschafter
gegenüber der Gesellschaft.
13.3. Jeder der Gesellschafter kann das Bestandverzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Abschluss des
jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) in der Gesellschafterversammlung (falls abgehalten) oder (b) mittels eines Schrift-
lichen Gesellschafterbeschlusses genehmigt werden.
Art. 14. Auditoren.
14.1. Falls gesetzlich vorgeschrieben sind die Tätigkeiten der Gesellschaft seitens eines oder mehrerer zugelassener
externer Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) zu beaufsichtigen. Die Gesellschafter bestellen, falls erfor-
derlich, die zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer, legen ihre Anzahl, Vergütung sowie ihre Amtszeit fest.
14.2. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft zwölf (12) übersteigt, sind die Tätigkeiten der Gesellschaft
von einem oder mehreren Revisoren zu beaufsichtigen, sofern das Gesetz nicht die Bestellung eines oder mehrerer
zugelassener externer Prüfer (réviseurs d'entreprises agréés) vorsieht. Die Revisoren unterliegen der Wiederernennung
durch die jährliche Gesellschafterversammlung. Sie können, aber müssen keine Gesellschafter sein.
Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Fünf Prozent (5%) des Jahresüberschusses der Gesellschaft sind den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen zu-
zuweisen (gesetzliche Rücklage). Diese Erfordernis endet, wenn die gesetzliche Rücklage einen Betrag erlangt, der zehn
Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.
15.2. Die Gesellschafter müssen die Zuteilung des Jahresüberschusses festlegen. Sie können sich für die Auszahlung
einer Dividende, die Zuweisung des Saldos auf ein Reservekonto oder einen Vortrag entsprechend den maßgeblichen
gesetzlichen Bestimmungen entscheiden.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit ausgeschüttet werden und unterliegen folgenden Bedingungen:
(i) die Geschäftsführung muss einen Zwischenabschluss erstellen;
(ii) anhand des Zwischenabschlusses muss nachgewiesen werden, dass ein ausreichender Gewinn und sonstige Rück-
lagen (einschließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; wobei davon ausgegangen wird, dass der auszuschüttende
Betrag nicht den Gewinn übersteigen darf, der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss
festgestellt wurde, erzielt wurde, erhöht um Gewinnvorträge und verfügbare Rücklagen sowie gemindert um Verlust-
vorträge und zu den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisende Beträge.
(iii) innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum des Zwischenabschlusses muss die Geschäftsführung den Beschluss
über die Ausschüttung der Zwischendividenden fassen; und
(iv) unter Berücksichtigung des Vermögens der Gesellschaft dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch
die Ausschüttung der Zwischendividenden nicht gefährdet werden. Falls die ausgezahlten Zwischendividenden den ver-
fügbaren Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, ist die Geschäftsführung berechtigt, die Erstattung der
Dividenden, die nicht dem tatsächlich erzielten Gewinn entsprechen, einzufordern und die Gesellschafter haben auf Ver-
langen der Geschäftsführung sofort den Überschuss der Gesellschaft rückzuvergüten.
VI. Auflösung - Liquidation
16.1. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Gesellschafterbeschlusses aufgelöst werden, der mit Zu-
stimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter gefasst wurde, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals
halten. Die Gesellschafter bestellen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, für die
Durchführung der Liquidation und legen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung fest. Sofern seitens der Gesellschafter
nicht anders entschieden wurde, sind die Insolvenzverwalter bevollmächtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu
verwerten und ihre Verbindlichkeiten zu begleichen.
16.2. Der Überschuss (falls vorhanden) nach der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlich-
keiten ist an die Gesellschafter proportional zu den von ihnen gehaltenen Anteilen auszuschütten.
126453
L
U X E M B O U R G
VII. Allgemeine Bestimmungen
17.1. Die Erstellung und der Verzicht auf Bekanntmachungen und Mitteilungen, die Fassung von Beschlüssen der Ge-
schäftsführung im Umlaufverfahren und der Schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse kann in schriftlicher Form, per Fax,
Email oder mittels eines anderen elektronischen Kommunikationsmittels erfolgen.
17.2. Vollmachten können in irgendeiner der oben angeführten Formen erteilt werden. Vollmachten in Verbindung
mit Versammlungen der Geschäftsführung können ebenso seitens eines Geschäftsführers erteilt werden, im Einklang mit
Bedingungen, die seitens der Geschäftsführung akzeptiert werden.
17.3. Unterschriften können handschriftlich sein oder in elektronischer Form, sofern sie alle gesetzlichen Anforde-
rungen erfüllen, um gleichbedeutend mit einer handschriftlichen Unterschrift zu sein. Unterschriften auf den im Umlauf-
verfahren gefassten Beschlüssen der Geschäftsführung, den seitens der Geschäftsführung in Telefon- oder Videokonferenz
gefassten Beschlüssen oder den Schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen können gegebenenfalls auf einem Originaldoku-
ment oder mehreren Kopien des selben Dokuments erscheinen, die insgesamt ein und dasselbe Dokument darstellen.
17.4. Alle nicht ausdrücklich in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden, im Einklang mit dem geltenden
Gesetz und vorbehaltlich etwaiger unabdingbarer Gesetzesbestimmungen, zur gegebenen Zeit seitens der Gesellschafter
bestimmt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit dem Tag dieses Dokuments und endet am einunddreißigsten (31.)
Dezember 2014 und die erste jährliche Generalversammlung wird vor dem 19. Februar 2015 stattfinden..
<i>Zeichnung und Zahlungi>
1.- Eric FERMAUD zeichnet siebentausendfünfhundert (7500) A Anteile in registrierter Form, mit einem Nominalwert
von einem Euro pro Anteil sowie zweitausendfünfhundert (2500) B Anteile, mit einem Nominalwert von einem Euro pro
Aktie und ist einverstanden, diese vollständig mittels einer Kapitaleinlage in Höhe von zehntausend Euro einzuzahlen.
2.- Mihály KUDRJÁVCEV zeichnet siebentausendfünfhundert (7500) A Anteile in registrierter Form, mit einem No-
minalwert von einem Euro pro Aktie sowie zweitausendfünfhundert (2500) B Anteile, mit einem Nominalwert von einem
Euro pro Aktie und ist einverstanden, diese vollständig mittels einer Kapitaleinlage in Höhe von zehntausend Euro ein-
zuzahlen.
3.- Dr. Klaus RICHTER zeichnet siebentausendfünfhundert (7500) A Anteile in registrierter Form, mit einem Nomi-
nalwert von einem Euro pro Aktie sowie zweitausendfünfhundert (2500) B Anteile, mit einem Nominalwert von einem
Euro pro Aktie und ist einverstanden, diese vollständig mittels einer Kapitaleinlage in Höhe von zehntausend Euro ein-
zuzahlen.
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreissig
tausend Euro (EUR 30.000) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich
bestätigt wird
<i>Kosteni>
Ausgaben, Kosten, Gebühren und Abgaben jeglicher Art, die seitens der Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung
und dem ersten Standort entstehen, werden auf EUR 1.500 (eintausendfünfhundert Euro ) geschätzt.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Kapital dar-
stellen, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Folgende Personen werden als Geschäftsführer der Klasse A der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt:
- Eric FERMAUD, geboren in Paris, Frankreich, am 25. September 1949, mit der Geschäftsadresse in 6, rue Jean
Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Mihály KUDRJÁVCEV, geboren in Moskau, Russland, am 18. September 1973, mit der Geschäftsadresse in 6, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2) Folgende Person wird als Geschäftsführer der Klasse B der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt:
- Dr Klaus RICHTER, geboren in Bad Lauterberg im Harz, Germany, am 4. März 1953, mit der Geschäftsadresse in 6,
rue Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich an der Adresse 6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Ersuchen der vorstehend bezeichneten Erschienenen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen
Version, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maß-
geblich ist.
126454
L
U X E M B O U R G
WORÜBER die vorliegende Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten
Tag.
Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen wurde, haben sie die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem
Notar unterzeichnet.
Signé: E. Fermaud, M. Kudrjávcev, K. Richter et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 août 2013. LAC/2013/38799. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2013.
Référence de publication: 2013124552/534.
(130151184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Hydra Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.884.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the second day of the month of August.
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 6NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500), registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg under number
B 166.230
represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 2 August 2013, which shall
be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Hydra Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Hydra Investment
S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
126455
L
U X E M B O U R G
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution
of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75 %) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers has, the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
126456
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2013.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
126457
L
U X E M B O U R G
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
BRE/Europe 6NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12,500.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12,500.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1.500,-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 164.777,
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am zweiten Tag des Monats August,
Vor dem unterzeichnenden Maître Francis Kesseler, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxem-
burg,
ist erschienen,
BRE/Europe 6NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgi-
schen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhun-
dert Euro (EUR 12.500,-) beträgt, und eingetragen ist im luxemburgischem Handels- und Gesellschaftsregister (Registre
de commerce et des sociétés) unter der Nummer, B 166.230
126458
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Herr Joe zeaiter, Juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht
vom 2 August 2013, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht
zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hydra Investment S.à r.l." (société à responsabilité limitée) wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
" Hydra Investment S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-
rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12,500.-), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25.-).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75 %) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
126459
L
U X E M B O U R G
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.
Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder „Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,
Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit" und „Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
126460
L
U X E M B O U R G
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2013 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
126461
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BRE/Europe 6NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12.500.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12.500.-
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-) betragen.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: Zeaiter, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 août 2013. Relation: EAC/2013/10660.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013124237/424.
(130150870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
MTI Luxco Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.111.480,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 166.050.
In the year two thousand and thirteen, the thirty-first day of July, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of MTI Luxco S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166.050 and having a share
capital of three million twenty-eight thousand eight hundred and ninety United States Dollars (USD 3,028,890,-) (the
Company). The Company has been incorporated on 14 December 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler,
126462
L
U X E M B O U R G
prenamed, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 555 dated 2 March 2012. The articles of
associations of the Company (the Articles) were amended most recently pursuant to a deed received by Maître Francis
Kesseler, prenamed, on 13 August 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2492 dated
6 October 2012.
THERE APPEARED:
1. SCP III AIV One, L.P., an exempted limited partnership under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, acting through its general partner
(Shareholder I);
2. G14M5 PATCO Equity, L.L.C., a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
pace of business at 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America;
3. T11M5 PATCO Equity, L.L.C., a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
pace of business at 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America;
4. GP09GV (Edison) Ltd., a corporation under the laws of the Province of Alberta, having its registered office at Suite
1100, 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
5. GP09PX (Edison) Ltd., a corporation under the laws of the Province of Alberta, having its registered office at Suite
1100, 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
6. Vesey Street Fund IV (ERISA) Blocker, L.P., a limited partnership under the laws of the Cayman Islands, having its
principal pace of business at 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey 08540, United States of America, acting
through its general partner;
7. MTI Co-Invest, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal pace of
business at 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey 08540, United States of America;
8. VCVC III LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal pace of business
at 505 Fifth Avenue, Suite 900, Seattle, Washington 98104, United States of America;
9. PineBridge Structured Capital Partners II, L.P., a limited partnership under the laws of the State of Delaware, having
its principal pace of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United States of America;
10. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II, L.P., a limited partnership under the laws of the Cayman Islands,
having its principal pace of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United States of America,
acting through its general partner;
11. American International Group, Inc., Retirement Plan Master Trust, a trust under the laws of the Commonwealth
of Massachusetts, acting through its trustee, having its principal pace of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New
York, New York 10022, United States of America;
12. Honeywell International Inc. Master Retirement Trust, a trust under the laws of the State of New Jersey, acting
through its investment advisor, having its principal place of business at 101 Columbia Road, Morristown, New Jersey
07962, United States of America;
13. Soper Investments Limited, a limited liability company under the laws of the Bailiwick of Guernsey, having its
registered office at Regency Court, Glategny Esplanade, St. Peter Port, Guernsey GY1 1WW;
14. West Maple Ventures, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
pace of business at 1603 Orrington Avenue, Suite 810, Evanston, Illinois 60201, United States of America;
15. Brenthurst Private Equity IV US, LP, an international limited partnership under the laws of the British Virgin Islands,
having its principal pace of business at 1 Charterhouse Street, London EC1N 65A, United Kingdom, acting through its
general partner;
16. John Carleton Lindgren, company executive, with professional address at 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, On-
tario K2K 2X1, Canada;
17. Nima Family Trust, a trust under the laws of the Province of Ontario, acting through its trustee, with professional
address at 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
18. Peter Gillingham Family Trust, a trust under the laws of the Province of Ontario, acting through its trustee, with
professional address at 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
19. Kim Family Trust, a trust under the laws of the Province of Ontario, acting through its trustee, with professional
address at 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
20. Shaer Family Trust, a trust under the laws of the Province of Ontario, acting through its trustee, with professional
address at 11 Hines Road, Suite 203;
21. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II-A, L.P, a limited partnership under the laws of the Cayman
Islands, having its principal pace of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United States
of America, acting through its general partner;
22. Rellim Trust Company, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
pace of business at 160 GREENTREE DR STE 101, Dover 19904, United States of America;
126463
L
U X E M B O U R G
23. Mark Pu, professionally residing at c/o PATCO Investors, L.L.C. 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor Chicago, IL
60606, United States of America; and
24. TPOP-MTI, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal pace of
business at 2711 CENTERVILLE RD STE 400, Wilmington 19808, United States of America (together with the sharehol-
ders listed from 1 to 23 above, the Shareholders),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, whose professional address is at
Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal,
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that three million twenty-eight thousand eight hundred and ninety (3,028,890), having a nominal value of USD 1.-
each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of eighty-two thousand five hundred and ninety United
States Dollars (USD 82,590.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of three million
twenty-eight thousand eight hundred and ninety United States Dollars (USD 3,028,890.-) represented by
(i) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class A units (the "Class A Units");
(ii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class B units (the "Class B Units");
(iii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class C units (the "Class C Units");
(iv) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class D units (the "Class D Units");
(v) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class E units (the "Class E Units");
(vi) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class F units (the "Class F Units");
(vii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class G units (the "Class G Units");
(viii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class H units (the "Class H Units");
(ix) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class I units (the "Class I Units"); and
(x) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class J units (the "Class J Units"),
to three million one hundred eleven thousand four hundred and eighty United States Dollars (USD 3,111,480.-) by
way of the issuance of eighty-two thousand five hundred and ninety (82,590) units, eight thousand two hundred and fifty-
nine (8,259) units in each class of units, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each;
3. Amendment of Article 17 of the articles of association of the Company;
4. Delegation of power;
5. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of eighty-two thousand five hundred
and ninety United States Dollars (USD 82,590.-) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of three million twenty-eight thousand eight hundred and ninety United States Dollars (USD 3,028,890.-) repre-
sented by
(xi) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class A units (the "Class A Units");
(xii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class B units (the "Class B Units");
(xiii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class C units (the "Class C Units");
(xiv) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class D units (the "Class D Units");
(xv) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class E units (the "Class E Units");
(xvi) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class F units (the "Class F Units");
(xvii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class G units (the "Class G Units");
(xviii) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class H units (the "Class H Units");
(xix) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class I units (the "Class I Units"); and
126464
L
U X E M B O U R G
(xx) three hundred two thousand eight hundred eighty-nine (302,889) class J units (the "Class J Units"),
to three million one hundred eleven thousand four hundred and eighty United States Dollars (USD 3,111,480.-) by
way of the issuance of eighty-two thousand five hundred and ninety (82,590) units, eight thousand two hundred and fifty-
nine (8,259) units in each class of units, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Shareholder I, represented as stated above, declares to subscribe to eighty-two thousand five hundred
and ninety (82,590) units, eight thousand two hundred and fifty-nine (8,259) units in each class of units, having a nominal
value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to two
million five hundred sixty-two thousand four hundred and five United States Dollars (USD 2,562,405.-) (the Contribution).
The Contribution in an aggregate amount two million five hundred sixty-two thousand four hundred and five United
States Dollars (USD 2,562,405.-) is to be allocated as follows:
(i) an amount of eighty-two thousand five hundred and ninety United States Dollars (USD 82,590.-) is to be allocated
to the share capital account of the Company; and
(ii) an amount of two million four hundred seventy-nine thousand eight hundred and fifteen United States Dollars (USD
2,479,815) is to be allocated to the share premium account of the Company attached to the shares.
The amount of two million five hundred sixty-two thousand four hundred and five United States Dollars (USD
2,562,405.-) corresponding to the Contribution is at the disposal of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend Article 17 of the Articles so that it reads henceforth as follows:
Art. 17. Capital.
(1) The capital of the company is three million one hundred eleven thousand four hundred and eighty United States
Dollars (USD 3,111,480.-) divided into
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class A units (the "Class A Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class B units (the "Class B Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class C units (the "Class C Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class D units (the "Class D Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class E units (the "Class E Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class F units (the "Class F Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class G units (the "Class G Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class H units (the "Class H Units");
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class I units (the "Class I Units"); and
- three hundred eleven thousand one hundred and forty-eight (311,148) class J units (the "Class J Units"),
all in registered form and with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each.
The rights and obligations attached to the Classes of Units shall be identical except to the extent otherwise provided
by the articles or by the Commercial Companies Act 1915.
(2) No unit is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any issuance premium to be paid to the
company in consideration for its issue.
(3) Ownership of a unit carries tacit knowledge of the resolutions validly adopted by the general meeting.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff in Luxembourg,
each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register
of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
126465
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trente-et-unième jour du mois de juillet, par devant Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de l'associé unique de MTI Luxco S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg au numéro
B 166.050 (la «Société»). La Société a été constituée le 14 décembre 2013 suivant acte de Maître Francis Kesseler,
prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°555 du 2 mars 2012. Les statuts de la Société
(les «Statuts») ont pas été modifiés pour la dernière fois le 13 août 2012 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°2492 le 6 octobre 2012.
ONT COMPARU:
1. SCP III AIV One, L.P., une société en commandite exemptée de droit des Iles Cayman, dont le siège social se situe
à P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY-1-1104, Iles Cayman, agissant par son associé commandité Associé
I»);
2. G14M5 PATCO Equity, L.L.C., une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établisse-
ment principal se situe au 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, Etats-Unis d'Amérique;
3. T11M5 PATCO Equity, L.L.C., une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établisse-
ment principal se situe au 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, Etats-Unis d'Amérique;
4. GP09GV (Edison) Ltd., une société commerciale de droit de la Province d'Alberta, dont le siège social se situe à
Suite 1100, 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
5. GP09PX (Edison) Ltd., une société commerciale de droit de la Province d'Alberta, dont le siège social se situe à
Suite 1100, 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
6. Vesey Street Fund IV (ERISA) Blocker, L.P., une société en commandite de droit des Iles Cayman, dont l'établissement
principal se situe à 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, agissant par son associé
commandité;
7. MTI Co-Invest, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établissement principal
se situe au 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique;
8. VCVC III LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établissement principal se
situe au 505 Fifth Avenue, Suite 900, Seattle, Washington 98104, Etats-Unis d'Amérique;
9. PineBridge Structured Capital Partners II, L.P., une société en commandite de droit de l'Etat du Delaware, dont
l'établissement principal se situe au 399 Park Avenue, 4
e
étage, New York, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique;
10. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II, L.P., une société en commandite de droit des Iles Cayman, dont
l'établissement principal se situe à 399 Park Avenue, 4
e
étage, New York, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique,
agissant par son associé commandité;
11. American International Group, Inc., Retirement Plan Master Trust, une fiducie de droit du Commonwealth du
Massachusetts, agissant par son fiduciaire, dont l'établissement principal se situe au 399 Park Avenue, 4e étage, New York,
NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;
12. Honeywell International Inc. Master Retirement Trust, une fiducie de droit de l'Etat du New Jersey, agissant par
son conseiller en investissements dont l'établissement principal se situe à 101 Columbia Road, Morristown, New Jersey
07962;
13. Soper Investments Limited, une société à responsabilité limitée de droit du bailliage de Guernesey, dont le siège
social se situe à Regency Court, Glategny Esplanade, St. Peter Port, Guernesey GY1 1WW;
14. West Maple Ventures, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établissement
principal se situe au 1603 Orrington Avenue, Suite 810, Evanston, Illinois 60201, Etats-Unis d'Amérique;
15. Brenthurst Private Equity IV US, LP, une société en commandite internationale de droit des Iles Vierges Britanniques,
dont l'établissement principal se situe au 1 Charterhouse Street, London EC1N 65A, Royaume-Uni, agissant par son
associé commandité;
16. John Carleton Lindgren, administrateur de société, dont l'adresse professionnelle se situe au 11 Hines Road, Suite
203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
17. Nima Family Trust, une fiducie de droit de la Province de l'Ontario, agissant par son fiduciaire, dont l'adresse
professionnelle se situe au 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
18. Peter Gillingham Family Trust, une fiducie de droit de la Province de l'Ontario, agissant par son fiduciaire, dont
l'adresse professionnelle se situe au 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
19. Kim Family Trust, une fiducie de droit de la Province de l'Ontario, agissant par son fiduciaire, dont l'adresse
professionnelle se situe au 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
20. Shaer Family Trust, une fiducie de droit de la Province de l'Ontario, agissant par son fiduciaire, dont l'adresse
professionnelle se situe au 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario K2K 2X1, Canada;
126466
L
U X E M B O U R G
21. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II-A, L.P, une société à responsabilité limitée de droit des Iles
Cayman, dont l'adresse professionnelle se situe au 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United
States of America, agissant par son general partner;
22. Rellim Trust Company, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établissement
principal se situe au 160 GREENTREE DR STE 101, Dover 19904, Etats-Unis d'Amérique;
23. Mark Pu, résident professionnellement au c/o PATCO Investors, L.L.C. 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor
Chicago, IL 60606, United States of America; et
24. TPOP-MTI, LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Delaware, dont l'établissement principal
se situe au 2711 CENTERVILLE RD STE 400, Wilmington 19808, Etats-Unis d'Amérique (ensemble avec les parties
mentionnées de 1 à 23 ci-dessus, les «Associés»),
dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle
à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Que trois millions vingt-huit mille huit cent quatre-vingt dix (3.028.890) parts sociales, ayant une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1) chacune, représentant l'intégralité du capital de la Société sont représentées à l'Assemblée
qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour reproduit ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux convocations d'usage;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt dix
Dollars Américains (USD 82.590) afin de porter le capital social de la société de trois millions vingt-huit mille huit cent
quatre-vingt dix Dollars Américains (USD 3.028.890), représenté par
(i) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de
Catégorie A»);
(ii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de
Catégorie B»);
(iii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de
Catégorie C»);
(iv) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de
Catégorie D»);
(v) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de
Catégorie E»);
(vi) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de
Catégorie F»);
(vii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de
Catégorie G»);
(viii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de
Catégorie H»);
(ix) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de
Catégorie I»); et
(x) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de
Catégorie J» ),
à trois millions cent onze mille quatre cent quatre-vingt Dollars Américains (USD 3.111.480) par l'émission de huit
mille deux cent cinquante-neuf (8.259) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune dans
chacune des catégories de parts sociales de la Société;
3. Modification de l'article 17 des Statuts;
4. Délégation de pouvoir; et
5. Divers.
III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux convocations d'usage, les as-
sociés se considèrent valablement convoqués et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué en avance.
126467
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-deux mille cinq cent
quatre-vingt dix Dollars Américains (USD 82.590) afin de porter le capital social de la société de trois millions vingt-huit
mille huit cent quatre-vingt dix Dollars Américains (USD 3.028.890), représenté par
(i) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de
Catégorie A»);
(ii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de
Catégorie B»);
(iii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de
Catégorie C»);
(iv) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de
Catégorie D»);
(v) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de
Catégorie E»);
(vi) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de
Catégorie F»);
(vii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de
Catégorie G»);
(viii) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de
Catégorie H»);
(ix) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de
Catégorie I»); et
(x) Trois cent deux mille huit cent quatre-vingt-neuf (302.889) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de
Catégorie J» ),
à trois millions cent onze mille quatre cent quatre-vingt Dollars Américains (USD 3.111.480) par l'émission de huit
mille deux cent cinquante-neuf (8.259) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune dans
chacune des catégories de parts sociales de la Société.
<i>Souscription et Libérationi>
Ces faits exposés, l'Associé I, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre-vingt-deux mille cinq
cent quatre-vingt dix (82.590) parts sociales, huit mille deux cent cinquante-neuf (8.259) parts sociales d'une valeur
nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune dans chacune des catégories de parts sociales de la Société, et les a
intégralement libérées par un apport en numéraire d'un montant de deux millions cinq cent soixante-deux mille quatre
cent cinq Dollars Américains (USD 2.562.405) Apport»).
L'apport d'un montant de deux millions cinq cent soixante-deux mille quatre cent cinq Dollars Américains (USD
2.562.405) est alloué comme suit:
(i) quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt dix Dollars Américains (USD 82.590) est alloué au compte de capital
social de la Société;
(ii) deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille huit cent quinze Dollars Américain (USD 2.479.815) est alloué
au compte de prime d'émission lié aux parts sociales de la Société.
En conséquence, le montant de deux millions cinq cent soixante-deux mille quatre cent cinq Dollars Américains (USD
2.562.405) est à la date de l'assemblée à la disposition de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts afin qu'ils aient désormais la teneur suivante:
« Art. 17. Capital social.
(1) Le capital social de la société est fixé a trois millions cent onze mille quatre cent quatre-vingt Dollars Américains
(USD 3.111.480), représenté par
(1) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie
A»);
(ii) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie
B»);
(iii) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie
C»);
(iv) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie
D»);
126468
L
U X E M B O U R G
(v) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie
E»);
(vi) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie
F»);
(vii) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie
G»);
(viii) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie
H»);
(ix) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie
I»); et
(x) Trois cent onze mille cent quarante-huit (311.148) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie
J»),
d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1) chacune.
Les droits et obligations attaches aux Catégories de Parts Sociales sont identiques, sauf disposition contraire des statuts
ou de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales.
(2) Aucune part sociale ne sera émise pour moins du montant total de sa valeur nominale et de toute prime payable
à la société en contrepartie de son émission.
(3) Le fait d'être propriétaire d'une Part Sociale vaut connaissance tacite des résolutions valablement adoptées par
l'assemblée générale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff à Luxembourg
pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des part sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ trois mille euros (EUR 3.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties
comparantes a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 août 2013. Relation: EAC/2013/10641.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013124348/381.
(130151161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Saigon S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. China Furnitures Sàrl).
Siège social: L-1260 Luxembourg, 15, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 115.951.
L'an deux mille treize,
le vingt-sept août.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Madame Nhân Nhân ON, gérante de société, demeurant à L-8010 Strassen, 180, route d'Arlon.
2.- Madame Limiao CHEN, gérante de société, demeurant à L-8010 Strassen, 174, route d'Arlon.
3.- Monsieur Zhiguang CHEN, gérant de société, demeurant à L-8010 Strassen, 174, route d'Arlon.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées en date du 26 août 2013,
126469
L
U X E M B O U R G
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Que les comparantes sub 1+2) sont les seules associées de la société à responsabilité limitée CHINA FURNITURES
SARL, avec siège social à L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 115.951 (NIN 2006 2413 787).
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg,
en date du 20 avril 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1328 du 10 juillet 2006.
Que le capital social de la société s'élève au montant de douze mille quatre cents Euros (€ 12.400.-), représenté par
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (€ 124.-) chacune.
Que suite à deux contrats de cession de parts sociales du 26 août 2013, lesquels contrats, après avoir été paraphés
"ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être
soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, les parts sociales sont attribuées comme suit:
1.- Madame Nhân Nhân ON, prénommée, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.- Madame Limiao CHEN, prénommée, quatre-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les cessions de parts sociales ont été acceptées au nom de la société conformément à l'article 1690 du Code Civil
avec dispense de signification, par les deux gérants de la société, à savoir Madame Limiao CHEN et Monsieur Zhiguang
CHEN, les deux prénommés.
Ensuite les comparantes sub 1+2), représentées comme dit ci-avant, agissant en leur qualité de seules associées de la
société, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (première phrase). La Société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration et d'un débit de
boissons alcoolisées et non-alcoolisées ainsi que l'import-export de tous produits ou marchandises y relatifs."
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident de changer la dénomination sociale de la société en SAIGON S.à r.l. et par conséquent de
modifier l'article 3 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 3. La Société prend la dénomination de SAIGON S.à r.l.."
<i>Troisième résolutioni>
Les associées décident de fixer le siège social à l'adresse suivante: L-1260 Luxembourg, 15, rue de Bonnevoie.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant d'après
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 28 août 2013. Relation: ECH/2013/1615. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 02 septembre 2013.
Référence de publication: 2013124720/56.
(130151782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Hupah Investor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 52.076.638,50.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 166.403.
In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Hupah Cayman Holding L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of Cayman Islands, having its
registered office at Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands and entered in the Cayman Islands Register under number 54966 (the "Shareholder"),
126470
L
U X E M B O U R G
hereby represented by Me Nicolas GAUZÈS, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal,
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
Hupah Investor Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having a share capital of fifty-one million nine hundred sixty-four thousand nine hundred sixty-five dollars of the
United-States of America and fifty cents (USD 51,964,965.50), with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2240
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 28 December
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 625 of 9 March 2012 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166403 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary notary,
of 19 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 342 of 12 February
2013.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred eleven thousand seven hundred
seventy-three dollars of the United States of America (USD 111,773) so as to raise it from its present amount of fifty-
one million nine hundred sixty-four thousand eight hundred sixty-five dollars of the United-States of America and fifty
cents (USD 51,964,865.50) to fifty-two million seventy-six thousand six hundred thirty-eight dollars of the United States
of America and fifty cents (USD 52,076,638.50).
2 To issue twenty-two thousand three hundred fifty-four (22.354) class A shares (the "Class A Shares"), twenty-two
thousand three hundred fifty-four (22,354) class B shares (the "Class B Shares"), twenty-two thousand three hundred
fifty-four (22,354) class C shares (the "Class C Shares"), twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) class D
shares (the "Class D Shares"), twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) class E shares (the "Class E Shares"),
twenty-two thousand three hundred fifty-five (22.355) class F shares (the "Class F Shares"), twenty-two thousand three
hundred fifty-five (22,355) class G shares (the "Class G Shares"), twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355)
class H shares (the "Class H Shares"), twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) class I shares (the "Class I
Shares") and twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) class J shares (the "Class J Shares"), with a nominal
value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents (USD 0,50.-) each, having the same rights and privileges
as the existing shares.
3 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of one million five
hundred seventy-eight thousand two hundred forty-one dollars of the United States of America and seventy cents (USD
1,578,241.70) by the sole shareholder and to accept full payment in cash for these new shares.
4 To amend the first paragraph of article five (5) of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect
the capital increase.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred eleven
thousand seven hundred seventy-three dollars of the United States of America (USD 111,773) so as to raise it from its
present amount of fifty-one million nine hundred sixty-four thousand eight hundred sixty-five dollars of the United-States
of America and fifty cents (USD 51,964,865.50) to fifty-two million seventy-six thousand six hundred thirty-eight dollars
of the United States of America and fifty cents (USD 52,076,638.50).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) Class A Shares, twenty-two
thousand three hundred fifty-four (22,354) Class B Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) Class
C Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) Class D Shares, twenty-two thousand three hundred
fifty-five (22,355) Class E Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) Class F Shares, twenty-two
thousand three hundred fifty-five (22,355) Class G Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) Class
H Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) Class I Shares and twenty-two thousand three hundred
fifty-five (22,355) Class J Shares, with a nominal value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents (USD
0,50) each, having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The Shareholder declared to subscribe for twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) Class A Shares,
twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) Class B Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-four
(22,354) Class C Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-four (22,354) Class D Shares, twenty-two thousand
126471
L
U X E M B O U R G
three hundred fifty-five (22,355) Class E Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) Class F Shares,
twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) Class G Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-five
(22,355) Class H Shares, twenty-two thousand three hundred fifty-five (22,355) Class I Shares and twenty-two thousand
three hundred fifty-five (22,355) Class J Shares with a nominal value of zero dollar of the United States of America and
fifty cents (USD 0,50) per share, with payment of a share premium in a total amount of one million five hundred seventy-
eight thousand two hundred forty-one dollars of the United States of America and seventy cents (USD 1,578,241.70) and
to fully pay in cash for these shares.
The amount of one million six hundred ninety thousand fourteen dollars of the United States of America and seventy
cents (USD 1,690,014.70) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been
submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above
mentioned subscription.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article five (5) of the articles of incorporation of the Company
in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
« Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at fifty-two million seventy-six thousand six hundred
thirty-eight dollars of the United States of America and fifty cents (USD 52,076,638.50) divided into ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class A shares (the "Class A Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class B shares (the "Class B Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class C shares (the "Class C Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class D shares (the "Class D Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class E shares (the "Class E Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class F shares (the "Class F Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-eight (10,415,328) class G shares (the "Class G Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-seven (10,415,327) class H shares (the "Class H Shares"), ten million four
hundred fifteen thousand three hundred twenty-seven (10,415,327) class I shares (the "Class I Shares") and ten million
four hundred fifteen thousand three hundred twenty-seven (10,415,327) class J shares (the "Class J Shares"), with a nominal
value of zero dollar of the United-States of America and fifty cents (USD 0.50) each, all of which fully paid up".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at two thousand three hundred (EUR 2.300.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dixième jour de juillet.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Hupah Cayman Holding L.P., an exempted limited partnership régie par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social
au Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans et imma-
triculée sous le numéro 54966 (l'«Associé»),
représenté aux fins des présentes par Maître Nicolas GAUZES, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique
de Hupah Investor Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital
social de cinquante et un millions neuf cent soixante-quatre mille neuf cent soixante-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique
et cinquante centimes (USD 51.964.965,50), dont le siège social est au 59, rue de Rollingergrund, L-2240 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, du 28 décembre 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 625 du 9 mars 2012, et immatriculée au Registre de Commerce
126472
L
U X E M B O U R G
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 166403 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés la
dernière fois suivant acte du notaire soussigné, en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 342 du 12 février 2013.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence cent onze mille sept cent soixante-treize dollars des
Etats-Unis d'Amérique (USD 111.773) pour le porter de son montant actuel de cinquante-et-un millions neuf cent
soixante-quatre mille huit cent soixante-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD
51.964.865,50) à cinquante-deux millions soixante-seize mille six cent trente-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et
cinquante centimes (USD 52.076.638,50).
2 Emission de vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales
de Catégorie A»), vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales
de Catégorie B»), vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales
de Catégorie C»), vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales
de Catégorie D»), vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de
Catégorie E»), vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de
Catégorie F»), vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de
Catégorie G»), vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de
Catégorie H»), vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de
Catégorie I») et vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de
Catégorie J»), d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD 0,50.-) cha-
cune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant
total d'un million cinq cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-
dix centimes (USD 1.578.241,70) par le seul associé à libérer intégralement en espèces.
4 Modification du premier paragraphe de l'article cinq (5) des statuts de la Société afin de refléter la réduction de
capital.
5 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence cent onze mille sept cent soixante-treize
dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 111.773) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un millions neuf
cent soixante-quatre mille huit cent soixante-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD
51.964.865,50) à cinquante-deux millions soixante-seize mille six cent trente-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et
cinquante centimes (USD 52.076.638,50).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) Parts Sociales de Catégorie A, vingt-
deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) Parts Sociales de Catégorie B, vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre
(22.354) Parts Sociales de Catégorie C, vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) Parts Sociales de Catégorie
D, vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie E, vingt-deux mille trois cent cinquante-
cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie F, vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie
G, vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie H, vingt-deux mille trois cent cinquante-
cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie I et vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de
Catégorie J, d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD 0,50) chacune,
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé a déclaré souscrire à vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) Parts Sociales de Catégorie A,
vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) Parts Sociales de Catégorie B, vingt-deux mille trois cent cinquante-
quatre (22.354) Parts Sociales de Catégorie C, vingt-deux mille trois cent cinquante-quatre (22.354) Parts Sociales de
Catégorie D, vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie E, vingt-deux mille trois cent
cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie F, vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales
de Catégorie G, vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie H, vingt-deux mille trois
cent cinquante-cinq (22.355) Parts Sociales de Catégorie I et vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq (22.355) Parts
Sociales de Catégorie J, d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD
0,50.-) chacune avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total d'un million cinq cent soixante-dix-huit mille
126473
L
U X E M B O U R G
deux cent quarante et un dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-dix centimes (USD 1.578.241,70) et les libérer
intégralement en espèces.
Le montant d'un million six cent quatre-vingt-dix mille quatorze dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-dix
centimes (USD 1.690.014,70) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été
rapportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les parts sociales nouvelles confor-
mément à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les
résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société s'élève à cinquante-deux millions soixante-seize mille six cent trente-
huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante centimes (USD 52.076.638,50) divisé en dix millions quatre cent
quinze mille trois cent vingt-huit (10.415.328) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), dix
millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-huit (10.415.328) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de
Catégorie B»), dix millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-huit (10.415.328) parts sociales de catégorie C (les
«Parts Sociales de Catégorie C»), dix millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-huit (10.415.328) parts sociales de
catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), dix millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-huit (10.415.328)
parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), dix millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-
huit (10.415.328) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), dix millions quatre cent quinze mille
trois cent vingt-huit (10.415.328) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), dix millions quatre
cent quinze mille trois cent vingt-sept (10.415.327) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»),
dix millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-sept (10.415.327) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales
de Catégorie I») et dix millions quatre cent quinze mille trois cent vingt-sept (10.415.327) parts sociales de catégorie J
(les «Parts Sociales de Catégorie J»), d'une valeur nominale de zéro dollar des Etats-Unis d'Amérique et cinquante cen-
times (USD 0,50.-) chacune, toutes sont entièrement libérées».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille trois cent euros (EUR 2.300.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: N. GAUZÈS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2013. Relation: DIE/2013/8829. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 août 2013.
Référence de publication: 2013124818/222.
(130152190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Victoria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 134.262.
In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of August.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the limited company (société anonyme) Victoria S.A.
(the "Company"), with registered office in L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, R.C.S. Luxembourg
section B number 134 262, incorporated pursuant to a deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster on
November 13
th
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 64 of January 10
th
,
2008.
126474
L
U X E M B O U R G
Its bylaws have been amended pursuant to a deed of Me Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, on 15 April
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1370 of 4 June 2008.
The meeting is presided by Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, company director, with professional address at 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Anne-Marie CHARLIER, corporate administrator, with professional address
at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Annerose GÔBEL, corporate administrator, with professional address at 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
I.- That the Agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Following the resolutions made by shareholders, at the occasion of the annual general meeting of the Company, to
proceed with the dissolution of the Company, decision to dissolve the Company and subsequently to put it into voluntary
liquidation.
2. Approval of the interim accounts as at 30 June 2013.
3. Election of Mr Marc SCHMIT, chief-accountant, with professional address at 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg, and Mrs Patsy WATSON, finance director, with professional address at 180 Great Portland Street, London
W1W 5QZ, United Kingdom, as Liquidators.
4. Authorization to the Liquidators to perform, besides the liquidation, such acts as shall be in the Company's interest
in accordance with Article 4 of the Articles of Incorporation and Article 145 of the Luxembourg law of 10
th
August 1915
on commercial companies.
5. Subject to approval of items 1 and 2, decision that the remuneration of the Liquidators be based on usual professional
fees and customary standards, at the expense of the Company.
6. Discharge to the Directors and the statutory Auditor with respect to their mandates for the period from 1 January
2013 until the date on which the Company is put into liquidation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders
and by the bureau of the Meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities and the proxies will be kept at the registered office of the Company.
III.- The Meeting was convened by a notice containing the agenda sent by registered mail to the shareholders on 2nd
of August 2013.
IV.- That it appears from the attendance list mentioned that out of 220,000,000 (two hundred and twenty million)
outstanding shares, 159,357,000 (one hundred fifty-nine million and three hundred fifty-seven thousand) shares are pre-
sent or represented at the present Meeting.
V.- After having acknowledged the report of the Chairman and having approved that the quorum has been reached
the meeting deliberated on the Agenda and took by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to dissolve the Company and puts it into voluntary liquidation.
<i>Second resolutioni>
The general meeting approves the interim accounts as at 30 June 2013.
<i>Third resolutioni>
The general meeting appoints Mr Marc SCHMIT, chief-accountant with professional address at 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg, and Mrs Patsy WATSON, finance director, with professional address at 180 Great Portland
Street, London W1W 5QZ, United Kingdom, as Liquidators.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting authorizes the Liquidators to perform, besides the liquidation, such acts as shall be in the Com-
pany's interest in accordance with Article 4 of the Articles of Incorporation and Article 145 of the Luxembourg law of
10th August 1915 on commercial companies.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides that the remuneration of the Liquidators shall be based on usual professional fees and
customary standards, at the expense of the Company.
126475
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting grants, by special vote, discharge to the Directors and the Statutory Auditor with respect to their
mandates for the period until the Company is put into liquidation.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 950.-
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le treize août.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Victoria S.A. (la «Société»),
avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, R.C.S. Luxembourg section B numéro 134
262, constituée suivant acte reçu par Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 13 novembre 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 64 du 10 janvier 2008.
Ses statuts ont été modifiés suivant acte de Me Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 avril 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1370 du 4 juin 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Anne-Marie CHARLIER, corporate administrator, avec adresse
professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Annerose GÔBEL, corporate aministrator, avec adresse profession-
nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Comme suite aux résolutions prises par les actionnaires, lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la société, de
procéder à la dissolution de la société, décision de dissoudre la Société et décision subséquente de la mettre en liquidation.
2. Approbation des comptes intérimaires au 30 juin 2013.
3. Nomination de M. Marc SCHMIT, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg, et Mme Patsy WATSON, finance director, avec adresse professionnelle au 180 Great Portland Street,
London W1W 5QZ, United Kingdom, comme Liquidateurs.
4. Autorisation à donner au Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l'intérêt de la Société
en conformité avec l'article 4 des statuts et l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
5. Sous réserve de l'approbation des points 1 et 2, décision que le Liquidateur sera rémunéré aux dépens de la Société
sur base des honoraires usuels pour ses services professionnels et le remboursement des dépenses encourues.
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de
la mise en liquidation de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des
actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement et les procurations seront conservées au siège social de la
Société.
III.- L'Assemblée a été convoquée par avis de convocation contenant l'ordre du jour envoyé par courrier recommandé
aux actionnaires le 2 août 2013.
126476
L
U X E M B O U R G
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur deux cent vingt millions (220.000.000) actions en circulation, cent
cinquante-neuf millions trois cent cinquante-sept mille (159.357.000) actions sont présentes ou représentées à l'Assem-
blée.
V.- Après avoir approuvé l'exposé du Président et après avoir reconnu que le quorum requis a été atteint, l'assemblée
a délibéré sur l'Ordre du Jour, et a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale approuve les comptes intérimaires au 30 juin 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale nomme M. Marc SCHMIT, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg, et Mme Patsy WATSON, finance director, avec adresse professionnelle au 180 Great
Portland Street, London W1W 5QZ, United Kingdom, à la fonction de Liquidateurs.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale autorise le Liquidateur à exécuter, à côté de la liquidation, les actes qui sont dans l'intérêt de la
Société en conformité avec l'article 4 des statuts et l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide que les Liquidateurs seront rémunérés aux dépens de la Société sur base des honoraires
usuels pour ses services professionnels et le remboursement des dépenses encourues.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale accorde, par vote spécial, décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 950,- EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Anne-Marie CHARLIER, Annerose GÖBEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2013. Relation GRE/2013/3467. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 3 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125107/155.
(130152204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
S.C.I. Sitego, Société Civile.
Siège social: L-7526 Mersch, 9, allée J.W. Léonard.
R.C.S. Luxembourg E 5.151.
STATUTS
L'an deux mil treize, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Madame Anneliese APPEL, gérante de sociétés, demeurant à L-7540 Rollingen, 70, rue de Luxembourg,
126477
L
U X E M B O U R G
2.- Monsieur Arsène GOUBER, employé privé, demeurant à L-7473 Schoenfels, 4A, rue du Village,
3.- Monsieur Alexandre TEIXEIRA DA GRACA, employé privé, demeurant à L-6212 Consdorf, 27, rue Hiel.
Ces comparants ont déclaré avoir convenu de constituer la société dont ils vont établir les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires
des parts sociales ci-après créées et de ceux qui pourront le devenir ultérieurement.
Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832
à 1872 du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs
immeubles, dans la limite d'opérations de caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes opérations commerciales.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également
se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société prend la dénomination suivante: S.C.I. SITEGO.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à Mersch.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée de vingt (20) ans à partir de ce jour. Dans ce cas, la procédure de
dissolution de la société sera effectuée par le ou les gérant(s) en fonction.
Les associés, par décision unanime portant modification des statuts, pourront modifier la forme juridique et décider
de la durée illimitée de la société.
La société peut être dissoute par décision des associés prise à l'unanimité.
La dissolution de la société n'est pas entraînée de plein droit par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un
associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.
Art. 6. Le capital social est fixé à DEUX MILLE SEPT CENTS (2.700.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts
d'intérêts de VINGT-SEPT (27.-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme
de DEUX MILLE SEPT CENTS (2.700.-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société civile, ainsi
qu'il a été justifié au notaire, qui le constate expressément.
Ces parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Anneliese APPEL, gérante de sociétés, demeurant à L-7540 Rollingen,
70, rue de Luxembourg, trente-quatre parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.- Monsieur Arsène GOUBER, employé privé, demeurant à L-7473 Schoenfels,
4A, rue du Village, trente-trois parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3.- Monsieur Alexandre TEIXEIRA DA GRACA, employé privé, demeurant à L-6212 Consdorf,
27, rue Hiel, trente-trois parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Total: CENT parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 7. Les parts d'intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
Chaque année l'assemblée des associés fixe la valeur d'une part d'intérêts.
Art. 8. La cession de parts d'intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être
opposable à la société, la cession doit conformément à l'article 1690 du code civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire
ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l'objet d'une
publicité au Mémorial Recueil Spécial C.
Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés, en ce
compris les héritiers ou légataires d'un associé, qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant
trois quarts du capital social. En cas de refus d'agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter un
autre acquéreur.
Art. 9. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à cette
désignation, la société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires indivis.
126478
L
U X E M B O U R G
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.
Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée
de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans
l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre des parts
existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société,
chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à
l'article 1863 du Code Civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous
les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de cette renonciation, intenter d'actions et de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.
Art. 11. La société est gérée collectivement par les associés. Toutefois, ils peuvent confier cette gestion à un ou
plusieurs associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la majorité simple des voix. Ils sont révocables dans les
mêmes conditions. L'assemblée fixe la durée de leur mandat.
Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-
constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 12. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comptes, à la date et
à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation verbale et sans
délai si tous les associés sont présents ou représentés.
Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la double majorité simple des associés et des voix attachées à leurs parts, présents ou
représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.
Art. 13. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu'elles qu'en soient la nature et l'importance.
Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à l'unanimité.
Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire
sera signé par tous les associés.
Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés proportionnellement à leur partici-
pation dans le capital social, les pertes s'il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des associés, ou des associés-gérants ou
de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Réunion des Associési>
A l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués. A l'unanimité, ils prennent les résolutions suivantes:
1.- Par référence à l'article onze des statuts, est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Arsène
GOUBER, préqualifié, qui engagera valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2. L'adresse de la société est fixée à L-7526 Mersch, 9, allée J.W. Léonard.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de MILLE (1.000.-) EUROS.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Appel, Gouber, Teixeira da Graca, THOLL.
126479
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Mersch, le 30 août 2013. Relation: MER/2013/1807. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Mersch, le 3 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125039/122.
(130152073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
T.D.S. Technologies, Development & Support Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 41.728.
<i>Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013i>
Transfert du siège social avec effet au 1
er
septembre 2013
- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125563/12.
(130152416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Life-Cap Brokerage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2672 Luxembourg, 4, rue de Virton.
R.C.S. Luxembourg B 144.533.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 août 2013i>
L'assemblée du 23 août 2013 a décidé:
- de clôturer la liquidation de la société, décidée le 21 août 2013;
- de déposer et conserver les livres et documents sociaux pendant cinq ans au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
<i>Pour LIFE-CAP BROKERAGE S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2013125967/15.
(130153430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.
Dalinvest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 85.208.
Par décision de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 23 août 2013, les mandats des administrateurs VALON
S.A., société anonyme, représentée par Monsieur Guy KETTMANN représentant permanent, LANNAGE S.A., société
anonyme, et KOFFOUR S.A., société anonyme, représentée par Monsieur Guy BAUMANN, représentant permanent,
tous au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été renouvelés pour une durée de six ans prenant fin lors de
l'assemblée générale annuelle de 2019.
Lors de cette même assemblée générale annuelle, le mandat du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société
anonyme, ayant son siège social au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été renouvelé pour une durée de six ans
prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2019.
Luxembourg, le 03.09.2013.
<i>Pour: DALINVEST S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2013125251/21.
(130152575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
126480
1-Days, S.àr.l.
7ème Quai Luxembourg S.A.
CEREP Tour Air 2 S.à r.l.
CEREP Valmy S.à r.l.
China Furnitures Sàrl
Clairvaux Invest SPF - S.A.
CLS Luxembourg S.à r.l.
Coachman S.à r.l.
COFRA Treasury Services S.A.
Continental Finance Group S.A.
Dalinvest SA
Delphinus S.à r.l.
Delphinus S.à r.l.
Delphinus S.à r.l.
Espace Concept S.A.
Europ Estate & Property Management S.A.
Eurosoft Consulting S.A.
Golden Ring Finance S.A.
GT Global S.A.
Hannover Holdings S.A.
Hasa Holding S.A.
Heidenkampsweg
Hoche Partners Real Estate S.A.
Holstein Retail S.A.
Hopetoun Holdings S.à r.l.
Hosting-Garage Sàrl
Hupah Investor Holdings S.à r.l.
Hydra Investment S.à r.l.
Imprimerie Gérard Klopp S.à r.l.
International Programs Development S.A.
Jardine Schindler (Pacific) S.à r.l.
J&B Concept S.A.
Jenebe International S.à r.l.
KANDAHAR (Springfield) S.à r.l.
LFPE S.C.A. SICAR
Life-Cap Brokerage S.A.
Luxemburg Capital Value
Meetings, Translations & Incentives Services S.A.
Men Sana S.à r.l.
M-INVEST S.A.
Mobey S.A.
Modesta Investments S.à r.l.
MPRGEFI S.à r.l.
MTI Luxco Sàrl
Nandrin Galet
Nettoservice S.A.
Neuhaus
North & South Airlogistics
OB Partnership GP S.à r.l.
OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) Blocker S.à r.l.
Oportet S.à r.l.
Paragon Management S.à r.l.
Phoenix Funding (Luxembourg) S.à r.l.
Presidential Partners S.A.
RedWall Management S.à r.l.
Saigon S.à r.l.
S.C.I. Sitego
T.D.S. Technologies, Development & Support Sàrl
Victoria S.A.
W2007 Parallel Bora S.à r.l.
Xeops Consulting (Luxembourg) S.à r.l.
Yeasty Minds S.A.