This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2590
17 octobre 2013
SOMMAIRE
Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124319
BCP Management Luxembourg S.à r.l. . . .
124313
Belval Plaza II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
Belval Plaza I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
'' BELVEDERE REAL ESTATE '' . . . . . . . . .
124313
'' BELVEDERE REAL ESTATE '' . . . . . . . . .
124320
BioPharma Secured Investments II Sub
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124311
Bocci Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Brainsourcing S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124311
BRE/Europe 3-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Buchler SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Bureau Européen de Comptabilité et de
Fiscalité S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124318
Burton Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
Cabbi Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124318
Casabiene S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124313
Catalyst EPF Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . .
124311
Cat Développement S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
124318
Chez Luz Maria Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124312
Chimindu International S.A. . . . . . . . . . . . .
124312
CMJ Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124318
Corton Meyney S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124318
Costa Martins S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124309
Cyrus Investissements 1 SA . . . . . . . . . . . . .
124317
DFR Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
124319
Esprit Coiffure Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124320
Eurosit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124320
GSCP VI AA Two Holding S.à r.l. . . . . . . . .
124274
High Point Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124285
International Company of Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124304
International Marketing Management . . . .
124286
International Medical Consult S.à r.l. . . . .
124303
International Paper Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124284
Investus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124295
I-Wohnen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124304
John Deere Cash Management S.A. . . . . . .
124285
Jopaco Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124286
JRS Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
124286
Julien Cajot S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124304
Juvema S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124286
KANDAHAR (Luxembourg) N°1 LIMITED
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124286
KANDAHAR (Luxembourg) N°2 LIMITED
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124284
KANDAHAR (Luxembourg) N°2 LIMITED
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124284
Karmaninvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124320
Kimi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124285
Kirchbergsee 1 V V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
124287
Kirchbergsee 2 V V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
124295
Landmark Investment Management Lux
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124303
Luxtecpro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124303
Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124274
Sani-Maintenance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
Surrey Healthcare Investments . . . . . . . . .
124310
Talia Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
124306
TCP Cable S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124309
Telenet Finance Luxembourg II S.A. . . . . .
124306
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l. . . . . . . . .
124306
Universal Securitisation Solutions . . . . . . .
124307
Vendest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124305
Verbriefungsgesellschaft REPE S.A. . . . . . .
124305
Vivimus SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124309
VLT Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124305
VP investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124307
VPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124305
YAO Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
124310
124273
L
U X E M B O U R G
GSCP VI AA Two Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 132.198.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 09 août 2013 , a décidé d'accepter:
- la démission de Maxime Nino en qualité de gérant de la Société avec effet au 9 août 2013.
- la nomination avec effet au 09 août 2013 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de GS
Lux Management Services Sarl, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88045
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 9 août 2013, composé comme suit:
- Marielle STIJGER, gérant
- GS Lux Management Services Sarl, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Marielle STIJGER
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2013123078/23.
(130149496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.
Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 157.443.
In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of August.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Mr. François Deprez, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA, having its registered
office at L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 157.443 (the "Company"),
pursuant to resolutions taken by the board of directors of the Company at a meeting held on 31
st
July 2013.
A copy of an excerpt of the minutes of such meeting, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary,
will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the declarations as follows:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean-Joseph Wagner, notary at that
time residing in Sanem, on 9 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mé-
morial C"), number 265 of 9 February 2011. The articles of association of the Company were last amended on 20 July
2012 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C number 2323, dated 18 September 2012.
2) The subscribed share capital of the Company was set at eighty-three thousand fourteen US dollars and eighty-nine
cents (USD 83,014.89), consisting of fifty-thousand (55,000) Class A shares having a nominal value of one US Dollar (USD
1) per share, one thousand nine hundred and fifty-nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B1 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand nine hundred and fifty-
nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand nine hundred and fifty-nine point six hundred and forty-nine
(1,959.649) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
one thousand nine hundred and fifty-nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B4 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand nine hundred and fifty-nine point
six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, one thousand nine hundred and fifty-nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class
B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand nine
hundred and fifty-nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a
124274
L
U X E M B O U R G
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand nine hundred and fifty-nine point six hundred and
forty-nine (1,959.649) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1)
per share, one thousand nine hundred and fifty-nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B9 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, one thousand nine hundred and fifty-
nine point six hundred and forty-nine (1,959.649) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84) Class C1 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight hundred and forty-one point
eighty-four (841.84) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84) Class C3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84) Class C4 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight hundred and forty-one
point eighty-four (841.84) Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD
1) per share, eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84) Class C6 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84) Class C7
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, eight hundred and forty-
one point eighty-four (841.84) Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84) Class C9 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and eight hundred and forty-one point eighty-four (841.84)
Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share.
3) Pursuant to article 5.2 of the articles of association of the Company, the authorised capital, including the issued
share capital, is set at five hundred fifty-five thousand US Dollars (USD 555,000), consisting of fifty-five thousand (55,000)
Class A shares having a nominal value of one US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B1
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand
(25,000) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
twenty-five thousand (25,000) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B6 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class B7 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class
B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand
(25,000) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
twenty-five thousand (25,000) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C3 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C4 Compul-
sorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000)
Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five
thousand (25,000) Class C6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, twenty-five thousand (25,000) Class C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, twenty-five thousand (25,000) Class C9 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and twenty-five thousand (25,000) Class C10 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share.
According to article 5.2.2. of the articles of association of the Company, during a period of time of five (5) years from
the date of publication of the articles of association or, as the case may be, during any additional period authorised pursuant
to article 5.2.3 of the articles of association of the Company and beginning on the date of publication of the resolution
to renew the authorisation set forth below in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, the board of directors be and is authorised to issue shares, to grant options, to
subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share
capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or
limiting the existing shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.
4) On 31
st
July 2013, the board of directors of the Company decided to increase the share capital of the Company
up to eighty-six thousand six hundred and fifty US dollars and fifty-nine cents (USD 86,650.59), consisting of fifty-five
thousand (55,000) Class A shares having a nominal value of one US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred
and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B2
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class
124275
L
U X E M B O U R G
B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class
B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class
B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class
B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and
fifty-one point zero four (951.04) Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C3
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-
one point zero four (951.04) Class C4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C5 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C6
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-
one point zero four (951.04) Class C7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C8 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C9
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and nine hundred and
fifty-one point zero four (951.04) Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, through the issuance of the Issued Shares (as defined below), having a par value of one US Dollar
(USD 1) each.
In accordance with article 5.2.2 of the articles of association of the Company, the board of directors decided to suppress
the preferential right of the existing shareholders to subscribe the newly issued shares.
The above issuance was subscribed as follows (such newly issued shares collectively referred to as the "Issued Shares"):
- Zeban Nominees Ltd, a private limited company incorporated and existing under the laws of England and Wales,
having its professional address at 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom, registered with the Companies
House under registration number 01000448, subscribed for 159.37 Class B1 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 159.37 Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 159.37 Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 159.37 Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, 159.37 Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, 159.37 Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, 159.37 Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD
1) per share, 159.37 Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, 159.37 Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
159.37 Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20
Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class
C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C3
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C4 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C5 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C6 Compulsorily Re-
deemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C7 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C8 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 79.20 Class C9 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and 79.20 Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate amount of two million three hundred and eighty-
five thousand seven hundred US dollars (USD 2,385,700.-), out of which an amount of two thousand three hundred and
eighty-five US dollars and seventy cents (USD 2,385.70), corresponding to the nominal value of the above mentioned
shares, is allocated to the share capital of the Company, and an aggregate amount of two million three hundred and eighty-
three thousand three hundred and fourteen US dollars and thirty cents (USD 2,383,314.30) is allocated to the share
premium account of the Company;
- Barclays Trust Channel Islands Ltd, a private limited company incorporated and existing under the laws of Jersey,
having its professional address at 39/41 Broad Street, St Helier, Jersey, JE4 8PU, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 470, subscribed for 8.50 Class B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 8.50 Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, 8.50 Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1)
US Dollar (USD 1) per share, 8.50 Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
124276
L
U X E M B O U R G
(USD 1) per share, 8.50 Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1)
per share, 8.50 Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
8.50 Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 8.50 Class
B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 8.50 Class B9
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and 8.50 Class B10
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate amount
of eighty-five thousand US dollars (uSd 85,000.-), out of which an amount of eighty-five US dollars (USD 85.-), corres-
ponding to the nominal value of the above mentioned shares, is allocated to the share capital of the Company, and an
aggregate amount of eighty-four thousand nine hundred and fifteen US dollars (USD 84,915.-) is allocated to the share
premium account of the Company;
- Barclays Bank (Suisse) SA, a société anonyme formed and existing under the laws of Switzerland, having its professional
address at Rue d'Italie, 10, CH-1204, Geneva, Switzerland, registered with the registre du commerce de Genève under
reference number 01381/1986 and federal registration number CH-660-0118986-6, subscribed for 69 Class B1 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B2 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B3 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B4 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, 69 Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US
Dollar (USD 1) per share, 69 Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, 69 Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1)
per share, 30 Class C1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
30 Class C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class
C3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class C4 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class C5 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class C6 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class C7 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 30 Class C9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and 30 Class C10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate amount of nine hundred and ninety thousand US dollars (USD
990,000.-), out of which an amount of nine hundred and ninety US dollars (USD 990.-), corresponding to the nominal
value of the above mentioned shares, is allocated to the share capital of the Company, and an aggregate amount of nine
hundred and eighty-nine thousand and ten US dollars (USD 989,010.-) is allocated to the share premium account of the
Company;
- Citco Global Custody N.V. ref Barclays Singapore Wealth Mgmt, a naamloze vennootschap incorporated and existing
under the laws of The Netherlands, having its professional address at Telestone 6 Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW
Amsterdam, The Netherlands, registered with the Dutch Central Bank under number 904070, subscribed for 12.50 Class
B1 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B2
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B3 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B4 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B5 Compulsorily Redee-
mable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B6 Compulsorily Redeemable
shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B7 Compulsorily Redeemable shares
having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B8 Compulsorily Redeemable shares having
a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 12.50 Class B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and 12.50 Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate amount of one hundred and twenty-five thousand US
dollars (USD 125,000.-), out of which an amount of one hundred and twenty-five US dollars (USD 125.-), corresponding
to the nominal value of the above mentioned shares, is allocated to the share capital of the Company, and an aggregate
amount of one hundred and twenty-four thousand eight hundred and seventy-five US dollars (USD 124,875.-) is allocated
to the share premium account of the Company; and
- Kernzahl AG, a limited liability company organized under the laws of Switzerland, having its professional address at
Stockerstrasse 44, CH-8002 Zürich, Switzerland, subscribed for 5 Class B1 Compulsorily Redeemable shares having a
nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 5 Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal
value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 5 Class B3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, 5 Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar
(USD 1) per share, 5 Class B5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per
share, 5 Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 5
Class B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 5 Class B8
124277
L
U X E M B O U R G
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, 5 Class B9 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share and 5 Class B10 Compulsorily Re-
deemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, for an aggregate amount of fifty thousand
US dollars (USD 50,000.-), out of which an amount of fifty US dollars (USD 50.-), corresponding to the nominal value of
the above mentioned shares, is allocated to the share capital of the Company, and an aggregate amount of forty-nine
thousand nine hundred and fifty US dollars (USD 49,950.-) is allocated to the share premium account of the Company.
The Issued Shares were fully paid up through a contribution in cash. The total amount of three million six hundred
and thirty-five thousand seven hundred US Dollars (USD 3,635,700) was made available to the Company, as it has been
shown to the undersigned notary.
5) As a consequence of such increase of share capital, paragraph 5.1.1 of article 5 of the articles of association is
amended and now read as follows:
" Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
5.1.1 The Company's issued share capital is set at eighty-six thousand six hundred and fifty US dollars and fifty-nine
cents (USD 86,650.59), consisting of fifty-five thousand (55,000) Class A shares having a nominal value of one US Dollar
(USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B1 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and
fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1)
US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B3 Com-
pulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred
and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B4 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one
(1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B5
Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class
B7 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class
B9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, two thousand two
hundred and fourteen point zero nineteen (2,214.019) Class B10 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value
of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C1 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero
four (951.04) Class C2 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C3 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C4 Compulsorily Re-
deemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero
four (951.04) Class C5 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C6 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C7 Compulsorily Re-
deemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share, nine hundred and fifty-one point zero
four (951.04) Class C8 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share,
nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C9 Compulsorily Redeemable shares having a nominal value of
one (1) US Dollar (USD 1) per share and nine hundred and fifty-one point zero four (951.04) Class C10 Compulsorily
Redeemable shares having a nominal value of one (1) US Dollar (USD 1) per share. (Class B1 Compulsorily Redeemable
shares, Class B2 Compulsorily Redeemable shares, Class B3 Compulsorily Redeemable shares, Class B4 Compulsorily
Redeemable shares, Class B5 Compulsorily Redeemable shares, Class B6 Compulsorily Redeemable shares, Class B7
Compulsorily Redeemable shares, Class B8 Compulsorily Redeemable shares, Class B9 Compulsorily Redeemable shares
and Class B10 Compulsorily Redeemable shares are hereinafter collectively referred to as "Class B Shares"); (Class C1
Compulsorily Redeemable shares, Class C2 Compulsorily Redeemable shares, Class C3 Compulsorily Redeemable shares,
Class C4 Compulsorily Redeemable share, Class C5 Compulsorily Redeemable shares, Class C6 Compulsorily Redee-
mable shares, Class C7 Compulsorily Redeemable shares, Class C8 Compulsorily Redeemable shares, Class C9
Compulsorily Redeemable shares and Class C10 Compulsorily Redeemable shares, are hereinafter collectively referred
to as "Class C Shares")."
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to four thousand euro.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this document.
124278
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le huit août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Monsieur François Deprez, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg,
agissant en sa qualité de représentant du conseil d'administration de Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA, ayant
son siège social au L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.443 (la «Société»),
conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société lors d'une réunion tenue le 31 juillet
2013.
Une copie d'un extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé «ne varietur» par le comparant et
par le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de documenter les
déclarations suivantes:
1) La Société a été constituée par un acte notarié par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
le 9 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), numéro 265 en date du
9 février 2011. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 20 juillet 2012 suivant acte passé par devant
le notaire soussigné, publié au Mémorial C n° 2323, en date du 18 septembre 2012.
2) La Société avait un capital social souscrit de quatre-vingt-trois mille quatorze dollars américains et quatre-vingt-neuf
cents (USD 83.014,89) représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf (1.959,649) actions Ob-
ligatoirement Rachetables de Classe B1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent
cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2 ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf
(1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B4 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six
cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B6 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent
cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7 ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf
(1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B9 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, mille neuf cent cinquante-neuf virgule six
cent quarante-neuf (1.959,649) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule
quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule
quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule
quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C7 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule
quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, huit cent quarante-et-un virgule quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C9 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et huit cent quarante-et-un
virgule quatre-vingt-quatre (841,84) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10 ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune.
3) Conformément à l'article 5.2 des statuts de la Société, le capital autorisé, y compris le capital social émis, est fixé à
cinq cent cinquante-cinq mille dollars américains (USD 555.000), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de
124279
L
U X E M B O U R G
Classe A ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe C5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille
(25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et vingt-cinq mille (25.000) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
Conformément à l'article 5.2.2 des statuts de la Société, durant une période de temps de cinq (5) ans à compter de la
date de publication des statuts ou, le cas échéant, durant toute période additionnelle autorisée conformément à l'article
5.2.3 des statuts de la Société et commençant à la date de la publication de la décision de renouveler l'autorisation telle
que prévue ci-dessous au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions, à accorder des options de souscription aux
actions et à émettre tout autre titre convertible en actions, dans la limite du capital autorisé, aux personnes et selon les
conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission en supprimant ou limitant le droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants pour les nouvelles actions qui seront émises.
4) Le 31 juillet 2013, le conseil d'administration de la société a décidé d'augmenter le capital social de la Société afin
de le porter à quatre-vingt-six mille six cent cinquante dollars américains et cinquante-neuf cents (USD 86.650,59) re-
présenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe
B1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-
neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro
dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4 ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule
zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6 ayant une valeur nominale d'un dollar amé-
ricain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B7 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze
virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B9 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze
virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10 ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Ra-
chetables de Classe C1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un
virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro
quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7 ayant une valeur
124280
L
U X E M B O U R G
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C8 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent
cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9 ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune et neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, par l'émission des Actions
Emises (comme défini ci-dessous), ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.
Conformément a l'article 5.2.2 des statuts de la Société, le conseil d'administration a décidé de supprimer le droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants pour les nouvelles actions émises.
L'émission ci-dessus a été souscrite comme suit (ces actions nouvellement émises sont ci-après désignées collective-
ment comme «Actions Emises»):
- Zeban Nominees Ltd, une private limited company constituée et existant selon les lois d'Angleterre et du Pays de
Galles, ayant son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Companies
House sous le numéro 01000448, a souscrit 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant
une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de Classe
B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rachetables de
Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement Rache-
tables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 159,37 actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 79,20 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 79,20
actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) cha-
cune, 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7, ayant une valeur nominale d'un dollar amé-
ricain (USD 1) chacune, 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune et 79,20 actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10, ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire de deux millions trois cent quatre-vingt-
cinq mille sept cents dollars américains (USD 2.385.700,-), desquels un montant de deux mille trois cent quatre-vingt-
cinq dollars américains et soixante-dix cents (USD 2.385,70), correspondant à la valeur nominale des actions
susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un montant global de deux millions trois cent quatre-vingt-
trois mille trois cent quatorze dollars américains et trente cents (USD 2.383.314,30) est alloué au compte de la prime
d'émission de la Société;
- Barclays Trust Channel Islands Ltd, une private limited company constituée et existant selon les lois de Jersey, ayant
son siège social au 39/41 Broad Street, St Helier, Jersey, JE4 8PU, enregistrée auprès de la Jersey Financial Services
Commission sous le numéro 470, a souscrit 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 8,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire d'un montant de quatre-
vingt-cinq mille dollars américains (USD 85.000,-), desquels un montant de quatre-vingt-cinq dollars américains (USD
85,-), correspondant à la valeur nominale des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un
montant global de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quinze dollars américains (USD 84.915,-) est alloué au compte de
la prime d'émission de la Société;
- Barclays Bank (Suisse) SA, une société anonyme constituée et existant selon les lois de la Suisse, ayant son siège social
au 10, Rue d'Italie, CH-1204, Genève, Suisse, enregistrée auprès du registre du commerce de Genève sous le numéro
de référence 01381/1986 et sous le numéro fédéral d'enregistrement CH-660-0118986-6, a souscrit 69 actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
124281
L
U X E M B O U R G
Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 69 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C8, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C9, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et 30 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C10, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange
d'un apport en numéraire d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (USD 990.000,-), desquels
un montant de neuf cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 990,-), correspondant à la valeur nominale des actions
susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un montant global de neuf cent quatre-vingt-neuf mille dix
dollars américains (USD 989.010,-) est alloué au compte de la prime d'émission de la Société;
- Citco Global Custody N.V. ref Barclays Singapore Wealth Mgmt, une naamloze vennootschap constituée et existant
selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au Telestone 6 Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Pays-
Bas, enregistrée auprès de la Banque Centrale des Pays-Bas sous le numéro 904070, a souscrit 12,50 actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B1, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 12,50 actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 12,50
actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) cha-
cune, 12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1)
chacune, 12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, 12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD 1) chacune, 12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une valeur nominale d'un dollar amé-
ricain (USD 1) chacune, 12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, 12,50 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une valeur nominale d'un
dollar américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire de cent vingt-cinq mille dollars américains (USD
125.000,-), desquels un montant de cent vingt-cinq dollars américains (USD 125,-), correspondant à la valeur nominale
des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un montant global de cent vingt-quatre mille huit
cent soixante-quinze dollars américains (USD 124.875,-) est alloué au compte de la prime d'émission de la Société; et
- Kernzahl AG, une société à responsabilité limitée organisée sous la loi suisse, ayant son adresse professionnelle à
Stockerstrasse 44, CH 8002 Zurich, Suisse, a souscrit 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B1, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B3, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B5, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B7, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B9, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, 5 actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, ayant une
valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, en échange d'un apport en numéraire de cinquante mille dollars
américains (USD 50.000,-), desquels un montant de cinquante dollars américains (USD 50,-), correspondant à la valeur
nominale des actions susmentionnées, est alloué au capital social de la Société et un montant global de quarante-neuf
mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 49.950,-) est alloué au compte de la prime d'émission de la Société.
Les Actions Emises ont été entièrement libérées par un apport en numéraire. Le montant total de trois millions six
cent trente-cinq mille sept cents dollars américains (USD 3.635.700) a été mis à la disposition de la Société, ce qui a été
démontré au notaire soussigné.
5) Suite à cette augmentation de capital social, le paragraphe 5.1.1 de l'article 5 des statuts de la Société est modifié
et a désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social.
5.1 capital social libéré
124282
L
U X E M B O U R G
5.1.1 La Société a un capital social émis de quatre-vingt-six mille six cent cinquante dollars américains et cinquante-
neuf cents (USD 86.650,59) représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de Classe A ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe B1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux
cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2 ayant une valeur no-
minale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille
deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille
deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B7 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille
deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B9 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, deux mille
deux cent quatorze virgule zéro dix-neuf (2.214,019) actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C1 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent
cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2 ayant une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C3 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un
virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4 ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C5 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro
quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C7
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune, neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04)
actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune,
neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obligatoirement Rachetables de Classe C9 ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune et neuf cent cinquante-et-un virgule zéro quatre (951,04) actions Obli-
gatoirement Rachetables de Classe C10 ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune. (Les actions
Obligatoirement Rachetables de Classe B1, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B2, les actions Obligatoi-
rement Rachetables de Classe B3, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B4, les actions Obligatoirement
Rachetables de Classe B5, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B6, les actions Obligatoirement Rachetables
de Classe B7, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B8, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe
B9, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe B10, sont dénommées ci-après «Actions de Classe B»); (Les actions
Obligatoirement Rachetables de Classe C1, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C2, les actions Obliga-
toirement Rachetables de Classe C3, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C4, les actions Obligatoirement
Rachetables de Classe C5, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C6, les actions Obligatoirement Rachetables
de Classe C7, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C8, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe
C9, les actions Obligatoirement Rachetables de Classe C10 sont dénommées ci-après «Actions de Classe C»).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes sont estimés à quatre mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. DEPREZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 août 2013. Relation: EAC/2013/10801. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2013125465/571.
(130152300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
124283
L
U X E M B O U R G
KANDAHAR (Luxembourg) N°2 LIMITED S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 120.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2013.
M. Gérald Stevens
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013124280/12.
(130151408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
KANDAHAR (Luxembourg) N°2 LIMITED S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 120.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2013.
M. Gérald Stevens
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013124281/12.
(130151410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.033.679.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 90.703.
Suite à l’Assemblée Générale Annuelle en date du 24 juin 2013 de la Société, les décisions suivantes ont été prises:
1. Démission du Gérant B suivant en date du 31 août 2013:
Monsieur Jorge Máximo Pacheco Matte, né le 12 février 1953 à Recoleta, Santiago du Chili, avec adresse professionnelle
au 166, Chaussée de la Hulpe, B-1170 Bruxelles en qualité de Gérant B de la Société.
2. Nomination du Gérant B suivant en date du 1
er
septembre 2013 pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Michel Ribiéras, né le 22 juin 1962 à Limoges, France, avec adresse professionnelle au 166, Chaussée
de la Hulpe, B-1170 Bruxelles en qualité de Gérant B de la Société.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:
- Manacor (Luxembourg) S.A., Gérant A;
- Monsieur Patrick L.C. van Denzen, Gérant A;
- Madame Kristien F.M Kaelen, Gérant B;
- Monsieur Jonathan Edward Ernst, Gérant B;
- Monsieur François Hinck, Gérant B;
- Madame Terri Lynn Herrington, Gérant B;
- Monsieur Olivier Taudien, Gérant B;
- Monsieur Jean-Michel Ribiéras, Gérant B;
- Monsieur Eric Gérard Michel Chartrain, Gérant B;
- Monsieur Errol A. Harris, Gérant B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
124284
L
U X E M B O U R G
International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2013124254/30.
(130151103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
John Deere Cash Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.957.
Monsieur James W. Robinson a démissionné de ses fonctions d’administrateur de John Deere Cash Management S.A.
(la «Société») avec effet au 1
er
septembre 2013.
Par décision en date du 23 août 2013, Monsieur Jason P. Rogers, avec adresse professionnelle au One John Deere
Place, Moline, IL 61625, USA, a été désigné administrateur de la Société avec effet au 1
er
septembre 2013 pour une durée
se terminant à l’assemblée générale ordinaire qui doit se tenir en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2013.
John Deere Luxembourg Investments Sarl
<i>Unique actionnaire
i>Thierry Pierrette
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013124264/18.
(130150552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Kimi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 145.938.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l' Associe Unique prises en date du 30 août 2013 que:
- La démission de Monsieur Marc LIBOUTON en sa qualité de gérant de la Société avec effet immédiat, a été acceptée.
- La nomination avec effet immédiat de Monsieur Stéphane ALLART, né le 19 février 1981 à Uccle, Belgique, demeurant
professionnellement au 16 rue Jean l'Aveugle, L-1148 LUXEMBOURG, en tant que nouveau gérant a été acceptée, pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2013124273/16.
(130150918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
High Point Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.078.
<i>Extrait des résolutions prises par les associées en date du 11 juillet 2013i>
1. Monsieur David MORRISON a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
3. Monsieur Georges SCHEUER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5
juin 1967, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nom-
mé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Michael SPIRO, administrateur de sociétés, né au Cap (Afrique du Sud), le 2 décembre 1950, demeurant
professionnellement à N2 0EF Londres, Lyttelton House, Lyttelton road, a été nommé comme gérant de catégorie B
pour une durée indéterminée.
124285
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 23 août 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour High Point Sarl
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013124233/20.
(130151139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
KANDAHAR (Luxembourg) N°1 LIMITED S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 120.696.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2013.
M. Gérald Stevens
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013124277/12.
(130151262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Juvema S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7243 Bereldange, 46, rue du Dix Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 25.578.
Les comptes annuels au 31. Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013124271/10.
(130150824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
JRS Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 153.367.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02.09.13.
Référence de publication: 2013124270/10.
(130151474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Jopaco Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 26.637.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013124268/10.
(130151352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
I2M, International Marketing Management, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 87.395.
- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
I2M, International Marketing Management, Société Anonyme. R.C.S. Luxembourg B 87.395.
et domiciliée au 29, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
124286
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 1
er
août 2013.
Philippe GAIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013124260/12.
(130151076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Kirchbergsee 1 V V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.893.
STATUTES
In the year two thousand thirteen, on the sixteenth of August.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared, the following:
FORATIS Gründungs GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with its registered office at Kurt-
Schumacher-Strasse 18-20, D-53113 Bonn, Germany.
The incorporator is here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing professionally at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney dated August 14, 2013 given under private seal.
The aforesaid power of attorney, being initialled "ne varietur" by the person who appeared and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities at the same time.
The incorporator, represented as stated above, has requested the notary to draw up the following Articles of Incor-
poration of a limited liability company ("société à responsabilité limitée").
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. A private limited liability company ("société à responsabilité limitée") is hereby formed, governed by the present
Articles of Incorporation and by current Luxembourg laws, especially the Law of August 10
th
, 1915 on Commercial
Companies, as amended.
Art. 2. The Company's name is "Kirchbergsee 1 V V S.àr.l."
Art. 3.
3.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,
interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
3.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private
placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has
a direct or indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect shareholder of the Company
or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Affiliated Companies").
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or
over some of its assets.
3.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
3.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.
Art. 4.
4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
124287
L
U X E M B O U R G
4.2 The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of an extraordinary meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of managers.
4.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
4.5 In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The existence of the Company is not affected by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of
any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, under any circums-
tances, to require the attachment of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must refer to the financial statements and to the resolutions of the meetings for
the exercise of their rights.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred EURO), divided into 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1.- (one EURO) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right as at the time of the passing of resolutions.
Art. 10.
10.1 The shares are freely transferable amongst the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarters
of the Company capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise, reference is made to the provisions of Articles 189 and 190 of the Law on Commercial Companies.
10.2 The shares are indivisible with regard to the Company, which shall allow only one owner per share.
Management
Art. 11.
11.1 The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will constitute
a Board of managers.
The manager(s) need not be shareholder(s). The managers may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of shareholders holding a majority of votes.
11.2 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided that
the terms of these Articles have been complied with.
11.3 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of managers.
11.4 The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality, the Board of
managers, by the joint signature of any two members of the Board of managers.
11.5 The manager, or in case of plurality of managers, the Board of managers may sub-delegate his/its powers for
specific tasks to one or several authorised representative(s).
11.6 The manager, or in case of plurality of managers, the Board of managers shall determine this representative's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his representative agency.
11.7 In case of plurality of managers, the validity of meetings and decision-makings of the Board of managers is subject
to the presence of at least the majority of managers.
In this case, the resolutions of the Board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
11.8 The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating
member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not
124288
L
U X E M B O U R G
using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall
be authorised to vote by video or by phone.
11.9 The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or to replace
the first managers will be determined in the deed of appointment.
Art. 12.
12.1 No manager shall be personally liable in his function concerning the obligations validly established by him in the
name of the Company; as a representative, he is only responsible for the execution of his mandate.
12.2 The Company shall indemnify any manager as well as his heirs, executors and administrators, against expenses,
damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the
Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent that the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the manager may be entitled.
Art. 13.
13.1 Resolutions of the managers shall be made in the meeting of the Board of managers.
13.2 Any manager may act for another manager as his proxy at any meeting of managers by appointment in writing or
by telefax, cable, telegram or telex.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, formulated either in writing by circular letter, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail, telefax or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders' resolutions
Art. 14. Shareholders' resolutions shall be made at shareholder's meetings.
However, the holding of meetings is not compulsory as long as the total number of shareholders is less than twenty-
five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telefax.
Art. 15.
15.1 Resolutions are validly adopted when made by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, a second meeting shall be immediately convened by registered letters
to the shareholders.
At this second meeting, resolutions shall be made by the majority of voting shareholders, regardless of the majority
of capital represented.
However, resolutions related to an amendment of the Articles of Incorporation shall require a majority vote of sha-
reholders representing three-quarters of the capital.
15.2 Every meeting shall be held in Luxembourg or such other places as the managers may from time to time determine.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the assets of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect the inventory, the balance sheet and the profit and loss account at the registered
office of the Company.
Art. 19.
19.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
19.2 Every year, five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
124289
L
U X E M B O U R G
This deduction shall no longer be compulsory when the statutory reserve amounts to one-tenth of the issued capital
but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has
been reduced below said amount.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, by majority vote and in accordance with the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidator(s), natural or legal person(s), appointed by the
general meeting of shareholders which will specify his/its/their powers and fix his/its/their remuneration.
When the liquidation of the Company is concluded, the assets of the Company will be distributed to the shareholders
at the pro-rata relationship of their participation in the share capital of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws mentioned above in Article one shall apply insofar as not otherwise regulated in these Articles of
Incorporation.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and shall end on December 31, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows
and fully paid up in cash:
FORATIS Grundungs GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500
EUR 12,500
Therefore, effective immediately, the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred EURO) is at the free
disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euro (EUR
1,300.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the Meeting, passed the following resolutions:
1) The following individuals are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Frank Przygodda, manager, born in Bochum, Germany, on February 28, 1968, with business address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Achim Bönninghaus, manager, born in Freiburg/Breisgau, Germany, on February 27, 1972, with business address
at Kurt-Schumacher-Str. 18-20, D-53113 Bonn, Germany;
In accordance with Article eleven of these Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two
managers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that, on request of the person who ap-
peared, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; in case of discrepancies
between the English and the German text, the English version shall prevail.
In faith of which I, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed, together with the
Notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes
Im Jahr zweitausenddreizehn am sechzehnten August
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
"FORATIS Gründungs GmbH", eine nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Geschäftssitz
in Kurt-Schumacher-Strasse 18-20, D-53113 Bonn, Deutschland.
124290
L
U X E M B O U R G
Die Gründerin ist hier vertreten durch Herrn Raymond THILL, "maître en droit", mit Berufsanschrift in 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer unter privatrechtlichen Vollmacht gegebenen am 14. August 2013.
Besagte Vollmacht bleibt, nachdem sie „ne varietur" von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar
unterzeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden und wird mit dieser zusammen bei den für die Eintragung zuständigen
Behörden eingereicht.
Die Gründerin, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichneten Notar beauftragt, die Gründungsurkunde einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée") wie folgt aufzusetzen:
Firma - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée") errichtet, die dieser
Gründungsurkunde und den derzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung, unterliegt.
Art. 2. Die Firma der Gesellschaft lautet „Kirchbergsee 1 V V S.à r.l."
Art. 3.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen
und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz
allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.
3.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und
beschaffen. Sie kann -ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen
und/oder Emissionen von Schuldtiteln, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter
oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Kon-
zerngesellschaft sind (nachfolgend als die "verbundenen Unternehmen" bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien
gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbun-
denen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden,
übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.
3.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder
sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
3.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
3.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-
rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb,
Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.
3.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 4.
4.1 Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Der eingetragene Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die in der für
eine Änderung der Satzung vorhergesehenen Weise beschließt, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.
4.3 Auf Beschluss der Geschäftsführer kann der eingetragene Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt
werden.
4.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.
4.5 Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass außerordentliche Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder ge-
sellschaftlicher Art stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an
ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem eingetragenen Geschäftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen werden, kann der eingetragene Geschäftssitz bis zum vollständigen Ende dieser
außerordentlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden
die Nationalität der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Sie bleibt trotz vorübergehender Verlegung des eingetragenen
124291
L
U X E M B O U R G
Geschäftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden ergriffen und allen inte-
ressierten Parteien durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bekanntgegeben.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer errichtet.
Art. 6. Die Existenz der Gesellschaft wird durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte oder die Insolvenz
eines der Gesellschafter nicht beeinträchtigt.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen
die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft verlangen oder in irgendeiner Weise in die
Verwaltung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanzberichte und die
Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro), aufgeteilt auf 12.500
(zwölftausendfünfhundert) Anteile von jeweils 1,- EUR (einem Euro).
Art. 9. Jeder Anteil gewährt dieselben Stimmrechte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung.
Art. 10.
10.1 Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos" an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals haben einer solchen Übertragung in einer Generalversammlung zuge-
stimmt.
Im Übrigen wird auf die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften verwiesen.
10.2 Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar; diese lässt je Anteil nur einen Inhaber zu.
Geschäftsführung
Art. 11.
11.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Wurden mehrere Geschäftsführer
bestellt, bilden diese die „Geschäftsführung".
Der/Die Geschäftsführer muss/müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit mit oder
ohne Grund durch einen Beschluss des Gesellschafters/der Gesellschafter mit Stimmenmehrheit abberufen werden.
11.2 Im Umgang mit Dritten hat der/haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen
der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Tätigkeiten durchzuführen, die im Einklang mit dem Gesellschafts-
zweck stehen, vorausgesetzt, dass die Bestimmungen dieser Gründungsurkunde beachtet werden.
11.3 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Gründungsurkunde der Generalversammlung
der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren
Geschäftsführern, der Geschäftsführung.
11.4 Die Gesellschaft ist durch Einzelunterschrift ihres alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Ge-
schäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Mitgliedern der Geschäftsführung gebunden.
11.5 Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung kann seine/ihre Be-
fugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere bevollmächtigte Vertreter übertragen.
11.6 Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung hat die Zuständigkeiten
und Vergütung (falls zutreffend) dieses Vertreters festzulegen sowie die Dauer der Vertretung und alle sonstigen maß-
geblichen Bedingungen seiner Vertretung.
11.7 Im Falle von mehreren Geschäftsführern werden die Sitzungen der Geschäftsführung nur gültig abgehalten und
Beschlüsse nur wirksam gefasst, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer verabschiedet.
11.8 Der Einsatz von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen ist zulässig, vorausgesetzt jedes teilneh-
mende Mitglied der Geschäftsführung ist in der Lage, alle anderen teilnehmenden Mitglieder zu hören und von diesen
gehört zu werden, gleich ob sie diese Technologie nutzen oder nicht, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäfts-
führung gilt als anwesend und ist dazu ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
11.9 Die Befugnisse und Vergütung der Geschäftsführer, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich
oder anstelle der ersten Geschäftsführer bestellt werden, werden in der Bestellungsurkunde festgelegt.
Art. 12.
12.1 Kein Geschäftsführer ist im Rahmen seiner Funktion für die von ihm wirksam im Namen der Gesellschaft einge-
gangenen Verpflichtungen persönlich haftbar; als Vertreter ist er lediglich für die Ausübung seines Mandats verantwortlich.
12.2 Die Gesellschaft stellt einen Geschäftsführer sowie dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Vermögensver-
walter von allen Ausgaben, Schäden, Aufwendungen und Kosten frei, die diesem in vertretbarem Maße in Verbindung mit
124292
L
U X E M B O U R G
einer Klage, einem Prozess oder Gerichtsverfahren entstanden sind, in welche er aufgrund der Tatsache verwickelt wurde,
dass er ein Geschäftsführer der Gesellschaft ist oder war, oder auf Verlangen der Gesellschaft ein Geschäftsführer einer
anderen Gesellschaft ist oder war, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist, und von der freigestellt zu werden
er nicht berechtigt ist - außer in Verbindung mit Angelegenheiten, bei denen er zum Abschluss einer solchen Klage, eines
solchen Prozesses oder Gerichtsverfahrens wegen grober Fahrlässigkeit oder groben Fehlverhaltens verurteilt wurde. Im
Falle eines Vergleichs erfolgt die Entschädigung lediglich im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die unter den Vergleich
fallen, und nur sofern die Gesellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende
Person keine derartige Pflichtverletzung begangen hat. Der vorliegende Anspruch auf Entschädigung schließt andere
Rechte des Geschäftsführers nicht aus.
Art. 13.
13.1 Geschäftsführerbeschlüsse sind in der Sitzung der Geschäftsführung zu fassen.
13.2 Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung einen anderen Geschäftsführer durch schriftliche
Ernennung oder Ernennung per Fax, Telegramm oder Telex vertreten.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet werden, haben dieselbe Rechts-
wirkung wie die bei einer Sitzung der Geschäftsführung gefassten Beschlüsse.
In solchen Fällen erfolgt die Beschlussfassung oder Entscheidung ausdrücklich durch Formulierung entweder per Rund-
schreiben und Übertragung per Brief, elektronischer Post oder Telefax oder per Telefon, Telekonferenz oder andere
Telekommunikationsmittel.
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Gesellschafterversammlung getroffen.
Das Abhalten von Versammlungen ist jedoch nicht vorgeschrieben, solange es weniger als fünfundzwanzig Gesell-
schafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, dass jeder Gesellschafter den vollständigen Text jedes zu fas-
senden Beschlusses oder jeder zu treffenden Entscheidung erhält; die Übermittlung erfolgt per Post, EMail oder Telefax.
Art. 15.
15.1 Beschlüsse werden rechtswirksam mit den Stimmen der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, gefasst.
Wird dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht, ist mittels Einschreiben an die Gesellschafter un-
verzüglich eine zweite Versammlung einzuberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden Beschlüsse durch die Mehrheit der stimmberechtigten Gesellschafter, un-
abhängig von der Mehrheit des vertretenen Kapitals, gefasst.
Beschlüsse über die Änderung der Gründungsurkunde bedürfen jedoch einer Stimmenmehrheit der Gesellschafter,
die drei Viertel des Kapitals vertreten.
15.2 Jede Versammlung findet in Luxemburg oder an einem Ort, den die Geschäftsführer jeweils bestimmen können,
statt.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 17. Die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr zum 31. Dezember eine Bilanz, die eine Aufzeichnung der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft umfasst und zusammen mit einem Anhang vorgelegt wird, der eine Zusammenfassung sämtlicher
Verpflichtungen und Schulden des Geschäftsführers/der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft enthält.
Gleichzeitig wird die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, die der Generalversammlung der
Gesellschafter zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann das Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung am eingetragenen
Geschäftssitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 19.
19.1 Der Guthabensaldo der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Auf-
wendungen und Rückstellungen, stellt den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
19.2 Fünf Prozent des Nettogewinns werden jedes Jahr der gesetzlichen Rücklage zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr zwingend erforderlich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des gezeichneten Ka-
pitals der Gesellschaft erreicht hat, muss jedoch wieder aufgenommen werden, bis die Rücklage vollständig wiederher-
gestellt ist, falls sie zu irgendeinem Zeitpunkt, gleich aus welchem Grund, unter den genannten Betrag gesenkt wurde.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Die Gesellschafter können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit den geltenden Gesetzen, be-
schließen, dass der Gewinn nach Abzug der Rücklagen entweder vorgetragen oder einer außerordentlichen Rücklage
zugeführt wird.
124293
L
U X E M B O U R G
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, vorge-
nommen, der/die von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt wird/werden, die dessen/deren Befugnisse
festlegt und dessen/deren Entlohnung bestimmt.
Nach Abschluss der Liquidation der Gesellschaft wird das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft aufgeteilt.
Anwendbares recht
Art. 21. Es gelten die in Artikel eins aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen, sofern in dieser Satzung nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Alle 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile, die das Kapital bilden, wurden wie folgt gezeichnet und vollständig in
bar eingezahlt:
FORATIS Grundungs GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR
12.500 EUR
Der Betrag von 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) steht der Gesellschaft daher mit sofortiger Wirkung
zur freien Verfügung, was dem Notar ordnungsgemäß nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Aufwendungen gleich welcher Art, die von der Gesellschaft in Verbindung mit
ihrer Gründung zu tragen sind oder dieser belastet werden, wurden auf rund eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-)
geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die oben bezeichnete Person, die die Gesamtheit des gezeichneten
Kapitals vertritt und die der Versammlung übertragenen Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern bestellt:
- Herr Frank Przygodda, Geschäftsführer, geboren in Bochum, Deutschland, am 28. Februar 1968, mit Berufsanschrift
in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
- Herr Achim Bönninghaus, Geschäftsführer, geboren in Freiburg/Breisgau, Deutschland, am 7. Februar 1972, mit
Berufsanschrift in Kurt-Schumacher-Str. 18-20, D-53113 Bonn, Deutschland;
In Einklang mit Artikel elf dieser Gründungsurkunde ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Geschäftsführern gebunden.
2) Die Gesellschaft wird ihren eingetragenen Geschäftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg haben.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen
Person die vorliegende Gründungsurkunde in englischer Sprache verfasst wurde und mit einer deutschen Übersetzung
versehen ist. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text ist die englische Fassung maßge-
bend.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. LAC/2013/38784. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Référence de publication: 2013124275/419.
(130151230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
124294
L
U X E M B O U R G
Investus S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 1.445.514,00.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 105.352.
Avec effet au 16 juillet 2013, l'adresse de Monsieur Louis Libart a été transférée au 165A, route de Longwy, L-4751
Pétange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013124263/13.
(130151007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Kirchbergsee 2 V V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.900.
STATUTES
In the year two thousand thirteen, on the sixteenth of August.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared, the following:
FORATIS Gründungs GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with its registered office at Kurt-
Schumacher-Strasse 18-20, D-53113 Bonn, Germany.
The incorporator is here represented by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing professionally at 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney dated August 14, 2013 given under private seal.
The aforesaid power of attorney, being initialled ne varietur by the person who appeared and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities at the same time.
The incorporator, represented as stated above, has requested the notary to draw up the following Articles of Incor-
poration of a limited liability company ("société à responsabilité limitée").
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. A private limited liability company ("société à responsabilité limitée") is hereby formed, governed by the present
Articles of Incorporation and by current Luxembourg laws, especially the Law of August 10
th
, 1915 on Commercial
Companies, as amended.
Art. 2. The Company's name is "Kirchbergsee 2 V V S.àr.l."
Art. 3.
3.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,
interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
3.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private
placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has
a direct or indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect shareholder of the Company
or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Affiliated Companies").
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create securities over all or
over some of its assets.
3.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
124295
L
U X E M B O U R G
3.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
3.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.
Art. 4.
4.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of an extraordinary meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of managers.
4.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
4.5 In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The existence of the Company is not affected by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of
any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, under any circums-
tances, to require the attachment of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must refer to the financial statements and to the resolutions of the meetings for
the exercise of their rights.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred EURO), divided into 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1.- (one EURO) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right as at the time of the passing of resolutions.
Art. 10.
10.1 The shares are freely transferable amongst the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarters
of the Company capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise, reference is made to the provisions of Articles 189 and 190 of the Law on Commercial Companies.
10.2 The shares are indivisible with regard to the Company, which shall allow only one owner per share.
Management
Art. 11.
11.1 The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will constitute
a Board of managers.
The manager(s) need not be shareholder(s). The managers may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of shareholders holding a majority of votes.
11.2 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided that
the terms of these Articles have been complied with.
11.3 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the Board of managers.
11.4 The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality, the Board of
managers, by the joint signature of any two members of the Board of managers.
11.5 The manager, or in case of plurality of managers, the Board of managers may sub-delegate his/its powers for
specific tasks to one or several authorised representative(s).
11.6 The manager, or in case of plurality of managers, the Board of managers shall determine this representative's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his representative agency.
124296
L
U X E M B O U R G
11.7 In case of plurality of managers, the validity of meetings and decision-makings of the Board of managers is subject
to the presence of at least the majority of managers.
In this case, the resolutions of the Board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
11.8 The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed provided that each participating
member of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not
using this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall
be authorised to vote by video or by phone.
11.9 The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or to replace
the first managers will be determined in the deed of appointment.
Art. 12.
12.1 No manager shall be personally liable in his function concerning the obligations validly established by him in the
name of the Company; as a representative, he is only responsible for the execution of his mandate.
12.2 The Company shall indemnify any manager as well as his heirs, executors and administrators, against expenses,
damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the
Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent that the Company is advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the manager may be entitled.
Art. 13.
13.1 Resolutions of the manager shall be made in the meeting of the Board of managers.
13.2 Any manager may act for another manager as his proxy at any meeting of managers by appointment in writing or
by telefax, cable, telegram or telex.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, formulated either in writing by circular letter, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail, telefax or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders' resolutions
Art. 14. Shareholders' resolutions shall be made at shareholder's meetings.
However, the holding of meetings is not compulsory as long as the total number of shareholders is less than twenty-
five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telefax.
Art. 15.
15.1 Resolutions are validly adopted when made by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, a second meeting shall be immediately convened by registered letters
to the shareholders.
At this second meeting, resolutions shall be made by the majority of voting shareholders, regardless of the majority
of capital represented.
However, resolutions related to an amendment of the Articles of Incorporation shall require a majority vote of sha-
reholders representing three-quarters of the capital.
15.2 Every meeting shall be held in Luxembourg or such other places as the managers may from time to time determine.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the assets of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect the inventory, the balance sheet and the profit and loss account at the registered
office of the Company.
124297
L
U X E M B O U R G
Art. 19.
19.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
19.2 Every year, five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction shall no longer be compulsory when the statutory reserve amounts to one-tenth of the issued capital
but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has
been reduced below said amount.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, by majority vote and in accordance with the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidator(s), natural or legal person(s), appointed by the
general meeting of shareholders which will specify his/its/their powers and fix his/its/their remuneration.
When the liquidation of the Company is concluded, the assets of the Company will be distributed to the shareholders
at the pro-rata relationship of their participation in the share capital of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws mentioned above in Article one shall apply insofar as not otherwise regulated in these Articles of
Incorporation.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and shall end on December 31, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows
and fully paid up in cash:
FORATIS Gründungs GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500
EUR 12,500
Therefore, effective immediately, the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred EURO) is at the free
disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred Euro (EUR
1,300.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the Meeting, passed the following resolutions:
1) The following individuals are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr Frank Przygodda, manager, born in Bochum, Germany, on February 28, 1968, with business address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Mr Achim Bönninghaus, manager, born in Freiburg/Breisgau, Germany, on February 27, 1972, with business address
at Kurt-Schumacher-Str. 18-20, D-53113 Bonn, Germany;
In accordance with Article eleven of these Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two
managers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that, on request of the person who ap-
peared, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; in case of discrepancies
between the English and the German text, the English version shall prevail.
In faith of which I, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed, together with the
Notary, the present original deed.
Deutsche übersetzung des vorhergehenden textes
Im Jahr zweitausenddreizehn am sechzehnten August
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
124298
L
U X E M B O U R G
Ist erschienen:
"FORATIS Gründungs GmbH", eine nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Geschäftssitz
in Kurt-Schumacher-Strasse 18-20, D-53113 Bonn, Deutschland.
Die Gründerin ist hier vertreten durch Herrn Raymond THILL, "maître en droit", mit Berufsanschrift in 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer unter privatrechtlichen Vollmacht gegebenen am 14. August 2013.
Besagte Vollmacht bleibt, nachdem sie ne varietur von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar
unterzeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden und wird mit dieser zusammen bei den für die Eintragung zuständigen
Behörden eingereicht.
Die Gründerin, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichneten Notar beauftragt, die Gründungsurkunde einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) wie folgt aufzusetzen:
Firma - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) errichtet, die dieser
Gründungsurkunde und den derzeit in Luxemburg geltenden Gesetzen, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung, unterliegt.
Art. 2. Die Firma der Gesellschaft lautet „Kirchbergsee 2 V V S.à r.l.“
Art. 3.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen
und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz
allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.
3.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und
beschaffen. Sie kann -ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen
und/oder Emissionen von Schuldtiteln, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter
oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Kon-
zerngesellschaft sind (nachfolgend als die "verbundenen Unternehmen" bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien
gewähren und Sicherheiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbun-
denen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden,
übertragen, belasten oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.
3.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder
sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
3.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
3.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-
rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb,
Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.
3.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 4.
4.1 Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Der eingetragene Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, die in der für
eine Änderung der Satzung vorhergesehenen Weise beschließt, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.
4.3 Auf Beschluss der Geschäftsführer kann der eingetragene Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt
werden.
4.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.
4.5 Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass außerordentliche Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder ge-
sellschaftlicher Art stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an
ihrem eingetragenen Geschäftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem eingetragenen Geschäftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen werden, kann der eingetragene Geschäftssitz bis zum vollständigen Ende dieser
124299
L
U X E M B O U R G
außerordentlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden
die Nationalität der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Sie bleibt trotz vorübergehender Verlegung des eingetragenen
Geschäftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden ergriffen und allen inte-
ressierten Parteien durch die Geschäftsführung der Gesellschaft bekanntgegeben.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer errichtet.
Art. 6. Die Existenz der Gesellschaft wird durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte oder die Insolvenz
eines der Gesellschafter nicht beeinträchtigt.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen
die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Dokumenten der Gesellschaft verlangen oder in irgendeiner Weise in die
Verwaltung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanzberichte und die
Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro), aufgeteilt auf 12.500
(zwölftausendfünf-hundert) Anteile von jeweils 1 EUR (einem Euro).
Art. 9. Jeder Anteil gewährt dieselben Stimmrechte zum Zeitpunkt der Beschlussfassung.
Art. 10.
10.1 Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals haben einer solchen Übertragung in einer Generalversammlung zuge-
stimmt.
Im Übrigen wird auf die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften verwiesen.
10.2 Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar; diese lässt je Anteil nur einen Inhaber zu.
Geschäftsführung
Art. 11.
11.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Wurden mehrere Geschäftsführer
bestellt, bilden diese die „Geschäftsführung“.
Der/Die Geschäftsführer muss/müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit mit oder
ohne Grund durch einen Beschluss des Gesellschafters/der Gesellschafter mit Stimmenmehrheit abberufen werden.
11.2 Im Umgang mit Dritten hat der/haben die Geschäftsführer alle Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen
der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Tätigkeiten durchzuführen, die im Einklang mit dem Gesellschafts-
zweck stehen, vorausgesetzt, dass die Bestimmungen dieser Gründungsurkunde beachtet werden.
11.3 Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Gründungsurkunde der Generalversammlung
der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren
Geschäftsführern, der Geschäftsführung.
11.4 Die Gesellschaft ist durch Einzelunterschrift ihres alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Ge-
schäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Mitgliedern der Geschäftsführung gebunden.
11.5 Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung kann seine/ihre Be-
fugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere bevollmächtigte Vertreter übertragen.
11.6 Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung hat die Zuständigkeiten
und Vergütung (falls zutreffend) dieses Vertreters festzulegen sowie die Dauer der Vertretung und alle sonstigen maß-
geblichen Bedingungen seiner Vertretung.
11.7 Im Falle von mehreren Geschäftsführern werden die Sitzungen der Geschäftsführung nur gültig abgehalten und
Beschlüsse nur wirksam gefasst, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer verabschiedet.
11.8 Der Einsatz von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen ist zulässig, vorausgesetzt jedes teilneh-
mende Mitglied der Geschäftsführung ist in der Lage, alle anderen teilnehmenden Mitglieder zu hören und von diesen
gehört zu werden, gleich ob sie diese Technologie nutzen oder nicht, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäfts-
führung gilt als anwesend und ist dazu ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
11.9 Die Befugnisse und Vergütung der Geschäftsführer, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich
oder anstelle der ersten Geschäftsführer bestellt werden, werden in der Bestellungsurkunde festgelegt.
Art. 12.
12.1 Kein Geschäftsführer ist im Rahmen seiner Funktion für die von ihm wirksam im Namen der Gesellschaft einge-
gangenen Verpflichtungen persönlich haftbar; als Vertreter ist er lediglich für die Ausübung seines Mandats verantwortlich.
124300
L
U X E M B O U R G
12.2 Die Gesellschaft stellt einen Geschäftsführer sowie dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Vermögensver-
walter von allen Ausgaben, Schäden, Aufwendungen und Kosten frei, die diesem in vertretbarem Maße in Verbindung mit
einer Klage, einem Prozess oder Gerichtsverfahren entstanden sind, in welche er aufgrund der Tatsache verwickelt wurde,
dass er ein Geschäftsführer der Gesellschaft ist oder war, oder auf Verlangen der Gesellschaft ein Geschäftsführer einer
anderen Gesellschaft ist oder war, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist, und von der freigestellt zu werden
er nicht berechtigt ist - außer in Verbindung mit Angelegenheiten, bei denen er zum Abschluss einer solchen Klage, eines
solchen Prozesses oder Gerichtsverfahrens wegen grober Fahrlässigkeit oder groben Fehlverhaltens verurteilt wurde. Im
Falle eines Vergleichs erfolgt die Entschädigung lediglich im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die unter den Vergleich
fallen, und nur sofern die Gesellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende
Person keine derartige Pflichtverletzung begangen hat. Der vorliegende Anspruch auf Entschädigung schließt andere
Rechte des Geschäftsführers nicht aus.
Art. 13.
13.1 Geschäftsführerbeschlüsse sind in der Sitzung der Geschäftsführung zu fassen.
13.2 Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung einen anderen Geschäftsführer durch schriftliche
Ernennung oder Ernennung per Fax, Telegramm oder Telex vertreten.
Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet werden, haben dieselbe Rechts-
wirkung wie die bei einer Sitzung der Geschäftsführung gefassten Beschlüsse.
In solchen Fällen erfolgt die Beschlussfassung oder Entscheidung ausdrücklich durch Formulierung entweder per Rund-
schreiben und Übertragung per Brief, elektronischer Post oder Telefax oder per Telefon, Telekonferenz oder andere
Telekommunikationsmittel.
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Gesellschafterversammlung getroffen.
Das Abhalten von Versammlungen ist jedoch nicht vorgeschrieben, solange es weniger als fünfundzwanzig Gesell-
schafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, dass jeder Gesellschafter den vollständigen Text jedes zu fas-
senden Beschlusses oder jeder zu treffenden Entscheidung erhält; die Übermittlung erfolgt per Post, E¬Mail oder Telefax.
Art. 15.
15.1 Beschlüsse werden rechtswirksam mit den Stimmen der Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, gefasst.
Wird dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht, ist mittels Einschreiben an die Gesellschafter un-
verzüglich eine zweite Versammlung einzuberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden Beschlüsse durch die Mehrheit der stimmberechtigten Gesellschafter, un-
abhängig von der Mehrheit des vertretenen Kapitals, gefasst.
Beschlüsse über die Änderung der Gründungsurkunde bedürfen jedoch einer Stimmenmehrheit der Gesellschafter,
die drei Viertel des Kapitals vertreten.
15.2 Jede Versammlung findet in Luxemburg oder an einem Ort, den die Geschäftsführer jeweils bestimmen können,
statt.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 17. Die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr zum 31. Dezember eine Bilanz, die eine Aufzeichnung der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft umfasst und zusammen mit einem Anhang vorgelegt wird, der eine Zusammenfassung sämtlicher
Verpflichtungen und Schulden des Geschäftsführers/der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft enthält.
Gleichzeitig wird die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, die der Generalversammlung der
Gesellschafter zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann das Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung am eingetragenen
Geschäftssitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 19.
19.1 Der Guthabensaldo der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Auf-
wendungen und Rückstellungen, stellt den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
19.2 Fünf Prozent des Nettogewinns werden jedes Jahr der gesetzlichen Rücklage zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr zwingend erforderlich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des gezeichneten Ka-
pitals der Gesellschaft erreicht hat, muss jedoch wieder aufgenommen werden, bis die Rücklage vollständig wiederher-
gestellt ist, falls sie zu irgendeinem Zeitpunkt, gleich aus welchem Grund, unter den genannten Betrag gesenkt wurde.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
124301
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschafter können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit den geltenden Gesetzen, be-
schließen, dass der Gewinn nach Abzug der Rücklagen entweder vorgetragen oder einer außerordentlichen Rücklage
zugeführt wird.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, vorge-
nommen, der/die von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt wird/werden, die dessen/deren Befugnisse
festlegt und dessen/deren Entlohnung bestimmt.
Nach Abschluss der Liquidation der Gesellschaft wird das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschafter im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft aufgeteilt.
Anwendbares recht
Art. 21. Es gelten die in Artikel eins aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen, sofern in dieser Satzung nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Alle 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile, die das Kapital bilden, wurden wie folgt gezeichnet und vollständig in
bar eingezahlt:
FORATIS Gründungs GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR
12.500 EUR
Der Betrag von 12.500,- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) steht der Gesellschaft daher mit sofortiger Wirkung
zur freien Verfügung, was dem Notar ordnungsgemäß nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Aufwendungen gleich welcher Art, die von der Gesellschaft in Verbindung mit
ihrer Gründung zu tragen sind oder dieser belastet werden, wurden auf rund eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-)
geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat die oben bezeichnete Person, die die Gesamtheit des gezeichneten
Kapitals vertritt und die der Versammlung übertragenen Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern bestellt:
- Herr Frank Przygodda, Geschäftsführer, geboren in Bochum, Deutschland, am 28. Februar 1968, mit Berufsanschrift
in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
- Herr Achim Bönninghaus, Geschäftsführer, geboren in Freiburg/Breisgau, Deutschland, am 7. Februar 1972, mit
Berufsanschrift in Kurt-Schumacher-Str. 18-20, D-53113 Bonn, Deutschland;
In Einklang mit Artikel elf dieser Gründungsurkunde ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Geschäftsführern gebunden.
2) Die Gesellschaft wird ihren eingetragenen Geschäftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg haben.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen
Person die vorliegende Gründungsurkunde in englischer Sprache verfasst wurde und mit einer deutschen Übersetzung
versehen ist. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text ist die englische Fassung maßge-
bend.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. LAC/2013/38785. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Référence de publication: 2013124276/419.
(130151406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
124302
L
U X E M B O U R G
International Medical Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 171.591.
Der zwischen der Gesellschaft International Medical Consult S.à r.l. mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 5, Rue
Goethe L - 1637 Luxembourg, eingetragen im Handels-/ und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 171.591,
und Maître Pierre METZLER, beruflich ansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg im Rahmen der Grün-
dung der Gesellschaft geschlossene Vertrag zur Domizilierung der Gesellschaft an der Anschrift 69, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxemburg, ist mit Wirkung zum 31. August 2013 beendet worden.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02.09.2013.
Référence de publication: 2013124261/13.
(130151367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Landmark Investment Management Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.525,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 113.428.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation en date du 30 août 2013 que la Société ayant son siège social au 64 avenue
de la liberté, 1930 Luxembourg, constituée suivant acte de Me Henri Hellinckx, le 16 décembre 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, le 5 avril 2006, sous le numéro 692, a été clôturée et que par conséquence la
Société est dissoute.
Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la
publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante:
64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 août 2013.
Référence de publication: 2013124295/19.
(130150946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Luxtecpro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5442 Roedt, 54, rue de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 172.405.
Im Jahre zweitausendunddreizehn, den vierzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, im Amtssitze zu Mersch.
Ist erschienen
Die Gesellschaft S.E.A. FINANCIAL CONSULTING LIMITED, mit Sitz in Dublin 18, Irland, The Courtyard, Carmanhall
Road, Sandyford, eingetragen im Gesellschaftsregister von Dublin, unter der Nummer 487345,
hier vertreten duch Herrn Michael ERNZERHOF, Privatangestellter, beruflich ansässig in Luxemburg, 6, avenue Guil-
laume,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „LUXTECPRO
S.à r.l.", mit Sitz in Luxemburg, welche gegründet wurde gemäss Urkunde des unterzeichenten Notars vom 25. Oktober
2012, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2902 vom 29. November 2012.
Der Erschienene, handelnd wie vorstehend, ersuchte den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach L-5442 Roedt, 54, rue de Remich zu
verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung, wie folgt abgeändert:
124303
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Roedt. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen
Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars,
am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. ERNZERHOF und H. HELLINCKX..
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. Relation: LAC/2013/38824. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 2. September 2013.
*.
Référence de publication: 2013124313/35.
(130151318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
International Company of Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 142.375.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique la Société en date du 30 juillet 2013:
D’accepter la démission de Monsieur Pedro Martin MOLINA REYES en tant que gérant de la Société avec effet au 02
septembre 2013; et
De nommer Monsieur Gonzalo SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, né le 3 septembre 1988 à Madrid, Espagne,
résidant professionnellement au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant
A de la Société avec effet au 02 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 septembre 2013.
Référence de publication: 2013124253/16.
(130151193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
I-Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.166.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 1 i>
<i>eri>
<i> août 2013i>
1. M. Elliot GREENBERG a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Mme Urszula PRZYBYSLAWSKA, administrateur de sociétés, née à Debica (Pologne), le 27 janvier 1972, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
a été nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour I-Wohnen S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013124249/16.
(130151099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Julien Cajot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 157.221.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013124265/9.
(130151409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
124304
L
U X E M B O U R G
VPL, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 146.962.
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 août 2013, le mandat du commissaire aux comptes est
renouvelé pour une nouvelle période et se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013125118/13.
(130151621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Vendest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 133.496.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 16 mai 2013i>
Il ressort des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 16 mai 2013,
que:
- Monsieur Christian FRANCOIS, né le 1
er
avril 1975 à Rocourt (Belgique), employé privé, demeurant profession-
nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du conseil d'administration.
Ce dernier assumera cette fonction pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2019.
Fait à Luxembourg, le 16 mai 2013.
<i>POUR VENDEST S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2013125111/17.
(130151939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
VLT Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 115.108.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2013i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2013.
Luxembourg, le 19 juillet 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013125115/18.
(130151777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Verbriefungsgesellschaft REPE S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 137.987.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 5 août 2013i>
L'actionnaire unique de Verbriefungsgesellschaft REPE S.A. (la Société), a décidé:
124305
L
U X E M B O U R G
(i) de révoquer Mme Amiirah Romjhon de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat au 5 août
2013;
(ii) de nommer en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 5 août 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2014, Luxembourg Corporation Company S.A., une société anonyme existant sous les lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B.37.974.
Verbriefungsgesellschaft REPE S.A.
Au nom et pour le compte de la société
Signature
Référence de publication: 2013125106/19.
(130152063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.800.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-36, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.572.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 02 septembre 2013i>
L’associé unique a accepté la démission de Monsieur Hui-Chung CHEN de ses fonctions de gérant de la Société.
La démission est acceptée avec effet au 08 août 2013.
L’assemblée générale a nommé Monsieur Chung-Zung KUNG, né le 26 septembre 1959 à Taichung City, Taïwan,
demeurant professionnellement à 18F, No. 95, Sec. 2, Dunhua S. Road, 106, Taipei City, Taïwan, comme gérant de la
Société avec effet au 08 août 2013.
Son mandat est de durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013125102/16.
(130151819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Talia Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 137.691.
EXTRAIT
- Il résulte des résolutions des associés signées en date du 1
er
septembre 2013 que M. Matthias Sprenker a démissionné
de son mandat de gérant, avec effet immédiat, et le gérant de la Société sera désormais:
Nom/Prénom: Barthels Yves;
Date de naissance: 10/10/1973;
Lieu de naissance: Luxembourg;
Pays de naissance: Luxembourg;
Adresse professionnelle: 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Référence de publication: 2013125096/19.
(130152189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Telenet Finance Luxembourg II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 156.414.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique et par le conseil d’administration en date du 30 août 2013i>
1. Monsieur Jonathan LEPAGE a démissionné de ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’adminis-
tration.
124306
L
U X E M B O U R G
2. Madame Céline TRIDANT, administrateur de sociétés, née à Mont-Saint-Martin (France), le 1
er
décembre 1979,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme
administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
3. Monsieur Oliver WOLF a été nommé comme président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2018.
Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Telenet Finance Luxembourg II S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013125088/19.
(130151761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Universal Securitisation Solutions, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 154.470.
Die ordentliche Generalversammlung hat am 26. August 2013 beschlossen, Herrn Alain Nati, Herrn Erich Hein und
Herrn Stefan Rockel als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen. Die Mandate enden mit der Generalversammlung
des Jahres 2014.
Herr Erik Wimmers ist mit Wirkung zum 26. August 2013 ersatzlos aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
Ferner hat die ordentliche Generalversammlung am 26. August 2013 beschlossen, PricewaterhouseCoopers, Société
Coopérative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg (RCS Luxembourg B 65477) zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft
zu wählen. Das Mandat endet mit der Generalversammlung des Jahres 2014.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 03. September 2013.
<i>Für die Universal Securitisation Solutions S.A.
i>Marc-Oliver Scharwath / Saskia Sander
Référence de publication: 2013125104/18.
(130151988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
VP investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 12, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 179.933.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-deux juillet.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Philippe VOGT, agent immobilier, né à Luxembourg, le 19 mai 1977, demeurant à L-5761 Hassel, 11A, rue de Dalheim.
La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de VP investments SARL.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Mondorf-les-Bains.
Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non-bâtis, la prise en bail, la location de
toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous
immeubles ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu, qu'elles soient commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières, ainsi que la promotion immobilière et l'exploitation d'une agence immobilière.
Elle a également pour objet la prestation de services administratifs généralement quelconques pour tiers, à l'exclusion
de toutes activités d'expert-comptable et de conseil économique, ainsi que la prise de participations, sous quelque forme
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
124307
L
U X E M B O U R G
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts
de cent (100.-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites par Philippe VOGT, agent immobilier, né à Luxembourg, le 19 mai 1977, demeurant à
L-5761 Hassel, 11A, rue de Dalheim. Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Frais.i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850.-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire.i>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-5670 Altwies, 12, route de Mondorf.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1 ).
- Est nommée gérante, pour une durée illimitée:
Philippe VOGT, agent immobilier, né à Luxembourg, le 19 mai 1977, demeurant à L-5761 Hassel, 11A, rue de Dalheim.
La société est engagée par la signature de la gérante unique.
<i>Déclarationi>
L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le béné-
ficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital
social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée
aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Vogt et Molitor.
Enregistré à LUXEMBOURG A.C., le 1 août 2013. Relation LAC/2013/36124. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Référence de publication: 2013125586/74.
(130152674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
124308
L
U X E M B O U R G
Costa Martins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 25, rue d'Audun.
R.C.S. Luxembourg B 113.555.
Lors de la reunion des associes en date 28 fevrier 2013 de la societe COSTA MARTINS SARL, les associes ont pris
les decisions suivantes:
- Donner la demission du gerant Technique, Monsieur Fernando Da Silva Costa de la societe mentionnee sous rubrique
en date du 28 fevrier 2013
- De nommer Madame Carla Sofia Martins Tejo, en tant que gerant technique de la societe mentionnee sous rubrique
en date du 1
er
mars 2013
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2013125148/16.
(130152105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Vivimus SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 107.064.
EXTRAIT
IL RESULTE D’UNE DECISION PRISE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2011:
- QUE SONT REELUS AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR, LEURS MANDATS SE TERMINANT LORS DE L’AS-
SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L’EXERCICE 2015
* FIDIGA S.A.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 23598 avec siège social au 30
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L - 1330 Luxembourg, dont le représentant permanent est Madame Marie Joseph
Renders, demeurant professionnellement au 11A, Boulevard Joseph II, L - 1840 Luxembourg
* Madame Marie Joseph RENDERS
née le 17 octobre 1948 à Halle (B), demeurant professionnellement au
11A, Boulevard Joseph II,
L - 1840 Luxembourg
* Madame Marie-Paul VAN WAELEM
née le 5 janvier 1950 à Uccle (B) demeurant professionnellement au
11A, Boulevard Joseph II,
L - 1840 Luxembourg
- QU'EST REELU AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, SON MANDAT SE TERMINANT LORS DE L’AS-
SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE STATUANT SUR L’EXERCICE 2015
* EWA REVISION S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 38 937 avec
siège social au 45 Avenue J.F. Kennedy, L – 9053 ETTELBRUCK
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013125585/29.
(130152521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
TCP Cable S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.009.532,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 171.808.
Il résulte des actes de la Société qu'en date du 8 Mars 2013, Trilantic Capital Partners IV (Europe) L.P. ayant son siège
social au 35, Portman Square, 6
th
Floor, London W1H 6LR, Royaume Uni, a cédé:
- 1 part sociale de la Société TCP Cable S.à r.l. à Trilantic Capital Management GP (Guernsey) Limited, ayant son siège
social au Heritage Hall, le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey GY1 4HY, Guernsey, enregistré au Guernsey Registry
sous le numéro 50224.
124309
L
U X E M B O U R G
- 1 part sociale de la Société TCP Cable S.à r.l. à Trilantic Capital Partners Management Limited, ayant son siège social
au Heritage Hall, le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey GY1 4HY, Guernsey, enregistré au Guernsey Registry sous
le numéro 50118.
- 87.405 parts sociales de la Société TCP Cable S.à r.l. à AlpInvest Partners Co-Investments 2012 I C.V., ayant son
siège social au Jachthavenweg 118, 1081 KJ Amsterdam, Pays- Bas, enregistré au Handelregister van de Kamer van Koo-
phandel de Amsterdam sous le numéro 851256545.
- 22.263 parts sociales de la Société TCP Cable S.à r.l. à AlpInvest Partners Co-Investments 2012 II C.V., ayant son
siège social au Jachthavenweg 118, 1081 KJ Amsterdam, Pays-Bas, enregistré au Handelregister van de Kamer van Koo-
phandel de Amsterdam sous le numéro 851256442.
TCP Cable S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature
Référence de publication: 2013125568/25.
(130152309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
YAO Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.100.000,00.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 120.608.
AUSZUG
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2013125598/14.
(130152609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
Surrey Healthcare Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 140.700,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 141.014.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 19 août 2013, a renouvelé les mandats des gérants:
- Stéphane KOFMAN, gérant de catégorie A, 19 Boulevard Malesherbes, F-75008 Paris, France.
- Karen DEAL, gérant de catégorie A, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni.
- Laurent HEILIGER, gérant de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
- Stéphanie GRISIUS, gérant de catégorie B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
- Manuel HACK, gérant de catégorie B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2013.
Luxembourg, le 19 août 2013.
<i>Pour SURREY HEALTHCARE INVESTMENTS
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2013125561/21.
(130152518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.
124310
L
U X E M B O U R G
BioPharma Secured Investments II Sub, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.961.
<i>Extrait des résolutions de l’associée unique prises en date du 5 septembre 2013i>
1. Monsieur David CATALA et Madame Fanny AUENALLAH ont démissionné de leur mandat de gérant.
2. Monsieur Eric SELLAM, administrateur de sociétés, né à Thionville (France), le 25 mai 1978, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.
3. Madame Nicola FOLEY, administrateur de sociétés, née le 6 octobre 1982 à Dublin (Irlande), demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 6 septembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BioPharma Secured Investments II Sub
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013126967/19.
(130154466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2013.
Catalyst EPF Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.746.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 28 août 2013i>
- La démission de Monsieur Michel van Krimpen de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l’associé
unique avec effet au 9 septembre 2013.
- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 9 septembre 2013
* Monsieur Onno Bouwmeister, né le 26 janvier 1977 à Maarssen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
- La démission de Monsieur Peter Kasch de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l’associé unique avec
effet immédiat.
- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat
* Monsieur Jonathan Petit, né le 24 avril 1955 à Worcester Park, United Kingdom, avec adresse professionnelle au 33
Cavendish Square, W1G 0PW London, United Kingdom;
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2013126988/23.
(130154495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2013.
Brainsourcing S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 140.861.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013126985/10.
(130154574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2013.
124311
L
U X E M B O U R G
Chimindu International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 162.986.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société CHIMINDU INTERNATIONAL S.A.i>
<i>qui s'est tenue en date du 26 août 2013i>
Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée Générale décide de remplacer Madame Natacha Kolodziej-Steurmann en sa qualité d'Administrateur
par Madame Alexandra Corre, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L- 1142 Lu-
xembourg.
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2017.
Le Conseil d'Administration est donc composé comme suit:
- Monsieur Didier Schönberger,
- Monsieur Nicolas Hamel, Madame
- Alexandra Corre.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013128245/21.
(130156274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Chez Luz Maria Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 53, rue Clair-Chêne.
R.C.S. Luxembourg B 175.234.
L'an deux mille treize, le dix-neuf août.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
- Monsieur Michael WEDDE, commerçant, demeurant à L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume de Machault,
seul associé de la société "CHEZ LUZ MARIA SARL", établie et ayant son siège à L-2111 Luxembourg, 11, rue Guillaume
de Machault, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 4 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Numéro 838 du 9 avril 2013, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 175.234.
Le comparant prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le comparant décide de transférer le siège social de Luxembourg à Esch-sur-Alzette et par conséquent de modifier
l'article 2 des statuts comme suit:
" Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette."
<i>Deuxième résolutioni>
Le comparant fixe l'adresse à L-4061 Esch-sur-Alzette, 53, rue Clair-Chêne.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: WEDDE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 août 2013. Relation: LAC/2013/39013.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signe): FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Référence de publication: 2013128243/32.
(130156223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
124312
L
U X E M B O U R G
BCP Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.416,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 171.607.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
Le siège social des associés suivants:
- Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P.
- Blackstone NSS Communications Partners (Cayman) L.P.
- Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P.
- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI L.P.
- Blackstone Energy Partners (Cayman) L.P.
a changé et doit désormais se lire comme suit: 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Îles
Caïmans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2013.
BCP Management Luxembourg S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013128199/22.
(130156272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Casabiene S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 173.870.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CASABIENE S.A. qui s'est tenue en date du 23 aoûti>
<i>2013i>
Il a été décidé ce qui suit:
- de coopter Monsieur Nicolas Hamel, Avocat, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Lu-
xembourg en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, avec effet au 25 août 2013.
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2018.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Véronique Wauthier, Messieurs Roger Zannier, Didier Schönberger et Nicolas Hamel.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013128232/18.
(130156547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
'' BELVEDERE REAL ESTATE '', Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 99.618.
In the year two thousand and thirteen, on the tenth of July;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "BELVEDERE REAL ESTATE", a public
limited company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having
its registered office in L-5365 Munsbach, 6b, rue Gabriel Lippmann, registered with the Trade and Companies' Registry
of Luxembourg, section B, under the number 99618, (the "Company"), originally incorporated under the legal form of a
private limited liability company called "EY REAL ESTATE", pursuant to a deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing
in Luxembourg, on February 24, 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 469 of
May 4, 2004,
and whose articles of association have been amended pursuant to deeds of the said notary Joseph ELVINGER:
124313
L
U X E M B O U R G
- on October 5, 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 440 of May 12, 2005,
containing the change of the corporate name into "ATOZ REAL ESTATE";
- on January 27, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 678 of July 9, 2005;
- on February 11, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 831 of April 22,
2010, containing the transformation of the legal form of the Company into a public limited company and the adoption of
its current denomination; and
- on December 2, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 129 of January 21,
2011.
The Meeting is presided by Mrs. Marjorie THIRY, employee, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 3A, bou-
levard du Prince Henri.
The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs. Nathalie FREITAS, employee, residing
professionally in L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office from Munsbach to L-2611 Howald, 183, route de Thionville, and subsequent
amendment of the first sentence of article 4 of the by-laws;
2. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Resolutioni>
The Meeting resolves to transfer, with immediate effect, the registered office from Munsbach to L-2611 Howald, 183,
route de Thionville, and to subsequently amend the first sentence of article 4 of the by-laws in order to give it the following
wording:
" Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Hesperange."
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at nine hundred and
twenty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dix juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
124314
L
U X E M B O U R G
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "BELVEDERE REAL ESTATE", une
société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-5365 Munsbach, 6b, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 99618, (la "Société"), constituée originairement sous la forme légale d'une société à responsabilité
limitée dénommée "EY REAL ESTATE", suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 24 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 469 du 4 mai 2004,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Joseph ELVINGER:
- le 5 octobre 2004, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 440 du 12 mai 2005, contentant
le changement de la dénomination sociale en "ATOZ REAL ESTATE";
- le 27 janvier 2005, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 678 du 9 juillet 2005;
- le 11 février 2010, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 831 du 22 avril 2010, con-
tentant la transformation de la forme légale de la Société en société anonyme et l'adoption de sa dénomination actuelle;
et
- le 2 décembre 2010, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 129 du 21 janvier 2011.
L'Assemblée est présidée par Madame Marjorie THIRY, employée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-
bourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nathalie FREITAS, em-
ployée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de Munsbach à L-2611 Howald, 183, route de Thionville, et modification subséquente de
la première phrase de l'article 4 des statuts;
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de Munsbach à L-2611 Howald, 183, route de
Thionville, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. Le siège de la Société est établi dans la commune de Hesperange."
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent vingt euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. THIRY, N. FREITAS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juillet 2013. LAC/2013/32217. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
124315
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 août 2013.
Référence de publication: 2013128202/126.
(130156400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Burton Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 108.182.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société BURTON INVEST S.A. qui s'est tenue en date dui>
<i>23 août 2013i>
Il a été décidé ce qui suit:
- de coopter Madame Alexandra Corre, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt,
L-1142 Luxembourg en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, avec effet au 25 août 2013.
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Mesdames Véronique Wauthier et Alexandra Corre et Monsieur Didier Schönberger.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013128215/18.
(130156539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Belval Plaza II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 119.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128190/9.
(130156408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Belval Plaza I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 115.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128189/9.
(130156363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Sani-Maintenance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 160.962.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128191/9.
(130155601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
124316
L
U X E M B O U R G
Cyrus Investissements 1 SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 173.001.
EXTRAIT
Au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 6 septembre 2013, les actionnaires de la Société
ont unanimement approuvé, avec effet à la date de la présente assemblée:
- le remplacement de M. Philippe NGUYEN-CONG-DUC, né le 31 janvier 1958 à Saint-Maur des fossés, France,
résidant à Paris, F-75008, 2 rue de l'Amiral Coligny en tant que membre du conseil de surveillance de la Société,
- par M. Marcouf THELOT, né le 25 janvier 1978 à Paris 14
ème
, résidant professionnellement 1, Boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg et Mme Florence BROSSARD, née le 7 novembre 1957 à Paris 17
ème
, résidant professionnellement
1, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, chacun pour un mandat de six ans;
et,
- le remplacement de Cyrus Investissements, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, Boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 174.303 en tant que membre unique du directoire de la Société,
- par M. Oren SAPIR, né le 1
er
février 1966 à Kfar Saba (Israël), demeurant 55, rue Hagilboa, (44864) Kokav-Yair
(Israël), en tant que Président du Directoire de la Société et M. Jean-Baptiste THELOT, né le 6 décembre 1980 à Paris,
demeurant F-75017, 86, Avenue de Clichy, Paris, en tant que membre du Directoire de la Société. Ce dernier ne fera
donc plus partie du conseil de surveillance de la Société. Ils sont chacun nommés pour un mandat de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Cyrus INVESTISSEMENTS 1 S.A.
i>Mélanie Sauvage
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013128229/27.
(130155965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
BRE/Europe 3-A, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 114.720.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128210/9.
(130156449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Bocci Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 172.163.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128194/9.
(130156392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Buchler SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4886 Lamadelaine, 3, rue Jean Thill.
R.C.S. Luxembourg E 5.091.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128213/9.
(130156243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
124317
L
U X E M B O U R G
Bureau Européen de Comptabilité et de Fiscalité S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 205, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 55.684.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128214/9.
(130156048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Cabbi Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.346.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128216/9.
(130156393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Cat Développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Aciérie.
R.C.S. Luxembourg B 99.988.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013128233/9.
(130155975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Corton Meyney S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 67.894.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CORTON MEYNEY S.A. qui s'est tenue en date dui>
<i>23 août 2013i>
Il a été décidé ce qui suit:
- de coopter Monsieur Nicolas Hamel, Avocat, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Lu-
xembourg en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, avec effet au 25 août 2013.
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2016.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Véronique Wauthier, Messieurs Didier Schönberger et Nicolas Hamel.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013128228/18.
(130156568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
CMJ Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 111.733.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CMJ HOLDINGS S.A. qui s'est tenue en date du 23i>
<i>août 2013i>
Il a été décidé ce qui suit:
- de coopter Monsieur Nicolas Hamel, Avocat, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Lu-
xembourg en remplacement de Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, avec effet au 25 août 2013.
Le mandat du nouvel Administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2017.
124318
L
U X E M B O U R G
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
Madame Véronique Wauthier, Messieurs Didier Schönberger et Nicolas Hamel.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013128247/18.
(130156560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
DFR Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 900.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 159.694.
<i>Extrait de l'assemblée générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire 28 Mai 2013i>
En date du 28 Mai 2013, l'Assemblée Générale de la société DFR Investment S.à r.l. a:
- nommé Monsieur Romolo Bardin (né à Belluno - Italie - le 23/04/1978 demeurant professionnellement à 26b Bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg) nouveau gérant de classe A de la société avec effet au 28 Mai 2013;
- nommé Monsieur Aloyse May (né à Strasbourg - France - le 16/07/1954 demeurant professionnellement à 2 Rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg) nouveau gérant de classe B de la société avec effet au 28 Mai 2013
Luxembourg, 6 Septembre 2013.
Pour extrait conforme
Romolo Bardin
<i>A Manageri>
Référence de publication: 2013128256/18.
(130156506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 111.817.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 5 septembre 2013i>
En date du 5 septembre 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
De révoquer:
- Barnes Group Luxembourg (No. 2) S.à r.l. en tant que gérant unique de la Société avec effet au 6 septembre 2013.
De nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe A de la Société:
- Monsieur Franklin Louis Weidema, né le 27 janvier 1960 à São Paulo, Brésil, résidant professionnellement à l'Atrium
Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 6 septembre 2013
et pour une durée indéterminée; et
- Monsieur Pieter-Jan van der Meer, né le 30 décembre 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement à
l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 6 sep-
tembre 2013 et pour une durée indéterminée.
De nommer les personnes suivantes en tant que gérants de classe B de la Société:
- Monsieur Christopher John Stephens Jr., né le 7 décembre 1964 dans l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, résidant pro-
fessionnellement à 123, Main Street, Bristol, CT 06010, Etats-Unis d'Amérique, avec effet au 6 septembre et pour une
durée indéterminée;
- Monsieur Gregory Allen Marshall, né le 19 juillet 1970 à Rhode Island, Etats-Unis d'Amérique, résidant profession-
nellement à 123, Main Street, Bristol, CT 06010, Etats-Unis d'Amérique, avec effet au 6 septembre et pour une durée
indéterminée; et
- Mademoiselle Claudia Susanne Toussaint, né le 11 juin 1963 à Hambourg, Allemagne, résidant professionnellement
à 123, Main Street, Bristol, CT 06010, Etats-Unis d'Amérique, avec effet au 6 septembre 2013 et pour une durée indé-
terminée.
Depuis le 6 septembre 2013, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
124319
L
U X E M B O U R G
<i>Gérants de classe A:i>
Monsieur Pieter-Jan van der Meer
Monsieur Franklin Louis Weidema
<i>Gérants de classe B:i>
Monsieur Christopher John Stephens Jr.
Monsieur Gregory Allen Marshall
Mademoiselle Claudia Susanne Toussaint
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2013.
Barnes Group Inc.
Référence de publication: 2013128187/40.
(130156032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
'' BELVEDERE REAL ESTATE '', Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 99.618.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2013.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013128203/14.
(130156409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Esprit Coiffure Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 94.509.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013124176/10.
(130151122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Eurosit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 42.860.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2013124179/10.
(130150791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2013.
Karmaninvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 102.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013124877/9.
(130152139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
124320
Barnes Group Luxembourg (No.1) S.à r.l.
BCP Management Luxembourg S.à r.l.
Belval Plaza II S.à r.l.
Belval Plaza I S.à r.l.
'' BELVEDERE REAL ESTATE ''
'' BELVEDERE REAL ESTATE ''
BioPharma Secured Investments II Sub
Bocci Holding S.à r.l.
Brainsourcing S.àr.l.
BRE/Europe 3-A
Buchler SCI
Bureau Européen de Comptabilité et de Fiscalité S.à.r.l.
Burton Invest S.A.
Cabbi Holding S. à r.l.
Casabiene S.A.
Catalyst EPF Luxembourg 1 S.à r.l.
Cat Développement S.A.
Chez Luz Maria Sàrl
Chimindu International S.A.
CMJ Holdings S.A.
Corton Meyney S.A.
Costa Martins S.à r.l.
Cyrus Investissements 1 SA
DFR Investment S.à r.l.
Esprit Coiffure Sàrl
Eurosit S.A.
GSCP VI AA Two Holding S.à r.l.
High Point Sàrl
International Company of Services S.à r.l.
International Marketing Management
International Medical Consult S.à r.l.
International Paper Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Investus S.A.
I-Wohnen S.à r.l.
John Deere Cash Management S.A.
Jopaco Holdings S.A.
JRS Asset Management S.A.
Julien Cajot S.à r.l.
Juvema S.A. SPF
KANDAHAR (Luxembourg) N°1 LIMITED S.àr.l.
KANDAHAR (Luxembourg) N°2 LIMITED S.àr.l.
KANDAHAR (Luxembourg) N°2 LIMITED S.àr.l.
Karmaninvest S.A.
Kimi S.à r.l.
Kirchbergsee 1 V V S.à r.l.
Kirchbergsee 2 V V S.à r.l.
Landmark Investment Management Lux S.à r.l.
Luxtecpro S.à r.l.
Paladin Realty Brazil Investors III (Lux) SA
Sani-Maintenance Sàrl
Surrey Healthcare Investments
Talia Properties S.à r.l.
TCP Cable S.à r.l.
Telenet Finance Luxembourg II S.A.
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.
Universal Securitisation Solutions
Vendest S.A.
Verbriefungsgesellschaft REPE S.A.
Vivimus SPF S.A.
VLT Properties S.A.
VP investments Sàrl
VPL
YAO Investments S.à r.l.