logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2553

15 octobre 2013

SOMMAIRE

ACMBernstein SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122498

AmBev Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122530

Axa Alternative Financing Management

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122502

Axa Alternative Financing Management

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122513

BNP Paribas Flexi I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122501

Charon SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122502

Chios SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122501

Fondamenta Private Equity S.A. . . . . . . . . .

122498

FT EuroCorporates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122529

Gems Progressive Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .

122499

IFM-Invest: 2 PrivateEquity  . . . . . . . . . . . . .

122530

Kadmos SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122500

Parsifal SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122502

Participe S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122544

Property Trust Bernau, S.à r.l.  . . . . . . . . . .

122519

Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . .

122515

Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l.  . . .

122519

Property Trust Moosburg, S.à r.l.  . . . . . . . .

122515

Property Trust Muehldorf, S.à r.l.  . . . . . . .

122515

Property Trust Treuchtlingen, S.à r.l.  . . . .

122515

Quilmes International Beverages S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122530

Relofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122542

Rohtak Holding S.A.- SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

122541

Roninvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122541

Rovi Global Services S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

122536

Royalty Opportunities Feeder S.A.  . . . . . .

122541

Salm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122515

SBM Installer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122539

SCOP Poland S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122541

SeaNet Maritime Services S.à r.l.  . . . . . . . .

122530

Sebino Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

122534

Sterner Research S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122542

Stora Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

122543

SVG Kudamm S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122542

Syllus S.A. Holding S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . .

122543

Synapse International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

122542

Syneco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122542

Tar Heel Trading International S.à r.l.  . . .

122543

Temps d'Or  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122544

Ternium Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

122543

Terre d'eau technologies Environnemen-

tales Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122544

The Carlyle Group (Luxembourg) JV  . . . .

122521

The Four Plus (Luxembourg) S.A.  . . . . . . .

122544

Thorenc PV Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

122543

Titan SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122500

Vivimus SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122502

Wolverton Mountain SPF S.A.  . . . . . . . . . .

122500

122497

L

U X E M B O U R G

Fondamenta Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 121.134.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>05.11.2013 à 10 heures 00 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur;
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation;
3. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
5. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
6. Clôture finale de la liquidation;
7. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires et créancier le cas échéant;
8. Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2013142558/45/19.

ACMBernstein SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.021.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Extraordinary General Meeting") of ACMBernstein SICAV (the "Company") will be held on

Thursday, <i>October 31, 2013 , at 10:30 AM, at the registered office of the Company, with the following Agenda:

<i>Agenda:

Full restatement of the articles of the incorporation of the Company (the "Articles") in order to, inter alia:

- Amend Article 3 to reflect the submission of the Company to the law of 17 December 2010 regarding collective

investment undertakings (the "Law") so as to read as follows:
"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and
other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of
the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the law of 17 December 2010 regarding
collective investment undertakings (the "Law").
The Company qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS")."

- Amend Article 4 of the Articles in order to provide that the board of directors of the Company (the "Board") may

transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.

- Amend Article 5 of the Articles in order to specify that the provisions of UCITS set forth in the Law and any

implementing regulation shall apply. Therefore, the merger of a class of shares will be decided by the Board unless
the Board decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the class of shares concerned.
No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case
of a merger of one or several class(es) of shares where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall
be decided by a meeting of shareholders for which no quorum is required and that may decide with a simple majority
of votes cast.

- Amend Article 6 of the Articles to provide that the personal data of shareholders may be transferred, according

to a personal data transfer policy determined from time to time by the Board and disclosed in the sales document
of the Company.

- Amend Article 8 of the Articles in order to (i) clarify and extend the power of the Board to impose restrictions

on the ownership of the shares and to avoid the Company (and indirectly the shareholders) from being exposed
to any adverse consequences, and (ii) insert FATCA detrimental consequences as a ground to redeem compulsorily
shares held by a Restricted Person.

- Amend Article 16 of the Articles in order to provide that a class may invest in one or more other classes of the

Company (cross sub-fund investments), to the extent permitted by the Luxembourg laws and regulations.

122498

L

U X E M B O U R G

- Amend Article 16 of the Articles in order to provide that the Board may create any master/feeder UCITS class,

convert any existing class into a feeder UCITS class or change the master UCITS of any of its feeder UCITS class,
if permitted and in accordance with the Luxembourg laws and regulations.

- Amend Article 21 to set out more clearly the provisions relating to the procedures and processes applicable to a

redemption request and to clarify that the Net Asset Value may be reduced by, amongst others, tax and tax liabilities
(including withholding taxes or those deriving from FATCA requirements) or by a redemption charge, if any.

- Amend Article 23 of the Articles in order to clarify the valuation of fixed-income securities: fixed-income securities

are valued at the most recent bid price provided by the principal market maker.

- Amend  Article  23  in  order  to  clarify  that  the  redemption  price  or  the  subscription  price  may  be  reduced  or

increased as a consequence of any fiscal considerations or penalty of a specific country to the extent that the
Company would otherwise incur any pecuniary disadvantage as a result of a shareholder having not complied with
the relevant legislation of that country (e.g. FATCA).

- Amend  the  content  of  various  articles  of  the  Articles  and  renumber  certain  Articles  in  order  to  (i)  take  into

consideration the new requirements of the Law, (ii) mirror the provisions of the latest amendments to the law
dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (iii) take into consideration the impact resulting from
the application of the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and (iv) update references to laws and
regulations.

<i>Effective Date

The resolution on the Agenda will be effective two months after the Extraordinary General Meeting approving such

resolution.

<i>Voting

The resolution on the Agenda of the Extraordinary General Meeting will require a quorum of 50% of the share capital

in issue and will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast.

Only shareholders of record at the close of business on Friday, October 25, 2013 are entitled to vote at the Extraor-

dinary General Meeting and at any adjournments thereof.

If the quorum is not reached, a second Extraordinary General Meeting will be convened for Thursday, December 12,

2013 at10:30 AM (Luxembourg time) with the same Agenda. There is no quorum required for the reconvened Extraor-
dinary General Meeting and all resolutions will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast.

Shareholders are advised to consult the fully stated version of the Articles which is available free of charge, in English,

at  the  registered  office  of  the  Company  and  which  is  also  available  to  be  downloaded  from  the  internet  site
www.acmberstein.com.

<i>Voting arrangements

Shareholders who cannot personally attend the Extraordinary General Meeting are requested to use the attached

proxy. Completed proxy must be received no later than 48 hours before the time appointed for the Extraordinary General
Meeting at the registered office of the Company.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2013143148/755/75.

Gems Progressive Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 109.162.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Corporation held on 27 September 2013 could not

validly deliberate due to a lack of quorum in respect of the first item of the agenda, the Shareholders are hereby convened
to attend the reconvened

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Corporation to be held at the registered office of the Corporation on <i>31 October 2013 at 2.00 p.m. (Luxembourg

time) or at any adjournment thereof to deliberate on and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

Amendment of the articles of incorporation of the Corporation (the "Articles") with effect from 1 November 2013

in order to amend article 4 so as to reflect the transfer of the Corporation's registered office from Luxembourg City to
Hesperange.

The draft of the amended consolidated Articles detailing the full text of the amendments is available at the registered

office of the Corporation during usual business hours and may be obtained, free of charge upon request, at the registered
office of the Corporation.

The Shareholders are advised that in order to be able to deliberate validly on the agenda, no quorum will be required

and the resolutions will be adopted if approved by the majority of two thirds of the votes cast. Votes cast shall not include

122499

L

U X E M B O U R G

votes attaching to shares in respect of which Shareholders have not taken part in the vote, have abstained or have returned
a blank or invalid vote. Each entire share is entitled to one vote. A Shareholder may act at the meeting by person or by
proxy.

Forms of proxy already received for the extraordinary general meeting held on 27 September 2013 remain valid unless

expressly revoked.

The form of proxy is available at the registered office of the Corporation, upon request of Shareholders.
To be valid, the form of proxy must be duly completed, dated, signed and lodged, before 10.00 am (Luxembourg time)

on 29 October 2013 , with Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., attention of Investor Relations Group,

either by fax to +352 260236 470
or by email to gems@citco.com
or by mail to Citco Fund Services (Luxembourg) S.A. / Attn. Investor Relations Group / 20, rue de la Poste / P.O. Box

230 / L-2012 Luxembourg

Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact Citco Fund Services

(Luxembourg) S.A., Investor Relations Group, either by fax to +352 260236 470 or by email to gems@citco.com or by
phone on +352 260236 801

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013135846/37.

Titan SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 83.613.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2013 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134550/1031/15.

Kadmos SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 83.905.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2013 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134552/1031/16.

Wolverton Mountain SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.530.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

122500

L

U X E M B O U R G

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2013 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134554/1031/15.

Chios SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 82.007.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2013 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134553/1031/16.

BNP Paribas Flexi I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 117.580.

The STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on Monday <i>October 28, 2013 at 11.00 a.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate
on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at June 30, 2013 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,

at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.

The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of

their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will

be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the Registered Office

of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request,
either by post to the following address : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013137690/755/30.

122501

L

U X E M B O U R G

Vivimus SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 107.064.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2013 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134557/1031/15.

Parsifal SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 42.472.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 octobre 2013 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134556/1031/15.

Charon SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 51.034.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2013 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013134555/1031/15.

Axa Alternative Financing Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 118.072.

In the year two thousand and thirteen,
on twenty-seventh day of September.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

122502

L

U X E M B O U R G

AXA Investment Managers Private Equity, a société anonyme à directoire et conseil de surveillance governed by the

laws of France with registered office at 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, France and registered with the Greffe du
Tribunal de Commerce de Paris under number 403081714 (the "Shareholder"),

here represented by Maître Jennifer Ferrand, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 25 Sep-

tember 2013,

Said proxy, after been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary shall

be annexed to the present deed for registration purposes.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of AXA

Alternative Financing Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having
a share capital of one hundred twenty five thousand euro (EUR 125,000.-), with registered office at 24, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of
21 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1751 of 19 September 2006 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118072 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To restate the articles of incorporation of the Company.
2 To appoint Marcus Thiel as Class A Manager and to confirm that the other managers shall be qualified as Class B

Managers.

3 Delegation of powers.
4 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company.
As a consequence the articles of incorporation of the Company shall from now on read as follows:

"Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established a private limited company (société a responsabilité limitée) (the "Company")

governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of "AXA Alternative Financing Management S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the city of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the

Manager(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the

Manager(s).

In the event that in the view of the Manager(s) extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The purpose of the Company is the creation, administration and management of AXA ALTERNATIVE

FINANCING FCP (the "Fund") and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided copro-
prietorship interests in the Fund.

The Company shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of the Fund.

It may on behalf of the Fund, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any
registrations and transfers in its name or in third parties' names in the register of shares of debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the holders of certificates of the Fund, all rights and privileges,
especially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

122503

L

U X E M B O U R G

The Company may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however,

within the limitations set forth by Chapter 14 of the Luxembourg law of 20 December 2002 relating to undertakings for
collective investment.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum

and majority rules provided by law or by these Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at one hundred and twenty five thousand euros (EUR

125,000.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of two hundred and fifty euros (EUR 250.-) each,
all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation
of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced in one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Manager(s), Statutory auditors

Art. 9. Managers(s). The Company shall be managed by one (1) or more managers who may be but need not be

shareholders (the "Manager(s)"). If the Company is managed by two (2) Managers, they shall jointly manage the Company.
If the Company is managed by three (3) or more Managers, they shall constitute a board of Managers (the "Board of
Managers") and any reference in the Articles of Incorporation to the Manager(s) shall constitute a reference to the Board
of Managers.

One (1) manager (the "Class A Manager") will be appointed amongst a list of candidates set out by AXA Konzern AG.

If a Board of Managers is constituted, the other managers of the Company will be appointed as Class B managers (the
"Class B Managers"). In addition, the Class A Manager (i) can request any items of the reserved matters listed below to
be put on the agenda of a meeting of the Board of Managers and (ii) will benefit from a veto right on the following list of
reserved matters:

- Appointment and revocation by the Company of service providers which are affiliated to AXA Investment Managers

Private Equity Europe SA, a French société anonyme, having its registered office located at 20 place Vendôme, 75001
Paris, France and registered with the Paris Trade and Companies Register under number 403 201 882 ("AXA PEE");

- Any amendment to existing services agreements entered into by the Company with AXA PEE and its affiliates (in-

cluding the Advisory Services Agreement entered into with AXA PEE or AXA Private Equity Germany GmbH, a limited
liability company incorporated under the laws of Germany, having its registered office located at An der Welle 4, D-60322
Frankfurt, Germany and registered with the Frankfurt Trade and Companies Register under number HRB 53953 ("AXA
PE Germany"), as the case may be);

- Any amendment to the Prospectus of the Fund;
- Any amendment to the Management Regulations of the Fund;

122504

L

U X E M B O U R G

- Appointment by the above-mentioned service providers which are affiliated to AXA PEE of agents acting in the name

of the Company under the relevant services agreement;

- Delegation by any above-mentioned service provider which is affiliated to AXA PEE of its duties under the relevant

services agreement to any third party (excluding other affiliates of AXA PEE); and

- Any instruction to be given by the Company to AXA PEE or AXA PE Germany as to the enforcement of their rights

against advisers they appointed in accordance with the relevant advisory agreement entered into between the Company
and AXA PEE or AXA PE Germany, as the case may be.

The Board of Managers will need to obtain the approval of the Class A Manager on the reserved matters as described

in the preceding paragraph. Before any of the abovementioned reserved matters can be put on the agenda of a meeting
of the Board of Managers, and therefore before any convening notice is sent to the members of the Board of Managers,
the person that is willing to convene a meeting of the Board will submit, at least five (5) business days before any convening
notice is sent to the members of the Board of Managers (except in cases the Class A Manager would accept a shorter
notice), the draft agenda to the Class A Manager and take into account, insofar as the reserved matters listed above are
concerned, any comments the Class A Manager may have on this draft agenda.

The Manager(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine the number of Managers

and the term of his/their office. Any Manager will hold office until his successor is elected. Any Manager is re-eligible and
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

The Board of Managers (if any) will appoint from among the Managers a chairman (the "Chairman"). It may also appoint

a secretary, who need not be a Manager, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers (if any) will meet upon convocation by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if

any) must be convened by the Chairman if any two (2) Managers so require, or if the Class A Manager so requires. The
agenda of any meeting of the Board of Managers is set by the person that convenes such meeting.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of

Managers (if any) may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the consent of all those entitled to attend, at least one (1) week's notice of Board

of Managers meetings (if any) shall be given in writing to each Manager and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Whenever any of the reserved matters listed above is on the agenda of a
meeting, notice shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of
a written text to each Manager at least five (5) business days before the contemplated date of the meeting. Any such
notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means of communication allowing for the trans-
mission of a written text, of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers (if any).

Every meetings of the Board of Managers (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of

Managers (if any) may from time to time determine. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers (if
any) by appointing in writing another Manager as his proxy.

A quorum of any meeting of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority

of the Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or via any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting.

A written resolution, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Manager, the Managers acting jointly, when the Company is managed by two

(2) Managers, or the Board of Managers, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Articles of Incor-
poration or by the Laws to the general meeting of shareholders are within the competence of the Manager, the Managers
acting jointly, when the Company is managed by two (2) Managers or the Board of Managers, as the case may be.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out

of his(their) management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred
by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 12. Managers' Liability. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation

to the commitments taken on behalf of the Company.

122505

L

U X E M B O U R G

Any such Manager is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies or entrust specific permanent or temporary functions to persons or committees of its/their choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the single signature or joint signatures of any person(s)

to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other

company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a Manager, officer or employee of the Company has an
interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of such other company or firm. Any person related
as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason solely of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering, voting or
otherwise acting upon any matters with respect to such contract or business.

Notwithstanding the above, when the Company is managed by two (2) or more Managers, in the event that any Manager

has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall make known such personal
interest to the Board of Managers or the other Manager and shall not consider or vote on any such transaction, and such
transaction and such interest of any Manager therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify the Manager(s), officers or employees of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses reasonably incurred by them in connection
with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been Managers,
officers or employees of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to
which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 15. Records of Resolutions of the Manager(s). If the Company is managed by one (1) Manager or two (2) Managers,

acting jointly, the resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing. Such resolutions can be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
Managers. Copies or extracts of such resolutions which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be
signed by any one Manager.

If the Company is managed by a Board of Managers, the minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed

by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes and of
written decisions adopted by the Board of Managers in conformity with article 9 of the Articles of Incorporation, which
may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by
any two (2) Managers.

Art. 16. Auditor. The operations of the Company, including particularly its books and the filing of any reports required

by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor. The independent auditor shall be elected by
the general meeting of shareholders or by the single shareholder and shall hold office until his successor is elected.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10

th

 , 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be

taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) to the
shareholders by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and transmit it by any means of communication allowing for the transmission of a
written text it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with Luxembourg law by the Manager(s), failing which, by the auditor or, failing which, by shareholders
representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the
time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

122506

L

U X E M B O U R G

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if circumstances of force majeure

so require.

Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company

represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest

powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than 25

shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice
convening the meeting on the last Friday in the month of April at 11 a.m. and, if such day is not a business day, on the
next business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose

adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority
rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at
least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or any Manager, as the case may be.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December every year.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s)

fix(es) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision

of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation,
unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended."

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to appoint Mr. Marcus Thiel, born on 5 March 1975 in Berlin, Germany, with professional

address at Colonia-Allee 10-20, D-51067 Cologne, Germany, as Class A Manager and for an indefinite period of time.

The Shareholder resolved to confirm that the other managers currently in office, i.e. Ian Kent, Simon Barnes, Jennifer

Ferrand, Alain Nicolai, Christophe Vulliez and Olivier Berment, shall be qualified as Class B Managers.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved that the foregoing resolutions will be conditional and effective upon the closing of the

acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.

The Shareholder resolved that the appointment of Mr. Marcus Thiel will be also conditional upon the approval of the

Commission de Surveillance du Secteur Financier.

The Shareholder further resolved to delegate all powers to each manager of the Company, acting individually and with

power of substitution, to acknowledge the satisfaction or non-satisfaction of the above mentioned conditions precedent.

122507

L

U X E M B O U R G

The Shareholder further resolved to delegate all powers to each manager of the Company and to any lawyer at

Linklaters LLP, Luxembourg, acting individually and with power of substitution, to have the effectiveness or non-effecti-
veness of the foregoing resolutions recorded in a notarial deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at thousand euro. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on
request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request
of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document. The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned
notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with Us the undersigned notary,
this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize,
le vingt-septième jour du mois de septembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

AXA Investment Managers Private Equity, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les

lois de France, ayant son siège social au 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, France et immatriculée au Greffe du Tribunal
de Commerce de Paris sous le numéro 403081714 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Jennifer Ferrand, juriste, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration donnée le 25 septembre 2013.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante, restera annexée

aux présentes à des fins d'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de AXA Alternative

Financing Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social
de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000.-), dont le siège social est au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1751 du19 septembre 2006, et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118072 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été
modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Refonte des statuts de la Société.
2 Nomination de Marcus Thiel en tant que Gérant de Catégorie A et confirmation que les autres gérants seront

qualifiés de Gérants de Catégorie B.

3 Délégation de pouvoirs.
4 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé de refondre les statuts de la Société. Les statuts seront dorénavant rédigés comme suit:

«Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, par l'article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Axa Alternative Financing Management S.à r.l.».

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une résolution du ou des

Gérant(s).

122508

L

U X E M B O U R G

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une

décision du ou des Gérant(s).

Au cas où le ou les Gérant(s) estimerai(en)t que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l'étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être temporairement transféré à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les Gérant(s).

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la création, l'administration et la gestion de AXA ALTERNATIVE FINANCING

FCP (le «Fonds») et l'émission de certificats ou confirmations faisant la preuve des parts de co-propriété indivise dans le
Fonds.

La Société se chargera de toute action en rapport avec la gestion, l'administration et la promotion du Fonds. Elle pourra

pour le compte du Fonds conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toute valeur mobilière, procéder
à toute inscription et tout transfert en son nom ou au nom de tiers dans le registre des actions ou obligations de toute
société luxembourgeoise ou étrangère et exercer pour le compte de la Société et des détenteurs des certificats du Fond,
tout droit et privilège, en particulier le droit de vote attaché aux valeurs mobilières constituant les avoirs du Fonds. Les
pouvoirs précités ne doivent pas être considérés comme exhaustifs mais simplement exemplatifs.

La Société pourra exercer toute activité destinée utile à l'accomplissement de son objet social en restant toutefois

dans les limites tracées par le Chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par les associés,

suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi ou les Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille cinq cents euros (EUR 125.000,-)

divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-), chacune
et chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de la

Société et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion
aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les
trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit,

en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et
de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement

similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérant(s). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être associé(s) mais qui n'en ont pas

l'obligation (les «Gérants»). Si la Société est gérée par deux (2) Gérants, ceux-ci gèrent la Société conjointement. Si la
Société est gérée par trois (3) Gérants ou un nombre supérieur de Gérants, ils constituent un conseil de gérance (le
«Conseil de Gérance») et toute référence dans les Statuts au(x) Gérant(s) constitue une référence au Conseil de Gérance.

Un (1) gérant (le «Gérant de Catégorie A») est nommé parmi une liste de candidats établie par AXA Konzern AG.

Dans le cas où un Conseil de Gérance serait constitué, les autres gérants de la Société seront nommés en tant que gérants

122509

L

U X E M B O U R G

de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»). De plus, le Gérant de Catégorie A (i) pourra demander que toute décision
de la liste suivante soit mise à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de Gérance et (ii) disposera d'un droit de véto
sur chacune des décisions listées ci-après:

- Nomination et révocation par la Société des prestataires de services qui sont affiliés à AXA Investment Managers

Private Equity Europe SA, une société anonyme de droit français ayant son siège social situé au 20 place Vendôme, 75001
Paris, France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 201 882 («AXA
PEE»);

- Toute modification des contrats de service existants conclus entre la Société et AXA PEE et ses affiliés (en ce compris

le contrat de services conclu avec AXA PEE ou avec AXA Private Equity Germany GmbH, une société à responsabilité
limitée de droit allemand ayant son siège social situé An der Welle 4, D-60322 Frankfort, Allemagne et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Frankfort sous le numéro HRB 53953 («AXA PE Germany»);

- Toute modification apportée au prospectus du Fonds;
- Toute modification apportée au règlement de gestion du Fonds;
- Nomination par les prestataires de services susmentionnés affiliés à AXA PEE d'agents agissant au nom de la Société

en vertu du contrat de services applicable;

- Délégation par tout prestataire de services susmentionné affilié à AXA PEE des obligations qui lui incombent en vertu

du contrat de services applicable à tout tiers (à l'exception des autres affiliés d'AXA PEE); et

- Toute instruction devant être donnée par la Société à AXA PEE ou AXA PE Germany concernant la mise en oeuvre

de leurs droits à indemnisation à l'encontre des conseils qu'ils ont nommés conformément au contrat de conseil conclu
entre la Société et AXA PEE ou AXA PE Germany, selon le cas.

Le Conseil de Gérance devra obtenir l'approbation du Gérant de Catégorie A pour chacune des décisions listées dans

le paragraphe précédent. Avant que l'une des décisions listées ci-dessus ne puisse être inscrite à l'ordre du jour d'une
réunion du Conseil de Gérance, et par conséquent avant que toute convocation ne soit envoyée aux Gérants, la personne
qui souhaite convoquer une réunion devra, au moins cinq (5) jours ouvrés avant que toute convocation ne soit envoyée
aux membres du Conseil de Gérance (sauf dans les cas où le Gérant de Catégorie A accepterait un délai d'information
plus court), soumettre le projet d'ordre du jour au Gérant de Catégorie A et devra prendre en compte, dans la mesure
où les décisions listées ci-dessus sont concernées, tout commentaire que le Gérant de Catégorie A pourrait avoir con-
cernant le projet d'ordre du jour. Le ou les Gérant(s) sera/seront nommés par l'assemblée générale des associés qui
déterminera le nombre de Gérant(s) et la durée de son/leur mandat. Tout Gérant restera en fonction jusqu'à la nomination
de son successeur. Tout Gérant est rééligible et peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution
de l'assemblée générale des associés.

Le Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra

également nommer un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de

Gérance (pour autant qu'il existe) doit être convoquée par le Président si deux (2) Gérants en font la demande, ou si le
Gérant de Catégorie A en fait la demande. L'ordre du jour de toute réunion du Conseil de Gérance est déterminé par
la personne qui convoque la réunion.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe), mais en son absence le

Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) pourra désigner un autre Gérant comme président pro tempore à la majorité
des Gérants présents ou représentés.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont le droit d'assister à cette réunion, une convocation écrite

à toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) devra être envoyée à tous les Gérants par tout moyen
de communication permettant la transmission d'un texte écrit, au moins une (1) semaine avant la date prévue pour la
réunion. Si une des décisions listées à l'Article 9 apparaît à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de Gérance, une
convocation écrite devra être transmise par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit aux Gérants au moins
cinq (5) jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion
ainsi que l'ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord
écrit de chaque Gérant transmis par tout moyen permettant la transmission d'un texte écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans un calendrier préalablement
adoptée par une résolution du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe).

Toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que

le Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) aura de temps à autres déterminé. Tout Gérant pourra se faire représenter
aux réunions du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) en désignant par écrit un autre Gérant comme son man-
dataire.

Le quorum requis pour toute réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe) est la majorité des Gérants

présents ou représentés.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

122510

L

U X E M B O U R G

Un ou plusieurs Gérant(s) peut/peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, une résolution écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable comme si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance (pour autant qu'il existe), dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu chacun signés par un ou plusieurs
Gérants.

Les associés ne doivent ni participer ni s'immiscer dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant, les Gérants agissant conjointement lorsque la Société est gérée par deux

(2) Gérants ou le Conseil de Gérance, selon le cas, a/ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par les
Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du Gérant, des Gérants agissant
conjointement lorsque la Société est gérée par deux (2) Gérants ou du Conseil de Gérance, selon le cas.

Art. 11. Rémunération et dépenses. Le ou les Gérant(s) peut/peuvent recevoir une rémunération pour la gestion de

la Société et doit/doivent, en plus, être remboursé(s) de toute dépense engagée en relation avec la gestion de la Société
ou la poursuite de l'objet social.

Art. 12. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant n'engage sa responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de

ses fonctions, il contracte des engagements pour le compte de la Société. Chaque Gérant est uniquement responsable
de l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le ou les Gérant(s) peut/peuvent conférer des pouvoirs

ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son/leur
choix.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un des Gérants.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le ou les Gérant(s), mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.

Art. 14. Conflit d'Intérêts - Indemnisation. Aucun contrat ni aucune autre opération entre la Société et d'autres sociétés

ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un Gérant, fondé de pouvoirs ou employé de la Société a un intérêt
dans une telle autre société ou entreprise, ou en est administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Toute
personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera
en relations d'affaires de toute autre façon, ne devra pas être empêchée de délibérer ou de voter sur un sujet relatif à
un tel contrat ou à une telle opération ou d'entreprendre toute autre action en relation avec ce contrat ou cette opération
au seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la Société est gérée par deux (2) Gérants ou plus et qu'un Gérant a ou pourrait

avoir un intérêt personnel dans une opération de la Société, ce Gérant doit en aviser le Conseil de Gérance ou l'autre
Gérant et il ne peut ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette opération et cette opération
ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée
générale des associés.

La Société indemnisera le(s) Gérant(s), les fondés de pouvoirs ou employés de la Société et, le cas échéant, leurs

héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils auront à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés, en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes en
tant que Gérant, fondé de pouvoirs ou employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans
laquelle la Société est actionnaire ou créancière et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des
cas où à l'issue de ces actions en justice, procès ou poursuites, ils auront été définitivement reconnu responsables de
négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les points
couverts par l'arrangement transactionnel pour lesquels la Société aura reçu confirmation par son conseiller juridique
que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est
pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes devant être indemnisées en vertu de Statuts pourraient prétendre.

Art. 15. Procès-Verbaux de Résolutions de Gérance. Si la Société est gérée par un (1) ou deux (2) Gérants, agissant

conjointement, les résolutions du/des Gérant(s) sont, consignées par écrit. Ces résolutions peuvent être consignées dans
un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé chacun par un ou plusieurs Gérants.
Les copies ou extraits de ces résolutions, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par un Gérant.

Si la Société est gérée par un Conseil de Gérance, les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront

signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y en
existe) ou par deux (2) Gérants.

122511

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Réviseur. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité et l'établissement

de toutes déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprises. Le réviseur
d'entreprises sera élu par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés jusqu'à l'élection de son successeur.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi
du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le ou les Gérant(s) aux associés par tout moyen de
communication permettant la transmission d'un texte écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre
leur vote écrit et de l'envoyer par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit à la Société,
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le ou les Gérant(s), ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou à
leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un manda-

taire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure.

Art. 18. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-

sente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au(x) Gérant(s) en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs les

plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la

Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis
de convocations le dernier vendredi du mois d'avril à 11.00 heures et, si un tel jour n'est pas un jour ouvrable, le jour
ouvrable qui suit.

Art. 20. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par l'un quelconque du ou des Gérant(s), selon le cas.

Chapitre V. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 21. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de

décembre de chaque année.

Art. 22. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer
aux associés comme dividendes.

Le ou les Gérant(s) peut/peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Le ou les Gérant(s) détermine(nt) le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou des associés

délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

122512

L

U X E M B O U R G

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommées

par l'associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément

à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée."

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de nommer M. Marcus Thiel, né le 5 mars 1975 à Berlin, Allemagne, avec adresse professionnelle

à Colonia-Allee 10-20, D-51067 Cologne, Allemagne, en tant que Gérant de Catégorie A pour une période indéterminée.

L'Associé a décidé de confirmer que les autres gérants en fonction, à savoir I an Kent, Simon Barnes, Jennifer Ferrand,

Alain Nicolai, Christophe Vulliez et Olivier Berment, seront qualifiés de Gérants de Catégorie B.

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé que les résolutions qui précèdent seront assujetties à la condition suspensive du, et effectives au,

closing de l'acquisition par Holding PE SAS de la majorité des actions d'AXA Investment Managers Private Equity S.A.

L'Associé a décidé que la nomination de M. Marcus Thiel est également assujettie à la condition suspensive de l'accord

de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

L'Associé a également décidé de déléguer tous pouvoirs à tout gérant de la Société, agissant individuellement et avec

pouvoir de substitution, pour prendre acte de la réalisation ou non-réalisation des conditions suspensives qui précèdent.

L'Associé a également décidé de déléguer tous pouvoirs à tout gérant de la Société et à tout avocat de Linklaters LLP,

Luxembourg, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour constater dans un acte notarié l'effectivité
ou non des résolutions qui précèdent.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. FERRAND, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 octobre 2013. Relation: EAC/2013/12691. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013141738/602.
(130173858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Axa Alternative Financing Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 118.072.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Mrs Pia LAVRYSEN, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as special attorney in fact of AXA Alternative Financing Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée

governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-),
with  registered  office  at  24,  avenue  Emile  Reuter,  L-2420  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  incorporated
following a deed of the undersigned notary of 21 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations number 1751 of 19 September 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 118.072 (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

122513

L

U X E M B O U R G

By virtue of the authority conferred on her by the sole shareholder of the Company on 27 September 2013 recorded

in a deed of the undersigned notary.

Said appearing person has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:
I. That the resolution of the sole shareholder of the Company of 27 September 2013 to fully restate the articles of

incorporation of the Company (the “First Resolution”) was conditional and effective upon the closing of the acquisition
by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A.

II. That the resolution of the sole shareholder of the Company of 27 September 2013 to appoint Mr. Marcus Thiel as

Class A manager for an indefinite period of time (the “Second Resolution”) was conditional and effective upon the closing
of the acquisition by Holding PE SAS of a majority of the shares in AXA Investment Managers Private Equity S.A. and was
also conditional upon the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

III. That Mrs Jennifer Ferrand, acting in her capacity as attorney in fact of the Company, and according to the authority

granted to her by the sole shareholder of the Company on 27 September 2013, has acknowledged and confirmed, in a
confirmation dated 30 September 2013, a copy of which shall remain attached to the present deed, that the condition
precedent to the First Resolution and the conditions precedent to the Second Resolution have been satisfied.

IV. That as a consequence the restatement of the articles of incorporation and the appointment of Mr. Marcus Thiel

have become effective.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with Us, the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trentième jour de septembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Maître Pia LAVRYSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant comme mandataire spécial de AXA Alternative Financing Management S.à r.l., une société à responsabilité

limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), dont le
siège social est au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte
du notaire soussigné en date du 21 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
1751 du 19 septembre 2006, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 118.072 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

En vertu d'une procuration qui lui a été conférée par l'associé unique de la Société en date du 27 septembre 2013,

consignée dans un acte du notaire soussigné.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les déclarations et constatations suivantes:
I. Que la résolution de l'associé unique de la Société en date du 27 septembre 2013 de refondre les statuts de la Société

(la «Première Résolution») était assujettie à la condition suspensive du, et effective au closing de l'acquisition par Holding
PE SAS de la majorité des actions d'AXA Investment Managers Private Equity S.A.

II. Que la résolution de l'associé unique de la Société en date du 27 septembre 2013 de nommer M. Marcus Thiel en

tant que gérant de Catégorie A pour une période indéterminée (la «Deuxième Résolution») était assujettie à la condition
suspensive du, et effective au closing de l'acquisition par Holding PE SAS de la majorité des actions d'AXA Investment
Managers Private Equity S.A. et également assujettie à la condition suspensive de l'accord de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier.

III. Que Mme Jennifer Ferrand, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la Société, et conformément au pouvoir

qui lui a été conféré par l'associé unique de la Société en date du 27 septembre 2013, a constaté et confirmé, dans une
confirmation en date du 30 septembre 2013, dont une copie restera annexée au présent acte, que la condition suspensive
à la Première Résolution et les conditions suspensives à la Deuxième Résolution ont été réalisées.

IV. Que dès lors la refonte des statuts et la nomination de M. Marcus Thiel sont devenues effectives.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, le notaire soussigné, le présent acte.

122514

L

U X E M B O U R G

Signé: P. LAVRYSEN, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 2 octobre 2013. Relation: EAC/2013/12712. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013141739/78.
(130173858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Salm, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 1 

er

 septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, août 2013

IPConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2013123124/10.
(130150079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 783.750,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.812.

Property Trust Treuchtlingen, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 347.750,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 110.984.

Property Trust Muehldorf, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 236.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 110.980.

Property Trust Moosburg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 203.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 110.661.

In the year two thousand thirteen, on the third day of the month of October.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 21,boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.812,

hereby represented by Ms. Carla Alves Silva, employee, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney-in-

fact of Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l. by virtue of a proxy given by the board of managers of PT Lux 1, in accordance
with the resolutions taken during the meeting dated 18 June 2013;

- Property Trust Treuchtlingen S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 21,boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.984,

hereby represented by Ms. Carla Alves Silva, prenamed, acting as attorney-in-fact of Property Trust Treuchtlingen S.à

r.l., by virtue of a proxy given by the board of managers of PT Lux Treuchtlingen, in accordance with the resolutions
taken during the meeting dated 18 June 2013;

- Property Trust Muehldorf S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.980,

122515

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Ms. Carla Alves Silva, prenamed, acting as attorney-in-fact of Property Trust Muehldorf S.à r.l.

by virtue of a proxy given by the board of managers of PT Muehldorf, in accordance with the resolutions taken during
the meeting dated 18 June 2013;

- Property Trust Moosburg S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.661,

hereby represented by Ms Carla Alves Silva, prenamed, acting as attorney-in-fact of Property Trust Moosburg S.à r.l.

by virtue of a proxy given by the board of managers of PT Moosburg, in accordance with the resolutions taken during
the meeting dated 18 June 2013;;

Such appearing persons, acting as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

- that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on 24 June

2013, published in the Mémorial C, number 1557 of 1 

st

 July 2013, Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l., a Luxembourg

société à responsabilité limitée, having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, with a share capital of seven hundred eighty-three thousand eight hundred seventy-five euro (EUR 783,875,-),
incorporated on 20 July 2005 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, published in
the Mémorial C, number 1401 of 16 December 2005, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 109.812; the articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary, residing in Luxembourg, dated 30 July 2007, published in the Mémorial C, number 2116 of 27 September
2007, as the absorbing company (the "Absorbing Company"), and

1) Property Trust Treuchtlingen S.à.r.l, a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at

21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with a share capital of three hundred forty-seven thou-
sand  seven  hundred  fifty  euro  (EUR  347,750,-),  incorporated  on  29  September  2005  as  a  Luxembourg  société  à
responsabilité  limitée,  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Gérard  Lecuit  notary,  residing  in  Luxembourg,  published  in  the
Mémorial C, number 191 of 27 January 2006, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 110.984; the articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit,
notary, residing in Luxembourg, dated 13 October 2006, published in the Mémorial C, number 47 of 25 January 2007,

2) Property Trust Muehldorf S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 21,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with a share capital of two hundred thirty-six thousand five
hundred euro (EUR 236,500,-), incorporated on 29 September 2005 as a Luxembourg société à responsabilité limitée
pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 121
of 18 January 2006, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.980; the articles
of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,
dated 22 March 2006, published in the Mémorial C, number 1230 of 26 June 2006, and

3) Property Trust Moosburg S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 21,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with a share capital of two hundred three thousand three
hundred euro (EUR 203.300,-), incorporated on 13 September 2005 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary,
residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 59 of 10 January 2006, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 110.661; the articles of incorporation have been amended for the last
time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, dated 22 March 2006, published in the Mémorial
C, number 1234 of 27 June 2006,

as absorbed companies (together the "Absorbed Companies"), contemplated to merge;
- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1)

month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be
convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in

the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies

and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

(ii) following the merger, the Absorbed Companies cease to exist,
(iii) following the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed

Companies shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Companies shall
be kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 21,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10 

th

1915 on commercial companies have been observed.

122516

L

U X E M B O U R G

<i>Costs and Expenses

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand one hundred Euro
(EUR 1,100).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trois octobre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le

siège social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 109.812,

représentée aux fins des présentes par Madame Caria Alves Silva, employée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, agissant en tant que mandataire de Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l. aux termes d'une procuration lui
conférée par décision des gérants prise en sa réunion du 18 juin 2013;

- Property Trust Treuchtlingen S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le

siège social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.984,

représentée aux fins des présentes par Madame Caria Alves Silva, prénommée, agissant en tant que mandataire de

Property Trust Treuchtlingen S.à r.l. aux termes d'une procuration lui conférée par décision des gérants prise en sa
réunion du 18 juin 2013;

- Property Trust Muehldorf S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège

social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.980,

représentée aux fins des présentes par Madame Caria Alves Silva, prénommée, agissant en tant que mandataire de

Property Trust Muehldorf S.à r.l. aux termes d'une procuration lui conférée par décision des gérants prise en sa réunion
du 18 juin 2013;

- Property Trust Moosburg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège

social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.661,

représentée aux fins des présentes par Madame Caria Alves Silva, prénommée, agissant en tant que mandataire de

Property Trust Moosburg S.à r.l. aux termes d'une procuration lui conférée par décision des gérant prise en sa réunion
du 18 juin 2013;

Les comparantes représentées comme mentionné ci-dessus ont requis le notaire soussigné de documenter les décla-

rations et constations:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 24 juin

2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1557 du 1er Juillet 2013, Property Trust
Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 21, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, ayant un capital social de sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante quinze
euros (EUR 783.875), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
20 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1401 du 16 décembre 2005,
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.812; les statuts ont été
modifiés la dernière fois par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet
2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2116 du 27 Septembre 2007, en tant que
société absorbante (la «Société Absorbante») et

1) Property Trust Treuchtlingen S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 21, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ayant un capital social de trois cent quarante sept mille sept cent
cinquante euros (EUR 347.750,-), constituée sous la forme d'une société à responsabilité limités suivant acte de Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2005, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 191 du 27 janvier 2006, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.984; les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Gérard

122517

L

U X E M B O U R G

Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 octobre 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 47 du 25 janvier 2007,

2) Property Trust Muehldorf S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 21, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ayant un capital social de deux cent trente-six mille cinq cents euros
(EUR 236.500,-), constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte de Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 121 du 18 janvier 2006, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 110.980; les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 22 mars 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 1230 du 18 janvier 2006, et

3) Property Trust Moosburg S.à r.l. une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 21, boulevard Grande-

Duchesse  Charlotte,  L-1331  Luxembourg,  ayant  un  capital  social  de  deux  cent  trois  mille  trois  cents  euros  (EUR
203.300,-), constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 septembre
2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 59 du 10 janvier 2006, et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.661; les statuts ont été modifiés la dernière
fois par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mars 2006, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1234 du 27 juin 2006,

en tant que sociétés absorbées (ensemble les «Sociétés Absorbées»), ont projeté de fusionner;

- qu'aucun associé de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant

la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusion-

nantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

(ii) que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées cessent d'exister;

(iii) que suite encore à l'absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les parts sociales des Sociétés

Absorbées seront annulées et tous les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal
(cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais et Dépenses

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille cent Euros (EUR 1.100).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparantes et
en cas de divergences entre les deux versions, la version Anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. ALVES SILVA, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45048. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2013141697/200.

(130172304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

122518

L

U X E M B O U R G

Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.023.

Property Trust Bernau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 374.250,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.751.

In the year two thousand thirteen, on the third day of the month of October.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Property Trust Luxembourg 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, with registered office at 21,boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 117.023,

hereby represented by Ms. Carla Alves Silva, employee, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney-in-

fact of Property Trust Luxembourg 3 S.à r.l by virtue of a proxy given by the board of managers of PT Lux 3, in accordance
with the resolutions taken during the meeting dated 18 June 2013;

- Property Trust Bernau S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-

xembourg, with registered office at with registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.751,

hereby represented by Ms. Carla Alves Silva, prenamed, acting as attorney-in-fact of Property Trust Bernau S.à r.l., by

virtue of a proxy given by the board of managers of PT Bernau, in accordance with the resolutions taken during the
meeting dated 18 June 2013;

Such appearing persons, acting as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

- that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on 24 June

2013, published in the Mémorial C, number 1557 of 1 

st

 July 2013, Property Trust Luxembourg 3 S.à r.l., a Luxembourg

société à responsabilité limitée, having its registered office at 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, with a share capital of forty-five thousand euro (EUR 45,000.-), incorporated on 2 June 2006 pursuant to a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number 1546 of 12 August 2006,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 117.023; the articles of incorporation
have been amended for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, dated 27 February
2007, published in the Mémorial C, number 943 of 22 May 2007, as the absorbing company (the "Absorbing Company"),
and

1) Property Trust Bernau S.à.r.l, a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 21,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, with a share capital of three hundred seventy-four thousand
two hundred fifty euro (EUR 374.250,-), incorporated on 24 February 2006 as a Luxembourg société à responsabilité
limitée, pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, number
999 of 22 May 2006, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.751; the articles
of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,
dated 27 April 2006, published in the Mémorial C, number 1390 of 19 July 2006,

as absorbed company (the "Absorbed Company"), contemplated to merge;
- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1)

month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be
convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in

the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies

and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;

(ii) following the merger, the Absorbed Company cease to exist,
(iii) following the absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed

Company shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Company shall be
kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 21, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

122519

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10 

th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs and Expenses

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand one hundred Euro
(EUR 1,100).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version and that at the request of the appearing persons and in case of divergences between
the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trois octobre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- Property Trust Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le

siège social est 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et im-
matriculée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 117.023,

représentée aux fins des présentes par Madame Caria Alves Silva, employée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, agissant en tant que mandataire de Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l. aux termes d'une procuration lui
conférée par décision des gérant prise en sa réunion du 18 juin 2013,

- Property Trust Bernau S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège

social est au 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.751,

représentée aux fins des présentes par Madame Caria Alves Silva, prénommée, agissant en tant que mandataire de

Property Trust Bernau S.à r.l. aux termes d'une procuration lui conférée par décision des gérant prise en sa réunion du
18 juin 2013;

Les comparantes représentées comme mentionné ci-dessus ont requis le notaire soussigné de documenter les décla-

rations et constations:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 24 juin

2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1557 du 1 

er

 Juillet 2013, Property Trust

Luxembourg 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 21, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, ayant un capital social de quarante cinq mille euros (EUR 45.000,-), constituée suivant
acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 1546 du 12 août 2006, et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.023; les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 943 du 22 May 2007, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et

1) Property Trust Bernau S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 21, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ayant un capital social de trois cent soixante quatorze mille deux cent cinquante
euros (EUR 374.250,-), constituée sous la forme d'une société à responsabilité limités suivant acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 Février 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 999 du 22 mai 2006, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 114.751; les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 27 Avril 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 1390 du 19 juillet 2006,

en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), a projeté de fusionner;
- qu'aucun associé de la Société Absorbante et de la Société Absorbée n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant

la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

122520

L

U X E M B O U R G

(i) la fusion deviendra définitive et entrainera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusion-

nantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

(ii) que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée cesse d'exister;
(iii) que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les parts sociales de la Société

Absorbée seront annulées et tous les livres et autres dossiers de cette dernière seront conservés pendant le délai légal
(cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais et Dépenses

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille cent Euros (EUR 1.100).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes,

le présent acte est rédigé, en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparantes
et en cas de divergences entre les deux versions, la version Anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte

Signé: C. ALVES SILVA, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45049. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2013141698/138.
(130172288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.676.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
was held an extraordinary general meeting of shareholders of The Carlyle Group (Luxembourg) JV, société en com-

mandite  par  actions,  having  its  registered  office  at  2,  Avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxembourg,  incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on September 5, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated October 10, 2003 under number 1054, and which articles of
incorporation have last been amended pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler dated May 8, 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated July 3, 2012 under number 1665.

The meeting was presided by Mrs Fatima Lahmer, residing professionally at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,(the "Chairman")

The Chairman appointed as secretary Mrs Eva Prekub, residing professionally at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Ms Nouria Mokhnache, residing professionally at 2, Avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

The board of the meeting then drew up the attendance list, which, after having been signed ne varietur by the holder

(s) of the powers of attorney representing the shareholders, will remain attached to the present minutes together with
said powers of attorney.

The Chairman declared that:
I. The shareholders representing the full amount of the share capital were present or validly represented at the sha-

reholders' meeting. The shareholders could thus validly deliberate and decide on all subjects on the agenda.

II. The agenda of the meeting was the following:

122521

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an

amount of nine hundred eight thousand thirty seven Euro and forty four Cents (EUR 908,037.44) so as to bring it from
its current amount of eleven million one hundred twenty three thousand three hundred forty five Euro and two Cents
(EUR 11,123,345.02) down ten million two hundred fifteen thousand three hundred seven Euro and fifty eight Cents (EUR
10,215,307.58) by cancellation of ninety million eight hundred three thousand seven hundred forty four (90,803,744) self-
held Class L ordinary shares of the Company of one Cent (EUR 0.01) of nominal value each;

2. Acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an

amount  of  one  million  two  hundred  ninety  seven  thousand  eight  hundred  seventeen  Euro  and  seventy  Cents  (EUR
1,297,817.70) so as to bring it from its current amount of ten million two hundred fifteen thousand three hundred seven
Euro and fifty eight Cents (EUR 10,215,307.58) down to eight million nine hundred seventeen thousand four hundred
eighty nine Euro and eighty eight Cents (EUR 8,917,489.88) by cancellation of one hundred twenty nine million seven
hundred eighty one thousand seven hundred seventy (129,781,770) self-held Class H ordinary shares of the Company of
one Cent (EUR 0.01) of nominal value each;

3. Approval of the payment to the shareholders of a redemption price adjustment in relation to the repurchase of

Class I ordinary shares of the Company in the amount of twenty eight thousand one hundred seventy six Euro (EUR
28,176) out of the Company's distributable reserves;

4. Approval of an increase of the share capital of the Company by an amount of forty thousand six hundred sixty one

Euro and forty two Cents (EUR 40,661.42) so as to bring it from its current amount of eight million nine hundred seventeen
thousand four hundred eighty nine Euro and eighty eight Cents (EUR 8,917,489.88) up to eight million nine hundred fifty
eight thousand one hundred fifty one Euro and thirty Cents (EUR 8,958,151.30) by creation of four million sixty six
thousand one hundred forty two (4,066,142) ordinary shares of Class K of the Company of one Cent (EUR 0.01) of
nominal value each;

5. Acknowledgement of a share redemption, and approval of a decrease of the share capital of the Company by an

amount of twenty seven thousand one hundred seventy eight Euro and thirteen Cents (EUR 27,178.13) so as to bring it
from its current amount of eight million nine hundred fifty eight thousand one hundred fifty one Euro and thirty Cents
(EUR 8,958,151.30) down to eight million nine hundred thirty thousand nine hundred seventy three Euro and seventeen
Cents  (EUR  8,930,973.17)  by  cancellation  of  two  million  seven  hundred  seventeen  thousand  eight  hundred  thirteen
(2,717,813) self-held ordinary shares of class K of the Company of one Cent (EUR 0.01) of nominal value each;

6. Amendment of article 6 of the Company's articles of association;
7. Granting of authorization to any one manager of the general partner of the Company, to carry out any action

necessary or incidental in relation to the record of the above decreases and increase of capital of the Company in the
shareholders' register of the Company,

8. Miscellanous.
The extraordinary general meeting of the Company moved the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of the Company resolved to acknowledge that, on or around the date hereof, the

Company redeemed ninety million eight hundred three thousand seven hundred forty four (90,803,744) Class L ordinary
shares at the Fair Market Value ("FMV"). The extraordinary general meeting now resolved to decrease (i) the share capital
of the Company by an amount of nine hundred eight thousand thirty seven Euro and forty four Cents (EUR 908,037.44)
so as to bring it from its current amount of eleven million one hundred twenty three thousand three hundred forty five
Euro and two Cents (EUR 11,123,345.02) down to ten million two hundred fifteen thousand three hundred seven Euro
and fifty eight Cents (EUR 10,215,307.58) by cancellation of ninety million eight hundred three thousand seven hundred
forty four (90,803,744) self-held Class L ordinary shares of the Company of one Cent (EUR 0.01) of nominal value each,
and (ii) a corresponding portion of the legal reserve amounting to ninety thousand eight hundred three Euro seventy four
Cents (EUR 90,803.74).

In compliance with article 49-8, paragraph 5) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended,

any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be available for distribution to the shareholders of the Company.

The extraordinary general meeting of the Company also resolved that (i) the difference between the book value of

the redeemed shares (ie nominal value increased by the legal reserve) and the redemption price, ie one million two
hundred twenty four thousand six hundred thirty six Euro and eighty two Cents (EUR 1,224,636.82) will be paid out of
the distributable reserves of the Company and (ii) the corresponding redemption price of two million two hundred twenty
three thousand four hundred seventy eight Euro (EUR 2,223,478) will be credited to the shareholders' payables (the
"Shareholders' Payables")

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of the Company resolved to acknowledge that, on or around the date hereof, the

Company  redeemed  one  hundred  twenty  nine  million  seven  hundred  eighty  one  thousand  seven  hundred  seventy

122522

L

U X E M B O U R G

(129,781,770) Class H ordinary shares at the FMV. The extraordinary general meeting now resolved to decrease (i) the
share capital of the Company by an amount one million two hundred ninety seven thousand eight hundred seventeen
Euro and seventy Cents (EUR 1,297,817.70) so as to bring it from its current amount of ten million two hundred fifteen
thousand three hundred seven Euro and fifty eight Cents (EUR 10,215,307.58) down to eight million nine hundred se-
venteen thousand four hundred eighty nine Euro and eighty eight Cents (EUR 8,917,489.88) by cancellation of one hundred
twenty nine million seven hundred eighty one thousand seven hundred seventy (129,781,770) self-held Class H ordinary
shares of the Company of one Cent (EUR 0.01) of nominal value each, and (ii) a corresponding portion of the legal reserve
amounting to one hundred twenty nine thousand seven hundred eighty one Euro and seventy six Cents (EUR 129,781.76).

In compliance with article 49-8, paragraph 5) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended,

any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be available for distribution to the shareholders of the Company.

The extraordinary general meeting of the Company also resolved that (i) the difference between the book value of

the redeemed shares and the redemption price, ie four hundred ninety six thousand six hundred sixty seven Euro and
fifty four Cents (EUR 496,667.54) will be paid out of the distributable reserves of the Company and (ii) the corresponding
redemption price of one million nine hundred twenty four thousand two hundred sixty seven Euro (EUR 1,924,267) will
be credited to the Shareholders' Payables.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of the Company resolved to approve the payment to the shareholders on a prorata

of their shareholding of a redemption price adjustment related to Comhem investment in the amount of twenty eight
thousand one hundred seventy six Euro (EUR 28,176) out of the Company's distributable reserves.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of the Company resolved to increase the share capital of the Company by an

amount of forty thousand six hundred sixty one Euro and forty two Cents (EUR 40,661.42) so as to bring it from its
current amount of eight million nine hundred seventeen thousand four hundred eighty nine Euro and eighty eight Cents
(EUR 8,917,489.88) up to eight million nine hundred fifty eight thousand one hundred fifty one Euro and thirty Cents
(EUR 8,958,151.30) by creation of four million sixty six thousand one hundred forty two (4,066,142) ordinary shares of
Class K of the Company of one Cent (EUR 0.01) of nominal value each for a subscription price of five hundred fifty five
thousand nine hundred sixty seven Euro and seventy five Cents (EUR 555,967.75) including a share premium in the amount
of five hundred fifteen thousand three hundred six Euro and thirty three Cents (EUR 515,306.33) to be further allocated
as (i) legal reserve for four thousand sixty six Euro and fourteen Cents (EUR 4,066.14) and (ii) other distributable reserves
account of the Company for five hundred eleven thousand two hundred fourty Euro and nineteen Cents (EUR 511,240.19).

The extraordinary general meeting declared that the total subscription price of five hundred fifty five thousand nine

hundred sixty seven Euro and seventy five Cents (EUR 555,967.75) is owned by the Company's shareholders as follows:

Shareholders

Number K

of shares

subscribed

Corresponding

nominal value

(in EUR)

Corresponding

legal reserve

(in EUR)

Allocation

to other

distributable

reserves

account

(in EUR)

-

Subscription

price to be

paid out of

Shareholders'

Payables

(in EUR)

Altamar Buyout Global II, FCR . . . . .

218,596

2,185.96

218.60

27,484.27 -

-29,888.83

Altamar Buyout Global III, FCR . . . .

171,754

1,717.54

171.75

21,594.79 -

-23,484.08

Altamar Secondary opportunities IV,
FCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

693,955

6,939.55

693.96

87,251.66 -

-94,885.17

Edmond de Rothschild SA . . . . . . . .

1,084,305

10,843.05

1,084.31

136,330.72 -

-148,258.08

Greenpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

813,228

8,132.28

813.23

102,248.04 -

-111,193.55

Assurances du Crédit Mutuel
Vie SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

813,228

8,132.28

813.22

102,248.04 -

-111,193.54

Assurances du Crédit Mutuel
IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271,076

2,710.76

271.07

34,082.67 -

-37,064.50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,066,142

40,661,42

4,066,14

511,240,19 =

-555,967,75

<i>Subscriptions - Payments

Thereupon intervened each limited shareholder of the Company, all represented by Fatima Lahmer by virtue of seven

(7) powers of attorney given September 2013 which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members
of the bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities. The said proxyholder has declared, with respect to each of its principal:

122523

L

U X E M B O U R G

1. Assurances du Credit Mutuel IARD confirmed its subscription for 271,076 new class K ordinary shares set forth in

the previous resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal value, allocation to the legal
reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total amount of EUR 37,064.50;

2. Assurance du Credit Mutuel VIE SA confirmed its subscription for 813,228 new class K ordinary shares set forth in

the previous resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal value, allocation to the legal
reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total amount of EUR 111,193.54;

3. Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun confirmed its subscription for 218,596 new class K ordinary

shares set forth in the previous resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal value, allocation
to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total amount of EUR
29,888.83;

4. Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun confirmed its subscription for 171,754 new class K ordinary

shares set forth in the previous resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal value, allocation
to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total amount of EUR
23,484.08;

5. Altamar Secondary Opportunities IV, FCR, de Regimen Simplificado confirmed its subscription for 693,955 new

class K ordinary shares set forth in the previous resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal
value, allocation to the legal reserve, and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total
amount of EUR 94,885.17

6. Edmond de Rothschild S.A confirmed its subscription for 1,084,305 new class K ordinary shares set forth in the

previous resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal value, allocation to the legal reserve,
and as the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total amount of EUR 148,258.08;

7. Green Park Azur S.à r.l. confirmed its subscription for 813,228 new class K ordinary shares set forth in the previous

resolution and its payment by contribution in kind for payment in nominal value, allocation to the legal reserve, and as
the case may be, allocation to other distributable reserves, for the total amount of EUR 111,193.55;

Evidence of the value and existence of the above-mentioned receivables was given to the notary by providing an original

copy of the report of Audit Conseil Services S.à r.l., independent auditor (réviseur d'entreprises) on the contribution in
kind, and which conclusion is the following:

"Based on the work performed and described above, we have no observations to mention on the value of the con-

tribution which corresponds at least in number and in value to the new shares to be issued as described above"

The said report, after having been signed "ne varietur" by the proxy and the undersigned notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of the Company resolved to acknowledge that, on or around the date hereof, the

Company redeemed two million seven hundred seventeen thousand eight hundred thirteen (2,717,813) Class K ordinary
shares at the FMV. The extraordinary general meeting now resolved to decrease (i) the share capital of the Company by
an amount of twenty seven thousand one hundred seventy eight Euro and thirteen Cents (EUR 27,178.13) so as to bring
it from its current amount of eight million nine hundred fifty eight thousand one hundred fifty one Euros and thirty Cents
(EUR 8,958,151.30) down to eight million nine hundred thirty thousand nine hundred seventy three Euro and seventeen
Cents  (EUR  8,930,973.17)  by  cancellation  of  two  million  seven  hundred  seventeen  thousand  eight  hundred  thirteen
(2,717,813) self-held Class K ordinary shares of the Company of one Cent (EUR 0.01) of nominal value each, and (ii) a
corresponding portion of the legal reserve amounting to two thousand seven hundred seventeen Euro eighty one Cents
(EUR 2,717.81).

In compliance with article 49-8, paragraph 5) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended,

any amount allocated to the special reserve by virtue of the former self-holding of the shares hereby cancelled shall now
be available for distribution to the shareholders of the Company.

The extraordinary general meeting of the Company also resolved that (i) the difference between the book value of

the redeemed shares and the redemption price, ie one hundred thirty two thousand four hundred ninety eight Euro forty
two Cents (EUR 132,498.42) will be paid out of the distributable reserves of the Company and (ii) the corresponding
redemption price of one hundred sixty two thousand three hundred ninety four Euro thirty six Cents (EUR 162,394.36)
will be credited to the Shareholders' Payables.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the extraordinary general meeting of the Company resolved to amend

the first two paragraphs of article 6 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth be read as
follows:

Art. 6. The Company has a subscribed capital of eight million nine hundred thirty thousand nine hundred seventy

three Euros and seventeen Cents (8,930,973.17) consisting in one (1) management share, one hundred thirty six million
two hundred eight thousand four hundred twenty three (136,208,423) Class K ordinary shares, one hundred twenty six

122524

L

U X E M B O U R G

million one hundred seventy one thousand three hundred forty six (126,171,346) Class L ordinary shares, thirty seven
thousand five hundred (37,500) Class N ordinary shares, two hundred eight million two hundred fourteen thousand one
hundred seventy-two (208,214,172) Class O ordinary shares, seventy four million nine hundred and eleven thousand nine
hundred and seventy nine (74,911,979) Class P ordinary shares, one hundred and seventy four million eight hundred
thousand seven hundred and sixty (174,800,760) Class R ordinary shares, one hundred seventy-two million seven hundred
fifty-three thousand one hundred thirty-six (172,753,136) Class S ordinary shares, all in registered form with a nominal
value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

The Class K, Class L, Class N, Class O, Class P, Class R and Class S ordinary shares together with the ordinary shares

of other classes which may be issued in the future shall be referred to as the «Ordinary Shares». The Ordinary Shares
and the Management Share are hereafter together referred to as a «Share» or the «Shares»."

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting of the Company resolved to grant authorization to any one manager of the general

partner of the Company, to carry out any action necessary or incidental in relation to the above resolutions, including,
without limitation thereto, to record the above decreases and increase of capital of the Company in the shareholders'
register of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at seven thousand euros.

<i>Power

The above appearing party(ies) hereby give(s) power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed with the registration, listing, deletion, publication or any other useful or necessary operations
following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo to this deed.

There being no further business, the meeting is adjourned.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the members of the bureau and to the proxy of the appearing persons, known to

the notary by their name, first name, civil status and residence, said persons signed together with the notary the present
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de The Carlyle Group (Luxembourg) JV, une société en commandite
par actions, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée par acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Société et Associations en date du 10 octobre 2003 sous le numéro 1054, et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois en vertu d'un acte de Maître Francis Kesseler, pris en date du 8 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations en date du 3 juillet 2012 sous le numéro 1665.

L'assemblée est présidée par Madame Fatima Lahmer, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg (le «Président»).

Le président nomma en qualité de secrétaire Madame Eva Prekub, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nouria Mokhnache, ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée des actionnaires établit ensuite la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur

par les détenteurs de procurations représentant les associés, restera attachée au présent procès-verbal avec lesdites
procurations.

Le Président déclara que:
I. Les actionnaires représentant la totalité du capital social sont présents ou valablement représentés à l'assemblée des

actionnaires. L'assemblée des actionnaires pourra donc valablement délibérer et voter concernant tous les points de
l'ordre du jour.

II. L'ordre du jour est le suivant:

122525

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Reconnaissance d'un rachat d'actions, et approbation d'une réduction du capital social de la Société pour un montant

de neuf cent huit mille trente-sept Euros et quarante-quatre Cents (EUR 908.037,44) pour l'amener de son montant
actuel de onze million cent vingt-trois mille trois cent quarante-cinq Euros et deux Cents (EUR 11.123.345,02) à dix
million deux cent quinze mille trois cent sept Euros et cinquante-huit Cents (EUR 10.215.307,58) par annulation de quatre-
vingt-dix million huit cent trois mille sept cent quarante-quatre (90.803.744) actions ordinaires de Classe L autodétenues
de la Société d'un Cent (EUR 0,01) de valeur nominale chacune;

2. Reconnaissance d'un rachat d'actions, et approbation d'une réduction du capital social de la Société pour un montant

de un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent dix-sept Euros et soixante-dix Cents (EUR 1.297.817,70)
pour l'amener de son montant actuel de dix million deux cent quinze mille trois cent sept Euros et cinquante-huit Cents
(EUR 10.215.307,58) à huit millions neuf cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf Euros et quatre-vingt-huit Cents
(EUR  8.917.489,88)  par  annulation  de  cent  vingt-neuf  millions  sept  cent  quatre-vingt-un  mille  sept  cent  soixante-dix
(129.781.770) actions ordinaires de Classe H autodétenues de la Société d'un Cent (EUR 0,01) de valeur nominale cha-
cune;

3. Approbation du paiement aux actionnaires d'un ajustement du prix de rachat relatif au rachat d'actions ordinaires

de Classe I d'un montant de vingt-huit mille cent soixante-seize Euros (EUR 28.176) des réserves distribuables de la
Société;

4. Approbation d'une augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante mille six cent soixante et

un Euros et quarante-deux Cents (EUR 40.661,42) pour l'amener de son montant actuel de huit millions neuf cent dix-
sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf Euros et quatre-vingt-huit Cents (EUR 8.917.489,88) à huit millions neuf cent
cinquante-huit mille cent cinquante et un Euros et trente Cents (EUR 8.958.151,30) par création de quatre millions
soixante-six mille cent quarante-deux (4.066.142) actions ordinaires de classe K de la Société d'un Cent (EUR 0,01) de
valeur nominale chacune;

5. Reconnaissance d'un rachat d'actions, et approbation d'une réduction du capital social de la Société pour un montant

de vingt-sept mille cent soixante-dix-huit Euros et treize Cents (EUR 27.178,13) pour l'amener de son montant actuel
de huit millions neuf cent cinquante-huit mille cent cinquante et un Euros et trente Cents (EUR 8.958.151,30) à huit
millions neuf cent trente mille neuf cent soixante-treize Euros et dix-sept Cents (EUR 8.930.973,17) par annulation de
deux millions sept cent dix-sept mille huit cent treize (2.717.813) actions ordinaires de Classe K autodétenues de la
Société d'un Cent (EUR 0,01) de valeur nominale chacune;

6. Modification de l'article 6 des statuts de la Société;
7. Autorisation à accorder à tout gérant du gérant commandité de la Société afin d'exécuter toute action nécessaire

ou incidente liée à l'enregistrement des réductions et augmentation de capital de la Société mentionnées ci-dessus dans
le registre des actionnaires de la Société;

8. Divers.
L'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé de reconnaitre que, peu avant ou à la date des présentes,

la Société a racheté quatre-vingt-dix millions huit cent trois mille sept cent quarante-quatre (90.803.744) actions ordinaires
de Classe L à Valeur de Marché («VM»).

L'assemblée générale extraordinaire a décidé maintenant de procéder à une réduction (i) du capital social de la Société

pour un montant de neuf cent huit mille trente-sept Euros et quarante-quatre Cents (EUR 908.037,44) pour l'amener de
son  montant  actuel  de  onze  million  cent  vingt-trois  mille  trois  cent  quarante-cinq  Euros  et  deux  Cents  (EUR
11.123.345,02) à dix millions deux cent quinze mille trois cent sept Euros et cinquante-huit Cents (EUR 10.215.307,58)
par annulation de quatre-vingt-dix millions huit cent trois mille sept cent quarante-quatre (90.803.744) actions ordinaires
de Classe L autodétenues de la Société d'un centime (EUR 0,01) de valeur nominale chacune et (ii) une portion corres-
pondante de la réserve légale s'élevant à quatre-vingt-dix mille huit cent trois Euros et soixante-quatorze Cents (EUR
90.803,74).

En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,

tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a également décidé que (i) la différence entre la valeur comptable

des actions annulées (la valeur nominale augmentée par la réserve légale) et le prix de rachat de un million deux cent
vingt-quatre mille six cent trente-six Euros et quatre-vingt-deux Cents (EUR 1.224.636,82) sera payée des autres réserves
distribuables de la Société et (ii) le prix de rachat correspondant à deux millions deux cent vingt-trois mille quatre cent
soixante-dix-huit Euros (EUR 2.223.478) sera crédité à la dette des actionnaires (la «Dette des Actionnaires»).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé de reconnaitre que, peu avant ou à la date des présentes,

la Société a racheté cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-dix (129.781.770) actions

122526

L

U X E M B O U R G

ordinaires de Classe H à la VM. L'assemblée générale extraordinaire a décidé maintenant de procéder à une réduction
(i) du capital social de la Société pour un montant de un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent dix-sept
Euros et soixante-dix Cents (EUR 1.297.817,70) pour l'amener de son montant actuel de dix millions deux cent quinze
mille trois cent sept Euros et cinquante-huit Cents (EUR 10.215.307,58) à huit millions neuf cent dix-sept mille quatre
cent quatre-vingt-neuf Euros et quatre¬vingt-huit Cents (EUR 8.917.489,88) par annulation de cent vingt-neuf millions
sept cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-dix (129.781.770) actions ordinaires de Classe H autodétenues de la
Société d'un centime (EUR 0,01) de valeur nominale chacune et (ii) une portion correspondante de la réserve légale
s'élevant à cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-un Euros et soixante-seize Cents (EUR 129.781,76).

En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,

tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a également décidé que (i) la différence entre la valeur comptable

des actions annulées et le prix de rachat, quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-sept Euros et cinquante-
quatre  Cents  (EUR  496.667,54)  sera  payée  des  autres  réserves  distribuables  de  la  Société  et  (ii)  le  prix  de  rachat
correspondant à un million neuf cent vingt-quatre mille deux cent soixante-sept Euros (EUR 1.924.267) sera crédité à la
Dette des Actionnaires.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé d'approuver le paiement aux actionnaires, au prorata de

leur détention, d'un ajustement du prix de rachat relatif à l'investissement Comhem d'un montant de vingt-huit mille cent
soixante-seize Euros (EUR 28.176), des réserves distribuables.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de

quarante mille six cent soixante et un Euros et quarante-deux Cents (EUR 40.661,42) pour l'amener de son montant
actuel  de  huit  millions  neuf  cent  dix-sept  mille  quatre  cent  quatre-vingt-neuf  Euros  et  quatre-vingt-huit  Cents  (EUR
8.917.489,88) à huit millions neuf cent cinquante-huit mille cent cinquante et un Euros et trente Cents (EUR 8.958.151,30)
par création de quatre millions soixante-six mille cent quarante-deux (4.066.142) actions ordinaires de classe K de la
Société d'un Cent (EUR 0,01) de valeur nominale chacune pour un prix de souscription de cinq cent cinquante-cinq mille
neuf cent soixante-sept Euros et soixante-quinze Cents (EUR 555.967,75) incluant une prime d'émission d'un montant
de cinq cent quinze mille trois cent six Euros et trente-trois Cents (EUR 515.306,33) à allouer ensuite à (i) la réserve
légale pour un montant de quatre mille soixante-six Euros et quatorze Cents (EUR 4.066,14) et (ii) au compte d'autres
réserves  distribuables  de  la  Société  pour  cinq  cent  onze  mille  deux  cent  quarante  Euros  et  dix-neuf  Cents  (EUR
511.240,19);

L'assemblée générale extraordinaire a déclaré que le prix total de souscription de cinq cent cinquante-cinq mille neuf

cent soixante-sept Euros et soixante-quinze Cents (EUR 555.967,75) est due par les actionnaires de la Société comme
suit:

Actionnaire

Nombre

d'action K

souscrite

Valeur nominale

correspondante

(en EUR)

Réserve légale

correspondante

(en EUR)

Allocation

aux autres

réserves

distribuables

(en EUR)

Prix de

souscription

à payer des

Dette des

Actionnaires

(en EUR)

Altamar Buyout Global II, FCR, de
Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . .

218.596

2.185,96

218,60

27.484,27

-29,888.83

Altamar Buyout Global III, FCR, de
Regimen Comun . . . . . . . . . . . . . . .

171.754

1.717,54

171,75

21.594,79

-23,484.08

Altamar Secondary Opportunities
IV, FCR, de Regimen
Simplificado . . . . . . . . . . . . . . . . . .

693.955

6.939,55

693,96

87.251,66

-94,885.17

Edmond de Rothschild . . . . . . . . . . 1.084.305

10.843,05

1.084,31

136.330,72

-148,258.08

Greenpark Azur Sàrl . . . . . . . . . . .

813.228

8.132,28

813,23

102.248,04

-111,193.55

Assurance du Credit Mutuel
VIE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

813.228

8.132,28

813,22

102.248,04

-111,193.54

Assurances du Credit Mutuel
IARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

271.076

2.710,76

271,07

34.082,67

-37,064.50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,066,142

40,661,42

4,066,14

511,240,19

-555,967,75

122527

L

U X E M B O U R G

<i>Souscriptions - Libérations

Est alors intervenu chaque actionnaire commanditaire de la Société, tous représentés par Fatima Lahmer en vertu de

sept (7) procurations données en septembre 2013 et qui, signées ne varietur par le mandataire, les membres du bureau
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

Ledit mandataire a déclaré ce qui suit, relativement à chacun de ses mandants:
1. Assurances du Credit Mutuel IARD, a confirmé sa souscription à 271.076 nouvelles actions ordinaires de classe K

énoncé dans les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un paiement en valeur nominale,
allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de 37.064,50;

2. Assurance du Credit Mutuel VIE SA, a confirmé sa souscription à 813.228 nouvelles actions ordinaires de classe K

énoncé dans les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un paiement en valeur nominale,
allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de EUR
111.193,54;

3. Altamar Buyout Global II, FCR, de Regimen Comun, a confirmé sa souscription à 218.596 nouvelles actions ordinaires

de classe K énoncé dans les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un paiement en valeur
nominale, allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total
de EUR 29.888,83;

4. Altamar Buyout Global III, FCR, de Regimen Comun, a confirmé sa souscription à 171.754 nouvelles actions ordi-

naires de classe K énoncé dans les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un paiement en
valeur nominale, allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant
total de EUR 23.484,08;

5. Altamar Secondary Opportunities IV, FCR, de Regimen Simplificado, a confirmé sa souscription à 693.955 nouvelles

actions ordinaires de classe K énoncé dans les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un
paiement en valeur nominale, allocation à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables,
au montant total de EUR 94.885,17;

6. Edmond de Rothschild S.A., a confirmé sa souscription à 1.084.305 nouvelles actions ordinaires de classe K énoncé

dans les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un paiement en valeur nominale, allocation
à la réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de EUR 148.258,08;

7. Green Park Azur S.à r.l, a confirmé sa souscription à 813.228 nouvelles actions ordinaires de classe K énoncé dans

les résolutions précédentes, et sa libération par apport en nature pour un paiement en valeur nominale, allocation à la
réserve légale, et le cas échéant, allocation aux autres réserves distribuables, au montant total de EUR 111.193,55;

La preuve de la valeur et de l'existence de la créance susmentionnée a été donnée au notaire par la remise d'un original

du rapport de Audit Conseil Services S.à r.l., réviseur d'entreprises sur l'apport en nature, dont la conclusion est la
suivante:

"Basé sur ce qui a été développé et décrit ci-dessus, nous n'avons aucune observation à faire concernant la valeur de

la contribution qui correspond au moins en son nombre et en sa valeur aux nouvelles actions émises comme décrit ci-
dessus"

Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur' par le mandataire et le notaire instrumentant, sera joint au présent

acte afin d'être enregistré avec ce dernier.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé de reconnaitre que, peu avant ou à la date des présentes,

la Société a racheté deux millions sept cent dix-sept mille huit cent treize (2.717.813) actions ordinaires de Classe K à
VM. L'assemblée générale extraordinaire a décidé maintenant de procéder à une réduction (i) du capital social de la
Société pour un montant de vingt-sept mille cent soixante-dix-huit Euros et treize Cents (EUR 27.178,13) pour l'amener
de son montant actuel de huit millions neuf cent cinquante-huit mille cent cinquante et un Euros et trente Cents (EUR
8.958.151,30) à huit millions neuf cent trente mille neuf cent soixante-treize Euros et dix-sept Cents (EUR 8.930.973,17)
par annulation de deux millions sept cent dix-sept mille huit cent treize (2.717.813) actions ordinaires de Classe K au-
todétenues de la Société d'un centime (EUR 0,01) de valeur nominale chacune et de réduire une portion correspondante
de la réserve légale s'élevant à deux millions sept cent dix-sept mille Euros et quatre-vingt-un Cents (EUR 2.717,81).

En application de l'article 49-8, alinéa 5), de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée,

tout montant alloué à la réserve spéciale constituée en raison de l'autodétention des actions susmentionnées et mainte-
nant annulées en vertu des présentes devient distribuable aux actionnaires de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a également décidé que (i) la différence entre la valeur comptable

des actions annulées et le prix de rachat,cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit Euros et quarante-deux
Cents (EUR 132.498,42) sera payée des autres réserves distribuables de la Société et (ii) le prix de rachat correspondant
à cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et trente-six Cents (EUR 162.394,36) sera crédité à la
Dette des Actionnaires.

122528

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé de modifier les deux

premiers paragraphes de l'article 6 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 6. La Société a un capital souscrit de huit millions neuf cent trente mille neuf cent soixante-treize Euros et dix-

sept Cents (EUR 8.930.973,17) représenté par une ( 1) action de commandité, cent trente-six millions deux cent huit
mille quatre cent vingt-trois (136.208.423) actions ordinaires de Classe K, cent vingt-six millions cent soixante et onze
mille trois cent quarante-six (126.171.346) actions ordinaires de Classe L, trente-sept mille cinq cent (37.500) actions
ordinaires de Classe N, deux cent huit millions deux cent quatorze mille cent soixante-douze (208.214.172) actions
ordinaires de Classe O, soixante-quatorze millions neuf cent onze mille neuf cent soixante-dix-neuf (74.911.979) actions
ordinaires de Classe P, cent soixante-quatorze millions huit cent mille quatre cent soixante (174,800,460) actions ordi-
naires de Classe R, cent soixante-douze millions sept cent cinquante-trois mille cent trente-six (172.753.136) actions
ordinaires de Classe S, toutes nominatives et d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Les actions ordinaires de Classe K, de Classe L, de Classe N, de Classe O, de Classe P, de Classe R et de Classe S,

ensemble avec les actions ordinaires d'autres classes qui pourront être émises dans le futur seront dénommées ci-après
les «Actions Ordinaires». Les Actions Ordinaires ensemble avec l'Action Commanditée sont dénommées ci-après l «Ac-
tion» ou les «Actions».

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé l'autorisation à accorder à tout gérant du gérant commandité

de la Société afin d'exécuter toute action nécessaire ou incidente liée aux résolutions ci-dessus, incluant mais sans limi-
tation, l'enregistrement des réductions et augmentation de capital de la Société mentionnées ci-dessus dans le registre
des actionnaires de la Société.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de sept mille euros.

<i>Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné,

agissant individuellement, afin de procéder à l'enregistrement, l'immatriculation, la radiation, la publication ou toutes
autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger,
ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date du jour mentionné au début du document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du

notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdites personnes ont signé avec le notaire le
présent acte aucun actionnaire n'exprimant le souhait de signer.

Signé: Lahmer, Prekub, Mokhnache, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 07 octobre 2013. Relation: RED/2013/1637. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 10 octobre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013142487/464.
(130173673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

FT EuroCorporates, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 9. Oktober 2013 gültige geänderte Verwaltungsreglement 10/2013 des Investmentfonds „FT

EuroCorporates“ wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

122529

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 09.10.2013.

Anell / Tiburzi
<i>Directeur / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2013141241/11.
(130172840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

IFM-Invest: 2 PrivateEquity, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de IFM-Invest: 2 PravateEquity modifié au 29.10.2013 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2013141690/11.
(130172857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2013.

SeaNet Maritime Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 180.071.

En date du 11 octobre 2013, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. d'accepter la démission avec effet immédiat du gérant Monsieur Peter Kleingarn;
2. de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Harald Strelen, demeurant à L-6914

Roodt-sur-Syre, 2, rue d'Olingen en tant que gérant.

Référence de publication: 2013143052/11.
(130174340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

AmBev Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: BRL 1.581.683.772,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 174.452.

Quilmes International Beverages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 113.855.370,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 178.656.

In the year two thousand and thirteen, on the first day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) The board of managers of AmBev Luxembourg, a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg
with a share capital amounting to BRL 1,581,683,772 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 174.452, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx,
enacted on December 17, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 7 March 2013
under number 567, and which articles of association have never been amended until the present deed ("AmBev" or the
"Absorbing Company"),

here represented by Mr. Regis Galiotto, residing professionally at 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

2) The board of managers of Quilmes International Beverages S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy
of Luxembourg with a share capital amounting to USD 113,855,370 and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 178.656, ("QIB" or the "Absorbed Com-
pany"),

122530

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr. Regis Galiotto, residing professionally at 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration;

Copies of the minutes of the meeting of the board of managers of the Absorbing Company and the Absorbed Company

shall remain attached to the present deed (the "Resolutions").

The appearing parties, represented as above stated, set up the following common merger plan and require the un-

dersigned notary to record the following:

COMMON MERGER PLAN (PROJET COMMUN DE FUSION)

1. Parties to the Merger.
1.1 The absorbing company AmBev Luxembourg, a Luxembourg private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg
with a share capital amounting to BRL 1,581,683,772 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 174.452 ("AmBev", hereinafter also referred to as the "Ab-
sorbing Company"); and

1.2 The absorbed company Quilmes International Beverages S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy
of Luxembourg with a share capital amounting to USD 113,855,370 and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 178.656 ("QIB", hereinafter also referred
to as the "Absorbed Company");

The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereinafter collectively referred to as the "Merging Parties"

or the "Companies".

AmBev is the sole shareholder of QIB.
For sound economic and commercial reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating

costs of the Merging Parties, the respective boards of managers of the Absorbing Company and the Absorbed Company
proposed to proceed to a merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company (the "Merger").

Considering that the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the share capital of the Absorbed

Company, the Merging Companies have decided to perform the Merger pursuant to the simplified merger procedure set
forth by Articles 278 et seq. of the Luxembourg Law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended from
time to time (the "Law").

2. Merger.
2.1 The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company with accounting effect on August 1st,

2013 (the "Effective Date"); as of the Effective Date, all operations and transactions of the Absorbed Company will be
considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

2.2 As a result of the Merger, the Absorbed Company will be dissolved without liquidation, its shares will be cancelled

and all of its assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.

2.3 The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company.
2.4 For purposes of the present Merger and on the basis of the net book value of QIB in the books of AmBev, as per

the interim financial statements as of July 31, 2013, the Merging Parties agree that the value of QIB that will be taken over
by AmBev will be BRL 6,837,421,927, including the associated goodwill.

3. Reports. Pursuant to article 278 of the Law, the common merger plan will not be subject to an (i) examination and

of a written report to the shareholder carried out by a qualified auditor and (ii) a detailed written report of the board of
managers of the Merging Parties.

4. Date of Merger Completion. The Merging Parties acknowledge and agree that as from the Effective Date, the

Absorbing Company will be, from an accounting standpoint, the sole and full owner of and may dispose over them assets
of the Absorbed Company and will assume all of its liabilities pay off its creditors and execute all ongoing agreements of
the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to
the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.

5. Special Rights and Advantages.
5.1 The Absorbing Company does not grant special rights to its shareholder or holders of securities.
5.2 No special advantage is granted to the managers of the board of managers or to the statutory or qualified auditor

of the Merging Parties.

6. Information of the Shareholder of AmBev (Article 267 of the Law). The shareholders of AmBev will have, during

the month following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the Common Merger Plan,
access at its registered office of to all documents listed in Article 267 (1) excluding Article 267 (1) d) and e) of the Law,
i.e. (i) the Common Merger Plan, (ii) the annual accounts of AmBev for the period from December 17, 2012 to December

122531

L

U X E M B O U R G

31, 2012 being the only accounts available since the incorporation of AmBev on December 17, 2012, and (iii) the interim
financial statements of AmBev as of July 31, 2013 and may obtain copies thereof, free of charge.

7. Bookkeeping of the Absorbed Company. The books and records of the Absorbed Company (including related

archives, originals of all deeds, agreements, accounting documents and titles of ownership) will be kept at the registered
office of the Absorbing Company for a period of five years starting on the Effective Date.

8. Effectiveness and Consequences of the Merger. The Merger will simultaneously carry the legal effects set out in

Article 274 of the Law being:

- the universal transfer, both as between the Absorbing Company as well as the Absorbed Company and vis-à-vis third

parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;

- the Absorbed Company shall cease to exist;
- the cancellation of shares or corporate units of the Absorbed Company held by the Absorbing Company or the

Absorbed Company, as appropriate;

- the end of the mandates of the managers of QIB. Discharge will be granted to them.

9. Formalities. The Absorbing Company shall:
- carry out all the legal formalities, including such announcements as prescribed by law relating to the transfers made

in the framework of the Merger;

- perform the formalities and notifications necessary with all relevant administrative matters in order to put all assets

and commitments of the Absorbed Company in its name and on its behalf;

- carry out any formality required by law or deemed necessary or useful to render the transfer of goods and rights

enforceable towards third parties.

10. Fees and Duties. Any charge, duties or fees owed as a result of the Merger shall be borne by the Absorbing

Company.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Common Merger Plan and of all acts, docu-

ments and formalities incumbent on the Merging Parties pursuant to the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the proxy holder,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy holder and in
case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned in the beginning of this

document.

The document having been read to the proxy holder, the said proxy holder signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le premier octobre.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Le conseil de gérance de la société AmBev Luxembourg, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant

son siège social au 5, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de
BRL 1.581.683.772, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
174.452, constituée par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, le 17 Décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N°567 du 7 mars 2013, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (ci-
après dénommée «AmBev» ou la «Société Absorbante»),

Ici représenté par Mr. Regis Galiotto, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration. Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le
mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.

2) Le conseil de gérance de la société Quilmes International Beverages S.à r.l., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise, ayant son siège social au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
avec un capital social de USD 113.855.370, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 178.656 (ci-après dénommée "QIB" ou la "Société Absorbée"),

Ici représenté par Mr. Regis Galiotto, ayant son adresse professionnelle au 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration. Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le
mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement;

Les copies des résolutions adoptées par les conseils de gérance respectifs de la Société Absorbante et de la Société

Absorbée resteront annexées au présent acte (ci-après les «Résolutions»).

122532

L

U X E M B O U R G

Les comparants, représentés tel que décrit ci-dessus, ont arrêté le projet commun de fusion suivant et requièrent le

notaire instrumentant d'acter que:

PROJET COMMUN DE FUSION

1. Les Parties à la Fusion.
1.1 La société absorbante AmBev Luxembourg, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège

social  au  5,  rue  Gabriel  Lippmann,  L-5365  Munsbach,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  avec  un  capital  social  de  BRL
1.581.683.772, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.452
("AmBev", ci-après dénomée la «Société Absorbante»); et

1.2 La société absorbée Quilmes International Beverages S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,

ayant son siège social au 5, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social
de USD 113.855.370, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
178.656, (ci-après dénommée "QIB" ou la "Société Absorbée");

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont dénommées ci-après comme étant les «Parties à la Fusion» ou les

«Sociétés».

AmBev est l'associé unique de QIB.
Pour des raisons économiques et commerciales, en vue de simplifier l'organigramme et de réduire les coûts d'exploi-

tation des Parties à la Fusion, les conseils de gérance respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont
proposé de procéder à une fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée (la «Fusion»).

Considérant que la Société Absorbante détient cent pour cent (100%) du capital social de la Société Absorbée, les

Parties à la Fusion ont décidé de procéder à la Fusion suivant la procédure de fusion simplifiée telle que définie aux Articles
278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

2. La Fusion.
2.1 La Société Absorbante telle que définie souhaite absorber la Société Absorbée avec effet comptable au 1 

er

 août

2013 (la «Date d'Effet»); à compter de la Date d'Effet, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée seront
considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

2.2 A l'issue de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation, ses parts sociales seront annulées et

l'ensemble de son actif et de son passif sera transféré à la Société Absorbante.

2.3 La Société Absorbante reprendra l'ensemble des contrats et obligations de toute nature de la Société Absorbée.
2.4 Aux fins de la présente Fusion et sur la base de la valeur nette comptable de QIB dans les livres d'AmBev, con-

formément aux états financiers au 31 juillet 2013, les Parties à la Fusion conviennent que la valeur de QIB qui sera reprise
par AmBev est de BRL 6.837.421.927, incluant le goodwill.

3. Rapports. Conformément à l'article 278 de la Loi, le Projet Commun de Fusion ne fera pas l'objet (i) d'un examen

et d'un rapport écrit à l'associé effectué par un réviseur d'entreprises agréé ni (ii) d'un rapport écrit détaillé des conseils
de gérance respectifs des Parties à la Fusion.

4. Date de Réalisation de la Fusion. Les Parties à la Fusion conviennent et acceptent qu'à compter de la Date d'Effet,

la Société Absorbante sera, d'un point de vue comptable, la seule et unique détentrice des actifs de la Société Absorbée,
pourra disposer de ces derniers et assumera l'ensemble des obligations à l'égard des créanciers et exécutera l'ensemble
des obligations à l'égard des cocontractants de la Société Absorbée. Les droits et les obligations compris dans actifs de
la Société Absorbée seront transmis à la Société Absorbante, y inclus toutes les garanties, qu'elles soient réelles ou
personnelles.

5. Droits Spéciaux et Avantages.
5.1 La Société Absorbante ne concède aucuns droits spéciaux à ses associés ou ses détenteurs de titres.
5.2 Aucun avantage spécial n'est consenti aux gérants des conseils de gérance, aux commissaires ou aux réviseurs

d'entreprises agréés des Parties à la Fusion.

6. Information des Associés d'AmBev (Article 267 de la Loi). Les associés d'Ambev pourront, au cours du mois suivant

la publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Projet Commun de Fusion, avoir accès au siège
social, à l'ensemble des documents définis dans l'Article 267 (1), sauf ceux de l'Article 267 (1) d) et e) de la Loi, i.e. (i) le
Projet Commun de Fusion, (ii) les comptes annuels d'AmBev pour la période du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2012,
seuls comptes disponibles depuis la constitution d'AmBev le 17 décembre 2012, et (iii) les états financiers intermédiaires
d'AmBev en date du 31 juillet 2013, et pourront obtenir les copies correspondantes, sans frais.

7. Documents de la Société Absorbée. Les livres et registres de la Société Absorbée (incluant les archives correspon-

dantes, les originaux de tous les actes, contrats, documents comptables et titres de propriété) seront conservés au siège
social de la Société Absorbante pour une période de cinq années à compter de la Date d'Effet.

8. Effet et conséquences de la Fusion. La Fusion aura comme effets juridiques sont définis à l'Article 274 de la Loi:

122533

L

U X E M B O U R G

- la transmission universelle de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, tant entre la

Société Absorbante et la Société Absorbée que vis-à-vis des tiers;

- la Société Absorbée cessera d'exister;
- l'annulation des actions ou parts de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante ou de la Société Ab-

sorbée, le cas échéant;

- la fin des mandats des gérants de QIB. Une décharge leur sera fournie.

9. Formalités. La Société Absorbante devra:
- procéder à l'ensemble des formalités légales, incluant les publications telles que prescrites par la loi relative à la

transmission réalisée dans le cadre de la Fusion;

- effectuer les formalités et les notifications nécessaires, y inclus l'ensemble des formalités administratives nécessaires

dans le but de mettre l'ensemble des actifs et des engagements de la Société Absorbée à son nom et pour son compte;

- effectuer toutes formalités requises par la loi ou considérées comme nécessaires ou utiles à la transmission des biens

et des droits opposables aux tiers.

10. Frais et Taxes. Tous frais, taxes, coûts et honoraires dû à l'issue de la Fusion, devront être supportés par la Société

Absorbante.

Le notaire instrumentant atteste de l'existence et de la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes,

documents et formalités incombant aux Parties à la Fusion, conformément à la Loi.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le

présent acte en langue anglaise suivi d'une

version française; à la demande des mêmes requérants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,

le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné au début du présent document.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant au comparant, celui-ci a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45018. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141723/226.
(130173193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

Sebino Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 137.311.

L'an deux mille treize, le neuf octobre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire, de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

la société SRE ONE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, place du Théâtre,

L-2613 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143056,

ici représentée par Madame Vania BARAVINI, dirigeante, demeurant à L-4062 Esch-sur-Alzette 89, rue Clair Chêne,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 8 octobre 2013.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associé unique de «SEBINO PROPERTIES S.à r.l.» (ci-après également «la Société»), une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 137311, constituée en date du 15
février 2008 suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 966, page 46336 du 18 avril 2008.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 décembre 2012 suivant acte reçu par Maître Cosita

DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C n. 280,
page 13398, le 5 février 2013.

L'associé unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

122534

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'EUR 835.000.- (huit cent trente-

cinq mille euros) en vue de le porter de son montant actuel d'EUR 70.000.- (soixante-dix mille euros) à un montant d'EUR
905.000.- (neuf cent cinq mille euros) par la création et l'émission de 90.500 (quatre-vingt-dix mille cinq cents) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale d'EUR 10.- (dix euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes, à souscrire au pair par l'associé unique de la Société, à savoir par la société SRE ONE S.A.
susmentionnée, au moyen de la conversion et de l'apport au capital social de la société jusqu'à concurrence du montant
d'EUR 835.000.- (huit cent trente-cinq mille euros) d'une créance certaine, liquide et exigible et non productive d'intérêts
détenue par cet associé unique à l'encontre de la Société.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue Madame Vania BARAVINI, pré-qualifiée, agissant en sa qualité de mandataire de la société SRE

ONE S.A., pré-qualifié, en vertu de la procuration susmentionnée datée du 8 octobre 2013,

lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 90.500 (quatre-vingt-dix mille cinq

cents)  parts  sociales  nouvelles  d'une  valeur  nominale  d'EUR  10.-  (dix  euros)  chacune  pour  un  montant  total  d'EUR
905.000.- (neuf cent cinq mille euros) moyennant la conversion et l'apport au capital de la Société jusqu'à concurrence
du montant d'EUR 905.000.- (neuf cent cinq mille euros), d'une créance certaine, liquide et exigible et non productive
d'intérêts détenue par cet associé à l'encontre de la Société, lequel apport est évalué à EUR 905.000.- (neuf cent cinq
mille euros).

La déclaration émanant du souscripteur concernant le caractère certain, liquide et exigible de la créance apportée à

la Société et la volonté du souscripteur de convertir et d'apporter ladite créance au capital social de la Société ainsi que
la déclaration émanant du gérant unique de la Société attestant que rien n'est venu à son attention qui lui laisse penser
que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins à l'augmentation de capital envisagée d'EUR 905.000.- (neuf cent
cinq mille euros) par la création et l'émission de 90.500 (quatre-vingt-dix mille cinq cents) parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale d'EUR 10.- (dix euros) chacune, ont été rapportées au notaire instrumentant et demeureront annexées
au présent acte pour en faire partie intégrante.

Suite à l'apport qui précède, la créance d'un montant nominal d'EUR 905.000.- (neuf cent cinq mille euros) est convertie

et incorporée au capital social de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant d'EUR 765.000.- (sept cent soixante-

cinq mille euros) afin de le ramener de son montant d'EUR 905.000.- (neuf cent cinq mille euros) à un montant d'EUR
140.000.- (cent quarante mille euros) moyennant annulation de 76.500 (soixante-seize mille cinq cents) parts sociales
d'une valeur nominale d'EUR 10.- (dix euro) chacune détenues par l'associé unique, la réduction se faisant comme suit:

- à hauteur d'un montant d'EUR 764.088,16 (sept cent soixante-quatre mille quatre-vingt-huit euros et seize cents),

par absorption des pertes reportées de la Société d'un montant total d'EUR 764.088,16 (sept cent soixante-quatre mille
quatre-vingt-huit euros et seize cents) telles qu'elles ressortent du bilan approuvé au 31.12.2012;

- à hauteur du montant d'EUR 911,84 (neuf cent onze euros et quatre-vingt-quatre cents) par affectation dudit montant

à une réserve libre de la Société.

La preuve de l'existence des pertes reportées telles que décrites ci-avant a été rapportée au notaire instrumentant au

moyen de la remise des comptes annuels approuvés de la Société concernant l'exercice clos le 31 décembre 2012, lesquels
comptes annuels demeureront annexés au présent acte pour en faire partie intégrante.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier comme suit l'article 5. des statuts de la Société pour l'adapter, d'une part, aux

décisions prises ci-avant et, d'autre part, pour lui donner la teneur suivante:

Ancienne version

« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 70.000.- (soixante-dix mille euros) représenté par 7.000 (sept mille) parts

sociales d'une valeur nominale d'EUR 10.- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Nouvelle version

« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 140.000.- (cent quarante mille euros) représenté par 14.000 (quatorze mille)

parts sociales d'une valeur nominale d'EUR 10.- (dix euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

est estimé approximativement à EUR .

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

122535

L

U X E M B O U R G

Le présent acte ayant été lu au mandataire de la comparante, cette dernière, connue du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. BARAVINI, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 11 octobre 2013. Relation: RED/2013/1681. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11 octobre 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013143072/87.
(130174450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Rovi Global Services S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.559.150,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.159.

In the year two thousand and thirteen on the thirtieth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Were taken the written resolutions of the sole shareholder of Rovi Global Services S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 42-44, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 1,559,150.- and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 157.159 (the Company). The Company has been incorporated
on 24 November 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  dated  13  January  2011,  N°  65.  The  articles  of  associations  of  the
Company were amended most recently pursuant to a deed received by Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 10 No-
vember 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3209 dated 29 December 2011.

THERE APPEARED:

EuroMedia Group, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,
registered with the Delaware Division of Corporations under number 2664176 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requested the undersigned notary to record:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder notes that the board of managers of the Company has presented to it the common draft terms

of the cross-border merger, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 2066 of August
26, 2013 in accordance with article 262 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law)
and providing for the absorption of Macrovision Licensing &amp; Holding B.V., a private limited liability company (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under Dutch law, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands
and its office address at Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, registered
with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34163574 (the Company Ceasing to Exist) by the
Company, whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all
the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company Ceasing to Exist to the Company (the
Merger Proposal).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law, except for the report

to be drawn up by the management body of the merging companies and the auditors' report with respect to the merger
pursuant to the waiver granted by the Sole shareholder, have been made available at the registered office of the Company
for due inspection by the shareholder(s) of the Company at least one month before the date hereof.

A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by an authorized representative of

the Company has been shown to the notary.

122536

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption

of the Company Ceasing to Exist by the Company, in accordance with the conditions detailed in the Merger Proposal
and in particular, in exchange for the contribution of all the assets and liabilities of the the Company Ceasing to Exist to
the Company, without any restriction or limitation.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder acknowledges that (i) from an accounting point of view, the operations of the Company Ceasing

to Exist shall be treated as having being carried out on behalf of the Company as from January 1, 2013, (ii) the merger
shall take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings or the written
resolutions of the shareholder(s) of the merging companies approving the merger (the Effective Date) and (b) vis-à-vis
third parties after the publication of the minutes of the general meetings or the written resolutions of shareholder(s)
prescribed by article 9 of the Law.

The Sole Shareholder further acknowledges, as from the Effective Date, (i) the dissolution without liquidation of the

Company Ceasing to Exist by way of transfer at book value of all its assets and liabilities to the Company in accordance
with the Merger Proposal and (ii) the cancelation of all the shares issued by the Company Ceasing to Exist.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any lawyer and employee of Loyens &amp; Loeff Luxembourg

S.à r.l., acting individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to
perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger and with
the above resolutions.

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the

present deed, in accordance with the terms of the merger, are estimated at approximately seven thousand Euros (7,000.-
EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed

is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the representative of the appearing party signed together

with the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente septembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont été prises les résolutions écrites de l'associé unique de de l'associé unique de Rovi Global Services S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42-44, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de USD 1.559.150 et immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg au numéro B 157.159 (la Société). La Société a été constituée le 24
novembre 2010 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociation n°65 du 13 janvier 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont pas été modifiés pour la dernière fois le 10
novembre 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n
°3209 le 29 décembre 2011.

A comparu:

EuroMedia Group, Inc., une société constituée par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son

siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, immatriculée
au Delaware Division of Corporations au numéro 2664176 (l'Associé Unique),

représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé;

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société;

122537

L

U X E M B O U R G

II. que l'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique constate que le conseil de gérance de la Société lui a présenté le projet commun de fusion trans-

frontalière publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 2066 du 26 août 2013, conformément à
l'article 262 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et prévoyant
l'absorption de Macrovision Licensing &amp; Holding B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) constituée selon les lois des Pays-Bas, dont le siège (official seat) se situe à Amsterdam, Pays-
Bas avec adresse (office address) au Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, les Pays-Bas et
enregistrée au Registre Commercial de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34163574 (la Société
Cessant d'Exister) par la Société, la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de
l'ensemble des actifs et passifs, sans exception ni réserve, de la Société Cessant d'Exister à la Société (le Projet de Fusion).

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi, à l'exception du rapport rédigé

par les organes de gérance des sociétés qui fusionnent et du rapport d'un réviseur d'entreprise sur le Projet de Fusion
conformément aux renonciations de l'Associé Unique, ont été déposés au siège social de la Société pour inspection par
l'associé de la Société au moins un mois avant la date des présentes.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents, signée par un représentant autorisé de la Société, restera annexée

au présent acte.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le projet de fusion et d'accomplir la fusion par absorption de la Société Cessant

d'Exister par la Société, en conformité avec les conditions détaillées dans le Projet de Fusion, et plus particulièrement,
en échange du transfert de l'ensemble des actifs et passifs, sans exception ni réserve, de la Société Cessant d'Exister à la
Société.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique prend acte (i) que d'un point de vue comptable et fiscal, les opérations de la Société Cessant d'Exister

seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du 1 

er

 janvier 2013, (ii) que la fusion

prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des décisions concordantes des assemblées générales ou
résolutions écrites des actionnaires des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion (la Date Effective) et (b) vis-à-vis des
tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des actionnaires conformément à l'article 9 de la Loi.

L'Associé Unique constate également, à compter de la Date Effective, (i) de la dissolution sans liquidation de la Société

Cessant d'Exister par voie de transfert à la valeur comptable de l'ensemble de ses actifs et passifs à la Société conformé-
ment au Projet de Fusion et (ii) l'annulation de toutes les actions émises par la Société Cessant d'Exister.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité à tout avocat et salarié de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l.,

agissant individuellement comme agent de la Société, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents
et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la
fusion et avec les résolutions ci-dessus.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité

des actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre

du présent acte, conformément au projet de fusion, est estimé à sept mille Euros (7.000.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45010. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

122538

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013142398/155.
(130173046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

SBM Installer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 570.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.403.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-first day of August.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

SBM Holding Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and

existing under Luxembourg laws, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, with a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20.000,00), and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172142;

here represented by Ms. Euryale Didillon, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given under private seal on August 20, 2013.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company

established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "SBM Installer S.à r.l." (hereinafter, the
Company), with registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179403, established pursuant to a deed of
the undersigned notary, dated August 2, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
and whose articles of association have not been amended since then.

II. The Company's share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20.000,00) represented by twenty

thousand (20.000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of five hundred fifty thousand

United States Dollars (USD 550.000,00) in order to raise it from its present amount of twenty thousand United States
Dollars (USD 20.000,00) to an amount of five hundred seventy thousand United States Dollars (USD 570.000,00) by
creation and issuance of five hundred fifty thousand (550.000) new shares, all with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1,00) each (the New Shares).

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder declares to subscribe for five hundred fifty thousand (550.000) New Shares and to fully pay them

up at their nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, for an aggregate amount of five hundred fifty
thousand United States Dollars (USD 550.000,00), together with a share premium in the amount of one million one
hundred thousand United States Dollars (USD 1.100.000,00) (the Share Premium), by contribution in cash in the total
amount of one million six hundred fifty thousand United States Dollars (USD 1.650.000,00).

The total amount of one million six hundred fifty thousand United States Dollars (USD 1.650.000,00) has been fully

paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.

IV. The sole shareholder resolves to link the Share Premium to the five hundred seventy thousand (570.000) shares

it holds in the Company.

V. The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company

in order to give it the following content:

Art. 5. Paragraph 1. "The subscribed share capital is set at five hundred seventy thousand United States Dollars (USD

570.000,00) represented by five hundred seventy thousand (570.000) shares with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1,00) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

above resolutions are estimated at two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

122539

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of

the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full

name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-et-un août.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

SBM Holding Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existant en vertu des lois du Luxem-

bourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un
capital social de vingt mille Dollars Américains (USD 20.000,00), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172142;

ici représentée par Melle Euryale Didillon, employée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 20 août 2013.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la personne comparante et le

notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La personne comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est l' associé unique de la société à responsabilité

limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «SBM Installer S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant
son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179403, constituée par acte du notaire soussigné,
en date du 2 août 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis lors.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20.000,00) représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent cinquante mille Dollars

Américains  (USD  550.000,00)  afin  de  porter  celui-ci  de  son  montant  actuel  de  vingt  mille  Dollars  Américains  (USD
20.000,00) à un montant de cinq cent soixante-dix mille Dollars Américains (USD 570.000,00) par la création et l'émission
de cinq cent cinquante mille (550.000) parts sociales nouvelles, toutes d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD
1,00) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).

<i>Souscription - Libération

L'associé unique déclare souscrire aux cinq cent cinquante mille (550.000) Nouvelles Parts Sociales et de les libérer

intégralement à leur valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, pour une valeur totale de cinq cent
cinquante mille Dollars Américains (USD 550.000,00), ensemble avec une prime d'émission d'un montant total d'un million
cent mille Dollars Américains (USD 1.100.000,00) (la Prime d'émission), par apport en numéraire d'un montant d'un
million six cent cinquante mille Dollars Américains (USD 1.650.000,00).

Le montant total d'un million six cent cinquante mille Dollars Américains (USD 1.650.000,00) a été intégralement libéré

et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

IV. L'associé unique décide de lier la Prime d'émission aux les cinq cent soixante-dix mille (570.000) parts sociales qu'il

détient dans la Société.

V. L'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner

la teneur suivante:

Art. 5. Paragraphe 1. «Le capital social de la Société s'élève à cinq cent soixante-dix mille Dollars Américains (USD

570.000,00) représenté par cinq cent soixante-dix mille (570.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Amé-
ricain (USD 1,00) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués approximativement à la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-).

122540

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et

prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Didillon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 août 2013. Relation: EAC/2013/11084. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013123352/115.
(130149922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Royalty Opportunities Feeder S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ROYALTY OPPORTUNITIES FEEDER S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013123327/11.
(130149617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Roninvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 90, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 54.590.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2013123325/11.
(130149938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Rohtak Holding S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 68.089.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ROHTAK HOLDING S.A.-SPF

Référence de publication: 2013123324/10.
(130149630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

SCOP Poland S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 101.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

122541

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013123354/10.
(130149539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Relofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 84.591.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013123318/12.
(130149997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Sterner Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.928.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 Août 2013.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2013123367/10.
(130149503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

SVG Kudamm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.169.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013123370/10.
(130149398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Syneco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7343 Steinsel, 14, rue des Templiers.

R.C.S. Luxembourg B 85.034.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013123375/10.
(130149770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Synapse International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 94.952.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2013123374/10.
(130149504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

122542

L

U X E M B O U R G

Stora Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.879.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 août 2013 que le mandat de Deloitte

S.A., commissaire de la Société, n'a pas été renouvelé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013123369/14.
(130149703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Syllus S.A. Holding S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013123373/10.
(130149277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Tar Heel Trading International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.008.

Les comptes annuels au 31 août 2012, établis en Euros, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rap-

portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013123376/11.
(130150026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Thorenc PV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2012.

Référence de publication: 2013123380/10.
(130150098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Ternium Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.731.412.994,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 154.306.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

122543

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013123379/11.

(130149900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

The Four Plus (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 49.717.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2013.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2013123394/12.

(130149730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2013.

Participe S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 66.935.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013123786/10.

(130150403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

Temps d'Or, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7411 Ansembourg, Vieux Château.

R.C.S. Luxembourg B 159.062.

Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph CANNIVY.

Référence de publication: 2013123846/10.

(130150288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

Terre d'eau technologies Environnementales Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 47, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.041.

Le Bilan abrege au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/08/2013.

Référence de publication: 2013123847/10.

(130150366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

122544


Document Outline

ACMBernstein SICAV

AmBev Luxembourg

Axa Alternative Financing Management S.à r.l.

Axa Alternative Financing Management S.à r.l.

BNP Paribas Flexi I

Charon SPF S.A.

Chios SPF S.A.

Fondamenta Private Equity S.A.

FT EuroCorporates

Gems Progressive Fund

IFM-Invest: 2 PrivateEquity

Kadmos SPF S.A.

Parsifal SPF S.A.

Participe S.A., SPF

Property Trust Bernau, S.à r.l.

Property Trust Luxembourg 1 S.à r.l.

Property Trust Luxembourg 3, S.à r.l.

Property Trust Moosburg, S.à r.l.

Property Trust Muehldorf, S.à r.l.

Property Trust Treuchtlingen, S.à r.l.

Quilmes International Beverages S.à r.l.

Relofin S.A.

Rohtak Holding S.A.- SPF

Roninvest S.A.

Rovi Global Services S.àr.l.

Royalty Opportunities Feeder S.A.

Salm

SBM Installer S.à r.l.

SCOP Poland S.àr.l.

SeaNet Maritime Services S.à r.l.

Sebino Properties S.à r.l.

Sterner Research S.A.

Stora Luxembourg S.à r.l.

SVG Kudamm S.à r.l.

Syllus S.A. Holding S.P.F.

Synapse International S.A.

Syneco S.à r.l.

Tar Heel Trading International S.à r.l.

Temps d'Or

Ternium Investments S.à r.l.

Terre d'eau technologies Environnementales Sàrl

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

The Four Plus (Luxembourg) S.A.

Thorenc PV Holding S.à r.l.

Titan SPF S.A.

Vivimus SPF S.A.

Wolverton Mountain SPF S.A.