logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2552

14 octobre 2013

SOMMAIRE

Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122461

Euroheart Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

122458

Family Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

122488

F.E. Luxfinco Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122473

Fingrade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122460

First Euro Industrial Properties III S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122496

Fish Center S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122460

FRS Hotel Group (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

122460

Galway II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122459

Galway I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122459

G-Brands.1946  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122459

Hellebore Participations S.à r.l.  . . . . . . . . .

122459

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122460

La Boqueria S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122484

Lengau Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

122489

Lux 9 Starlight EUR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

122489

Mansfield II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122491

Mascot S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122450

MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

122496

M.L. Technique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122493

Moderna Renaissance Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122450

M.V.A. Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122450

Neva Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122452

New Casastyle s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122453

Nice Living  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122453

North American Capital Investors of Lu-

xembourg (NACIL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122452

Nova Holdings S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

122451

NSK Euro Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

122451

Optique Clement & Grassini S. à r.l.  . . . . .

122451

Oranje-Nassau Développement S.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122453

Oscar-1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122454

OXEA FINANCE & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . .

122452

Painworld S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122453

Participe 49, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122455

Peche Aquarium S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

122456

Pecunia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122454

Pecunia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122455

Pentavest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122453

Performance Fibers Europe 2, S.à r.l.  . . . .

122451

PétroVan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122454

P.F. Logistic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122452

Plemont Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

122457

Portugal Resorts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122454

Prebivego Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122457

Prebivego Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122457

Précis-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122455

President C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122455

Pribinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122458

Prime Credit 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122455

Prime Credit 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122456

Prime Credit 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122456

Primedale Participation S.A.  . . . . . . . . . . . .

122458

Proform S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122454

PRT Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

122450

Quintiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122456

Quintiles Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122457

Quintiles Luxembourg European Holding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122457

Quintiles Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . .

122458

REI Latin America I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

122458

Researches and International Communica-

tions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122456

The Park 4 Holdings Lux S.à r.l.  . . . . . . . . .

122489

122449

L

U X E M B O U R G

Mascot S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 122.780.

Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé le contrat de domiciliation conclu avec la société sous

rubrique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2013.

<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
Alan Botfield / Wim Rits
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013122550/14.
(130148591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Moderna Renaissance Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.422.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 26 août 2013

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 21 mai 1986, demeurant profes-

sionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-Duchesse  Charlotte,  a  été  nommé  comme  gérant  de
catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Moderna Renaissance Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122552/16.
(130148837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

M.V.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 8.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122544/9.
(130148662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

PRT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 411.650,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.497.

En date du 08 août 2013, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- la démission de Jacques de Patoul en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 22 août 2013;
- Erik Johan Cornelis Schoop, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 07 juin 1970, avec adresse professionnelle au 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour
une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013122637/15.
(130148877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122450

L

U X E M B O U R G

Optique Clement &amp; Grassini S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.903.

La société OPTIQUE CLEMENT &amp; GRASSINI S.à r.l. représentée par Monsieur Laurent GRASSINI, agissant en sa

qualité de gérant administratif de la société référencée ci-dessus et par Monsieur Alain CLEMENT, agissant en sa qualité
de gérant administratif de la société référencée ci-dessus, déclarent prendre la décision suivante:

<i>Première et unique décision

Transfert du siège social de la société au L-3440 DUDELANGE, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122603/13.
(130148679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Nova Holdings S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.123.

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 juillet 2013

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l’issue de la présente Assemblée,

l’Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d’Administrateur de Monsieur Romain THIL-
LENS (Président du Conseil d’Administration), de Monsieur Joseph HAMOD et Monsieur Roger KHOURI MELKI, ainsi
que celui de Commissaire de EXCOMA S.àr.l. pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NOVA HOLDINGS S.A. - SPF

Référence de publication: 2013122599/16.
(130149253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

NSK Euro Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 104.327.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122600/9.
(130149004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Performance Fibers Europe 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4902 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 113.980.

<i>Résolutions de l'associé unique du 31 Décembre 2012

L'assemblée générale extraordinaire du 31 Décembre 2012 a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Erwin BETTE en qualité de gérant avec effet immédiat.

<i>Seconde résolution:

L'associé unique nomme Monsieur Alexander CARNEVALE, résident professionnellement à ZAE Robert Steichen, 5

rue Bommel à L-4940 Hautcharage, pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

<i>Pour l'associé unique
Signature

Référence de publication: 2013122614/16.
(130148888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122451

L

U X E M B O U R G

Neva Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 145.562.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration

- Il est pris acte de la démission de Madame Isabelle SCHUL de son mandat d'administrateur avec effet au 5 août 2013.
- Monsieur Christian FRANCOIS, né le 1 

er

 avril 1975 à Rocourt (Belgique), employé privé, demeurant profession-

nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Madame
Isabelle SCHUL, démissionnaire, avec effet au 6 août 2013.

Le mandat de Monsieur Christian FRANCOIS viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale statutaire

de l'an 2014.

La cooptation de Monsieur Christian FRANCOIS sera ratifiée à la prochaine assemblée générale statutaire.
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 7 mai 1974 à Strasbourg (France), employé privé, demeurant professionnel-

lement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du conseil d'administration. Ce dernier assumera
cette fonction jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 6 août 2013.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR NEVA INVESTMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2013122594/22.
(130148951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

North American Capital Investors of Luxembourg (NACIL), Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 178.245.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 14 juin 2013 à Luxembour

- de nommer JALYNE S.A., représentée par Jacques BONNIER, en tant que Président du Conseil d'administration.

Copie Conforme
JALYNE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013122592/13.
(130148753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

P.F. Logistic, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 122.947.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122610/9.
(130149313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.693.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013122609/10.
(130148688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122452

L

U X E M B O U R G

New Casastyle s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4959 Bascharage, 54, Zone Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 145.574.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2013122595/11.
(130148967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Nice Living, Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 144.807.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2013122596/11.
(130148961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Pentavest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.065.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 19 avril 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 mai 2013.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2013122613/13.
(130149107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Painworld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 18, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 98.950.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122622/9.
(130149037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 166.568.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122605/10.
(130149172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122453

L

U X E M B O U R G

Oscar-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 159.041.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28. Août 2013.

Référence de publication: 2013122606/10.
(130149325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

PétroVan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 102.648.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013122612/10.
(130149011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Proform S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 62.425.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2013.

GERARD Rachel.

Référence de publication: 2013122621/10.
(130149294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Portugal Resorts, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 170.773.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Georges Beckene

Référence de publication: 2013122616/11.
(130148667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Pecunia Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 38.344.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. August 2013

Die Mandate des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen Generalver-

sammlung des Jahres 2019.

Die neue Anschrift des Herrn Pascal Wagner lautet:
59, route de Luxembourg, L-4761 Pétange.

<i>Die Versammlung

Référence de publication: 2013122625/13.
(130149052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122454

L

U X E M B O U R G

Précis-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 55, allée de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 123.066.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 août 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013122617/11.
(130149102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Prime Credit 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 311.392,00.

Siège social: L-5365 Luxembourg, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 163.274.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013122618/11.
(130148737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Pecunia Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 38.344.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122626/9.
(130149055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Participe 49, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 116.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013122623/10.
(130148677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

President C, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2013.

TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2013122632/13.
(130149266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122455

L

U X E M B O U R G

Prime Credit 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 160.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 165.787.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013122619/11.
(130148815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Prime Credit 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 929.314,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 165.786.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2013122620/11.
(130148936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Peche Aquarium S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 57.836.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 26.8.2013.

Référence de publication: 2013122624/10.
(130149024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Quintiles, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 149.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122638/9.
(130149140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Researches and International Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 86.077.

Il résulte des lettres recommandée adressées à la société en date du 17 juillet 2013 que Monsieur Olivier Block,

Monsieur Gérard Scheiwen et Monsieur Luc Nickels adresse professionnel 126, rue du Cents L-1319 Luxembourg ont
démissionné de leurs poste d’administrateur de la société avec effet au 17 juillet 2013.

Luxembourg, le 9 août 2013.

<i>Pour la société
Mandataire

Référence de publication: 2013122651/13.
(130148928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122456

L

U X E M B O U R G

Plemont Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 130.981.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle survenue sur le dépôt L130003335 en date du 8 janvier 2013, il est à noter que la société

transfère son siège du 35 avenue Monterey L-2163 Luxembourg au 12 rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg au lieu du
41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013122629/14.
(130148825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Prebivego Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 131.009.

Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2013122630/11.
(130148962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Quintiles Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 149.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122639/9.
(130149186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Quintiles Luxembourg European Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 149.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122640/9.
(130149210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Prebivego Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 131.009.

Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2013122631/11.
(130148963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122457

L

U X E M B O U R G

Pribinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.957.

<i>Dépôt rectificatif du 31.07.2012 Sous la Référence L120134838

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122633/10.
(130149155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Primedale Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.373.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122635/10.
(130148906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Quintiles Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 115.379.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122641/9.
(130149224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

REI Latin America I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 130.137.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2013,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2013122650/11.
(130148982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Euroheart Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.526.

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans le dépôt L130147503 du 26 août 2013.
Il y a lieu de lire que Monsieur Jérôme DEVILLET a été nommé comme gérant de catégorie A pour une période

indéterminée, et non comme gérant de catégorie B, comme indiqué par erreur.

Luxembourg, le 28 août 2013.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EUROHEART INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122398/14.
(130148905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122458

L

U X E M B O U R G

Galway I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 177.808.

<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 26 août 2013

1. Monsieur Jonathan LEPAGE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Galway I S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122432/16.
(130148664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Galway II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 177.826.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 26 août 2013

1. Monsieur Jonathan LEPAGE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Galway II S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013122433/16.
(130148672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

G-Brands.1946, Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 111.899.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122431/9.
(130149109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Hellebore Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.859.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 24 avril 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 24 mai 2013.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2013122451/13.
(130149086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122459

L

U X E M B O U R G

FRS Hotel Group (Lux), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.690.125,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 110.245.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 18 juin 2012

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Aidan FOLEY, gérant de classe A en qualité de gérant de classe B de

la Société avec effet au 8 août 2013.

L’associé unique a décidé de nommer Monsieur Michael GLENNIE, gérant de classe B en qualité de gérant de classe

A de la Société avec effet au 8 août 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013122426/14.
(130148908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 104.948.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites de l’associé unique de la Société prises en date du 27 août 2013 que:
- Monsieur Lawrence Kurland a été révoqué de sa fonction de gérant de catégorie A, avec effet au 18 juillet 2013;
- Monsieur Scott McKinlay, né le 11 avril 1983 à Dunfermline, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 16,

avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B avec effet au 18 juillet 2013 et ce pour une durée
indéterminée;

- Monsieur Benoît Jean Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B avec effet au 18 juillet 2013 et ce pour une durée
indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 28 août 2013.

Référence de publication: 2013122465/20.
(130149199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Fish Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 29.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 28.8.2013.

Référence de publication: 2013122420/10.
(130149082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Fingrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.727.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 aout 2013.

Référence de publication: 2013122419/10.
(130148741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122460

L

U X E M B O U R G

Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 179.769.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth of June.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

Appeared the following:

1. Mr. Murat Cem SERTOGLU, businessman, born in Ankara on 23 October 1971, having his professional address at

Sari Konaklar B41 d5, Etiler 32335, Istanbul, Turkey, from Turkish nationality;

2.  Mr.  Roland  MANGER,  businessman,  born  in  Speyer  on  15  November  1963,  having  his  professional  address  at

Waldschulstrasse 70a, 81872 Munich, Germany, from German nationality;

3. Mr. Evren UCOK, businessman, born in Istanbul on 23 November 1975, having his professional address at Bahcesehir

1. Kisim Mah. Nilüfer Cayi Sok. Villa 7 No:1; Basaksehir - Istanbul, Turkey, from Turkish nationality;

4. Mr. Dan LUPU, businessman, born in Bucharest, Romania on 28 

th

 Febuary 1973, having his professional address at

10 Tintasului St, 12166 Bucharest, Romania;

each represented by Mr Tobias SEIDL, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-

bourg), by virtue of proxies, which, after having been initialled and signed "ne varietur' by the proxy holder and the
undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such parties, represented as above stated, have requested the notary to draw up the following articles of incorporation

of a société anonyme which they declare to establish as follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become

owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société a responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by
the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l." (in short form "EDEF Advisory").

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Managers

is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's registered
office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Object. The main objective of the Company is to serve as the exclusive investment advisor to

Earlybird Luxembourg EDEF Management (the "General Partner"), in relation to Earlybird Digital East Fund 2012 SCA
SICAR (the "SICAR") and perform the advisory services as contemplated in the advisory agreement with the General
Partner (the "Advisory Agreement"), the articles of association of the SICAR (the "SICAR Articles") and the information
memorandum of the SICAR (the "Information Memorandum").

In general, the Company may carry out any commercial, industrial, or financial operation and engage in such other

activities, as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with the accom-
plishment and development of the foregoing. Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction
which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require
the Company to have any other license.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros

(€12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) registered shares with a par value of one euro (€1) each.

122461

L

U X E M B O U R G

In addition to the share capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share in addition

to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares
which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by

any shareholder. This register shall contain all of the information required by Article 185 of the Law.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter any change of address. The Company will be entitled

to rely on the last address so communicated.

Shareholders may request the Company to issue and deliver certificates setting out their respective holdings of shares

which certificate shall be signed by all Managers.

If and when the Company has only one shareholder, this shareholder may freely transfer its/her/his shares.
If and when the Company has several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst the shareholders.

The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders,
at which at least three quarters of the share capital, which present or represented, cast their vote in favour of such
transfer.

Shares may be transferred either by means of a notarised instrument or a private agreement. Any such transfer is not

binding on the Company or third parties unless duly notified to or accepted by the Company, in accordance with Article
1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the

Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

In the event a shareholder becomes a "leaver" under the applicable leaver/joiner rules of an entity managed or advised

by the Earlybird Group, such leaving shareholder must transfer the entirety of its shareholding, to be compensated at par
value, at any time and in any manner prescribed by a resolution passed at a general shareholder meeting by a 2/3 vote of
the remaining, non-leaving shareholders present or represented at the meeting.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased

or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any
amendment of these Articles.

Chapter III. Managers, Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company is managed by a board of managers (the "Board of Directors") composed of

three  (3)  managers (each  a "Manager"  and  in  plural  the "Managers"). The  Manager(s)  shall  be appointed by the  sole
shareholder or, as the case may be, general meeting of shareholders. The Managers will hold office until their successors
are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause,
by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental

to the Company's interests -except when such a disclosure is mandatory by law or is in the public interest.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from

among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be

convened if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may

appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all the Managers at the meeting or otherwise. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or at such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his

representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office.

122462

L

U X E M B O U R G

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting.

Each Manager has one vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered equivalent to a physical presence at the meeting. A written
decision passed by circular means and transmitted by cable, facsimile or any other similar means of communication, signed
by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly
convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having
the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers shall be

drawn up and signed by all Managers present at the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by all Managers.

Art. 12. General Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to act

on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful
for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as
the case may be, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management and

affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or
members of the Board of Managers or to any other person, who need not be a Manager or a Shareholder of the Company,
acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Board of Managers shall determine.

The delegation of the daily management to a member of the Board of Managers entails the obligation for the Board

of Managers to report each year to the ordinary general meeting of shareholders on the salary, fees and any advantages
granted to the delegate.

The Board of Managers may also confer certain powers and/or special mandates to any member or members of the

Board of Managers or to any other person, who need not be a Manager or a Shareholder of the Company, acting either
alone or jointly, under such terms and with such powers as the Board of Managers shall determine.

The Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and

purpose.

Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of

two Managers, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has
delegated such signatory power, within the limits of such power.

Art. 15. Investment Committee. The Company shall form an executive committee to scout and select potential in-

vestments for the SICAR (the "Investment Committee"). The initial membership of the Investment Committee shall
include Dan Lupu, Roland Manger, Cem Sertoglu and Evren Ucok, and non-voting observers may be appointed by sha-
reholders of the SICAR in the sole discretion of the Board of Directors.

The purpose of the Investment Committee shall be to provide investment recommendations to the General Partner

in the manner set forth in the Information Memorandum. Decisions of the Investment Committee shall be taken by
unanimous consent. Meetings of the Investment Committee shall take place as often and on the terms as contemplated
in the Information Memorandum.

Art. 16. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more of the Managers, managers, associates, members,
officers or employees of the Company has a personal interest in, or is a manager, manager, associate, member, officer
or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the
Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business, shall not solely, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company has a personal interest in any transaction

to which the Company is a party, other than transactions concluded under normal conditions and falling within the scope
of the day-to-day management of the Company which is conflicting with the Company's interest therein, he shall make
known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such
transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or as the case may be, to the
next general meeting of shareholders.

Art. 17. Application of the SICAR Articles and the Information Memorandum. Each Manager, manager, associate,

member, officer and employee of the Company shall be obliged in a personal capacity to comply with the provisions of
the SICAR Articles and the Information Memorandum in relation to time devotion, conflicts of interest, restraint in
competition, confidentiality and any other personal obligations to the extent applicable to such Manager, manager, asso-

122463

L

U X E M B O U R G

ciate, member, officer or employee. Furthermore, each Manager, manager, associate, member, officer and employee shall
be obliged to comply with the relevant change of control mechanisms and constraints in relation to transfers contained
in the SICAR Articles and the Information Memorandum in relation to their shares in the Company and any other interest
they are holding in members of the Earlybird Group (meaning the General Partner, the SICAR, Earlybird Digital East
S.C.S., EDEF Principals Investment S.C.S., their respective affiliated enterprises and any collective investment vehicles
managed and/ or advised by them, Earlybird Venture Capital GmbH &amp; Co. KG, Earlybird VC Management GmbH &amp; Co.
KG or their respective affiliated enterprises).

Art. 18. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such
action, suit or procedure in relation to matters for which he shall be held liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its
legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights which the relevant person may be entitled to.

Art. 19. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the

requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, or shall be if the Company has more
than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors, who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the statutory auditor, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory or supervisory auditors,
if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors
will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general
meeting of shareholders.

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 20. Annual General Meeting. The annual General Meeting to be held only if the Company has more than twenty-

five (25) shareholders, shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered
office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office or at such other place as may be
specified in the convening notice of the meeting, on the last Wednesday of June of each year at 3.00 p.m..

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following

business day.

Art. 21. Other General Meetings of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter

exercises the powers granted by the law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder
shall be recorded in minutes.

The Manager or Board of Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half

of the Company's share capital can call other general meetings of shareholders in accordance with the requirements of
the Law.

If the Company has less than twenty-five (25) shareholders general meetings of shareholder are not mandatory and

the shareholders may vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary

opinion of the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.

Art. 22. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders. The general meeting of shareholders shall have the powers vested
to it by the Law and by these Articles.

Art. 24. Procedure, Vote, Minutes. The general meeting of shareholders will meet upon call by the Board of Managers

or the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half of the Company's share capital, which meets the requi-
rements of the Law and these Articles.

The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the date, time, place and agenda of the

meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as his proxy

who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

122464

L

U X E M B O U R G

The Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general

meeting of shareholders.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
Any shareholder may cast his vote by correspondence. For such purpose, the shareholder may only use the voting

forms provided by the Company.

Any executed and filled in voting forms shall be delivered to the Company at its registered office either by hand with

acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier.

Any voting form ("formulaire") which is not signed by the relevant shareholder or its authorised representative(s), as

applicable, and does not bear at least the following mentions or indications is to be considered null and void:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares and, if applicable, number of shares of each class, held by the relevant shareholder in the share

capital of the Company;

- place, date and time of the general meeting to be held;
- agenda of the general meeting to be held;
- vote by the relevant shareholder indicating, with respect to each of the proposed resolutions, whether the relevant

shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and

- name and title of the authorised representative of the relevant shareholder, if applicable.
Any voting form ("formulaire") shall be received by the Company no later than 6 p.m., Luxembourg time, on the day

which immediately precedes the day on which the general meeting shall be held and on which banks are generally open
for business in the Grand Duchy of Luxembourg. Any voting form ("formulaire") received by the Company after such
deadline shall be disregarded.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers, or, in his absence,

by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).
The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed,

form the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the

name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles must be

approved by (i) a majority of the shareholders in numerical terms and (ii) representing three-quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Law or these Articles, all other resolutions must be approved by shareholders

representing more than half of the share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, the shareholders
shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the
votes cast, regardless of the percentage of the share capital represented.

Art. 24. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts from the decisions of the sole shareholder or, as the case may be, the minutes of the general

meeting of shareholders shall be certified by all Managers the sole Manager, Chairman of the Board of Mangers or any
two Managers, as the case may be.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 25. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the

last day of the month of December every year.

Art. 26. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of

Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them to the auditor
(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its/her/his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company

as provided for by the Law.

Art. 27. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder

of the annual net profits will be allocated. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to absorb existing

122465

L

U X E M B O U R G

losses, if any, to put it into a reserve or a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute
it to the shareholder(s) as dividend.

Art. 28. Interim Dividends. The Board of Managers are authorised to pay out interim dividends in compliance with the

Law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining

to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro
rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the ap-

plicable Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed for the number of

shares and paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders:

number of shares:

Murat Cem SERTOGLU, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 (three thousand seven hundred fifty)
Roland MANGER, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 (three thousand seven hundred fifty)
Evren UCOK, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 (three thousand seven hundred fifty)
Dan LUPU, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 (one thousand two hundred fifty)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500 (twelve thousand five hundred)

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been
duly given to the notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately EUR 1.400.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 

st

 December 2013.

<i>Extraordinary general meeting

The above mentioned shareholders, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as

having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of directors of the Company be set at three (3);
(ii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for an unlimited duration:
a) Mr. Murat Cem SERTOGLU, businessman, born in Ankara on 23 October 1971, having his professional address at

Sari Konaklar B41 d5, Etiler 32335, Istanbul, Turkey, from Turkish nationality;

b) Mr. Evren UCOK, businessman, born in Istanbul on 23 November 1975, having his professional address at Bahcesehir

1. Kisim Mah. Nilüfer Cayi Sok. Villa 7 No:1; Basaksehir - Istanbul, Turkey, from Turkish nationality,

c) Mr. Dan LUPU, businessman, born in Bucharest, Romania on 28 

th

 Febuary 1973, having his professional address at

10 Tintasului St, 12166 Bucharest, Romania,

(iii) that there be appointed as supervisory auditor («commissaire aux comptes») of the Company for a term ending

at the next annual general meeting to be held in 2014: Kohnen &amp; Associés S.à r.l., with registered office at 62, avenue de
la Liberté in L-1930 Luxembourg.

(iv) that the address of the registered office of the Company is set at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

122466

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in
case of discrepancies between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, who are known to the notary by their

surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend dreizehn, am zwölften Juli.
Vor mir dem Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz zu Rambruch, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Mr. Murat Cem SERTOGLU, Geschäftsmann, geboren in Ankara am 23. Oktober 1971, geschäftsansässig in Sari

Konaklar B41 d5, Etiler 32335, Istanbul, Türkei, mit Türkischer Nationalität;

2. Mr. Roland MANGER, Geschäftsmann, geboren in Speyer am 15. November 1963, geschäftsansässig in Waldschul-

strasse 70a, 81872 München, Deutschland, mit Deutscher Nationalität;

3. Mr. Evren UCOK, Geschäftsmann, geboren in Istanbul am 23. November 1975, geschäftsansässig in Bahcesehir 1.

Kisim Mah. Nilüfer Cayi Sok. Villa 7 No:1; Basaksehir - Istanbul, Türkei, mit Türkischer Nationalität;

4. Mr. Dan LUPU, Geschäftsmann, geboren in Bucharest, Rumänien am 28. Februar 1973, geschäftsansässig in 10

Tintasului St, 12166 Bucharest, Rumänien;

allesamt hier vertreten durch Tobias Seidl, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund ihm erteilte Voll-

machten.

Die von dem Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben dieser

Urkunde beigefügt und sind zusammen mit diesen bei den zuständigen Registerstellen einzureichen.

Die wie vorstehend beschriebenen Vertretenen haben den Notar gebeten, den nachstehenden Gesellschaftervertrag

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung auszufertigen:

Kapitel I. Gesellschaftsform, Gesellschaftsname, Eingetragener Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Gesellschaftsform, Gesellschaftsname. Zwischen den Zeichnern und allen Personen, die eventuell Eigentümer

von zu einem späteren Zeitpunkt begebenen Anteilen werden, wird eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (die „Gesellschaft") konstituiert, die dem Recht des Großherzog-
tums Luxemburg und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils aktuellen
Fassung (das „Gesetz"), Artikel 1832 des Zivilgesetzbuchs in der jeweils aktuellen Fassung und der vorliegenden Satzung
(die „Satzung") unterliegt.

Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l." (Kurzform: „EDEF Advisory").

Art. 2. Eingetragener Sitz. Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in der Stadt Luxemburg. Die Geschäftsführung

ist befugt, die Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde, in der sich der eingetragene
Sitz der Gesellschaft befindet, zu ändern.

Zweigstellen oder sonstige Niederlassungen können durch Beschluss der Geschäftsführung entweder im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

Falls nach Ansicht der Geschäftsführung außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen ein-

treten  oder  bevorstehen,  die  die  normale  Geschäftstätigkeit  der  Gesellschaft  an  ihrem  eingetragenen  Sitz  oder  die
Kommunikation  mit  diesem  Sitz  oder  zwischen  diesem  Sitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen  könnten,  kann  er  den
eingetragenen Sitz bis zum Ende dieser außergewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegen. Solche vorübergehenden
Maßnahmen wirken sich nicht auf die Nationalität der Gesellschaft aus, die trotz einer vorübergehenden Verlegung des
eingetragenen Sitzes eine Gesellschaft bleibt, die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Hauptzweck der Gesellschaft besteht darin, als ausschließlicher Anlageberater für die

Earlybird Luxembourg EDEF Management (der „Hauptgesellschafter") in Bezug auf die Earlybird Digital East Fund 2012
SCA SICAR (die „SICAR") zu dienen und die im Beratungsvertrag mit dem Hauptgesellschafter (der „Beratungsvertrag"),
in der Satzung der SICAR (die „SICAR-Satzung") und im Informationsmemorandum der SICAR (das „Informationsme-
morandum") vorgesehenen Beratungsleistungen zu erbringen.

Die Gesellschaft kann allgemein alle kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen sowie sonstigen Tätigkeiten aus-

üben, die nach Ansicht der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Erreichen des Vorgenannten notwendig, ratsam oder
günstig sind, damit einhergehen oder nicht damit unvereinbar sind. Unbeschadet des Vorgenannten darf die Gesellschaft
keine Geschäfte tätigen, die dazu führen würden, dass davon ausgegangen wird, dass sie eine regulierte Tätigkeit ausübt
oder eine Tätigkeit, für die die Gesellschaft eine sonstige Zulassung benötigen würde.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer konstituiert.

122467

L

U X E M B O U R G

Kapitel II. Anteilskapital, Anteile

Art. 5. Anteilskapital. Das gezeichnete Anteilskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500)

unterteilt in zwölftausendfündhundert (12.500) Namensanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1).

Zusätzlich zum Anteilskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, auf das sämtliche zusätzlich zum Nennwert für

einen Anteil gezahlten Agios überwiesen werden. Der Betrag auf dem Agiokonto kann zur Begleichung von Anteilen
verwendet werden, die die Gesellschaft von ihren Anteilsinhabern zurücknimmt, zum Ausgleich eines realisierten Net-
toverlustes, zur Vornahme von Ausschüttungen an die Anteilsinhaber oder zur Zuweisung von Mitteln an die gesetzlichen
Rücklagen.

Art. 6. Anteile. Alle Anteile sind und bleiben Namensanteile.
Ein Anteilsregister wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft aufbewahrt, wo es allen Anteilsinhabern zur Einsicht

zur Verfügung steht. Dieses Register enthält alle gemäß Artikel 185 des Gesetzes erforderlichen Angaben.

Jeder Anteilsinhaber hat der Gesellschaft jegliche Adressänderung per Einschreiben mitzuteilen. Die Gesellschaft darf

sich auf die letzte auf diese Weise mitgeteilte Adresse verlassen.

Anteilsinhaber können verlangen, dass die Gesellschaft Bescheinigungen über ihre jeweiligen Anteilsbestände ausstellt

und ausliefert, wobei diese Bescheinigungen von allen Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichnet werden müssen.

Wenn die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, kann dieser Anteilsinhaber seine Anteile frei übertragen.
Wenn die Gesellschaft mehrere Anteilsinhaber hat, können die Anteile nur zwischen den Anteilsinhabern frei über-

tragen werden. Die Anteile dürfen nur mit der Zustimmung der Hauptversammlung der Anteilsinhaber, die mit einer
Mehrheit von mindestens drei Viertel des anwesenden oder vertretenen Anteilskapitals erteilt werden muss, an Nicht-
anteilsinhaber übertragen werden.

Anteile können durch einen notariellen Vertrag oder einen privatschriftlichen Vertrag übertragen werden. Eine solche

Übertragung  ist  nur  für  die  Gesellschaft  oder  Dritte  verbindlich,  wenn  sie  der  Gesellschaft  gemäß  Artikel  1690  des
Zivilgesetzbuchs gemeldet oder von dieser akzeptiert wurde.

Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar. Miteigentümer müssen der Gesellschaft gegenüber durch einen

gemeinsamen Vertreter vertreten werden, der aus ihrer Mitte bestellt wurde oder nicht. Die Gesellschaft hat das Recht,
die Ausübung aller mit dem jeweiligen Anteil verbundenen Rechte auszusetzen, bis ein gemeinsamer Vertreter bestellt
wurde.

Falls ein Anteilsinhaber ein „Aussteiger" gemäß den maßgeblichen Ein/Aussteigerregeln eines von der Earlybird-Gruppe

verwalteten oder beratenen Unternehmens wird, muss dieser aussteigende Anteilsinhaber seine gesamte Beteiligung, die
zum Nennwert vergütet wird, zu einem Zeitpunkt und auf eine Weise übertragen, die in einem mit Zweidrittelmehrheit
der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen verbleibenden nicht aussteigenden Anteilsinhaber gefassten Be-
schluss einer Hauptversammlung der Anteilsinhaber geregelt werden.

Art. 7. Erhöhung und Reduzierung des Anteilskapitals. Das gezeichnete Anteilskapital der Gesellschaft kann ein- oder

mehrmals durch einen Beschluss des einzigen Anteilsinhabers bzw. der Hauptversammlung der Anteilsinhaber, die unter
Anwendung der in dieser Satzung bzw. bei Änderungen dieser Satzung durch das Gesetz geregelten Bestimmungen zur
Beschlussfähigkeit und Mehrheitsbildung abstimmt, erhöht oder reduziert werden.

Kapitel II. Geschäftsführungsmitglieder, Geschäftsführung, Gesetzliche Abschlussprüfer

Art. 9. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einer Geschäftsführung (die „Geschäftsführung") geführt, der sich

aus drei (3) Geschäftsführungsmitgliedern (jeweils ein „Geschäftsführungsmitglied" und im Plural die „Geschäftsführungs-
mitglieder") zusammensetzt. Die Geschäftsführungsmitglieder werden vom einzigen Anteilsinhaber bzw. von der Haupt-
versammlung der Anteilsinhaber bestellt. Die Geschäftsführungsmitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.
Sie können am Ende ihrer Amtszeit wiedergewählt werden und sie können jederzeit mit oder ohne Grund durch einen
Beschluss des einzigen Anteilsinhabers bzw. der Hauptversammlung der Anteilsinhaber aus ihrem Amt enthoben werden.

Selbst nach Ablauf ihres Mandats dürfen die Geschäftsführungsmitglieder keine Gesellschaftsinformationen weiterge-

ben, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es sei denn, das Gesetz oder das öffentliche Interesse gebieten
eine solche Weitergabe.

Art. 10. Sitzungen der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung bestellt einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende") aus

seiner Mitte. Er kann außerdem einen Sekretär bestellen, der kein Mitglied der Geschäftsführung zu sein braucht und der
für die Führung der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Versammlungen der Anteilsinhaber zuständig
ist.

Die Geschäftsführung tritt auf Ladung des Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung der Geschäftsführung muss einberufen

werden, wenn zwei Geschäftsführungsmitglieder dies verlangen.

Der Vorsitzende führt bei allen Sitzungen der Geschäftsführung den Vorsitz. In seiner Abwesenheit kann die Ge-

schäftsführung mit der bei dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen Mehrheit ein anderes Geschäftsführungsmitglied
zum vorübergehenden Vorsitzenden bestellen.

122468

L

U X E M B O U R G

Außer in Notfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten ist mindestens vierundzwanzig

Stunden im Voraus schriftlich zu Sitzungen der Geschäftsführung zu laden. Jede derartige Ladung muss den Ort, das Datum,
die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung enthalten.

Auf die Ladung kann durch einstimmige schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführungsmitglieder bei der Sitzung oder

auf sonstige Weise verzichtet werden. Für Sitzungen, die zu Terminen und an Orten abgehalten werden, die in einem
zuvor durch Beschluss der Geschäftsführung festgehaltenen Terminplan enthalten sind, ist keine separate Ladung erfor-
derlich.

Alle Sitzungen der Geschäftsführung sind in Luxemburg oder an einem anderen in der Ladung angegebenen Ort ab-

zuhalten.

Jedes Geschäftsführungsmitglied kann sich bei einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten lassen, indem er schriftlich

ein anderes Geschäftsführungsmitglied zu seinem Vertreter bestellt.

Die Geschäftsführung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der amtierenden Geschäftsführungsmitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der bei der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-

schäftsführungsmitglieder gefasst. Jedes Geschäftsführungsmitglied hat eine Stimme.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsmitglieder können per Telefonkonferenz oder Videokonferenz oder mithilfe ähn-

licher Kommunikationsmittel, die mehreren daran teilnehmenden Personen die gleichzeitige Kommunikation miteinander
ermöglichen, an einer Sitzung teilnehmen. Diese Teilnahmemethoden sind als mit einer physischen Anwesenheit bei der
Sitzung gleichwertig anzusehen. Ein per Rundschreiben gefasster und per Kabel, Fax oder ähnliche Kommunikationsmittel
übermittelter und von allen Geschäftsführungsmitgliedern unterzeichneter schriftlicher Beschluss ist ebenso wirksam, als
wäre er auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung der Geschäftsführung gefasst worden. Ein sol-
cher Beschluss kann in einem einzelnen oder in mehreren jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführungsmitgliedern
unterzeichneten separaten Dokumenten mit demselben Inhalt dokumentiert werden.

Art. 11. Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung. Es ist ein Protokoll der Sitzung der Geschäftsführung zu

erstellen, das von allen bei der Sitzung anwesenden Geschäftsführungsmitgliedern zu unterzeichnen ist. Sämtliche Ver-
tretungsvollmachten bleiben diesem im Anhang beigefügt.

Kopien oder Auszüge sind von allen Geschäftsführungsmitgliedern zu bescheinigen.

Art. 12. Allgemeine Befugnisse der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung ist umfassend ermächtigt, für die Gesell-

schaft zu handeln und alle zur Verfolgung des Zwecks der Gesellschaft erforderlichen oder nützlichen administrativen
Maßnahmen oder Verfügungen vorzunehmen oder zu genehmigen. Alle Befugnisse, die nicht gemäß dem Gesetz aus-
drücklich dem einzigen Anteilsinhaber bzw. der Hauptversammlung der Anteilsinhaber vorbehalten sind, liegen in der
Zuständigkeit der Geschäftsführung.

Art. 13. Delegierung von Befugnissen. Die Geschäftsführung kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der

Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieses Tagesgeschäfts einem oder mehreren Mitgliedern der
Geschäftsführung oder einer sonstigen Person, die kein Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft sein muss, über-
tragen, wobei diese Beauftragten einzeln oder gemeinsam handeln können und die der Geschäftsführung die jeweiligen
Bedingungen und Befugnisse bestimmt.

Die Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts an ein Mitglied der Geschäftsführung verpflichtet die Geschäftsfüh-

rung dazu, der ordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber jedes Jahr Angaben zum Gehalt, zu den Gebühren
und zu allen dem Beauftragten gewährten Vergünstigungen zu machen.

Die Geschäftsführung kann außerdem bestimmte Befugnisse und/oder Sondermandate einem oder mehreren Mitglie-

dern der Geschäftsführung oder einer sonstigen Person übertragen, die kein Mitglied der Geschäftsführung der Gesell-
schaft  sein  muss,  wobei  diese  Beauftragten  einzeln  oder  gemeinsam  handeln  können  und  die  Geschäftsführung  die
jeweiligen Bedingungen und Befugnisse bestimmt.

Die der Geschäftsführung kann außerdem einen oder mehrere Beiräte bestellen und deren Zusammensetzung und

Zweck bestimmen.

Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von

zwei Geschäftsführungsmitgliedern sowie innerhalb der Grenzen dieser Befugnis durch die gemeinsame Unterschrift oder
alleinige Unterschrift aller Personen gebunden, denen die Geschäftsführung diese Zeichnungsbefugnis übertragen hat.

Art. 15. Anlageausschuss. Die Gesellschaft bildet einen Anlageausschuss, um potenzielle Anlagen für die SICAR aufzu-

finden und auszuwählen (der „Anlageausschuss"). Die anfänglichen Mitglieder des Anlageausschusses umfassen Dan Lupu,
Roland Manger, Cem Sertoglu und Evren Ucok, und die Anteilsinhaber der SICAR können im Ermessen der Geschäfts-
führung nicht stimmberechtigte Beobachter bestellen.

Der Zweck des Anlageausschusses besteht darin, dem Hauptgesellschafter wie im Informationsmemorandum dargelegt

Anlageempfehlungen zu erteilen. Entscheidungen des Anlageausschusses sind einstimmig zu treffen. Sitzungen des Anla-
geausschusses finden so oft und zu den Konditionen statt wie im Informationsmemorandum dargelegt.

122469

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Interessenskonflikt. Kein Vertrag oder sonstiger Geschäftsvorfall zwischen der Gesellschaft und einer anderen

Gesellschaft oder Firma wird durch die alleinige Tatsache berührt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Führungskräfte,
verbundene Personen, Mitglieder der Geschäftsführung oder Mitarbeiter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an
dieser anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Geschäftsführungsmitglieder, Führungskräfte, verbundene Personen,
Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter dieser anderen Gesellschaft oder Firma sind. Sofern
nachstehend keine abweichende Regelung vorgesehen ist, ist ein Geschäftsführungsmitglied oder Mitglied der Geschäfts-
leitung der Gesellschaft, das gleichzeitig ein Geschäftsführungsmitglied, eine verbundene Person, ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung  oder  Mitarbeiter  einer  anderen  Gesellschaft  oder  Firma  ist,  mit  der  die  Gesellschaft  Verträge  oder
anderweitig Geschäfte abschließt, nicht allein aufgrund dieser Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Firma
automatisch daran gehindert, in Bezug auf solche Verträge oder anderen Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.

Unbeschadet des Vorgenannten hat jedes Geschäftsführungsmitglied der Gesellschaft, falls es ein persönliches Interesse

an einem Geschäft hat, an dem die Gesellschaft als Partei beteiligt ist, mit Ausnahme von Geschäften, die zu normalen
Bedingungen  abgeschlossen  werden  und  die  zum  Tagesgeschäft  der  Gesellschaft  gehören,  die  Geschäftsführung  über
dieses persönliche Interesse zu informieren, wenn dieses mit dem Interesse der Gesellschaft an diesem Geschäft kollidiert,
und er darf in Bezug auf dieses Geschäft nicht beraten oder abstimmen, und dieses Geschäft und das Interesse dieses
Geschäftsführungsmitglieds daran sind dem einzigen Anteilsinhaber bzw. der nächsten Hauptversammlung der Anteilsin-
haber zu melden.

Art. 17. Anwendung der SICAR-Satzung und des Informationsmemorandums. Alle Geschäftsführungsmitglieder, Füh-

rungskräfte, verbundenen Personen, Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Gesellschaft sind persönlich
verpflichtet, die Bestimmungen der SICAR-Satzung und des Informationsmemorandums in Bezug auf Zeitaufwand, Inte-
ressenskonflikte,  Wettbewerbsverbote,  Vertraulichkeit  und  sonstige  persönliche  Verpflichtungen  einzuhalten,  sofern
diese für diese Geschäftsführungsmitglieder, Führungskräfte, verbundenen Personen, Gesellschafter, Mitglieder der Ge-
schäftsleitung und Mitarbeiter greifen. Darüber hinaus müssen alle Geschäftsführungsmitglieder, Führungskräfte, verbun-
denen Personen, Gesellschafter, Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter in Bezug auf Übertragungen ihrer Anteile
der  Gesellschaft  und  sonstigen  Beteiligungen  an  Mitgliedern  der  Earlybird-Gruppe  (d.  h.  der  Hauptgesellschafter,  die
SICAR, Earlybird Digital East S.C.S., EDEF Principals Investment S.C.S., ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und
von diesen verwaltete und/oder beratene kollektive Anlagevehikel, Earlybird Venture Capital GmbH &amp; Co. KG, Earlybird
VC Management GmbH &amp; Co. KG oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen) die maßgeblichen in der SICAR-
Satzung und dem Informationsmemorandum enthaltenen Mechanismen und Beschränkungen in Bezug auf die Änderung
der Beherrschungsverhältnisse einhalten.

Art. 18. Entschädigung. Die Gesellschaft hat alle Geschäftsführungsmitglieder und ihre Erben, Testamentsvollstrecker

und Verwalter für sämtliche Aufwendungen zu entschädigen, die diesen angemessenerweise im Zusammenhang mit Kla-
gen, Prozessen oder Verfahren entstehen, an denen sie eventuell aufgrund ihrer Eigenschaft als Geschäftsführungsmit-
glieder der Gesellschaft oder auf Antrag der Gesellschaft einer sonstigen Gesellschaft als Partei beteiligt werden, deren
Anteilsinhaberin oder Gläubigerin die Gesellschaft ist und gegenüber der kein Entschädigungsanspruch besteht. Davon
ausgenommen sind Klagen, Prozesse und Verfahren in Bezug auf Angelegenheiten, bezüglich derer sie für grobe Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz haftbar sind. Im Falle eines Vergleichs erfolgt die Entschädigung nur für Angelegenheiten, bezüglich
derer die Rechtsberater der Gesellschaft mitgeteilt haben, dass die zu entschädigende Person keine derartige Pflichtver-
letzung  begangen  hat.  Der  vorstehende  Entschädigungsanspruch  schließt  andere  Ansprüche,  die  die  jeweilige  Person
eventuell hat, nicht aus.

Art. 19. Abschlussprüfung. Sofern der Jahresabschluss der Gesellschaft nicht im Einklang mit den Anforderungen des

Gesetzes von einem unabhängigen Abschlussprüfer geprüft wird, kann bzw. muss, wenn die Gesellschaft mehr als fünf-
undzwanzig  (25)  Anteilsinhaber  hat,  die  Überwachung  der  Geschäftstätigkeit  der  Gesellschaft  einem  oder  mehreren
Abschlussprüfern anvertraut werden, die keine Anteilsinhaber sein müssen.

Die Abschlussprüfer bzw. der unabhängige Abschlussprüfer werden bzw. wird vom einzigen Anteilsinhaber bzw. von

der Hauptversammlung der Anteilsinhaber bestellt, der bzw. die ggf. die Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen oder
Aufsicht führenden Abschlussprüfer, die Vergütung des gesetzlichen oder unabhängigen Abschlussprüfers und die Dauer
seines Mandats bestimmt. Die Abschlussprüfer bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie können am Ende ihrer
Amtszeit wiedergewählt werden und sie können jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des einzigen
Anteilsinhabers bzw. der Hauptversammlung der Anteilsinhaber aus ihrem Amt enthoben werden.

Kapitel IV. Versammlungen der Anteilsinhaber

Art. 20. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung, die nur abgehalten werden muss, wenn die Gesell-

schaft mehr als fünfundzwanzig (25) Anteilsinhaber hat, ist im Einklang mit luxemburgischem Recht in Luxemburg am
letzten Mittwoch im Juni jedes Jahres um 15 Uhr an der Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft oder an einem
anderen Ort in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz befindet, oder an einem sonstigen Ort abzuhalten, der
eventuell in der Ladung zu der Versammlung angegeben wird.

Wenn dieser Tag in Luxemburg kein Bankgeschäftstag ist, wird die Jahreshauptversammlung am nächsten darauffol-

genden Geschäftstag abgehalten.

122470

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Sonstige Hauptversammlungen der Anteilsinhaber. Wenn die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt

dieser die Befugnisse aus, die von Gesetzes wegen der Hauptversammlung der Anteilsinhaber zustehen. Die Beschlüsse
des einzigen Anteilsinhabers sind zu protokollieren.

Das Geschäftsführungsmitglied bzw. die Geschäftsführung, der bzw. die Abschlussprüfer oder Anteilsinhaber, die über

die Hälfte des Anteilskapitals der Gesellschaft halten, können im Einklang mit den Anforderungen des Gesetzes sonstige
Hauptversammlungen der Anteilsinhaber einberufen.

Wenn die Gesellschaft weniger als fünfundzwanzig (25) Anteilsinhaber hat, sind keine Hauptversammlungen der An-

teilsinhaber erforderlich und die Anteilsinhaber können schriftlich über Beschlussvorlagen abstimmen.

Hauptversammlungen der Anteilsinhaber einschließlich der Jahreshauptversammlung dürfen nur dann im Ausland ab-

gehalten werden, wenn im Ermessen der Geschäftsführung Umstände höherer Gewalt dies erfordern.

Art. 22. Befugnisse der Versammlung der Anteilsinhaber. Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung der

Anteilsinhaber der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Anteilsinhaber. Die Hauptversammlung der Anteilsinhaber
hat die Befugnisse, die ihr durch das Gesetz und diese Satzung eingeräumt werden.

Art. 24. Verfahren, Abstimmungen, Protokolle. Die Hauptversammlung der Anteilsinhaber tritt auf Einberufung durch

den die Geschäftsführung oder den bzw. die Abschlussprüfer oder durch Anteilsinhaber, die über die Hälfte des Anteils-
kapitals der Gesellschaft halten, zusammen, sofern diese Einberufung die Anforderungen des Gesetzes und dieser Satzung
erfüllt.

Die gemäß dem Gesetz an die Anteilsinhaber geschickte Ladung muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Ta-

gesordnung der Versammlung enthalten.

Wenn alle Anteilsinhaber bei einer Versammlung der Anteilsinhaber anwesend oder vertreten sind und wenn sie

angeben, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige
Ladung abgehalten werden.

Ein Anteilsinhaber kann sich bei einer Versammlung der Anteilsinhaber vertreten lassen, indem er schriftlich oder per

Fax eine andere Person zu seinem Vertreter bestellt, die kein Anteilsinhaber sein muss.

Ein oder mehrere Anteilsinhaber können per Telefonkonferenz oder Videokonferenz oder mithilfe ähnlicher Kom-

munikationsmittel, die mehreren daran teilnehmenden Personen die gleichzeitige Kommunikation miteinander ermögli-
chen,  an  einer  Versammlung  teilnehmen.  Eine  solche  Teilnahme  ist  als  mit  einer  physischen  Anwesenheit  bei  der
Versammlung gleichwertig anzusehen.

Die Geschäftsführung kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, die zur Teilnahme an einer Hauptversammlung der

Anteilsinhaber erfüllt werden müssen.

Sofern das Gesetz keine abweichende Regelung vorsieht, ist mit jedem Anteil eine Stimme verbunden.
Jeder Anteilsinhaber kann seine Stimme per Briefwahl abgeben. Dazu darf der Anteilsinhaber nur die von der Gesell-

schaft zur Verfügung gestellten Abstimmungsformulare verwenden.

Alle ausgefüllten und unterzeichneten Abstimmungsformulare sind entweder persönlich mit Eingangsbestätigung, per

Einschreiben oder per Kurier an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft zuzustellen.

Jedes Abstimmungsformular („formulaire"), das nicht vom jeweiligen Anteilsinhaber bzw. seinem ermächtigten Ver-

treter unterzeichnet ist und nicht die folgenden Angaben enthält, ist nichtig:

- den Namen und eingetragenen Sitz und/oder Wohnsitz des jeweiligen Anteilsinhabers;
- die Gesamtzahl der Anteile und ggf. die Anzahl der Anteile jeder Klasse, die der jeweilige Anteilsinhaber am Anteils-

kapital der Gesellschaft hält;

- den Ort, das Datum und die Uhrzeit der abzuhaltenden Hauptversammlung;
- die Tagesordnung der abzuhaltenden Hauptversammlung;
- die Stimmabgabe des jeweiligen Anteilsinhabers, die in Bezug auf jede Beschlussvorlage angibt, ob der jeweilige An-

teilsinhaber sich enthält oder für oder gegen diese Beschlussvorlage stimmt; und

- ggf. den Namen und Titel des ermächtigten Vertreters des jeweiligen Anteilsinhabers.
Abstimmungsformulare („formulaire") müssen bis 18 Uhr Luxemburger Zeit am dem Tag, an dem die Hauptversamm-

lung  abgehalten  werden  soll,  unmittelbar  vorhergehenden  Tag,  an  dem  die  Banken  im  Großherzogtum  Luxemburg
allgemein für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, bei der Gesellschaft eingehen. Sämtliche nach dieser Frist bei der Ge-
sellschaft eingehenden Abstimmungsformulare („formulaire") werden nicht berücksichtigt.

Bei jeder Hauptversammlung der Anteilsinhaber führt der Vorsitzende der Geschäftsführung oder in seiner Abwe-

senheit eine andere von der Hauptversammlung der Anteilsinhaber bestellte Person den Vorsitz.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung der Anteilsinhaber bestellt einen Sekretär.
Die Hauptversammlung der Anteilsinhaber bestellt einen oder mehrere Stimmenzähler.
Der Vorsitzende der Hauptversammlung der Anteilsinhaber bildet zusammen mit dem Sekretär und den auf diese

Weise bestellten Stimmenzählern den Vorstand der Hauptversammlung.

122471

L

U X E M B O U R G

Es wird eine Anwesenheitsliste mit den Namen der Anteilsinhaber, der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile und

ggf. dem Namen ihres Vertreters erstellt und vom Vorstand der Hauptversammlung der Anteilsinhaber bzw. von ihren
Vertretern unterzeichnet.

Sofern  das  Gesetz  oder  die  vorliegende  Satzung  keine  abweichende  Regelung  vorsehen,  müssen  Änderungen  der

vorliegenden Satzung von (i) einer zahlenmäßigen Mehrheit der Anteilsinhaber, die (ii) drei Viertel des Anteilskapitals
vertreten, genehmigt werden.

Sofern das Gesetz oder diese Satzung keine abweichende Regelung vorsehen, müssen alle sonstigen Beschlüsse von

Anteilsinhabern gefasst werden, die über die Hälfte des Anteilskapitals vertreten. Wenn die erste Versammlung nicht
beschlussfähig ist, werden die Anteilsinhaber per Einschreiben ein zweites Mal geladen oder konsultiert, und Beschlüsse
werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen unabhängig vom vertretenen Anteil am Anteilskapital gefasst.

Art. 24. Protokollierung von Beschlüssen der Anteilsinhaber.  Protokolle  der  schriftlichen  Beschlüsse  des  einzigen

Anteilsinhabers bzw. der Hauptversammlungen der Anteilsinhaber werden vom einzigen Anteilsinhaber bzw. vom Vor-
stand der Versammlung erstellt und unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der Beschlüsse des einzigen Anteilsinhabers bzw. der Protokolle der Hauptversammlung der

Anteilsinhaber sind von allen Geschäftsführungsmitgliedern vom einzigen Geschäftsführungsmitglied, Vorsitzenden der
Geschäftsführung bzw. zwei Geschäftsführungsmitgliedern zu bescheinigen.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am

letzten Tag des Monats Dezember jedes Jahres.

Art. 26. Genehmigung des Jahresabschlusses. Am Ende jedes Geschäftsjahrs werden die Bücher geschlossen und die

Geschäftsführung  erstellt  den  Jahresabschluss  der  Gesellschaft  im  Einklang  mit  dem  Gesetz  und  legt  diesen  den  Ab-
schlussprüfern  zur  Prüfung  sowie  dem  einzigen  Anteilsinhaber  bzw.  der  Hauptversammlung  der  Anteilsinhaber  zur
Genehmigung vor.

Jeder Anteilsinhaber oder sein Vertreter kann den Jahresabschluss wie im Gesetz geregelt am eingetragenen Sitz der

Gesellschaft einsehen.

Art. 27. Zuweisung von Gewinnen. Fünf Prozent (5 %) des Jahresnettogewinns der Gesellschaft werden den durch das

Gesetz vorgeschriebenen Rücklagen zugewiesen. Diese Zuweisung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange sich
die Rücklagen auf zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Anteilskapitals der Gesellschaft belaufen.

Der einzige Anteilsinhaber bzw. die Hauptversammlung der Anteilsinhaber bestimmt, wie der verbleibende Jahres-

nettogewinn verwendet wird. Er bzw. sie kann beschließen, den Rest ganz oder teilweise dem Ausgleich eventueller
bestehender Verluste zuzuweisen, Rücklagen oder Rückstellungen zu bilden oder den Rest auf das nächste Geschäftsjahr
vorzutragen oder als Dividende an die Anteilsinhaber auszuschütten.

Art. 28. Zwischendividenden. Die Geschäftsführung ist befugt, im Einklang mit dem Gesetz Zwischendividenden aus-

zuzahlen.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation der Gesellschaft

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des einzigen Anteilsinhabers bzw. der

Hauptversammlung der Anteilsinhaber aufgelöst werden, für den dieselben Anforderungen in Bezug auf die Beschlussfä-
higkeit  und  die  Mehrheitsbildung  gelten  wie  für  die  Änderung  dieser  Satzung,  sofern  das  Gesetz  keine  abweichende
Regelung vorsieht.

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren (die natürliche

oder juristische Personen sein können) durchgeführt, die vom einzigen Anteilsinhaber bzw. von der Hauptversammlung
der Anteilsinhaber bestellt werden, der bzw. die deren Befugnisse und Vergütung bestimmt.

Das nach der Zahlung aller offenen Schulden und Lasten gegen die Gesellschaft einschließlich von Steuern und Auf-

wendungen im Zusammenhang mit dem Liquidationsprozess verbleibende Nettovermögen der Gesellschaft ist gleichmä-
ßig anteilig gemäß der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile an die Anteilsinhaber zu verteilen.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem anwendbaren

Recht.

<i>Üebergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile wurden vollständig von den Anteilseignern eingezahlt (siehe Tabelle in

Englischer Originalversion), so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft zur
Verfügung steht, wie es gegenüber dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

122472

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Aufwendungen, Kosten, Honorare oder

Gebühren in jeglicher Form, belaufen sich auf schätzungsweise 1.400 EUR.

<i>Gesellschafterversammlung

Die Anteilseigner, die das gesamte gezeichneten Kapital der Gesellschaft vertreten, berufen sofort eine Gesellschaf-

terversammlung der Gesellschaft ein und fassen folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Geschäftsführungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
2. Die folgenden Personen werden für einen unbestimmten Zeitraum in Übereinstimmung mit geltendem Recht als

Geschäftsführungsmitglieder bestellt:

1. Mr. Murat Cem SERTOGLU, Geschäftsmann, geboren in Ankara am 23. Oktober 1971, geschäftsansässig in Sari

Konaklar B41 d5, Etiler 32335, Istanbul, Türkei, mit Türkischer Nationalität;

2. Mr. Roland MANGER, Geschäftsmann, geboren in Speyer am 15. November 1963, geschäftsansässig in Waldschul-

strasse 70a, 81872 München, Deutschland, mit Deutscher Nationalität;

3. Mr. Evren UCOK, Geschäftsmann, geboren in Istanbul am 23. November 1975, geschäftsansässig in Bahcesehir 1.

Kisim Mah. Nilüfer Cayi Sok. Villa 7 No:1; Basaksehir - Istanbul, Türkei, mit Türkischer Nationalität;

3. Als Abschlussprüfer ("commissaire aux comptes") wird Kohnen &amp; Associés S.à r.l. mit Sitz in 62, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg bestellt.

4. Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft befindet sich in 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Großher-

zogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor-und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar

bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: Seidl, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 juillet 2013. Relation: RED/2013/1212. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 22 août 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013121698/694.
(130148303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

F.E. Luxfinco Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 179.753.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty ninth day of July.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

"Future Electronics Inc" existing under New Brunswick Law, with a registered office at 10 

th

 Floor, Brunswick House,

44 Chipman Hill, P.O. Box 7288, Station "A", Saint-John, New Brunswick, Canada, E2L 4S6, and a chief executive office
at 237 Hymus Boulevard, Pointe-Claire, Québec, Canada, H9R 5C7, registered under the Business Corporations Act of
New Brunswick under number 505565 and with the Québec Régistraire des entreprises under number 1143366962,

here represented by Maître Véronique WAUTHIER, lawyer, residing professionally in L-1142 Luxembourg, 10 rue

Pierre d'Aspelt, by virtue of a power of attorney given on July 25, 2013.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association (the Articles) of a private limited liability company (the Company):

122473

L

U X E M B O U R G

Art. 1. Name. There is formed by the present deed a private limited liability company under the name F.E. Luxfinco

Services.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is primarily to engage in, make, purchase or invest in loans,

securities or other financial assets.

The Company may also (i) acquire participations, either in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in

any form whatsoever, and participate in the administration, management, control and development of such participations;
(ii) acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and/or other parti-
cipation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments, and more generally any
securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever; (iii) participate in the creation,
development, management and control of any companies or enterprises; and (iv) make direct or indirect investments and
invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or
origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever except by way of public offer. It may issue, by way of private

placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries,
affiliated companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant securities over all or over some of its assets to guarantee its own
obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons, and, generally, for
its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons, in each case to the extent that those activities are
not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange,
interest rates risks and any other risks.

The Company may in general perform all operations and transactions that directly or indirectly favor or relate to its

object.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

Shareholder or in the case of plurality of Shareholders by means of a resolution of the Shareholders' general meeting.

Agencies or branches may be established by the Company in any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg

or abroad.

Art. 5. Capital. The corporate capital is set at twenty five thousand US dollars (USD 25,000.-) represented by
(i) twenty five thousand (25,000) ordinary shares of one US dollar (USD 1.-) each, all attributed to the sole Shareholder,

Future Electronics Inc. (the Ordinary Shares). The holder(s) of Ordinary Shares are hereinafter individually referred to
as an Ordinary Shareholder and collectively as the Ordinary Shareholders; and

(ii) zero (0) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS and, together with the Ordinary Shares, the Shares)

with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up, which are redeemable in accordance
with these Articles. The holder(s) of MRPS are hereinafter individually referred to as a MRPS Shareholder and collectively
as the MRPS Shareholders. The Ordinary Shareholder(s) and the MRPS Shareholder(s) are hereinafter collectively referred
to as the Shareholders.

The Company shall maintain a share premium reserve account for the Ordinary Shares (the Ordinary Share Premium

Reserve Account) in US dollars, and there shall be recorded to such account, the amounts or values of any premium paid
up on the Ordinary Shares. Amounts so recorded to this share premium reserve account will constitute freely distribu-
table reserves of the Company for the sole benefit of the Ordinary Shareholders.

The Company shall maintain a share premium reserve account for the MRPS (the MRPS Share Premium Reserve

Account) in US dollars, and there shall be recorded to such account, the amounts or values of any premium paid up in
relation to the MRPS. Amounts so recorded to the MRPS Share Premium Reserve Account will constitute freely distri-
butable reserves of the Company for the sole benefit of the MRPS Shareholders.

Towards the Company, the Shares are indivisible since only one owner is recognized per Share.
The creditors, beneficiaries or heirs are not allowed for any reason whatsoever to seal the assets and the documents

of the Company off.

The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by decision of the Shareholders'

general meeting.

Art. 6. Redemption.
6.1. General - Acquisition or redemption by the Company of Shares.
The Company may redeem its own Ordinary Shares and MRPS provided that the Company has sufficient distributable

reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

122474

L

U X E M B O U R G

6.2. Mandatory redemption or acquisition of the MRPS by the Company.
6.2.1 To the extent permitted by Law, at the Redemption Date, the Company must redeem or acquire all (but not

some) of the MRPS still outstanding on that date.

6.2.2 At the Redemption Date, if the Company has insufficient distributable reserve to redeem in cash and/or in kind

all the MRPS at the Redemption Price (as defined below), each MRPS shall be redeemed in full, in cash and/or in kind for
the portion of the available distributable reserve divided by the number of MRPS (the Partial Payment). The Company
shall, in priority to any other amounts payable in respect of its share capital, pay in cash and/or in kind the difference
between the Redemption Price per MRPS and the Partial Payment to the former MRPS Shareholders but only upon the
condition (condition suspensive) and at the moment when the Company will have sufficient distributable reserve for such
payment.

6.3. Optional redemption of the MRPS by the Company.
Subject to article 6.1 the Company may redeem MRPS in cash and/or in kind (including but without being limited to

the allocation of Company's assets) with prior written notice, as described under article 8.

Art. 7. Consideration payable to MRPS Shareholder(s) on redemption or acquisition. The MRPS Shareholder(s), in

consideration of a redemption or acquisition of its(their) MRPS by the Company under article article 6, shall be entitled
to receive an amount (either in cash and/or in kind) equal to the sum of (the Redemption Price): (i) the MRPS Investment
Amount pro rata to the MRPS being redeemed or acquired; and (ii) the MRPS Coupon Entitlement pro rata to the MRPS
being redeemed or acquired; and (iii) the balance of the MRPS Profit Account pro rata to the MRPS being redeemed or
acquired, whereby the balance of the MRPS Profit Account is determined on the assumption that the calendar day im-
mediately preceding the resolution of the Shareholder(s) deciding on the redemption is a MRPS Period End Date.

Art. 8. MRPS redemption procedure.
8.1. At least ten (10) calendar days prior to the redemption date, written notice shall be delivered in person or sent

by registered mail, post, fax, email or by service of process to each registered MRPS Shareholder, at his, its or her address
last shown in the register of the MRPS Shareholders, notifying such MRPS Shareholders of the number of MRPS to be
redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the necessary procedure(s) to submit the MRPS to the
Company for redemption and the anticipated date of the general meeting of Shareholders resolving on the redemption
of MRPS. Save as otherwise agreed, the redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose
name appears on the register of the MRPS Shareholders as the owner thereof on the bank account provided to the
Company by such MRPS Shareholder before the redemption date, subject as the case may be to the provisions of articles
6.2.1 and 7.

8.2. Any notice or other communication to be given under this article shall be in writing and may be delivered in person

or sent by registered mail, post, fax, email or service of process to the relevant party and shall be deemed to be given:
(i) if delivered in person or by registered mail, respectively at the time of delivery or the day of delivery; or (ii) if sent by
post, at 10.00 a.m. on the second Business Day after it was put into the post, if sent within the same jurisdiction, or at
10.00 a.m. on the third Business Day after it was put into the post, if sent by airmail; or (iii) if sent by fax, at 10.00 a.m.
(local time at the place of destination) on the next Business Day following the date of dispatch, or (iv) if sent by email, at
10.00 a.m. (local time at the place of destination) on the next Business Day following the date of sending. In proving service
of a notice or document, it shall be sufficient to prove that delivery was made or that the envelope containing the notice
or communication was properly addressed and posted, or that the fax or email was properly addressed and sent.

Art. 9. Transfer of Shares. In case of a sole Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are

freely transferable.

The transfer of Shares "inter vivos" to non-Shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of the

Shareholders representing at least three-quarters of the corporate capital.

Corporate Shares may not be transmitted by reason of death to non-Shareholders except with the approval of the

general meeting of the Shareholders representing at least three-quarters of the Shares owned by the survivors. In this
case however, no consent shall be required where the Shares are transferred either to ascendants or descendants or to
the surviving spouse.

In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the fundamental law of 10 

th

 August, 1915 on commercial companies as modified (the Law).

Art. 10. Death, Suppression of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the Shareholder(s). The death, suspension of

civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders will not bring the Company
to an end.

Art. 11. Management and Representation. The Company is managed and administered by one or more managers,

appointed by the sole Shareholder or the Shareholders general meeting which sets their powers. The sole manager or
the board of managers may, under its liability, delegate its powers to one or more agents. The Shareholders may decide
to appoint managers of two different classes, i.e. one (1) or several class A managers and one (1) or several class B
managers.

122475

L

U X E M B O U R G

If several managers have been appointed, the Company is managed by the board of managers which may appoint

between its members a president. It may also appoint a secretary, whether manager or not, who will be in charge of the
drafting of the minutes of the board of managers meetings.

The board of managers shall meet upon call of any manager at the place indicated in the convening notice. The president

shall preside all the meetings of the board of managers; in the absence of a president, the board of managers may appoint
at the majority of the members present during this meeting any other manager to preside these meetings.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice. The notice may be waived by the consent in writing, or by email, facsimile or
by any other similar means of communication, of each member of the board of managers. Separate written notice shall
not be required for a meeting that is held at the time and place prescribed in a schedule previously adopted by resolution
of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by email, facsimile or by any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of
his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak
to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board of managers may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented.

Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided
that if the Shareholders have appointed one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers, at
least one (1) class A and one (1) class B manager vote in favour of the resolutions.

The resolutions are validly taken by the unanimity of the managers present or represented.
Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been

appointed, by all the managers present or represented.

The board of managers can pass circular resolutions with approval expressed on a single document or on multiple

written copies or by email, facsimile, or by any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the
whole representing the minutes evidencing the resolution.

The Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole manager or if several managers have

been appointed, by the joint signature of any two (2) managers and, in case the Shareholders have appointed one (1) or
several class A managers and one (1) or several class B managers, by the joint signature of one (1) class A manager and
one (1) class B manager.

The copies and extracts of the minutes to be produced in justice and somewhere else shall be signed by the president

or by two managers or by any person to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company. Simple representatives, they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 12. Shareholders general meetings. Each Shareholder may participate to the general meetings, independently of

the number of Shares he is holding. Each Shareholder has voting rights commensurate to the number of Shares he is
holding or representing.

If no higher quorum mentioned in the Articles, collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted

by Shareholders owning more than one-half of the corporate capital.

The Shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote. All other statutory changes may

be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the corporate capital.

Art. 13. Accounting year. The Company's year ends on December 31 of each year.

Art. 14. Profits and Distributions.
14.1. General.
The Company shall maintain (i) a legal reserve account (the Legal Reserve Account); (ii) an MRPS profit account (the

MRPS Profit Account); and (iii) a general profit account (the General Profit Account) (which is not a MRPS Profit Account),
all to be kept in US dollars (USD).

14.2. Allocation of losses.
Any losses (including notably foreign exchange losses connected to loans granted to affiliated group companies and/

or loans received from affiliated group companies) appearing from the profit and loss account adopted by the general
meeting shall be allocated as follows: (i) first, to the MRPS Profit Account, if and to the extent this account shows a
positive amount; (ii) second, the balance after the allocation pursuant to paragraph (i) above, if any, to the General Profit
Account.

14.3. Allocation of profits.

122476

L

U X E M B O U R G

The Shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits shown in the annual accounts of

the Company, which, for the avoidance of doubt, shall include the MRPS Coupon Entitlement, to the accounts referred
to in article 14.1 in the following order: (i) first, an amount corresponding to five percent (5%) of the profit distributable
by Law shall be allocated to the Legal Reserve Account, until the aggregate amount allocated to the Legal Reserve Account
is equal to ten percent (10%) of the issued corporate capital of the Company; (ii) second, with respect to any financial
year, the MRPS Coupon Entitlement that has not been fully allocated to the MRPS Profit Account due to insufficient
profits in any previous financial year shall be allocated to the MRPS Profit Account; and (iii) third, with respect to any
financial year, the MRPS Coupon Entitlement that has been allocated to the MRPS Profit Account and which has thereafter
been withdrawn from the MRPS Profit Account due to allocation of losses under article 14.2 in a subsequent financial
year shall be allocated to the MRPS Profit Account; (iv) fourth, with respect to any financial year, an amount equal to the
MRPS Coupon Entitlement for such financial year shall be allocated to the MRPS Profit Account; and (v) finally, the part
of the profit remaining after the allocations pursuant to paragraph (i) to and including (iv) shall be allocated to the General
Profit Account.

14.4. Interim dividends may be distributed in cash and/or in kind at any time, in accordance with the preferential

distribution rights as stated in these Articles and subject to the following conditions: (i) the board of managers must draw
up interim accounts; (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share pre-
mium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits
carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal
Reserve; (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the board of managers must resolve to distribute
the interim dividends; and (iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must
not be threatened by the distribution of an interim dividend.

14.5. If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the board of managers

has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the Shareholders
must immediately refund the excess to the Company if so required by the board of managers.

14.6. The final dividend with respect to a financial year must be declared by a resolution of the general meeting, taking

into consideration any advance payment on dividends declared by the board of managers with respect to the same financial
year and in accordance with the preferential distribution rights as stated in these Articles. Said dividend can be paid in
cash and/or in kind.

14.7. Each Shareholder who is entitled to receive a final dividend or, as the case may be, an advance payment on

dividends may decide that said dividend shall accrue and be paid on a later date.

Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the Shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The Shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the Shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

15.2. Any assets remaining after payment of all of the Company's debts shall be applied as follows: (i) first, to the MRPS

Shareholder(s), the MRPS Investment Amount, any accrued but unpaid MRPS Coupon Entitlement and the balance of the
MRPS Profit Account, whereby the balance of the MRPS Profit Account is determined on the assumption that the calendar
day immediately preceding the resolution of the Shareholder(s) provided for in article 15.1 is a MRPS Period End Date;
(ii) second, to the Ordinary Shareholder(s), the paid up part on the Ordinary Shares; (iii) third, to the Ordinary Share-
holder(s), the remainder after the distributions pursuant to paragraphs (i) to (ii).

15.3. After the liquidation has been completed, the books and records of the Company shall be kept for the period

prescribed by Law by the person appointed for that purpose in the resolution of the general meeting, to dissolve the
Company. Where the general meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.

Art. 16. Definitions. The following capitalised terms used in these Articles shall have the following meaning:
Applicable Margin means the arm's length margin expressed in basis points to be earned by the Company under

Luxembourg transfer pricing principles, as determined from time to time in a transfer pricing study (including addenda,
if any) prepared for the Company.

Business Day means a day (other than a Saturday or public holiday) on which commercial banks are generally open

for business in Canada or Luxembourg.

Commencement Date means July 29, 2013.
General Profit Account has the meaning given in article 14.1.
Legal Reserve Account has the meaning given in article 14.1.
MRPS has the meaning given in article 5.
MRPS Coupon Entitlement means the right conferred to the MRPS Shareholders, as a class, to receive, out of the

profits of the Company available for distribution by way of dividends (i) a preferential and cumulative dividend of 0.1%

122477

L

U X E M B O U R G

per year over the nominal value of the MRPS and the share premium attached to the MRPS which shall accrue daily and
be calculated on the basis of a 365 day a year (the Dividend 1) plus (ii) a preferential and cumulative dividend equal to (a)
any and all income derived by the Company during such MRPS Coupon Period from the MRPS Investment (including for
the avoidance of doubt any realized income and gains derived from the reinvestment of such income, foreign exchange
gains and reversal of depreciation), less (b) the total of (A) any costs directly related to the MRPS Investment (including
any interest expenses and foreign exchange losses derived from the MRPS Investment and reinvested income), (B) the
Dividend 1 and (C) the Applicable Margin.

MRPS Coupon Period means the period: (i) starting on (and including) the Commencement Date or a MRPS Period

End Date; and (ii) ending on (but not including) the next MRPS Period End Date, based on a year of 365 days and the
number of whole days in the relevant MRPS Coupon Period.

MRPS Investment means any and all of the outstanding loan receivables owned by the Company which the Company

has financed out of the proceeds received from the issuance of the MRPS.

MRPS Investment Amount means the sum of: (i) the nominal value of each MRPS multiplied by the number of MRPS

on issue; and (ii) the balance of the MRPS Share Premium Reserve Account.

MRPS Period End Date means: (i) December 31 of each year occurring before the Redemption Date; and (ii) each date

of redemption of MRPS by the Company pursuant to article 6.2, or, if such date is not a Business Day, the next Business
Day (unless that falls in the following financial year, in which case the MRPS Period End Date ends on the previous Business
Day).

MRPS Profit Account has the meaning given to it in article 14.1.
MRPS Shareholder(s) has the meaning given in article 5.
MRPS Share Premium Reserve Account has the meaning given to it in article 5.
Ordinary Shareholder(s) has the meaning given in article 5.
Ordinary Shares has the meaning given in article 5.
Ordinary Shares Share Premium Reserve Account has the meaning given to it in article 5.
Partial Payment has the meaning given in article 6.2.2.
Profit Accounts means the MRPS Profit Account and the General Profit Account.
Redemption Date means ten (10) years after the Commencement Date.
Shareholders has the meaning given in article 5.
Shares has the meaning given in article 5.

Art. 17. Various. Reference is made to the applicable provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision:

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31, 2013.

<i>Subscription and Liberation:

All the shares have been subscribed by the sole partner, "Future Electronics Inc.", prenamed, and have been fully paid-

up by contribution in cash, so that the amount of twenty five thousand US dollars (USD 25,000.-) is at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who states it.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately at one thousand one hundred seventeen euro (EUR 1,117.-).

<i>Resolutions of the sole partner:

Immediately after the incorporation, the sole Shareholder, prenamed, representing the entire subscribed capital of the

Company has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three (3).
The meeting appoints as class A manager of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Steven ADAMS, Vice-President Taxation, born in the City of Quebec on December 10, 1956, residing at 4, 111

th

 West Avenue, QC J7C 4N8 Blainville.

The meeting appoints as class B managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mrs. Véronique WAUTHIER, lawyer, prenamed,
- Mr. Marcel STEPHANY, chartered accountant, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bertrange.
2) The registered office is established in L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II.
3) An additional sum of two thousand five hundred US dollars (USD 2,500.-) transferred onto the bank account of the

Company is allocated to the Legal Reserve Account.

122478

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-neuf juillet.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

"Future Electronics Inc" existant sous la Loi de New Brunswick, avec un siège social au 10 

ème

 étage, Brunswick House,

44 Chipman Hill, P.O. Box 7288, Station "A", Saint-John, New Brunswick, Canada, E2L 4S6, et un siège d'exploitation
principal au 237 Hymus Boulevard, Pointe-Claire, Québec, Canada, H9R 5C7, immatriculée sous le Business Corporations
Act  de  New  Brunswick  sous  le  numéro  505565  et  auprès  du  Québec  Régistraire  des  entreprises  sous  le  numéro
1143366962,

ici représentée par Maître Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Lu-

xembourg, 10 rue Pierre d'Aspelt en vertu d'une procuration donnée le 25 juillet 2013.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée (la Société) dont elle a arrêté les statuts (les Statuts) comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de

F.E. Luxfinco Services.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est principalement de s'engager dans, accorder, acheter ou investir dans des

prêts, valeurs ou autres actifs financiers.

La Société peut également (i) acquérir des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et participer à l'administration, à la gestion, au contrôle et au développement
de ces participations; (ii) acquérir par voie de souscription, d'achat, et d'échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette,
et, en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée; (iii) participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises; et (iv) effectuer directement
ou indirectement des investissements et investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres
représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou
à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres
obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière
générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces
activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue

de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou

indirectement ou se rapportent à son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'Associé

unique ou en cas de pluralité d'Associés par décision de l'assemblée générale des Associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg ou à

l'étranger.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille US dollars (USD 25.000,-) divisé en

122479

L

U X E M B O U R G

(i) vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires de un US dollar (USD 1,-) chacune, toutes attribuées à l'Associé

unique, Future Electronics Inc. (les Parts Sociales Ordinaires). Le(s) détenteur(s) des Parts sociales Ordinaires sont ci-
après désignés individuellement comme un Associé Ordinaire et ensemble comme les Associés Ordinaires; et

(ii) zéro (0) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les PSPOR et, ensemble avec les Parts Sociales

Ordinaires, les Parts Sociales) ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement  libérées,  qui  sont  rachetables  conformément  à  ces  Statuts.  Le(s)  détenteur(s)  des  PSPOR  sont  ci-après
désignés individuellement comme un Associé PSPOR et ensemble comme les Associés PSPOR. L'(les) Associé(s) Ordinaire
(s) et l'(les) Associé(s) PSPOR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.

La Société devra maintenir un compte de réserve de prime d'émission pour les Parts Sociales Ordinaires (le Compte

de Réserve de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires) en dollars US et il y sera enregistré le montant ou la valeur
de toute prime payée en relation avec les Parts Sociales Ordinaires. Les montants ainsi enregistrés sur ce compte de
réserve de prime d'émission constitueront des réserves librement distribuables de la Société pour le seul bénéfice des
Associés Ordinaires.

La Société devra maintenir un compte de réserve de prime d'émission lié aux PSPOR (le Compte de Réserve de Prime

d'Emission des PSPOR) en dollars US et il y sera enregistré le montant ou la valeur de toute prime payée en relation avec
les PSPOR. Les montants ainsi enregistrés sur ce Compte de Réserve de Prime d'Emission des PSPOR constitueront des
réserves librement distribuables de la Société pour le seul bénéfice des Associés PSPOR.

Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les créanciers, bénéficiaires ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens

et documents de la Société.

Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'Associé unique sinon de l'assemblée

générale des Associés.

Art. 6. Rachat.
6.1. Généralités - Acquisition ou rachat des Parts Sociales par la Société.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales Ordinaires et PSPOR à condition qu'elle dispose des réserves

distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

6.2. Rachat obligatoire ou acquisition des PSPOR par la Société.
6.2.1. Dans la mesure permise par la Loi, à la Date de Rachat, la Société devra racheter ou acquérir toutes (et non une

partie) les PSPOR encore en circulation à cette date.

6.2.2. A la Date de Rachat, si la Société ne dispose pas de réserves distribuables suffisantes pour racheter en numéraire

et/ou en nature toutes les PSPOR au Prix de Rachat (tel que défini ci-dessous), chaque PSPOR sera rachetée en entier,
en numéraire et/ou en nature dans la mesure des réserves distribuables disponibles divisées par le nombre de PSPOR (le
Paiement Partiel). La Société paiera, de manière prioritaire par rapport à tous les autres montants dus relatifs à son capital
social, la différence entre le Prix de Rachat par PSPOR et le Paiement Partiel à tous les anciens Associés PSPOR mais à
la condition suspensive que et lorsque la Société disposera de réserve distribuables suffisantes pour effectuer ledit paie-
ment.

6.3. Rachat optionnel des PSPOR par la Société.
Sous réserve de l'article 6.1, la Société peut racheter des PSPOR en numéraire et/ou en nature avec un avis préalable

écrit, tel que prévu à l'article 8.

Art. 7. Contrepartie due à l'(aux) Associé(s) PSPOR lors du rachat ou de l'acquisition.
7.1. L'(les) Associé(s) PSPOR recevra(ont), en contrepartie d'un rachat ou d'une acquisition de ses(leurs) PSPOR par

la Société en vertu de l'article 6, un montant (en numéraire ou en nature) équivalant à la somme (le Prix de Rachat): (i)
du Montant d'Investissement PSPOR proportionnellement aux PSPOR rachetées ou acquises, et (ii) du Droit au Coupon
PSPOR proportionnellement aux PSPOR rachetées ou acquises, et (iii) du solde du Compte de Profits PSPOR propor-
tionnellement aux PSPOR rachetées ou acquises, lorsque le solde du Compte de Profits PSPOR est déterminé en assumant
que le jour calendaire précédant immédiatement la résolution de l'(des) Associé(s) décidant du rachat est un Jour de Fin
de Période PSPOR.

Art. 8. Procédure de rachat des PSPOR.
8.1. Dix (10) jours calendaires au moins avant la date de rachat, un avis écrit sera délivré en personne ou envoyé par

lettre recommandée, courrier, fax, e-mail ou notification à chaque Associé PSPOR enregistré, à la dernière adresse figurant
dans le registre des Associés PSPOR, indiquant à cet Associé PSPOR le nombre de PSPOR qui seront rachetées, ainsi
que la date de rachat, le prix de rachat, la procédure de remise des PSPOR à la Société pour rachat et la date prévue de
l'assemblée générale des Associés statuant sur le rachat des PSPOR. Sauf disposition contraire, le prix de rachat desdites
PSPOR sera dû à l'ordre de la personne dont le nom figure dans le registre des Associés PSPOR comme en étant le
détenteur et sur le compte bancaire fourni à la Société par ledit Associé PSPOR avant la date de rachat, sous réserve le
cas échéant des dispositions des articles 6.2.1 et 7.

8.2. Tout avis ou autre communication devant être envoyé conformément au présent article sera écrit et délivré en

personne ou envoyé par lettre recommandée, courrier, fax, e-mail ou notification à la partie concernée et sera considéré

122480

L

U X E M B O U R G

comme reçu: (i) dans le cas d'une livraison en personne ou par lettre recommandée, respectivement au moment de la
livraison ou le jour de la livraison; ou (ii) dans le cas d'un envoi par courrier, à 10.00 heures du matin, le deuxième Jour
Ouvrable suivant l'envoi à la poste, dans le cas d'un envoi dans la même juridiction ou à 10.00 heures du matin le troisième
Jour Ouvrable suivant après l'envoi à la poste dans le cas d'un envoi par avion; ou (iii) dans le cas d'un envoi par fax, à
10.00 heures du matin (heure locale de destination) le Jour Ouvrable suivant la date d'envoi; ou (iv) dans le cas d'un envoi
par e-mail, à 10.00 heures du matin (heure locale de destination) le Jour Ouvrable suivant la date d'envoi. Pour prouver
l'envoi d'un avis ou d'un document, il sera suffisant de prouver la livraison ou que l'enveloppe contenant l'avis ou le
document a été correctement adressée ou postée ou que le fax ou l'e-mail a été correctement adressé ou envoyé.

Art. 9. Cession des Parts Sociales. Toutes cessions de Parts Sociales détenues par l'Associé unique sont libres.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-Associé que de l'accord donné en assemblée générale des Associés

représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément donné

en assemblée générale des Associés représentant les trois-quarts des parts appartenant aux Associés survivants. Dans ce
dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les Parts Sociales sont transmises soit à des ascendants
ou descendants, soit au conjoint survivant.

En cas de pluralité d'Associés, les Parts Sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi fondamentale du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi).

Art. 10. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture de l'(des) Associé(s). Le décès, l'interdiction, la faillite ou la dé-

confiture de l'Associé unique, sinon d'un des Associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 11. Gestion et Représentation. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par

l'Associé unique ou les Associés réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant unique ou le conseil
de gérance peuvent sous leur responsabilité déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir. Les Associés
peuvent décider de répartir les gérants en différentes catégories, à savoir un (1) ou plusieurs gérants de catégorie A et
un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par le conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un

président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut
pas représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir uniquement en cas de majorité de ses membres présents ou

représentés. Dans l'éventualité où un (1) ou plusieurs gérants de catégorie A et un (1) ou plusieurs gérants de catégorie
B ont été nommés, au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B doivent approuver la résolution.

Les résolutions sont valablement prises si elles sont approuvées à l'unanimité des gérants présents ou représentés.
Les décisions du conseil de gérance sont actées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, en

l'absence de président, par tous les gérants présents ou représentés.

Le conseil de gérance pourra prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un

ou de plusieurs écrits ou par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit,
le tout ensemble constituant le procès-verbal faisait preuve de la décision intervenue.

Pour engager valablement la Société, la signature du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, la signature

conjointe de deux (2) gérants et, dans l'éventualité où un (1) ou plusieurs gérants de catégorie A et un (1) ou plusieurs
gérants de catégorie B ont été nommés, la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie A et d'un (1) gérant de catégorie
B est requise.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par

deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

122481

L

U X E M B O U R G

Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. Assemblées générales des Associés. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le

nombre de Parts Sociales qui lui appartient. Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales qu'il
détient ou représente.

Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises

que pour autant qu'elles ont été adoptées par des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les Associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

Statuts sont décidées à la majorité des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Bénéfices et Distributions.
14.1. Généralités
La Société aura: (i) un compte de réserve légale (le Compte de Réserve Légale); (ii) un compte de profits PSPOR (le

Compte de Profits PSPOR); et (iii) un compte général de profits (le Compte Général de Profits) (qui n'est pas un compte
de Profits PSPOR), tous libellés en dollars US (USD).

14.2. Affectation des Pertes.
Toutes les pertes (en ce compris notamment les pertes liées aux taux de change, connectées aux prêts octroyés aux

sociétés affiliées du groupe et/ou les prêts reçus de sociétés affiliées du groupe) figurant dans le compte de profits et
pertes adopté par l'assemblée générale seront affectées de la manière suivante: (i) premièrement, au Compte de Profits
PSPOR si et dans la mesure où le solde de ce compte est positif; (ii) deuxièmement, le solde restant après affectation en
vertu du paragraphe (i) ci-dessus, au Compte Général de Profits.

14.3. Affectation des bénéfices.
Les Associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels figurant dans les comptes annuels de la

Société, qui, en tout état de cause, doivent inclure le Droit au Coupon PSPOR, sur les comptes mentionnés à l'article
14.1 dans l'ordre suivant: (i) premièrement, un montant correspondant à cinq pour cent (5%) des bénéfices distribuables
selon la Loi, sera affecté au Compte de Réserve Légale jusqu'à ce que le montant total affecté au Compte de Réserve
Légale corresponde à dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société; (ii) deuxièmement, lors de chaque
exercice social, le Droit au Coupon PSPOR qui n'aura pas entièrement été affecté au Compte de Profits PSPOR en raison
de bénéfices insuffisants lors d'un exercice social précédent, sera affecté au Compte de Profits PSPOR; (iii) troisièmement,
lors de chaque exercice social, le Droit au Coupon PSPOR qui a été affecté au Compte de Profits PSPOR mais qui a
ensuite été retiré du Compte de Profits PSPOR en raison de l'affectation des pertes en vertu de l'article 14.2 lors d'un
exercice social subséquent sera affecté au Compte de Profits PSPOR; (iv) quatrièmement, lors de chaque exercice social,
un montant correspondant au Droit au Coupon PSPOR pour ledit exercice social sera affecté au Compte de Profits
PSPOR; et (v) enfin, le solde des bénéfices restant après affectation en vertu des paragraphes (i) à (iv) inclus ci-dessus
sera affecté au Compte Général de Profits.

14.4. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués en numéraire et/ou en nature, conformément aux droits de

distribution préférentiels tel qu'indiqué dans ces Statuts et sous réserve des conditions suivantes: (i) des comptes intér-
imaires sont établis par le conseil de gérance; (ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices
et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant
à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes
annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par
les pertes reportées et les sommes à affecter à la Réserve Légale; (iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires
doit être adoptée par le conseil de gérance dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et (iv) compte
tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la distribution de
dividendes intérimaires.

14.5. Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

le conseil de gérance a le droit de réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices
réellement acquis et les Associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du conseil de gérance.

14.6. Le dividende final d'un exercice social sera déclaré par une résolution de l'assemblée générale en tenant compte

de toute avance sur le paiement des dividendes déclarée par le conseil de gérance lors dudit exercice social et en con-
formité avec les droits de distribution préférentiels indiqués dans ces Statuts. Ledit dividende peut être payé en numéraire
ou en nature.

14.7. Tout Associé en droit de recevoir un dividende final ou, le cas échéant, un dividende intérimaire, peut décider

que ledit dividende coure et soit payé à une date ultérieure.

Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Associés adoptée par la majorité (en nombre)

des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les Associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,

122482

L

U X E M B O U R G

Associés ou non, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des Associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

15.2. Tous les actifs restant après le paiement de toutes les dettes de la Société seront affectés de la manière suivante:

(i) premièrement, à l' ou aux Associé(s) PSPOR, le Montant d'Investissement PSPOR et le solde du Compte de Profits
PSPOR, le solde du Compte de Profits PSPOR sera calculé en assumant que le jour calendaire précédant immédiatement
la résolution des Associés prévue à l'article 15.1 est une Date de Fin de Période PSPOR; (ii) deuxièmement, à l' ou aux
Associé(s) Ordinaire(s), la partie libérée des Parts Sociales Ordinaires; (iii) troisièmement, à l' ou aux Associé(s) Ordinaire
(s), le solde restant après affectations conformément aux paragraphes (i) à (ii).

15.3. Après la clôture de la liquidation, les livres et dossiers de la Société seront conservés pendant la période prévue

par la Loi par la personne nommée à cet effet dans la résolution de l'assemblée générale décidant de dissoudre la Société.
Si l'assemblée générale n'a pas nommé de telle personne, les liquidateurs s'en chargeront.

Art. 16. Définitions. Les termes définis suivants utilisés dans les présents Statuts auront la signification suivante:
Marge Applicable signifie la marge dans des conditions normales de concurrence, exprimée en points de base, que la

Société peut gagner selon les règles sur les prix de transfert en vigueur à Luxembourg, telle que déterminée dans le temps
dans une étude sur les prix de transfert (y compris les addenda, le cas échéant) établie pour la Société.

Jour Ouvrable signifie un jour (autre qu'un samedi ou jour férié) lors duquel les banques commerciales sont généra-

lement ouvertes pour affaires au Canada ou à Luxembourg.

Date de Début signifie le 29 juillet 2013.
Compte Général de Profits a la signification qui lui est attribuée à l'article 14.1.
Compte de Réserve Légale a la signification qui lui est attribuée à l'article 14.1.
PSPOR a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.
Droit au Coupon PSPOR signifie le droit conféré aux Associés PSPOR, en tant que classe, de recevoir, hors des

bénéfices de la Société disponibles à la distribution par voie de dividendes (i) un dividende préférentiel et cumulatif de
0,1% par an sur la valeur nominale des PSPOR et la prime d'émission y attachée qui portera intérêt quotidiennement et
qui sera calculé sur une base de 365 jours par an (le Dividende 1) plus (ii) un dividende préférentiel et cumulatif égal à
(a) tout revenu tiré d'un Investissement PSPOR par la Société pendant cette Période de Coupon PSPOR (en ce compris,
en tout état de cause, tout revenu réalisé et gains tirés du réinvestissement de ces revenus, gains provenant d'opérations
de change et amortissements récupérés), moins (b) le total de (A) tous coûts directement liés à un Investissement PSPOR
(en ce compris toutes charges d'intérêts et pertes provenant d'opérations de change liées aux Investissement PSPOR et
revenu réinvesti), (B) le Dividende 1 et (C) la Marge Applicable.

Période de Coupon PSPOR signifie la période: (i) commençant à (et incluant) la Date de Début ou la Date de Fin de

Période PSPOR; et (ii) prenant fin (et n'incluant pas) la Date de Fin de Période PSPOR suivante, sur base d'une année de
365 jours et du nombre de jours entiers dans ladite Période de Coupon PSPOR. Investissement PSPOR signifie toutes
créances de prêts en cours détenues par la Société que la Société a financé hors des produits tirés de l'émission des
PSPOR.

Montant d'Investissement PSPOR signifie la somme de: (i) la valeur nominale de chaque PSPOR multipliée par le nombre

de PSPOR en circulation; et (ii) le solde du Compte de Réserve de Prime d'Emission PSPOR.

Date de Fin de Période PSPOR signifie: (i) le 31 décembre de chaque année avant la Date de Rachat; et (ii) chaque date

de rachat de PSPOR par la Société en vertu de l'article 6.2 ou, si cette date n'est pas un Jour Ouvrable, le Jour Ouvrable
suivant (sauf si ce jour tombe dans l'exercice social suivant, auquel cas, la Date de Fin de Période PSPOR prendra fin le
Jour Ouvrable précédent).

Compte de Profits PSPOR a la signification qui lui est attribuée à l'article 14.1.
Associé(s) PSPOR a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.
Compte de Réserve de Prime d'Emission des PSPOR a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.
Associé(s) Ordinaire(s) a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.
Parts Sociales Ordinaires a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.
Compte de Réserve de Primes d'Emission des Parts Sociales Ordinaires a la signification qui lui est attribuée à l'article

5.

Paiement Partiel a la signification qui lui est attribuée à l'article 6.2.2.
Compte de Profits signifie le Compte de Profits PSPOR et le Compte Général de Profits.
Date de Rachat signifie dix (10) années après la Date de Début.
Associés a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.
Parts Sociales a la signification qui lui est attribuée à l'article 5.

Art. 17. Divers. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les Associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

122483

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire:

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2013.

<i>Souscription et Libération:

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'Associé unique, "Future Electronics Inc.", prénommée, et ont été

intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille US dollars (USD 25.000,-) se
trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cent dix-sept euros (1.117,-
EUR).

<i>Décisions de l'associé unique:

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé unique prénommé, représenté comme ci-avant et repré-

sentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3).
Est nommé gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Steven ADAMS, Vice-Président Fiscalité, né à Québec, le 10 décembre 1956, demeurant au 4, 111 

ème

Avenue Ouest, QC J7C 4N8 Blainville.

Sont nommés gérants de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Véronique WAUTHIER, prénommée,
- Monsieur Marcel STEPHANY, expert-comptable, demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bertrange.
2) L'adresse du siège social de la Société est établie à L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II.
3) Une somme complémentaire de deux mille cinq cents US dollars (USD 2.500,-) a été transférée sur le compte

bancaire de la Société et sera affectée au Compte de Réserve Légale.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de cette même comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

nous, notaire.

Signé: V.WAUTHIER, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30/07/2013. Relation: LAC/2013/35624. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 26/08/2013.

Référence de publication: 2013121732/621.
(130148008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

La Boqueria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2011 Luxembourg, 46, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 179.748.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the fourteenth day of August.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

GGM Investments S.à.r.l., a limited liability company established under the laws of Luxembourg, established and having

its registered office at L-5265 Munsbach, 2, rued Gabriel Lippmann, filed with the Registre de Commerce et des Sociétiés
de Luxembourg under number B-154,746,

here represented by its sole manager Mr. Guillermo Morales, professionally residing in Luxembourg.
Such appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the

articles of association of a société à responsabilité limitée:

122484

L

U X E M B O U R G

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended

(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The object of the corporation is the exploitation of a restaurant selling and serving alcoholic or nonalcoholic

beverages.

Supervise and/or hire on his own account or on behalf of third parties account the human resources necessary to

achieve its object and delegate in one or several persons the fulfillment of mandates commissions, services and any other
liability under its object.

In general, it may carry out all commercial, financial movable and immovable operations that are directly related to

the company object or whose nature is likely to facilitate or develop it.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "La Boqueria S. a r.l."

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided into FIVE HUN-

DRED (500) shares of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The corporation is committed by the joint signatures of two Managers or by the individual signature of the delegate

of the board.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

122485

L

U X E M B O U R G

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders representing at

least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 17. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 18. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-

first of December 2013.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company have been drawn up by the appearing party. This party has subscribed

and entirely paid-up in cash the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) representing
FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25,-) each.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the 1915 Law have been observed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an unlimited periode of time:
a.- Mr. Hugo Aguado, Cano, born in Barcelona, on 5 August 1975, residing professionally at L-2011 Luxembourg, 46,

Place Guillaume.

b.- Mr. Juan Pedro López, born in Cardoba, on 29 September 1978, residing professionally at L-2011 Luxembourg, 46,

Place Guillaume.

2) The registered office of the company is fixed at 46, Place Guillaume L-2011 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le quatorze août.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Luxembourg).

A COMPARU:

GGM Investments S.à.r.l., une société à responsabilit limitée, ayant son siège social à L-5265 Munsbach, 2, rue Gabriel

Lippmann, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétiés à Luxembourg sous le numéro B-154,746,

ici représentée par son gérant unqiue Monsieur Guillermo Morales, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.

122486

L

U X E M B O U R G

Gérer et ou employer pour son propre compte ou pour le compte de tierces parties les ressources humaines néces-

saires  à  l'accomplissement  de  son  objet  social  et  la  délégation  de  personnel  aux  fins  de  l'exécution  de  mandats,
commissions, services ou autres charges relevant de son objet social.

En général, la société pourra effectuer toute opération commerciale, financière, mobilière et immobilière nécessaires

et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination «La Boqueria S. à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CINQ CENTS

(500) parts sociales de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est engagée par les signatures conjointes de deux gérants ou par la signature individuelle du délégué du

conseil.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il

y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

122487

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 17. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 18. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2013.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ont été arrêtés par la partie comparante. Cette partie a souscrit et entièrement libéré en

espèces le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représentant CINQ CENTS (500) parts
sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article

183 de la Loi de 1915 ont été respectées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent à environ EUR 1.200.-.

<i>Décisions de l'associé

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a.- Monsieur Hugo Aguado Cano, né à Barcelone, le 5 août 1975, demeurant professionnellement à L-2011 Luxem-

bourg, 46, Place Guillaume.

b.- Monsieur Juan Pedro López, né à Cordoba, le 29 septembre 1978, demeurant professionnellement à L-2011 Lu-

xembourg, 46, Place Guillaume.

2) Le siège social est fixé à L-2011 Luxembourg, 46, Place Guillaume.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. MORALES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2013. Relation: LAC/2013/38475. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121882/208.
(130147947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

Family Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 116.096.

<i>Extrait de l’avis de l’organe de gérance

En date du 20 août 2013, la gérance de la société Family Partners SàRL prend acte de la démission de Monsieur Axel

CARDON de LICHTBUER de son mandat de gérant avec effet au 25 juin 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 20 août 2013.

Référence de publication: 2013122414/13.
(130148899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

122488

L

U X E M B O U R G

Lengau Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 145.622.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013122502/12.
(130149319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

The Park 4 Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Lux 9 Starlight EUR S.à r.l.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 176.078.

In the year two thousand thirteen, on the sixteenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The Park 3 Holdings Lux S.à r.l. (previously: Lux 8 Starlight EUR S.à r.l.), a company incorporated under the laws of

Luxembourg and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Registre
du Commerce et des Sociétés under number B 176.064, here represented by its Manager Mister Thierry Drinka, private
employee, residing professionally at L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart.

The appearing party is the sole shareholder of "Lux 9 Starlight EUR S.à r.l.", a société à responsabilité limitée established

in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 176.078, incorporated by deed enacted by Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, on March 7, 2013 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on May 18, 2013 under number 1182. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing parties requested to the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the registered name of the Company, to be changed into "The Park 4 Holdings Lux S.à r.l";
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action;
3. Acknowledgement of the change of statutory seat to 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as decided in a

resolution voted by the Board of Managers on August 1, 2013.

4. Acknowledgment of the appointment of a new manager, Mrs Peggy Murphy, as decided in a resolution voted by the

sole Shareholder on August 1, 2013.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution:

The sole shareholder resolves to change the name of the Company, from "Lux 9 Starlight EUR S.à r.l." into "The Park

4 Holdings Lux S.à r.l."

<i>Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend Article 1 of the Articles of

Association, which will henceforth read as follows:

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

"The Park 4 Holdings Lux S.à r.l." (the "Company"), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Company Law") and by the present articles
of association (the "Articles").

<i>Third resolution:

As a result of a decision taken by the managers of the Board in a resolution dated August 1, 2013 to transfer the

statutory seat to 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, the sole shareholder resolves to ratify this decision.

122489

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution:

The sole shareholder reminds its resolution dated August 1, 2013 to appoint Mrs Peggy Murphy, with professional

address 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as additional Manager of The Park 4 Holdings Lux S.a r.l., with
effective date August 1, 2013 for an undetermined period.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le seize août,
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

The Park 3 Holdings Lux S.à r.l. (anciennement: Lux 8 Starlight EUR S.à r.l.), une société constituée et existante sous

les lois du Luxembourg et ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 176.064, ici représentée par son Gérant Monsieur Thierry Drinka, employé
privé, demeurant professionnellement à L-2166 Luxembourg, 3, rue Mozart.

Laquelle partie déclare être l'associé unique de la société à responsabilité limitée Lux 9 Starlight EUR S.à r.l. établie et

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 176.078, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg
en date du 7 mars 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 18 mai 2013 sous le
numéro 1182. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante a requis le notaire d'acter comme suit que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de la dénomination sociale de la société, à changer en «The Park 4 Holdings Lux S.à r.l.»;
2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la société;

3. Ratification de la décision du Conseil de Gérance du 1 

er

 août 2013 décidant du transfert du siège social de la société

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

4. Constatation de la nomination de Madame Peggy Murphy en tant que gérante supplémentaire, telle que décidée

dans une résolution de l'associé unique en date du 1 

er

 août 2013.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, ce dernier a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société, de «Lux 9 Starlight EUR S.à r.l.» en «The

Park 4 Holdings Lux S.à r.l.».

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «The Park 4 Holdings

Lux S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

<i>Troisième résolution:

L'associé unique décide de ratifier la décision votée par les gérants dans une résolution du Conseil de gérance tenue

le 1 

er

 août 2013, ayant transféré le siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

122490

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution:

L'associé unique constate, pour autant que de besoins, la nomination de Madame Peggy Murphy, employée privée, avec

adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que nouveau membre du Conseil de gérance
de la société The Park 4 Holdings Lux S.à r.l. avec date effective au 1 

er

 août 2013, et pour une période indéterminée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: T. Drinka et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 août 2013. Relation: LAC/2013/38689. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013121892/109.
(130148155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

Mansfield II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 91.853.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-first day of August.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

314 Commonwealth Ave. Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered

offices at Suite 400, 2711 Centerville Road, Wilmington, 19808 Delaware, United States of America, and registered with
the State of Delaware Register under number 2850155,

here represented by:
Maître Karin BARTHOLOMÉ, lawyer, residing professionally in L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforementioned, requested the undersigned notary to record the following:
I.- 314 Commonwealth Ave. Inc., pre-named is the sole shareholder of Mansfield II S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, re-
gistered with the Luxembourg register of commerce and companies (registre de commerce et des sociétés) under the
number B 91853 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Me Léon Thomas known as Tom Metzler, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated January 24, 2003 published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 324 dated March 26, 2003 and which articles of association have been amended for the
last time by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of February 7,
2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 782 of August 4, 2005.

II.- The Company’s corporate capital is fixed at USD 681,328,100.-(six hundred eighty-one million three hundred

twenty-eight thousand one hundred US dollars), represented by 6,813,281.-(six million eight hundred thirteen thousand
two hundred eighty-one) shares with a nominal value of USD 100.(one hundred US dollars) each, all subscribed and fully
paid-up.

All 6,813,281 (six million eight hundred thirteen thousand two hundred eighty-one) shares are owned by the sole

shareholder 314 Commonwealth Ave. Inc., pre-named.

122491

L

U X E M B O U R G

314 Commonwealth Ave. Inc., represented as here above stated, acting in its capacity as sole shareholder of the

Company, then takes the following resolutions:

- The sole shareholder, representing the whole Company’s corporate capital, declares that the Company has discon-

tinued all its activities as of 21 August 2013, and decides to dissolve and to liquidate the Company with effect as of 21
August 2013.

- The sole shareholder, acting in its capacity as liquidator of the Company, declares that the liquidation of the Company

has been done in accordance with the rights of any interested party, that it will take over all the assets and liabilities of
the Company and that it will pay all liabilities of the Company, even if unknown at present.

- Full and entire discharge is granted to the managers of the Company for the performance of their assignment.
- All books and documents of the Company will be kept for the legal duration of five (5) years at the offices of G.T.

Fiduciaires S.A., a public company limited by shares (société anonyme), incorporated under the laws of Luxembourg having
its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg register of commerce
and companies under the number B 121820.

- G.T. Fiduciaires S.A, pre-named, is authorized, in the name and on behalf of the sole shareholder to file any tax

declaration, notice to the Luxembourg register of commerce and companies and any other documents necessary or useful
for the closing of the liquidation.

III.- The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as

a result of the present deed, are estimated at approximately € 1,100.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the

notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-et-un août.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

314 Commonwealth Ave. Inc., une société constituée sous les lois du Delaware, ayant son siège social à Suite 400,2711

Centerville Road, Wilmington, 19808 Delaware, États-Unis, et enregistrée auprès du Registre de l’État du Delaware sous
le numéro 2850155,

ici représentée par:
Maître Karin BARTHOLOMÉ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste

Zithe,

en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé.
Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  le  mandataire  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I.- 314 Commonwealth Ave. Inc., pré-qualifiée est l’associée unique de Mansfield II S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, enregistrée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91853 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas
dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 janvier 2003, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 324 du 26 mars 2003, les statuts de laquelle ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en date du 7 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 782 du 4 août
2005.

II.- Le capital social de la Société est fixé à USD 681.328.100.-(six cent quatre-vingt-un millions trois cent vingt-huit

mille cent dollars américains), représenté par 6.813.281 (six millions huit cent treize mille deux cent quatre-vingt-un)
parts sociales d’une valeur nominale de USD 100.(cent dollars américains) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

Toutes les 6.813.281 (six millions huit cent treize mille deux cent quatre-vingt-un) parts sociales sont détenues par

l’associée unique 314 Commonwealth Ave. Inc., pré-qualifiée.

314 Commonwealth Ave. Inc., pré-qualifié, représentée ainsi qu’il a été dit ci-avant, agissant en sa qualité d’associée

unique de la Société, a pris ensuite les décisions suivantes:

- L’associée unique, représentant l’intégralité du capital social de la Société, déclare que la Société a arrêté ses activités

à compter du 21 août 2013 et décide de dissoudre et de liquider la Société avec effet au 21 août 2013.

122492

L

U X E M B O U R G

- L’associée unique, agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que la liquidation de la Société a été

réalisée en respectant les droits de toute partie intéressée, qu’elle s’engage à reprendre tous les éléments d’actifs et de
passifs de la Société, et qu’elle s’engage à payer toutes les dettes de la Société, même inconnues à l’instant.

- Décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l’exécution de leur mandat.
- Tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq (5) ans au siège de G.T.

Fiduciaires S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de
Bitbourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121820.

- G.T. Fiduciaires S.A., pré-qualifiée est autorisé au nom et pour le compte de l’associée unique à déposer toute

déclaration fiscale, notification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et tout autre document nécessaire
ou utile à la clôture de la liquidation.

III.- Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison

du présent acte sont évalués approximativement à la somme de € 1.100,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de différences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: BARTHOLOME, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26/08/2013. Relation: EAC/2013/11096. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 27 août 2013.

Référence de publication: 2013121934/113.
(130147983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

M.L. Technique, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windholf, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 179.754.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-neuf juillet.
Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Rodrigues Fernandes ORLANDO, indépendant, né le 5 septembre 1974 à Tondela (Portugal), demeurant

au 83, rue des Romains L-8041 Strassen.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme qu'il déclare constituer:

Titre I 

er

 - Objet - Raison sociale

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objets:
- l'exploitation d'une entreprise de Fumisterie et de nettoyage de chaudières, ainsi que toutes activités et la vente se

rapportant à la branche;

- l'exploitation d'une entreprise de ramonage et de nettoyage de cheminées;
- l'exploitation d'une entreprise d'installation de chauffage-Sanitaire-Frigoriste
- l'étude et la réalisation d'installations de chauffage, de sanitaire, le contrôle, l'entretien, la réparation et l'exploitation

d'installations de chauffage, l'achat, la vente, la location et le montage de tous appareils de chauffage, ainsi que les pres-
tations de service après-vente y afférentes.

D'une façon générale, elle pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 3. La société anonyme prend la dénomination de «M.L. TECHNIQUE».

122493

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du Conseil d'administration et ce jusqu'à disparition desdits
événements. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Capital social - Actions

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions

chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut-être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 7. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de décès de l'un des actionnaires constituant,

l'actionnaire restant possède un droit préférentiel pour le rachat des actions détenues par l'actionnaire décédé et ce
pendant un délai de six (6) mois à compter de la date de décès.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l'accord unanime

de tous les actionnaires.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restant ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-actionnaire. En cas d'exercice de ce droit de préemption,
la valeur de rachat des actions est calculée en fonction des deux derniers bilans approuvés qui serviront de base pour la
détermination de la valeur des actions à céder.

Titre III - Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des prérogatives
dévolues au conseil d'administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts, il est fait
référence au conseil d'administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "conseil d'administration", selon
le cas.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera

remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou message électronique, les trois derniers étant à

confirmer par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

122494

L

U X E M B O U R G

Art. 11. La société se trouve valablement engagée, vis-à-vis des tiers par la signature de deux administrateurs dont

celle, en toutes circonstances de l'administrateur-délégué, ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué ou
de l'administrateur unique.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou de la personne déléguée par le conseil.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Titre IV - Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 15. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du

jour soumis aux délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit

à une voix.

Titre V - Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à quinze heures au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins à la formation ou à l'alimentation du

fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint
dix pour cent du capital nominal.

Art. 19. L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde et de la distribution éventuelle de

dividendes.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 21. La loi relative aux sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les

présents statuts.

<i>Dispositions transitoires:

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et Libération:

Les cent (100) actions ont toutes été souscrites par l'actionnaire unique Rodrigues Fernandes ORLANDO, prénommé,

et ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que le montant
de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate.

Les actions sont et resteront nominatives jusqu'à l'entière libération du capital social.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000.-EUR).

<i>Décisions de l'actionnaire unique:

Les  statuts  de  la  société  ayant  été  ainsi  arrêtés,  l'actionnaire  unique,  représenté  comme  ci-avant  et  représentant

l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

122495

L

U X E M B O U R G

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui du commissaire aux comptes à un (1).
2. Est nommé administrateur unique de la Société:
Monsieur Rodrigues Fernandes ORLANDO, prénommé, né le 5 septembre 1974 à Tondela (Portugal), demeurant au

83, rue des Romains L-8041 Strassen, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers
par sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Mme Rosana TAVARES MARTINS, employée privé, née le 16 août 1990 à Aveiro (Portugal), demeurant au 176, route

de Beggen L-1220 Luxembourg.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

5. Le siège de la société est établi au 11, rue des Trois Cantons L-8399 Windhof.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du Notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: R. ORLANDO, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30/07/2013. Relation: LAC/2013/35617. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 26/08/2013.

Référence de publication: 2013121931/154.
(130148066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2013.

First Euro Industrial Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.267.800,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 104.016.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle en date du 27 Août 2013 que:
- Monsieur Jamal Dutheil, né le 25 Janvier 1979 à Paris, France et résident professionnellement au 15 Sloane Square,

SW1W 8ER, à Londres, Royaume-Uni, est nommé en tant que Gérant B du Conseil de gérance de la Société avec effet
au 27 Août 2013.

Par conséquent le Conseil de gérance est composé comme suit:
- Olivier Dorier, Gérant A
- Herman Schommarz, Gérant A
- Lee Hausman, Gérant B
- Mohammed Chowdhury, Gérant B
- Jamal Dutheil, Gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 27 Août 2013.

Référence de publication: 2013122405/20.
(130148681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 3.000.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 137.138.

Le bilan au 28 février 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013122568/12.
(130149195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

122496


Document Outline

Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l.

Euroheart Investments S.à r.l.

Family Partners S.à r.l.

F.E. Luxfinco Services

Fingrade S.A.

First Euro Industrial Properties III S.à r.l.

Fish Center S.à r.l.

FRS Hotel Group (Lux)

Galway II S.à r.l.

Galway I S.à r.l.

G-Brands.1946

Hellebore Participations S.à r.l.

Ingersoll-Rand Lux Euro Financing S.àr.l.

La Boqueria S.à r.l.

Lengau Holdings S.à r.l.

Lux 9 Starlight EUR S.à r.l.

Mansfield II S.à.r.l.

Mascot S.à r.l.

MGJL Holding Co (Lux) S.à r.l.

M.L. Technique

Moderna Renaissance Investments S.à r.l.

M.V.A. Luxembourg

Neva Investment S.A.

New Casastyle s.à r.l.

Nice Living

North American Capital Investors of Luxembourg (NACIL)

Nova Holdings S.A. - SPF

NSK Euro Holdings S.A.

Optique Clement &amp; Grassini S. à r.l.

Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR

Oscar-1 S.à r.l.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A.

Painworld S.à r.l.

Participe 49, s.à r.l.

Peche Aquarium S.à.r.l.

Pecunia Invest S.A.

Pecunia Invest S.A.

Pentavest S.à r.l.

Performance Fibers Europe 2, S.à r.l.

PétroVan S.A.

P.F. Logistic

Plemont Properties S.A.

Portugal Resorts

Prebivego Sàrl

Prebivego Sàrl

Précis-Lux S.à r.l.

President C

Pribinvest S.A.

Prime Credit 1 S.à r.l.

Prime Credit 2 S.à r.l.

Prime Credit 3 S.à r.l.

Primedale Participation S.A.

Proform S.A.

PRT Luxembourg S.à r.l.

Quintiles

Quintiles Holdings

Quintiles Luxembourg European Holding

Quintiles Luxembourg S. à r.l.

REI Latin America I S.à r.l.

Researches and International Communications S.A.

The Park 4 Holdings Lux S.à r.l.