This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2524
10 octobre 2013
SOMMAIRE
Brillant-Express, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121148
Clear Vision International S.A. . . . . . . . . . .
121147
Edmund Propco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121119
Emerging Markets Online Food Delivery
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121120
Globstory S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121151
Ingersoll-Rand Lux Roza III S.àr.l. . . . . . . . .
121152
Lusana Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
121118
Mehonne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121106
M-Square Finance S.A. SPF . . . . . . . . . . . . .
121106
M-Square Management S.à.r.l. . . . . . . . . . .
121106
MSR Luxoil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121106
Newan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121106
New Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121107
Newport Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121107
Newtra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121107
Newtra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121108
Novaluxco 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121107
Ordinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121150
Overland Trade SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121108
Pala Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121108
Pan European Real Estate Fund 2 S.A. . . .
121110
Pan European Real Estate Fund 3 S.A. . . .
121110
Pan European Real Estate Fund 4 S.A. . . .
121110
Pan European Real Estate Fund 5 S.A. . . .
121109
Pan European Real Estate Fund 6 S.A. . . .
121111
Paritex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121111
Parkettcenter S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121111
Patrick Weber S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121112
PAUL International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121107
PayPal International S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
121108
PE Feeder SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121111
Peintures-Décors Oestreicher S.à r.l. . . . .
121109
Pérez Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121108
Pimlico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121112
Piwo International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121113
PO Co-invest IHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121110
PPTM International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
121112
Prime Credit 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121109
Private Equity International S.A. . . . . . . . .
121109
Private Equity Selection International (PE-
SI) 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121149
Proprio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121109
RWM Luxoil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121113
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . .
121112
Sancopia Portfolios-A S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
121114
Sancopia Portfolios No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . .
121113
Santana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121112
Savrow Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121114
Sedco Capital Global Funds . . . . . . . . . . . . .
121152
Senna Cordonnerie Rapide Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121113
Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121114
Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121115
Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121115
Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121115
SQLI Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121147
StoneCreek Capital International Ltd. . . .
121115
Stonecreek Technologies Inc. . . . . . . . . . . .
121111
St. Stephan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121116
Tika S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121113
Voyages Wengler s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
121110
World Cosmetics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121114
121105
L
U X E M B O U R G
Newan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 76.019.
Le bilan au 30.06.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2013120076/14.
(130145461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
M-Square Finance S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 82.901.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120031/10.
(130145869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
M-Square Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 111.507.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120032/10.
(130145512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Mehonne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 105.376.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Chotin Barbara.
Référence de publication: 2013120058/10.
(130145577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
MSR Luxoil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 71, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 99.865.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120063/10.
(130146097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121106
L
U X E M B O U R G
Newport Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 76.711.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120077/10.
(130145871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
New Line, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 32.036.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120075/9.
(130145616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Newtra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 76.020.
Le bilan au 30.06.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2013120079/14.
(130145462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Novaluxco 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 158.762.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120082/10.
(130145610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PAUL International, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 65.534.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PAUL International
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120128/11.
(130145699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121107
L
U X E M B O U R G
Newtra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 76.020.
Le bilan au 30.06.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2013120080/14.
(130145463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Overland Trade SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 81.781.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120093/10.
(130145875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Pérez Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 139.666.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120097/10.
(130145860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Pala Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.936.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120100/10.
(130145826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PayPal International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 350.099,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 174.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120103/10.
(130145994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121108
L
U X E M B O U R G
Private Equity International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 70.348.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signatures
<i>Agent administratifi>
Référence de publication: 2013120116/14.
(130145905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Peintures-Décors Oestreicher S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 103.741.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120104/10.
(130145833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Prime Credit 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.786.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Léonie GRETHEN.
Référence de publication: 2013120115/10.
(130145559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Proprio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 85.960.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120118/10.
(130145864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PERF5 SA, Pan European Real Estate Fund 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.271.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120123/10.
(130145535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121109
L
U X E M B O U R G
PERF2 SA, Pan European Real Estate Fund 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.232.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120120/10.
(130145522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PERF3 SA, Pan European Real Estate Fund 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.236.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120121/10.
(130145530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PERF4 SA, Pan European Real Estate Fund 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.270.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120122/10.
(130145533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PO Co-invest IHS, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 177.074.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 août 2013.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2013120135/11.
(130145829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Voyages Wengler s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 46, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 29.343.
Il a été décidé que l'adresse de l'agence de voyage, sise à Esch-sur-Alzette, est transférée du 11, rue Zénon Bernard
au 46, rue de l'Alzette, L - 4010 Esch-sur-Alzette avec effet au 31 août 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>BDO Tax & Accounting
Signature
Référence de publication: 2013120248/13.
(130145917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121110
L
U X E M B O U R G
PERF6 SA, Pan European Real Estate Fund 6 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 162.272.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120124/10.
(130145537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Paritex S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 109.359.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120125/10.
(130146006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Parkettcenter S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5374 Munsbach, 4, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 67.324.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schwebsange, den 22.08.2013.
Référence de publication: 2013120126/10.
(130145691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PE Feeder SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 145.670.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120129/9.
(130146042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Stonecreek Technologies Inc., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 165.576.
EXTRAIT
En date du 6 août 2013, l’associé unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Jacques de Patoul, en tant qu’administrateur de catégorie B de la Société, est acceptée avec effet au
22 août 2013.
- Cedric Muenze, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel admi-
nistrateur de catégorie B de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée de 6 ans.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120175/15.
(130145845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121111
L
U X E M B O U R G
Samsonite International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.469.
<i>Extrait additionneli>
En addition à la réquisition déposée auprès du Registre de commerce et des sociétés Luxembourg le 24 juillet 2013
référence L130126469, le mandat de président de Mr. Timothy Charles Parker a été également renouvelé par le conseil
d'administration en date du 6 juin 2013 pour une durée de 3 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013120177/15.
(130145582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Santana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 48, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 85.346.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120179/9.
(130145676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Patrick Weber S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9186 Stegen, 14, Gerelwee.
R.C.S. Luxembourg B 108.121.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120127/10.
(130145834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Pimlico, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 128.363.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120131/9.
(130145580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
PPTM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 170.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PPTM International S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120136/11.
(130145432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121112
L
U X E M B O U R G
Piwo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 72.685.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120132/10.
(130145865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
RWM Luxoil SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9806 Hosingen, 1, Zac Happerfeld.
R.C.S. Luxembourg B 94.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120158/10.
(130146096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Sancopia Portfolios No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 168.560.
L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Richard Dominic SHELTON, gérant de la Société, est la suivante: 51,
Homer Road, Solihull, West Midlands, UK - B91 3QJ.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120160/11.
(130146142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Senna Cordonnerie Rapide Luxembourg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.832.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120188/9.
(130146058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Tika S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.835.
EXTRAIT
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013120219/14.
(130145544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121113
L
U X E M B O U R G
Sancopia Portfolios-A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.501,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 168.561.
L'adresse professionnelle actuelle de Monsieur Richard Dominic SHELTON, gérant de la Société, est la suivante: 51,
Homer Road, Solihull, West Midlands, UK - B91 3QJ.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120161/11.
(130146146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Savrow Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.533.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.839.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 9 août 2013 que:
- Monsieur Simon Shelley a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 5 août 2013.
- A été nommé aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 9 août 2013 et ce pour une durée indéterminée:
* Monsieur Antoine de Oliveira e Castro résidant professionnellement au Grafenauweg 6, CH-6304 Zug, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013120165/17.
(130145618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.475.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120171/11.
(130146180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
World Cosmetics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.133.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 8 août 2013i>
En date du 8 août 2013, les actionnaires de la Société ont pris la résolution suivante:
- De renouveler le mandat d'Eckart Vogler en tant qu'Administrateur de la Société, son mandat expirant après l'As-
semblée Générale des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Virginie Boussard
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013120255/15.
(130145752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121114
L
U X E M B O U R G
Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.475.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 31 juillet 2013i>
1. M, Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Vincent COINTEPAS, administrateur de sociétés, né le 16 juillet 1985 à Blois (France), demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B
pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120170/16.
(130145536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.476.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 31 juillet 2013i>
1. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
2. M. Vincent COINTEPAS, administrateur de sociétés, né à Blois (France), le 16 juillet 1985, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe B
pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120172/16.
(130145543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.476.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120173/11.
(130146192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
StoneCreek Capital International Ltd., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.605.
Les comptes annuels au 30 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/08/2013.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013120176/11.
(130146005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
121115
L
U X E M B O U R G
St. Stephan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.782.
In the year two thousand thirteen, on the 2
nd
August.
Before Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notary residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLS Luxembourg S.à r.l a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, having a share capital of EUR 5,200,000.-, registered with the Registre de commerce et des sociétés, Lu-
xembourg under the number B 110163
being the sole shareholder (the "Sole Shareholder"), of St. Stephan S.à r.l. a "société à responsabilité limitée", having
its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, having a share capital of EUR 37,500.-, registered with
the Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg under the number B 115782, incorporated by a notarial deed by
Maître André SCHWACHTGEN residing in Luxembourg enacted on 13 April 2006, published in the Memorial C, number
1257 of 29
th
June 2006, on page 60332,
whose articles of association have been amended for the last time by a notarial deed by Maître Jean Joseph WAGNER,
residing in Sanem, enacted on 19
th
May 2010, published in the Memorial C, number 1453 of 15
th
July 2010, on page
69708,
hereby represented by Mr Samuel Haas, Manager, with professional address at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Lu-
xembourg,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 1 August 2013.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall read as
follows:
" Art. 2. The Company has as its main corporate object the investment in real estate or real estate related assets,
situated in Luxembourg or abroad, in order to derive income from its rental and management. This will be undertaken
through acquisition, option of purchase, development and construction of real estate or by any other means. The Company
may, from time to time, realise its investments in real estate by sale or any other means.
The Company may, by acquisition of holdings in whatever form or by any other type of investment or security, take
part in the establishment and development of any company, registered in Luxembourg or abroad, manufacturer or com-
mercial, having an identical, similar or related corporate purpose than the corporate purpose of the Company or which
can facilitate or promote the development of the Company, as well as administer, manage, develop financially, improve,
oversee and liquidate, permanently or temporarily, those interests or holdings. The Company can also give assistance to
any such company as well as to any company being part of the same group of companies as the Company by means of
loans, advances, guarantees or otherwise.
Finally, the Company may carry out, both in Luxembourg and abroad, any kind of general, industrial, commercial,
financial, movable or real estate operations as well as any measures of control or supervision relating directly or indirectly,
in all or in part, to the fulfillment of its corporate purpose as referred to in the above 2 paragraphs, including to request
financing in its favour from any Luxembourg or foreign credit institutions or from a different company or natural person
by means of loans, advances, guarantees or by any other means."
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately seven hundred and seventy Euro (EUR 770.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
121116
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the representative of the appearing party, the said person signed, together with
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille treize, le 2 août 2013.
Par-devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CLS Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social 55, Avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 5.200.000,-, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés
sous le numéro B 110163
l'associé unique «Associé Unique» de St. Stephan S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au
55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 37,500,-, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés sous le numéro B 115782, constituée suivant acte notarié reçu par Maître André SCHWACHT-
GEN de Luxembourg en date du 13 avril 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1257
du 29 juin 2006, page 60332,
lesquels statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié reçu par Maître Jean Joseph WAGNER de résidence
à Sanem, en date du 19 mai 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1453 du 15 juillet
2010, page 69708,
ici dûment représentée par Monsieur Samuel Haas, gérant, résidant professionnellement au 55, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé avec pouvoir de substitution donné le 1 août 2013.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
L'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société de la façon suivante:
« Art. 2. La Société a comme objet social principal l'investissement dans l'immobilier ou dans les actifs liés à l'immobilier,
situés à Luxembourg ou à l'étranger, afin de générer des revenus provenant de leur location et leur gestion. Cela pourra
se réaliser par l'acquisition, l'option d'achat, le développement et la construction d'immeubles ou par tout autre moyen.
La Société peut, de temps à autre, effectuer des investissements dans l'immobilier par la vente ou tout autre moyen.
La Société peut, par la prise de participations de quelque forme que ce soit ou par toute autre forme de placement
ou valeurs mobilières, prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise, immatriculée au Luxem-
bourg ou à l'étranger, industrielle ou commerciale, ayant un objet social identique, analogue ou connexe à l'objet social
de la Société ou qui est de nature à favoriser ou faciliter le développement de la Société, ainsi qu'administrer, gérer,
développer financièrement, mettre en valeur, superviser et liquider, à titre permanent ou temporaire, ces intérêts ou
participations. La Société peut également prêter assistance à une telle entreprise ainsi qu'à toute société faisant partie du
même groupe de sociétés que la Société au moyen de prêts, avances, garanties ou autrement.
Pour finir, la Société peut accomplir, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ainsi que toutes mesures de contrôle ou de surveil-
lance se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'accomplissement de son objet social tel que
défini aux deux paragraphes ci-dessus, parmi lesquelles solliciter des financements en sa faveur auprès de tout établisse-
ment de crédits luxembourgeois ou étranger ou de toute autre société ou personne physique au moyen de prêts, avances,
garanties ou de tout autre manière.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge
à raison du présent acte s'élève à environ sept cent soixante dix euros (EUR 770,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Le Notaire, Joëlle SCHWACHTGEN, soussigné, certifie que l'acte ci-dessus a bien été signé par devant elle en date
de ce jour.
121117
L
U X E M B O U R G
Signé: Haas, Joëlle SCHWACHTGEN.
Enregistré à Wiltz, le 06 août 2013. Relation: WIL/2013/507. Reçu soixante-quinze euros (75,- €),
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Zeimes.
Pour expédition conforme délivrée à la société pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Wiltz, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120842/115.
(130146312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Lusana Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 54.484.
DISSOLUTION
L'an deux mille treize, le douze août.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, "LUSANA PARTICIPATIONS S.A.", établie et ayant son siège social à L-2086
Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 54484, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline HANSEN-PEFFER, alors notaire de
résidence à Capellen, en remplacement de Maître Marthe THYES-WALCH, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 29 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 324 du 3 juillet 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant profession-
nellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
La Présidente désigne Mademoiselle Joëlle RAGOT, employée privée, demeurant professionnellement au 412F route
d'Esch, L-2086 Luxembourg, comme secrétaire.
L'assemblée choisit Mademoiselle Catherine BORTOLOTTO, employée privée, demeurant professionnellement au
412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, comme scrutatrice.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et à la mettre en liquidation;
2. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses prérogatives;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes jusqu'au jour de la liquidation;
4. Divers.
B) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
C) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation vo-
lontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée "Merlis S.à r.l.", établie et ayant son siège social à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 111320, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.
121118
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de
la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").
L'assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'en date des présentes.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente a ajourné l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros (EUR
1.100,-).
DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, lesdites comparantes ont toutes signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. MOSTADE, J. RAGOT, C. BORTOLOTTO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2013. LAC/2013/37801. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 23 août 2013.
Référence de publication: 2013120703/79.
(130146876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Edmund Propco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.021.
EXTRAIT
I/ En vertu d'un contrat de cession de parts sociales en date du 18 mars 2013, l'associé unique de la société, OCM
Luxembourg ROF VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 175220, a cédé une partie des parts sociales qu'il détient dans la société, soit mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales sur les douze mille cinq cent (12.500), à la société PATRIZIA Investment Management S.C.S., une
société en commandite simple régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175874.
En conséquence de cette cession de parts sociales, PATRIZIA Investment Management S.C.S., précitée, est désormais
associé de la société et détient mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales dans la société et OCM Luxembourg ROF
VI S.à r.l. détient désormais onze mille deux cent cinquante (11.250) parts sociales dans la société.
II/ En vertu d'un contrat de cession de parts sociales en date du 2 août 2013, les associés de la société, OCM Luxem-
bourg ROF VI S.à r.l. et PATRIZIA Investment Management S.C.S., ont ensuite cédé la totalité des parts sociales qu'ils
détiennent respectivement dans la société, à la société Plymouth Sound (UK) Holdings LP, une limited partnership régie
par les lois d'Angleterre, ayant son siège social à Swatton Barn, Badbury, Swindon, Wiltshire SN4 0EU, Royaume-Uni,
immatriculée auprès du Registrar of Companies for England & Wales sous le numéro LP15450, comme suit:
121119
L
U X E M B O U R G
1/ OCM Luxembourg ROF VI S.à r.l. a cédé onze mille deux cent cinquante (11.250) parts sociales à la société Plymouth
Sound (UK) Holdings LP; et
2/ PATRIZIA Investment Management S.C.S., a cédé mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales à la société
Plymouth Sound (UK) Holdings LP.
En conséquence de ces deux cessions de parts sociales, Plymouth Sound (UK) Holdings LP, précitée, est désormais
l'associé unique de la société et détient douze mille cinq cents (12.500) parts sociales dans la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2013121153/33.
(130147086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.312,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 175.738.
In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of July.
before us, Maitre Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws
of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB
109262 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter "Rocket Internet"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin, on 10 July 2013, and
2. Kinnevik Online AB (formerly Kinnevik Online Ventures AB), a limited liability company (aktiebolag) existing under
the laws of Sweden registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, having its
registered address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden (hereinafter "Kinnevik Online AB"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Stockholm, on 10 July 2013, and
3. Bambino 53. V V UG (haftungbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungbeschränkt))
existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Ger-
many, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
"Bambino 53. V V"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin, on 10 July 2013, and
4. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg (hereinafter "AI European Holdings"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg, on 10 July 2013,and
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under number B 176544, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, the Grand Duchy of Luxembourg, and with a share capital of EUR 18,494.00 (hereinafter "Aismare Lux Holdings
S.à r.l."),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg, 12 July 2013, and
6. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands (hereinafter ""Phenomen"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Moscow, on 11 July 2013, and
7. Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws
of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register at the local court of
121120
L
U X E M B O U R G
Munich under no. HRB 200948, having its business address at Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany (herei-
nafter "New Investor" or "Mercura"), participating and voting only for purposes of Agenda point 4 et seqq.,
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Munich, on 10 July 2013.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1. through 6. (the "Existing Shareholders") are all the shareholders of Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 175.738 and incorporated pursuant to a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 28 February 2013, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 956 dated 22 April 2013. The articles of incorporation were amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on 30 April 2013, published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1572 dated 2 July 2013.
The Existing Shareholders representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the
general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the
New Investor participates and votes for purpose of Agenda point 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) additional class of shares referred to as the series B3 shares (hereinafter "Series B3
Shares") and to hence have nine (9) classes of shares in total.
2. Acceptance of Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing
under the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register at the
local court of Munich under no. HRB 200948, having its business address at Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg,
Germany (hereinafter "New Investor") as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR
1,875) so as to raise it from its current amount of thirty-three thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437)
up to thirty-five thousand three hundred and twelve euro (EUR 35,312) by issuing one thousand eight hundred and
seventy-five (1,875) Series B3 Shares.
4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-five thousand three hundred and twelve euro (EUR 35,312), represented
by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"), (ii) one
hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series A1a Shares"), (iii) one thousand eight hundred and seven
(1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares (hereinafter
"Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thousand six
hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand seven hundred and
fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1 Shares"), (viii) four thousand six hundred and eighty-seven (4,687)
series B2 shares (hereinafter the "Series B2 Shares" and (ix) one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) series
B3 shares (hereinafter "Series B3 Shares" and, together with the Series B1 Shares and the Series B2 Shares, the "Series
B Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux
Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP and (vi) Mercura Capital GmbH shall be entitled to subscribe for such amount
of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being
neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party
Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based. Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii)
Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP and (vi) Mercura Capital GmbH
shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if Rocket Internet GmbH and/or Kinnevik Online
AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP and/or
Mercura Capital GmbH intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article
5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further shares in the Company."
121121
L
U X E M B O U R G
5. Subsequent amendment of article seven point four a (7.4a) of the articles of association of the Company so that it
shall henceforth read as follows:
"a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l.,(v) Phenomen Ventures LP and
(vi) Mercura Capital GmbH (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP and Mercura Capital GmbH hereinafter jointly referred to as "Investors"; each
individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG) to the respective Investor;"
6. Subsequent amendment of articles twenty-five point 1 (25.1) and twenty-five point 3 (25.3) of the articles of asso-
ciation of the Company so that they shall henceforth read as follows:
" 25.1. The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of ten (10) voting members.
The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of
members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board."
" 25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification
towards the Company as follows:
a) five (5) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in its
sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion; and
f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mercura Capital GmbH in its
sole discretion."
7. Decision to amend and fully restate the articles of association of the Company.
8. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares referred to as series B3 shares
(hereinafter "Series B3 Shares") and to hence have nine (9) classes of shares in total.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with
the commercial register at the local court of Munich under no. HRB 200948, having its business address at
Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany, as a new shareholder of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one
thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR 1,875) so as to raise it from its current amount of thirty-three
thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437) up to thirty-five thousand three hundred and twelve euro
(EUR 35,312) by issuing one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) Series B3 Shares having a par value of one
euro (EUR 1.-) each.
<i>Subscriptioni>
One thousand eight hundred and seventy-five (1,875) Series B3 Shares have been duly subscribed by Mercura Capital
GmbH, aforementioned, for the price of one thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR 1,875).
<i>Paymenti>
The one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) Series B3 Shares subscribed by the New Investor, afore-
mentioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand eight hundred and
seventy-five euro (EUR 1,875).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
121122
L
U X E M B O U R G
The contribution in the amount of one thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR 1,875) is entirely allocated
to the share capital.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledges that Mercura Capital GmbH has now become holder of the issued
one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) Series B3 Shares.
As a consequence Mercura Capital GmbH, entitled to vote and here represented by Katia Gauzes, Avocat a la Cour,
professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munich, on 10 July 2013, joins the general meeting
of shareholders for purpose of the following resolutions.
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the
Company so that it shall now henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-five thousand three hundred and twelve euro (EUR 35,312), represented
by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"), (ii) one
hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series A1a Shares"), (iii) one thousand eight hundred and seven
(1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares (hereinafter
"Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thousand six
hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand seven hundred and
fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1 Shares"), (viii) four thousand six hundred and eighty-seven (4,687)
series B2 shares (hereinafter the "Series B2 Shares", and (ix) one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) series
B3 shares (hereinafter "Series B3 Shares" and, together with the Series B1 Shares and the Series B2 Shares, the "Series
B Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux
Holdings S.a r.l. (v) Phenomen Ventures LP and (vi) Mercura Capital GmbH shall be entitled to subscribe for such amount
of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being
neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party
Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB,
(iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP and (vi) Mercura Capital
GmbH shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if Rocket Internet GmbH and/or Kinnevik
Online AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.a r.l. and/or Phenomen Ventures LP and/
or Mercura Capital GmbH intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article
5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further shares in the Company."
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article seven point four a (7.4a) of the articles of
association of the Company so that it shall now henceforth read as follows:
"a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP and
(vi) Mercura Capital GmbH (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP and Mercura Capital GmbH hereinafter jointly referred to as "Investors"; each
individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG) to the respective Investor;"
<i>Sixth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of articles twenty-five point 1 (25.1) and twenty-five
point three (25.3) of the articles of association of the Company so that they shall now henceforth read as follows:
" 25.1. The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of ten (10) voting members.
The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of
members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board."
121123
L
U X E M B O U R G
" 25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification
towards the Company as follows:
a) five (5) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in its
sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion; and
f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mercura Capital GmbH in its
sole discretion."
<i>Seventh Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
"A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Emerging
Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-five thousand three hundred and twelve euro (EUR 35,312), represented
by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"), (ii) one
121124
L
U X E M B O U R G
hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series Ala Shares"), (iii) one thousand eight hundred and seven
(1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares (hereinafter
"Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thousand six
hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand seven hundred and
fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1 Shares"), (viii) four thousand six hundred and eighty-seven (4,687)
series B2 shares (hereinafter the "Series B2 Shares", and (ix) one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) series
B3 shares (hereinafter "Series B3 Shares" and, together with the Series B1 Shares and the Series B2 Shares, the "Series
B Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (v) Phenomen Ventures LP and (vi) Mercura Capital GmbH shall be entitled to subscribe for such amount
of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being
neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party
Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB,
(iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP and (vi) Mercura Capital
GmbH shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if Rocket Internet GmbH and/or Kinnevik
Online AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP and/
or Mercura Capital GmbH intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article
5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further shares in the Company.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions of
any shareholders agreement between the shareholders if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP and
(vi) Mercura Capital GmbH (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP and Mercura Capital GmbH hereinafter jointly referred to as "Investors"; each
individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG) to the respective Investor;
b) in case of the transfer of shares of one Investor to a company or entity (x) which is directly or indirectly Controlling,
Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect shareholders of
the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or "Controlling" shall mean
the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a) managing the company as managing shareholder,
(b) holding the majority of shares, (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting pool, or (d)
121125
L
U X E M B O U R G
the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person, whether
through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more share-
holders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
c) in case of a share transfer to a third party acquiring shares under the simplified employee participation, or by a
shareholder to the Company and/or any Investors pursuant to a call option under a vesting scheme.
7.5 To the extent a transfer of shares requires no additional consent of the shareholders' meeting pursuant to article
7.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or
drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a "Liquidity
Event"), the proceeds ("Exit Proceeds") - subject to articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with
article 8.4 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level ("First Level") the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series B
Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company).
8.3 On a second level ("Second Level") the holders of Series Ala Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series
A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:
Share Class
Amount
per
Share
in Euro
Series Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,554.76
8.4 After the payments on the First Level and Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be
allocated on a third level ("Third Level") to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be
allocated to such shareholder on the Third Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Third Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level and/or Second Level. The allocation
at Third Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or
not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation on the First Level and Second Level applies to each of the respective Series B Shares,
Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares as long as on the respective
Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares the amount
stipulated in article 8.2 and/or in the table pursuant to article 8.3 has not yet been distributed once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
121126
L
U X E M B O U R G
a) insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
b) the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the Law and the
Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer
in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in Lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective decisions of the shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
121127
L
U X E M B O U R G
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General meetings of shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 16. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Decisions requiring specific majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent
of the Advisory Board:
a) disposition of all the Company's assets, of a significant part of the Company's assets or all or significant part of assets
of any direct or indirect subsidiary of the Company including the resolution with respect to the liquidation of the Company;
b) disposition of shares in direct or indirect subsidiaries of the Company, except for share transfers under the simplified
employee participation as agreed by the shareholders in any shareholders agreement;
c) amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to the
merger, separation and transformation of the Company;
d) appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits
to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
e) conclusion of intra-group agreements (Unternehmensvertrage within the meaning of articles 291 et seqq. of the
German Stock Corporation Act (AktG));
f) conclusion of company participations of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other
contractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of
the Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including
agreements concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners;
g) approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year and the annual accounts;
121128
L
U X E M B O U R G
h) removal and appointment of managers.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the prior consent
of all of the Investors.
a) exclusion of subscription rights in case of capital increases;
b) acquisition of the Company's own shares, including redemption of shares with the exception of acquisitions in
accordance with article 9.2 and transfers in accordance with article 11.1 of these articles of association.
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
17.4 Any changes in the decision making process (including the competence of meetings of shareholders, Advisory
Board and any specific majority necessary for adoption of some of the decisions) of the Company to the unilateral
disadvantage of any of the Investors shall not be made without such Investor's consent. For the avoidance of doubt any
decrease of the number of votes or change of the voting rights of shareholders or directors necessary for adoption of
any decision will bring the unilateral disadvantage of the Investors.
17.5 Any of the following measures shall, irrespective of the consents or approvals otherwise required under any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company or
these articles, always require a % majority of the Investors: (i) sale of IP rights by the Company or any of its direct or
indirect subsidiaries; (ii) sale of a direct or indirect subsidiary by the Company.
D. Board of managers and Advisory board
Art. 18. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of office of managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, pursuant to
article 17.1 lit. h).
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the office of a manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening meetings of the board of managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
121129
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the prior consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the
Company and its direct or indirect subsidiaries which are beyond the ordinary course of business of the Company, and
- in any case - for the legal transactions and measures of the Company and its direct or indirect subsidiaries specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders' meeting:
a) incorporation, acquisition or disposal of enterprises or partial-businesses;
b) amendment of articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise (or waiver)
of shareholders' rights in companies in which an interest is held directly or indirectly;
c) acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
d) material change to the nature of the business of the Company and the termination of any material business operation;
e) assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euro (EUR
200,000) in aggregate;
f) granting of loans in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate, excluding, however, such
loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
g) conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred
thousand euro (EUR 200,000) in aggregate and amendments to the credit framework, excluding, however, such agree-
ments between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
h) futures transactions concerning currencies, securities and exchange- traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
i) granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
j) conclusion amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial impor-
tance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
k) institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than ten thousand euro (EUR 10,000) in the individual case;
l) disposition of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights including copyrights or any other
property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation by the enterprise and/or a third
party, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
m) business dealings of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be shareholders, affiliated companies, as well as relatives of direct or indirect shareholders as far as
the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to
this lit. (m) does not apply if the business dealing belongs to the ordinary course of business of the Company and is at
arm's length;
n) amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensvertrage within the meaning of articles 291
et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));
121130
L
U X E M B O U R G
o) exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that
this exercise would require the consent of the shareholders' meeting under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this article 22.8 lit. a) to o), article 17.1 or 17.2.
Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the prior consent of the Advisory
Board.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this article apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of ten (10) voting members.
The shareholders' meeting may by way of unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of mem-
bers of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non¬voting member of the Advisory Board.
25.2 The shareholders' meeting shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of a
unanimous shareholders' resolution.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards
the Company as follows:
a) five (5) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in its
sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion; and
f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mercura Capital GmbH in its
sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. One of the Rocket-Members shall be the
chairman of the Advisory Board and shall not have a casting vote. The rules of procedure of the Advisory Board shall
provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which the shareholders' meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these
121131
L
U X E M B O U R G
articles of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iii) by way of shareholders' resolution or (iv) in any
shareholders' agreement.
25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the
Company by way of a unanimous shareholders' resolution.
25.7 In addition to the consent requirements provided for in article 22.8 and article 22.9, the Advisory Board has a
consultative function and will not interfere in the management of the Company.
E. Audit and Supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual accounts and Allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders
121132
L
U X E M B O U R G
and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these
articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter
partes and to the extent permitted by Luxembourg law.
These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and
the German text, the English version shall prevail."
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,500.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed."
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am zwölftenTag des Monats Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstraße
20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket Internet"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 10.
Juli 2013, ausgestellt in Berlin, und
2. Kinnevik Online AB (vormals Kinnevik Online Ventures AB), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktiebolag)
nach schwedischem Recht, eingetragen im Gesellschaftsregister in Schweden (Bolagsverket), unter der Nummer
556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden („Kinnevik Online AB"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 10.
Juli 2013, ausgestellt in Stockholm, und
3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 10.
Juli 2013, ausgestellt in Berlin, und
4. AI European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
luxemburgischem Recht, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés), unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg („Al European
Holdings"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 10.
Juli 2013, ausgestellt in Luxemburg, und
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
luxemburgischem Recht, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés), unter der Nummer B 176544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Lu-
xemburg, und mit einem Gesellschaftskapital von achtzehntausendvierhundertvierundneunzig Euro (EUR 18.494,00)
(„Aismare Lux Holdings S.à r.l."),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12.
Juli 2013, ausgestellt in Luxemburg, und
6. Phenomen Ventures LP, eine exempted limited partnership nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), mit
der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands
(„Phenomen"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
Juli 2013, ausgestellt in Moskau, und
7. Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem
Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, unter der Nummer HRB
121133
L
U X E M B O U R G
200948, mit Geschäftssitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland (der „Neue Investor" oder „Mercura"),
die ausschließlich für Punkt 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist,
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 10.
Juli 2013, ausgestellt in München.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar
ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1 bis 6 (die „Bestehenden Gesellschafter") sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738, gegründet
am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, veröffentlicht am 22.
April 2013 im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 956. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt
am 30. April 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg abgeändert und am 2.
Juli 2013 im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1572 veröffentlicht.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei der Neue Investor ausschließlich für Punkt 4 ff. teilnahme- und stimmberechtigt
ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, die als Anteile der Serie B3 bezeichnet
werden (die „Anteile der Serie B3"), wodurch nunmehr insgesamt neun (9) Anteilsklassen bestehen.
2. Annahme von Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit sat-
zungsmäßigem Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, unter der
Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland (der „Neue Investor"),
als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreiunddreißigtausendvier-
hundertsiebenunddreißig Euro (EUR 33.437) um einen Betrag von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.875)
auf einen Betrag von fünfunddreißigtausenddreihundertzwölf Euro (EUR 35.312) durch die Ausgabe von eintausendach-
thundertfünfundsiebzig (l.875) Anteilen der Serie B3.
4. Anschließende Änderung von Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausenddreihundertzwölf Euro (EUR 35.312), auf-
geteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii) einhunder-
tachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807) Anteile der
Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c"),
(v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsundfünfzig
(1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b"), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der
Serie B1 (die „Anteile der Serie B1"), (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 (die
„Anteile der Serie B2") und (ix) eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3 (die „Anteile der Serie
B3" und gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 und den Anteilen der Serie B2 die „Anteile der Serie B") mit einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)
Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH ist zur Zeichnung einer Anzahl
weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten um-
gesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne des Artikels 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor") handelt), und der vom
Beratenden Ausschuss zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten") - unabhängig davon, ob diese vom Drittin-
vestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote
an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer
Investition eines Dritten. (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare
Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH haben die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu unterrichten, sofern Rocket Internet GmbH und/oder Kinnevik
Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures
LP und/oder Mercura Capital GmbH ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchten. Für
121134
L
U X E M B O U R G
den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser Artikel 5.3 entsprechend anzu-
wenden."
5. Anschließende Änderung von Artikel sieben Punkt vier a (7.4 a) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v)
Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European
Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP und Mercura Capital GmbH im Folgenden ge-
meinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor") an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);"
6. Anschließende Änderung der Artikel fünfundzwanzig Punkt eins (25.1) und fünfundzwanzig Punkt drei (25.3) der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lauten:
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus zehn (10)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen."
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schrift-
liche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) fünf (5) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures
LP nach eigenem Ermessen ernannt; und
f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Mercura Capital GmbH
nach eigenem Ermessen ernannt."
7. Beschluss bezüglich der Änderung und gänzlichen Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Beratung über jeden Tagesordnungspunkt fasst die Hauptversammlung der Gesellschafter
einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, die als Anteile
der Serie B3 bezeichnet werden (die „Anteile der Serie B3") und somit insgesamt neun (9) Anteilsklassen zu haben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München, unter der Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg,
Deutschland, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen
Betrag von dreiunddreißigtausendvierhundertsiebenunddreißig Euro (EUR 33.437) um einen Betrag von eintausendach-
thundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.875) auf einen Betrag von fünfunddreißigtausenddreihundertzwölf Euro (EUR 35.312)
durch die Ausgabe von eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie B3 mit einem Nominalwert von
einem Euro (EUR 1) pro Anteil zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3 wurden ordnungsgemäß von Mercura Capital
GmbH, vorbenannt, zu einem Preis von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.875) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die vom Neuen Investor, vorbenannt, gezeichneten eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3
wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.875).
121135
L
U X E M B O U R G
Der Nachweis für die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von eintausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.875) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter erkennt an, dass Mercura Capital GmbH nun der Inhaber der ausgegebenen
eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3 geworden ist.
Infolgedessen schließt sich Mercura Capital GmbH, stimmberechtigt und hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à
la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 10. Juli 2013, ausgestellt in München, für die nach-
stehenden Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschafter an.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausenddreihundertzwölf Euro (EUR 35.312), auf-
geteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii) einhunder-
tachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807) Anteile der
Serie A1b (die „Anteile der Serie A1b"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c"),
(v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsundfünfzig
(1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b"), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der
Serie B1 (die „Anteile der Serie B1"), (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 (die
„Anteile der Serie B2") und (ix) eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3 (die „Anteile der Serie
B3" und gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 und den Anteilen der Serie B2 die „Anteile der Serie B") mit einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)
Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH ist zur Zeichnung einer Anzahl
weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten um-
gesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne des Artikels 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor") handelt), und der vom
Beratenden Ausschuss zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten") - unabhängig davon, ob diese vom Drittin-
vestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote
an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer
Investition eines Dritten. (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare
Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH haben die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu unterrichten, sofern Rocket Internet GmbH und/oder Kinnevik
Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures
LP und/oder Mercura Capital GmbH ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchten. Für
den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser Artikel 5.3 entsprechend anzu-
wenden."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel sieben Punkt vier a (7.4 a) der Satzung der Gesellschaft
zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v)
Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European
Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP und Mercura Capital GmbH im Folgenden ge-
meinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor") an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);"
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, die Artikel fünfundzwanzig Punkt eins (25.1) und fünfundzwanzig
Punkt drei (25.3) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welche nunmehr wie folgt lauten:
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus zehn (10)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
121136
L
U X E M B O U R G
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen."
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schrift-
liche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) fünf (5) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures
LP nach eigenem Ermessen ernannt; und
f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Mercura Capital GmbH
nach eigenem Ermessen ernannt."
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und ihr zur
Erreichung dieser Zwecke, im Hinblick auf die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, förderlich
erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst
werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss der Geschäftsführung verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird,
kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss der Geschäftsführung im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte die Geschäftsführung entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwick-
lungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
121137
L
U X E M B O U R G
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfunddreißigtausenddreihundertzwölf Euro (EUR 35.312), auf-
geteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii) einhunder-
tachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807) Anteile der
Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c"),
(v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsundfünfzig
(1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b"), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der
Serie B1 (die „Anteile der Serie B1 "), (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 (die
„Anteile der Serie B2") und (ix) eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3 (die „Anteile der Serie
B3" und gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 und den Anteilen der Serie B2 die „Anteile der Serie B") mit einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)
Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH ist zur Zeichnung einer Anzahl
weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten um-
gesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor") handelt), und dem vom
Beratenden Ausschuss zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten") - unabhängig davon, ob diese vom Drittin-
vestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote
an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer
Investition eines Dritten. (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare
Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH haben die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu unterrichten, sofern Rocket Internet GmbH und/oder Kinnevik
Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures
LP und/oder Mercura Capital GmbH ihr Recht gemäß dem vorstehenden Satz dieses Artikels 5.3 ausüben möchten. Für
den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser Artikel 5.3 entsprechend anzu-
wenden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nennwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann als Gegenleistung Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit") und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
121138
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine zusätzliche Zustimmung zur
Übertragung der Anteile nicht erforderlich:
a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v)
Phenomen Ventures LP und (vi) Mercura Capital GmbH (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European
Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP und Mercura Capital GmbH im Folgenden ge-
meinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor") an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
b) bei der Übertragung von Anteilen eines Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welches direkt
oder indirekt über (i) einen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des Investors
herrscht, von diesem abhängig ist, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht (jeweils eine „Kontrollierte
Gesellschaft"), wobei die Worte „Kontrolle" oder „Abhängig" oder „Herrscht" die direkte oder indirekte Kontrolle der
Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) das
Halten der Mehrheit der Anteile, (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinba-
rung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, die Richtung der Geschäftsleitung und Geschäftspolitik einer Person, entweder
durch den Besitz von Wertpapieren oder anderweitig zu bewirken oder (y) in welcher der Investor oder einer oder
mehrere Gesellschafter des Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
c) bei einer Übertragung von Anteilen an einen Dritten, welcher Anteile unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbe-
teiligung erwirbt, oder von einem Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer
Kaufoption im Rahmen eines Übertragungssystems.
7.5 Sofern eine Übertragung von Anteilen gemäß Artikel 7.4 keiner weiteren Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung bedarf, gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitver-
kaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn die Zustimmung zu einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit (unter Ausschluss der Anteile des
verstorbenen Gesellschafters) erteilt wurde. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern,
Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Ge-
sellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis" bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse") - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel
8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR 1.600
pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend
aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Ka-
pitaleinlagen (Punkt 115 des Luxemburger Standard-Kontenrahmens), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt
wurden).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie
A1b, Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteils-
klasse (und zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der
entsprechenden Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro
Anteil in
Euro
Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.554,76
121139
L
U X E M B O U R G
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene") an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Beträge
mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Dritten Ebene und werden anschließend entspre-
chend dieser Dritten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten
und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Dritten Ebene erfolgt solange, bis alle
Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquidi-
tätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den
Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzu-
zahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den
Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Ge-
sellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene ist auf alle entsprechenden Anteile der Serie
B, Anteile der Serie A1a, Anteile der Serie A1b, Anteile der Serie A1c, Anteile der Serie A2a und Anteile der Serie A2b
anwendbar, solange bei den jeweiligen Anteilen der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b, Anteilen der
Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b der in Artikel 8.2 und/oder der in der Tabelle in Artikel
8.3 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte jeder der von der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile werden ruhen, solange sie von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
a) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
b) ein Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil ein-
geleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Nach Erhalt der von der Geschäftsführung übersandten Rückkaufserklärung durch diesen Gesellschafter werden die
Anteile automatisch zurückgekauft, wobei es keiner weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam
mit der Rückkaufserklärung ein gültiges Schriftstück im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar, und die Ge-
sellschaft erkennt an und akzeptiert hiermit in einem solchen Fall die Übertragung der Anteile und verpflichtet sich zur
Eintragung der Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Einreichung.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können die gemeinsam berechtigten Personen die Gesellschafterrechte nur ein-
heitlich durch eine von diesen Personen ausüben, indem sie eine der gemeinsam berechtigten Personen zu diesem Zweck
unverzüglich nach Aufkommen des gemeinsamen Anteilsrechts ernennen.
9.4 Ein Rückkauf kann durch die Geschäftsführung erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald der
betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer im
Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Tag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Tribunal d'Arrondissement bestimmt. Die Entscheidung des
Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem ersuchenden Ge-
sellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der von diesem Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rückkaufspreis
verrechnet und dieser entsprechend herabgesetzt wird. Sofern die vom Gesellschafter zu tragenden Kosten für das
Gutachten nicht vom Rückkaufspreis gedeckt werden, gehen die restlichen Kosten zu Lasten des Gesellschafters.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung des Anteils an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
121140
L
U X E M B O U R G
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst wer-
den. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E¬Mail
oder Fax) oder telefonisch gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht wird und kein
anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses Verfahren ge-
genüber der Geschäftsführung der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein Widerspruch gemäß
dem vorstehenden Satz eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehmenden Gesellschafter
als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen und die Niederschrift
ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form gefasst wurden, sind
schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter nach den
Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Hauptversammlung der Gesellschafter" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zu-
sammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter werden
vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 13. Hauptversammlung der Gesellschafter.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der entsprechenden Einladung
genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Hauptversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4) Wochen
und bei außerordentlichen Hauptversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wochen einzuhalten
ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der
Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und auf
Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung begleitet oder von einem anderen
durch eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer unter der Berufsverschwiegenheitspflicht vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
121141
L
U X E M B O U R G
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 17. Beschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und die vorherige
Zustimmung des Beratenden Ausschusses:
a) Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens oder
des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Abwicklung der Gesellschaft;
b) Veräußerung von Anteilen in direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, mit Ausnahme von
Anteilsübertragungen unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung, wie von den Gesellschafter in einer Gesellschaf-
tervereinbarung vereinbart;
c) Änderung dieser Satzung (einschließlich des vorliegenden Artikels 17) einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der
Verschmelzung, Spaltung und Umwandlung der Gesellschaft;
d) Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher
Gewinne auf neue Konten: Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;
e) Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
f) Abschluss von Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art, einschließlich stiller Gesellschaften und sämtlicher Verträge,
durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche
vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der
Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder An-
gestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge
zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;
g) Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr und des Jahresabschlusses;
h) Abberufung und Ernennung von Geschäftsführern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und die vorherige
Zustimmung aller Investoren:
a) Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
b) Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen mit Ausnahme der Erwerbe
gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Sofern das Gesellschaftskapital der Gesellschaft in unterschiedliche Anteilsklassen unterteilt ist, können die mit
jeder Klasse verbundenen speziellen Rechte und Pflichten mit der schriftlichen und einstimmigen Zustimmung der Ge-
sellschafter, welche die Gesamtheit der ausgegebenen Anteile dieser Klasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
17.4 Alle Änderungen im Beschlussfassungsprozess der Gesellschaft (einschließlich der Zuständigkeit der Gesellschaf-
terversammlungen, der Sitzungen des Beratenden Ausschusses und jeder notwendigen spezifischen Mehrheit zur Annah-
me einiger Beschlüsse) zum einseitigen Nachteil eines Investors sind nicht ohne Zustimmung dieses Investors
vorzunehmen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass ein einseitiger Nachteil der Investoren bei einer Herab-
setzung der Stimmanzahl oder bei einer Änderung der Stimmrechte von Gesellschaftern oder Direktoren besteht, die
zur Annahme eines Beschlusses erforderlich sind.
17.5 Bei jeder der folgenden Handlungen bedarf es, unabhängig anderer Bestimmungen bezüglich der Zustimmung oder
der Annahme in anderen Gesellschaftervereinbarungen, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft
eingehen, oder dieser Satzung immer einer Dreiviertel-Mehrheit der Investoren: (i) Veräußerung von Rechten geistigen
Eigentums durch die Gesellschaft oder durch eine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft; (ii) Ver-
äußerung einer direkten oder indirekten Tochtergesellschaft durch die Gesellschaft.
D. Geschäftsführung und Beratender Ausschuss
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse der Geschäftsführung.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese die Geschäftsführung.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf die „Geschäftsführung" als
Verweis auf den alleinigen Geschäftsführer auszulegen.
18.3 Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und
alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
121142
L
U X E M B O U R G
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehaltenen
Handlungen.
Art. 19. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche ihre
Bezüge und Amtszeit festlegt.
19.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund gemäß Artikel 17.1 h) gewählt oder abberufen werden.
19.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-
schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten werden und die Geschäftsführer sind der Kategorie zuzuordnen, der sie angehören.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Hauptversammlung der Gesellschafter neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen der Geschäftsführung.
21.1 Die Geschäftsführung versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen der Ge-
schäftsführung finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung der Geschäftsführung schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen der
Geschäftsführung ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss der Geschäftsführung
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder der Ge-
schäftsführung diesen zugestimmt haben und sie unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Die Geschäftsführung kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Die Geschäftsführung kann
auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Mitglied der Geschäftsführung sein muss und der für
die Protokollführung der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen der Geschäftsführung werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung geleitet.
In dessen Abwesenheit kann die Geschäftsführung einen anderen Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an einer Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen, indem es ein anderes
Mitglied der Geschäftsführung schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommu-
nikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied der
Geschäftsführung kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung der Geschäftsführung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes
Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.
22.5 Die Geschäftsführung kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung der Geschäftsführung teil-
nehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, falls vorhanden, hat im
Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse der Geschäftsführung nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Die Geschäftsführung kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax-
schreiben, oder per E- Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können
121143
L
U X E M B O U R G
ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft und deren direkten oder indirekten
Tochtergesellschaften liegen, und - in jedem Fall - für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesell-
schaft und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert wurden und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung genehmigt wurden:
a) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen oder Teil¬Gesellschaften;
b) Änderung der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Ausübung (oder der Aus-
schluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, mit denen ein direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis
besteht;
c) Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
d) Wesentliche Änderungen der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Einstellung eines wesentlichen Ge-
schäftsbetriebs;
e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihun-
derttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;
f) Gewährung von Darlehen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten,
unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft;
g) Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die einen Gesamtbetrag
von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, unter Ausschluss von
Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
h) Künftige Transaktionen bezüglich Devisen, Sicherheiten und börsengehandelten Gütern und Rechten sowie weitere
Transaktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
i) Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
j) Abschluss, Änderung oder Kündigung von
Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hin-
sichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
k) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert
von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;
l) Verfügung über Nutzungsrechte jeglicher Art hinsichtlich der
Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Wei-
tergabe von Know-how zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder Drittparteien, unter Ausschluss von Bestim-
mungen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
m) Geschäfte der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen Personen und Einzelpersonen. Als
Gesellschafter werden verbundene Gesellschaften sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter angesehen,
sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmungsver-
pflichtung gemäß des vorliegenden Punktes m) ist nicht anwendbar, wenn das Geschäft zum gewöhnlichen Geschäftsgang
der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
n) Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG));
o) Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter
ist, sofern diese Ausübung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß
dieses Artikels 22.8, a) bis o), Artikel 17.1 oder 17.2.
Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Beratenden Ausschusses.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf und zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beratenden Ausschusses erfordern. Der Beratende Ausschuss kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten
von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für Geschäftsführer be-
schließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels, soweit gesetzlich möglich, auf
die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt oder
indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
121144
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Protokoll von Sitzungen der Geschäftsführung - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung der Geschäftsführung wird vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, falls vorhanden
oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden), oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), durch gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführer
der Kategorie A (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder
auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, falls vorhanden, oder von
zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), durch gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführer der
Kategorie A (oder deren Vertreter).
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, wirksam verpflichtet;
sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich
Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch die Geschäftsführung übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 25. Beratender Ausschuss.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus zehn (10)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung des Beratenden Ausschusses nur durch einen ein-
stimmigen Gesellschafterbeschluss genehmigen oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schriftliche
Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) fünf (5) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures
LP nach eigenem Ermessen ernannt; und
f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Mercura Capital GmbH
nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beratende Ausschuss hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Eines der Rocket-
Mitglieder ist der Vorsitzende des Beratenden Ausschusses und hat nicht die entscheidende Stimme. Die Geschäftsord-
nung des Beratenden Ausschusses hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des
Beratenden Ausschusses, zu enthalten.
25.5 Der Beratende Ausschuss ist zuständig für die Erteilung von Zustimmungen zu Transaktionen und Maßnahmen
der Geschäftsführer, die die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beratenden Ausschusses ent-
weder (i) in dieser Satzung, (ii) in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss
oder (iv) in jedweder Gesellschaftervereinbarung erteilt hat.
25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beratenden Ausschusses wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der
Gesellschaft durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.
25.7 Neben den in den Artikeln 22.8 und 22.9 vorgesehenen Zustimmungserfordernissen hat der Beratende Ausschuss
eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
121145
L
U X E M B O U R G
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Hauptversammlung der Ge-
sellschafter ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen
werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und die Geschäftsführung erstellt im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachten Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag der Geschäftsführung bestimmt die Hauptversammlung der Gesellschafter im Einklang mit den
gesetzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung wie der verbleibende Jahresnettogewinns der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Die Geschäftsführung kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche durch
die Geschäftsführung vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt und
darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht
durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste
oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt
werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Ver-
mögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der
Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel
dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaf-
tervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach Luxemburger Recht zulässig, maßgebend.
121146
L
U X E M B O U R G
Die vorliegende Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend."
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen und Ausgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft entste-
hen, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.500,-.
Worüber die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem oben angegebenen Tag erstellt wurde.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit auf Antrag der erschie-
nenen Parteien, dass diese Urkunde auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen
derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die
englische Fassung maßgebend.
Die Urkunde ist in Anwesenheit der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, die dem Notar mit Namen, Vorn-
amen, Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dieser sowie von dem Notar unterzeichnet worden.
Gezeichnet: K. GAUZES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2013. Relation: LAC/2013/33593. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 22. August 2013.
Référence de publication: 2013121156/1523.
(130147146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.
SQLI Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. Clear Vision International S.A.).
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 72.155.
L'an deux mille treize.
Le dix-neuf août.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEAR VISION INTERNA-
TIONAL S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.155 (NIN 1999 2226 695),
constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald NEUMAN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 octobre
1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 986 du 22 décembre 1999, et dont les statuts
ont été modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Reginald NEUMAN en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 280 du 13 avril 2000;
- suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 11 octobre 2001, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 344 du 1
er
mars 2002.
Le capital social s'élève au montant de quatre-vingt-treize mille Euros (€ 93.000.-), représenté par trois mille (3.000)
actions d'une valeur nominale de trente-et-un Euros (€ 31.-) chacune, entièrement libérées.
L'assemblée est présidée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach,
9, Rabatt,
qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette SCHOU, employée
privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt.
Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
Changement de la dénomination sociale en SQLI Luxembourg S.A. avec modification afférente de l'article 1 des statuts
afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SQLI Luxembourg S.A.."
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
121147
L
U X E M B O U R G
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en SQLI Luxembourg S.A. et par con-
séquent de modifier l'article 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SQLI Luxembourg S.A.."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame le Président lève la séance.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: P. SIMON, M.SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 21 août 2013. Relation: ECH/2013/1565. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 23 août 2013.
Référence de publication: 2013121114/52.
(130147165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.
Brillant-Express, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 31.468.
L'an deux mil treize.
Le trente-et-un juillet.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Ali MOGHADDAM, commerçant, né à Shostar (Iran) le 10 mai 1950 (No. Matricule 19500510059),
demeurant à L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.
2) Madame Flora AFTAHI, commerçante, épouse de Monsieur Ali MOGHADDAM, née à Teheran (Iran) le 1
er
avril
1952 (No. Matricule 19520401086), demeurant à L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «BRIL-
LANT-EXPRESS Sàrl» (Matricule 19892404960), avec siège social à L-8340 Olm, 89 Boulevard Robert Schuman;
inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B31.468;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 août 1989, publié au Mémorial C de 1990,
page 922;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 mars 2005, publié au Mémorial C de 2005,
page 37.145.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-8340 Olm, 89 Boulevard Robert Schuman à L-8077
Bertrange, 117A rue de Luxembourg.
<i>Deuxième et Dernière résolution:i>
Suite au prédit transfert de siège social, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est à lire comme suit:
« Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est à Bertrange.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
<i>Frais:i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale,
s'élève approximativement au montant de HUIT CENT VINGT EURO (Euro 820.-).
121148
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel.
Signé: Moghaddam, Aftahi, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 09 août 2013. Relation: EAC/2013/10617. Reçu soixante quinze euros 75,00.- EUROS.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Bettembourg, le 19 août 2013.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2013120281/42.
(130145856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 84.135.
L'an deux mille treize, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
La Société «CACEIS BANK Luxembourg» ayant son siège social à Luxembourg, 5, allée Scheffer, ici représentée par
Mme Ana VASQUEZ, employée privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
laquelle comparante, ici représentée comme ci-avant. agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'admi-
nistration de la société anonyme «PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 2 S.A.», ayant son siège
social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 28 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
305 du 23 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 3 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 918 du 6 mai 2011,
immatriculée près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 84.135 (ci-après la Société),
en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration ci-après relatée.
A exposé et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à quinze millions d'euros (EUR
15.000.000,-) représenté par un million cinq cent mille (1.500.000,-) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR
10,-) chacune et le conseil d'administration a été autorisé de décider de la réalisation de cette augmentation de capital,
l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.
II.- Suivant résolutions prise par le conseil d'administration en adoptées le 15 février 2013, et documentée par actes
de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le conseil d'administration a été autorisé à émettre
des obligations convertibles dans le cadre du capital autorisé statutaire.
III.- Que le conseil d'administration, en diverses réunions, en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de
l'article 5 des statuts et en vertu des emprunts obligataires émis par la société, a constaté plusieurs conversions et réalisé
en conséquence une (1) augmentation de capital autorisée, à savoir:
1) en exécution des résolutions prise lors de sa réunion du 15 février 2013, à concurrence de 12.470,- EUR (douze
mille quatre cent soixante-dix euros) pour porter le capital de son montant actuel de 683.490,- EUR (six cent quatre-
vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix mille euros), à un montant de six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent
soixante euros (695.960,-EUR) par la création de mille deux cent quarante-sept (1.247) actions nouvelles de catégorie
«TAND» d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes
toutes souscrites suite à conversions par l'actionnaire suivant:
- Mille deux cent quarante-sept (1.247) actions souscrites par Predica 2007, Fonds Commun de Placement à Risque
(FCPR) de droit français.
Un extrait desdites résolutions, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte avec lequel ils seront formalisés.
IV.- Les emprunts obligataires et donc toutes les actions nouvelles converties ont été libérées intégralement en nu-
méraire par versements à un compte bancaire au nom de la société Predica 2007, prénommée, de sorte que la somme
totale de douze mille quatre cent soixante-dix euros (12.470,-EUR) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives requises.
V.- Suite à la réalisation de cette tranche de l'augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l'article cinq des
statuts est modifié en conséquence et à la teneur suivante:
121149
L
U X E M B O U R G
« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante euros (695.960,-
EUR), représenté par soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize (69.596) actions réparties comme suit:
- Deux cent quatre-vingt-sept (287) actions de catégorie «P4»;
- Trente-six mille sept cent une (36.701) actions de catégorie «CVC»;
- Trente-deux mille six cent huit (32.608) actions de catégorie «TAND»;
chacune libérée intégralement et d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinquante euros (1.050,- EUR).
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, état et demeure, ils
ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. VAZQUEZ, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26/06/2013. Relation: LAC/2013/29351. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 23/08/2013.
Référence de publication: 2013120769/64.
(130146841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Ordinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 91.629.
L'an deux mille treize, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Ordinvest S.A.» constituée suivant acte reçu
par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Hesperange, le 9 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 270 le 13 mars 2003,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 91.629 (la "So-
ciété").
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Géraldine NUCERA, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
La présidente nomme comme secrétaire Madame Anne LAUER, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la présidente a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre la Société «Ordinvest S.A.» en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur donner pleine et entière décharge
jusqu'à ce jour.
4. Divers.
II. Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire dudit actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'ac-
tions détenues par ce dernier, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par la mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, la procuration de l'actionnaire
unique représenté, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire, les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
121150
L
U X E M B O U R G
III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à l'assemblée et que l'actionnaire unique représenté a déclaré
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et a renoncé à son droit d'être formel-
lement convoqué.
IV. Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
V. Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale nomme Roger Caurla, maître en droit, demeurant professionnellement au 3, Place Dargent
L-1413 Luxembourg comme liquidateur.
L'assemblée générale des actionnaires a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des
pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société,
quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,
il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par
la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,
pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre
les parties concernées.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur donner pleine et entière
décharge jusqu'à ce jour.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à huit cents euros (800,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes connues du notaire instrumentant par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec le Notaire, le présent acte.
Signé: G. NUCERA, A. LAUER, V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26/06/2013. Relation: LAC/2013/29325. Reçu 12,- € (douze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/08/2013.
Référence de publication: 2013120758/76.
(130146276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Globstory S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.077.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013121221/9.
(130147312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.
121151
L
U X E M B O U R G
Sedco Capital Global Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 168.687.
L’assemblée générale qui s’est tenue le 12 juin 2013, a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Germain Birgen,
Hasan S. Aljabri, Paul Touloumbadjian et Yaser S. Binmahfouz en tant que membres du conseil d’administration de la
société SEDCO Capital Global Funds et ce, jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2014.
Le conseil d’administration est composé dès lors, comme suit:
Germain Birgen, Membre du conseil d’administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Hasan S. Aljabri, Membre du conseil d’administration
Morjan Dist Road Malik, Jeddah, Saudi Arabia
Paul Touloumbadjian, Membre du conseil d’administration
Malik Road 21493 Jeddah, Saudi Arabia
Yaser S. Binmahfouz, Membre du conseil d’administration
Morjan Dist Road Malik, Jeddah, Saudi Arabia
Deloitte Audit Sàrl (Luxembourg) (anciennement Deloitte SA), sis au 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, a été
réélu comme réviseur d’entreprises et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Référence de publication: 2013120185/26.
(130145780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Ingersoll-Rand Lux Roza III S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 125.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 111.324.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société que:
1. La démission de Monsieur Lawrence Kurland, gérant de catégorie A de la Société, a été acceptée avec effet au 18
juillet 2013.
2. Monsieur Scott McKinlay, né le 11 avril 1983 à Dunfermline (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 16,
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet au 18 juillet 2013 et ce
pour une durée indéterminée.
3. Monsieur Benoît Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société avec effet au 18 juillet 2013 et ce pour
une durée indéterminée.
4. Monsieur Jeffrey Tallyen devient gérant de catégorie A.
Suite aux résolutions qui précèdent, le Conseil de gérance se compose comme suit:
Mr Olivier Caremans, gérant de catégorie A;
Mr Jeffrey Tallyen, gérant de catégorie A;
Mr Scott McKinlay, gérant de catégorie B;
Mme Agnes Csorgo, gérant de catégorie B; et
Mr Benoît Bauduin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120625/28.
(130146613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
121152
Brillant-Express, S.à r.l.
Clear Vision International S.A.
Edmund Propco S.à r.l.
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.
Globstory S.à r.l. SPF
Ingersoll-Rand Lux Roza III S.àr.l.
Lusana Participations S.A.
Mehonne S.A.
M-Square Finance S.A. SPF
M-Square Management S.à.r.l.
MSR Luxoil S.A.
Newan S.A.
New Line
Newport Ventures S.A.
Newtra S.A.
Newtra S.A.
Novaluxco 1 S.A.
Ordinvest S.A.
Overland Trade SA
Pala Real Estate S.à r.l.
Pan European Real Estate Fund 2 S.A.
Pan European Real Estate Fund 3 S.A.
Pan European Real Estate Fund 4 S.A.
Pan European Real Estate Fund 5 S.A.
Pan European Real Estate Fund 6 S.A.
Paritex S.A.
Parkettcenter S.à.r.l.
Patrick Weber S.àr.l.
PAUL International
PayPal International S.à.r.l.
PE Feeder SIF
Peintures-Décors Oestreicher S.à r.l.
Pérez Capital S.A.
Pimlico
Piwo International S.A.
PO Co-invest IHS
PPTM International S.à r.l.
Prime Credit 3 S.à r.l.
Private Equity International S.A.
Private Equity Selection International (PESI) 2 S.A.
Proprio S.A.
RWM Luxoil SA
Samsonite International S.A.
Sancopia Portfolios-A S.à r.l.
Sancopia Portfolios No. 1 S.à r.l.
Santana S.à r.l.
Savrow Holdings S.à r.l.
Sedco Capital Global Funds
Senna Cordonnerie Rapide Luxembourg S.A.
Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à r.l.
Spring Petroleum Investments Luxco 1 S.à r.l.
Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.
Spring Petroleum Investments Luxco 2 S.à r.l.
SQLI Luxembourg S.A.
StoneCreek Capital International Ltd.
Stonecreek Technologies Inc.
St. Stephan S.à r.l.
Tika S.àr.l.
Voyages Wengler s.à r.l.
World Cosmetics S.A.