This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2520
10 octobre 2013
SOMMAIRE
Boreas Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
120934
Cassiopea Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .
120914
Centre Equestre Lippert s.à r.l. . . . . . . . . . .
120916
Chaos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120914
Christine de Monbel S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
120923
Clearinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120933
Cofimag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120914
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120914
CommCapital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120914
Crakoukass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120915
DMA Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120915
Domaines Invests S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120915
Dust Fiduciaire S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120916
Dynamo Studio Graphique Sàrl . . . . . . . . .
120916
Earth Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120916
FAM Energy Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . .
120923
Farena Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120924
First Data International Luxembourg II S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120916
Fluxen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120947
Fondalux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120960
Fulham Broadway S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
120934
Gemplus International S.A. . . . . . . . . . . . . .
120923
Idem Luxembourg (No. 6) . . . . . . . . . . . . . .
120948
Influence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120960
International Administration Group (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120954
Lipizzaner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120952
Nix Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120924
Prime Credit 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120948
Run Out Kletterschule S.à r.l. . . . . . . . . . . .
120945
SAIC Lux, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Sant Topco Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
120922
Sant Topco Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
120922
S&B Minerals S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120939
SD Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Sedlen Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120922
SEI-Société Européenne d'Investissements
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Sigma Fin International S.à.r.l. . . . . . . . . . .
120932
Silverex Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120918
Socalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120918
Société de Développement International
et de Capitaux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120918
Sommelier-Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120921
Sorep S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Station SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120921
Stratego Managing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
120920
Substantial Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
120920
Sun Sail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120920
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120923
Sydney International Properties S.A. . . . .
120921
Système de Développement Européen
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120921
Taygeta Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
120919
Teroko S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120920
The West of England Ship Owners Mutual
Insurance Association (Luxembourg) . . .
120918
Threadline Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
120919
Tivolex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120919
TK SEI Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
120919
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. &
Partners, S.C.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120922
Tunon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120921
Tusculanum SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120917
Tyco Electronics Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
120919
U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
120915
Umeco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
120920
Zen Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120940
120913
L
U X E M B O U R G
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 678.884,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 119.647.
EXTRAIT
Il convient de noter que l'adresse de l'associé unique de la Société a changé. Désormais le siège social de l'associé
unique de la Société est 20, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 23.08.2013.
Référence de publication: 2013120445/13.
(130146746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Cassiopea Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 150.850.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CASSIOPEA INVESTMENT S.A.
i>Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Signatures
<i>Agent administratifi>
Référence de publication: 2013120457/14.
(130146363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Chaos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse.
R.C.S. Luxembourg B 114.878.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120469/9.
(130146837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Cofimag S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.860.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120473/9.
(130146832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
CommCapital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.053.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120474/9.
(130146645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120914
L
U X E M B O U R G
Crakoukass S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 131.718.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120482/9.
(130146384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
DMA Holdings S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 108.914.
<i>Extrait du procès - verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 août 2013i>
Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolution: Renouvellement du mandat de l’administrateur pour une période de six ans:i>
- Darragh MAC ANTHONY, demeurant 235, Am Durrbach, Haus 2, CH-6390 Engelberg.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> Résolution: Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans:i>
- Fibetrust S.àr.l., avec siège social à 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.
Pour l'exactitude de l'extrait
Référence de publication: 2013120495/14.
(130146847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Domaines Invests S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 117.002.
La Société constate que:
- Monsieur Jean Sébastien MINETTI en sa qualité d’administrateur de la Société est désormais demeurant au 16, rue
Johannes Gutenberg, L-1649 Luxembourg.
- Madame Philippine RICOTTA-WALAS en sa qualité d’administrateur de la Société est désormais demeurant au 4,
place de la Paix, L-4275 Esch-sur-Alzette.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2013.
Référence de publication: 2013120497/14.
(130146555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.050,00.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 105.894.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 août 2013i>
1. Monsieur Andrew O'SHEA a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120910/17.
(130146457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120915
L
U X E M B O U R G
Centre Equestre Lippert s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 43, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 106.046.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CENTRE EQUESTRE LIPPERT, s.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013120463/11.
(130147026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Dust Fiduciaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 161.939.
Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120498/9.
(130146799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Dynamo Studio Graphique Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2651 Luxembourg, 25, rue St. Ulric.
R.C.S. Luxembourg B 109.872.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DYNAMO STUDIO GRAPHIQUE SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013120500/11.
(130147011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Earth Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 172.164.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120501/9.
(130146349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
First Data International Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 129.169.375,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.175.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012 de la société mère, notamment First Data Corporation ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 aout 2013.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013120534/14.
(130146464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120916
L
U X E M B O U R G
SAIC Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 3, Passage Gëlle Klack.
R.C.S. Luxembourg B 153.632.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 8 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1486
du 20 juillet 2010
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SAIC Lux, S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013120846/15.
(130146755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
SD Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 162.531.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120850/10.
(130146416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
SEI-Société Européenne d'Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 52.811.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2012 au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120853/11.
(130146776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Sorep S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Schifflange, Z.I. Um Monkeler.
R.C.S. Luxembourg B 49.266.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120869/9.
(130146227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Tusculanum SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 150.869.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120891/9.
(130146668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120917
L
U X E M B O U R G
Silverex Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande.Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 121.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 Août 2013.
Référence de publication: 2013120858/10.
(130146394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Socalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 39.683.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Alain JACOB. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2019.
Luxembourg, le 13 juin 2013.
Certifié sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
E. MAROT / P. TYCHON / A. JACOB
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013120860/15.
(130146684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
S.D.I.C. S.A., Société de Développement International et de Capitaux S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 92.598.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2012 au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120864/11.
(130146657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg), Association d'Assurances
Mutuelles.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 8.963.
<i>Extrait rectificatif concernant la modification déposée le 9 Juillet 2013 sous la référence L130114091i>
Le présent document est établi en vue de corriger les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg. En effet, une erreur s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 9 juillet 2013 sous la
référence L130114091.
Monsieur Philip A. ASPDEN, délégué à la gestion journalière, est né le 22 juillet 1945 et non le 22 juillet 1948.
Toutes les autres mentions de la publication restent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
Signature
Référence de publication: 2013120886/18.
(130146283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120918
L
U X E M B O U R G
TK SEI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 140.522.
Le siège social de la société a été transféré à L-1273 Luxembourg, 19 rue de Bitbourg, avec immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013120902/12.
(130146496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Tivolex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.421.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120901/10.
(130146609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Threadline Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 113.329.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120897/10.
(130146409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Taygeta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 106.216.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TAYGETA INVESTMENTS S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120894/11.
(130146277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.078.
Les statuts coordonnés au 1
er
août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013120892/11.
(130146695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120919
L
U X E M B O U R G
Teroko S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 115.732.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 8 avril 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 8 mai 2013.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2013120895/13.
(130146629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Sun Sail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 65.002.
Le bilan rectificatif au 31/12/2012 (Rectificatif du dépôt du bilan 2012 déposé le 31/07/2013, N° L130132132), a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013120877/11.
(130146912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Substantial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 77.186.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120875/10.
(130146748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Stratego Managing S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 165.077.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120874/10.
(130146992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Umeco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 149.758.
Les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2013120917/10.
(130146890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120920
L
U X E M B O U R G
Station SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 34.047.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013120873/11.
(130146482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Tunon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 100.912.
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 21 aout 2013, le contrat de domiciliation
conclu avec la société sous rubrique
Luxembourg, le 22 aout 2013.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Rits / Alan Botfield
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2013120890/13.
(130146361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Sydney International Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 105.356.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120880/10.
(130146411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Système de Développement Européen S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 38.774.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013120881/10.
(130146410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Sommelier-Conseil, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 62, rue de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 34.098.
Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120868/10.
(130146509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120921
L
U X E M B O U R G
Sant Topco Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.064.120,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.451.
Il est porté à la connaissance de tous que le nom de l'actionnaire Pearl Assurance plc a fait l'objet d'un changement.
A savoir:
- Phœnix Life Assurance Limited, siège social: 1 Wythall Green Way, Wythall, Birmingham, England B47 6WG.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013120827/13.
(130146679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Sedlen Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 152.933.
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 2012 et comptes de pertes et profits, tel qu’approuvés par l’associé unique, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour le fonds
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013120829/14.
(130147010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Sant Topco Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 242.219.150,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.448.
Il est porté à la connaissance de tous que le nom de l'actionnaire Pearl Assurance Limited a fait l'objet d'un changement.
A savoir:
- Phœnix Life Assurance Limited, siège social: 1 Wythall Green Way, Wythall, Birmingham, England B47 6WG.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013120828/12.
(130146680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. & Partners, S.C.S, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 110.954.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par les résolutions du 20 août 2013, les associés de la Société ont décidé:
- que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la Société à la date de
la clôture de la liquidation,
120922
L
U X E M B O U R G
- que les fonds restants dans la Société seront utilisés pour régler les factures et impôts en suspens, le cas échéant, et
que le solde bancaire créditeur éventuel ultérieur sera versé aux associés de la Société,
- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 21 août 2013.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2013119638/25.
(130145381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2013.
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.008.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de la Société Swedbank AB (publ) du 26 juin 2013.i>
Le Conseil d'Administration a pris la décision suivante:
§7b. Pouvoir de signature
Le Conseil d'Administration a accepté la démission d'un représentant permanent suivant:
- Monsieur Lars FRIBERG, né le 17 septembre 1962, demeurant professionnellement à 65 Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, en date du 13 août 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Stockholm, Suède, le 26 juin 2013.
Anders Sundström / Ulrika Francke.
Référence de publication: 2013120845/15.
(130146594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Christine de Monbel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
R.C.S. Luxembourg B 121.312.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120523/9.
(130146917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Gemplus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 73.145.
Les comptes consolidés de la société Gemalto N.V. au 31 décembre 2012, reprenant les comptes annuels de Gemplus
International S.A., ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120574/10.
(130146359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
FAM Energy Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel LIppmann.
R.C.S. Luxembourg B 127.177.
Les comptes annuels au 31. Dezember 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120545/9.
(130146321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120923
L
U X E M B O U R G
Farena Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.727.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 juin 2013i>
En date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Noelle PICCIONE, de son mandat de gérant de catégorie B de
la Société avec effet au 30 juin 2013.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Karl Josef HIER, gérant de catégorie A
- Monsieur Patricio BALMACEDA, gérant de catégorie A
- Monsieur Céline BONVALET, gérant de catégorie B
- Madame Chantal MATHU, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Farena Invest S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013120530/21.
(130146447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Nix Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.636.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the second day of the month of August.
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered
office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 164.012,
represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 2 August 2013, which shall
be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Nix Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Nix Investment S.à
r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
120924
L
U X E M B O U R G
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-)
represented by seven hundred and fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each. The
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers has, the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all 3 circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
120925
L
U X E M B O U R G
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by 6 law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
120926
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2013.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (GBP)
BRE/Europe 6Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15,000.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 164.777,
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
120927
L
U X E M B O U R G
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am zweiten Tag des Monats August,
Vor Uns, Maître Francis Kesseler, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) beträgt, und eingetragen ist im luxemburgischem Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de com-
merce et des sociétés) unter der Nummer B 164.012.
hier vertreten durch Herr Joe Zeaiter, juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht
vom 2 August 2013, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht
zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Nix Investment S.à r.l." (société à responsabilité limitée) wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Nix Investment S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebe-
nenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-
rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000,-), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
zwanzig Pfund Sterling (GBP 20,-).
120928
L
U X E M B O U R G
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.
120929
L
U X E M B O U R G
Die Begriffe „Klage", „Streitsache", „Prozess" oder „Verfahren" finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,
Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit" und „Ausgaben" beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; (iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht
unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2013 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
120930
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(GBP)
BRE/Europe 6Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000,-
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr eintausend fünfhundert euro (EUR 1.500,-) betragen.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: Zeaiter, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 09 août 2013. Relation EAC/2013/10656.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expedition conforme.
Référence de publication: 2013120069/421.
(130145653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
120931
L
U X E M B O U R G
SIGMAFIN Sàrl, Sigma Fin International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2012 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 143.018.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille treize, le trente juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Madame Maria Luce SAMPIETRO, employée, née à Rome (Italie) le 28 janvier 1960, demeurant à L-1526 Luxemboug,
38, Val Fleuri,
ici représentée par Monsieur Kim JENSEN, employé, ne à Klim (Danemark) le 17 juillet 1962, demeurant à L-1526
Luxemboug, 38, Val Fleuri, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signeé «ne varietur» par la
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée «Sigma Fin International S.à.r.l.», en abrégé «SIGMAFIN S.à r.l.»,établie et ayant
son siège social au 34B, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 143.018, constitué suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de
résidence à Bettembourg, en date du 30 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations numéro
2886 du 03 décembre 2008 (ci-après la «Société»).
La Société a été mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 mai 2013,
en voie de publication au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
- Que la comparante est le seul et unique associé de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale
extraordinaire et a pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur, approuve ce rapport ainsi que les comptes de
liquidation.
Dans le cas où les provisions s'avéreraient insuffisantes pour faire face aux dettes, les associés s'engagent à reprendre
ces dettes pour leur compte.
Le rapport du liquidateur, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et aux gérants pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme
de neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Kim JENSEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 01 août 2013. Relation GRE/2013/3195. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
120932
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013120169/55.
(130146241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Clearinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 34.387.
L'an deux mille treize, le onze juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEARINVEST, ayant son
siège social à L-2314 Luxembourg, 2a, place de Paris, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de
Luxembourg sous le numéro B 34387, constituée suivant acte reçu le 26 juillet 1990 de Maître Edmond SCHROEDER,
notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, page 1192 de 1991, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu du notaire instrumentaire le 20 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
670, daté du 19 septembre 1998, page 32157;
et encore suivant acte du notaire instrumentaire du 5 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1422, daté du 2
octobre 2022, page 68224,
et encore pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire instrumentaire le 30 décembre 2002, publié au Mémorial
C numéro 248 daté du 7 mars 2003, page 11893, L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant
à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Maître Romain LUTGEN, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, la Présidente déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée nomme liquidateur: la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège à Luxembourg
15-17, avenue Guillaume, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B83527. Sa rémunération
est fixée à 7000,00 euros, plus TVA.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée
générale des associés
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.
120933
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. UHL, R. LUTGEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 15 juillet 2013. Relation: LAC/2013/32678. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveuri> (signé): C. FRISING.
Référence de publication: 2013120471/62.
(130146559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Fulham Broadway S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 163.543.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Fulham Broadway S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013120543/11.
(130146607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Boreas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 148.696.
In the year two thousand and thirteen, on the first day of August.
Before Us, Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch.
There appeared:
1) “EIG Energy Fund XIV L.P.”, formerly named “TCW Energy Fund XIV LP.”, a limited partnership incorporated under
the laws of the state of Delaware (United States of America), having its registered office at 160 Greentree Drive, Suite
101, Dover, Delaware 19904, USA (United States of America),
represented here by Mr Daniel BLEY, bank employee, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard
Konrad Adenauer,
by virtue of a proxy under private seal given on 26 July 2013,
2) “EIG Energy Fund XIV-A L.P.”, formerly named “TCW Energy Fund XIV-A L.P.”, a limited partnership incorporated
under the laws of the state of Delaware (United States of America), having its registered office at 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover, Delaware 19904, USA (United States of America),
represented here by Mr Daniel BLEY, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 26 July 2013,
3) “EIG Energy Fund XIV-B L.P.”, formerly named “TCW Energy Fund XIV-B L.P.”, a limited partnership incorporated
under the laws of the state of Delaware (United States of America), having its registered office at 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover, Delaware 19904, USA (United States of America),
represented here by Mr Daniel BLEY, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 26 July 2013,
4) “EIG Energy Fund XIV (Cayman) L.P.”, formerly named “TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P.”, a limited partnership
incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered office in Grand Cayman (Cayman Islands), 4
th
Floor,
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive,
represented here by Mr Daniel BLEY, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 26 July 2013,
5) “European Clean Energy Fund L.P.”, a limited partnership incorporated under the laws of England, having its regis-
tered office in BS1 6BU Bristol (United Kingdom), 1, Mitchell Lane,
represented here by Mr Daniel BLEY, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 26 July 2013,
(each being individually a Shareholder and jointly the Shareholders).
120934
L
U X E M B O U R G
The abovementioned proxies, initialled “ne varietur”, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The Shareholders, acting through the proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following:
1. “EIG Energy Fund XIV L.P.”, “EIG Energy Fund XIV-A L.P.”, “EIG Energy Fund XIV-B L.P.”, “EIG Energy Fund XIV
(Cayman) L.P.” and “European Clean Energy Fund L.P.”, prenamed, are the Shareholders of “Boreas Holdings S.à r.l.”, a
private limited liability company under Luxembourg Law (société à responsabilité limitée), having its registered office in
L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, incorporated by deed of notary Martine SCHAEFFER, residing in
Luxembourg, on 8 October 2009, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 2162 of
5 November 2009, modified by deed of notary Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg, on 10 December 2009,
published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 902 of 30 April 2010, modified by deed of
the prenamed notary HELLINCKX on 25 February 2010, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C”, number 951 of 6 May 2010, modified by deed of the prenamed notary HELLINCKX on 14 February 2011, published
in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C”, number 1181 of 1 June 2011, modified by deed of notary Emile
SCHLESSER, residing in Luxembourg, on 21 June 2011, published in the “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C”, number 2049 of 3 September 2011, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under
section B and number 148.696, with a share capital of one million eight hundred twenty-eight thousand five hundred and
eighty British Pounds (GBP 1,828,580.00), represented by one billion eight hundred twenty-eight million five hundred and
eighty thousand (1,828,580,000) shares with a nominal value of one thousandth of a British Pound (GBP 0.001) each (the
Company).
2. The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred thousand British
Pounds (GBP 200,000.00) in order to bring the share capital from its current amount of one million eight hundred twenty-
eight thousand five hundred and eighty British Pounds (GBP 1,828,580.00), represented by one billion eight hundred
twenty-eight million five hundred and eighty thousand (1,828,580,000) shares with a nominal value of one thousandth of
a British Pound (GBP 0.001) each, to an amount of one million six hundred and twenty-eight thousand five hundred and
eighty British Pounds (GBP 1,628,580.00), represented by one billion six hundred and twenty-eight million five hundred
and eighty thousand (1,628,580,000) shares with a nominal value of one thousandth of a British Pound (GBP 0.001) each,
by way of the repurchase and the subsequent cancellation of all the Class I Shares held by the Shareholders in the share
capital of the Company (the Repurchased Shares) for an aggregate repurchase price of five million British Pounds (GBP
5,000,000.00) (the Repurchase Price).
The Shareholders resolve in accordance with the provisions set forth in the Articles and based on the recommendations
made by the board of managers of the Company to set the Total Cancellation Amount (as defined in the Articles) for
the Repurchased Shares at five million British Pounds (GBP 5,000,000.00), and the Shareholders acknowledge the Can-
cellation Value per Share price of zero point zero two five British Pounds (GBP 0.025).
The interim accounts dated 31 July 2013 (the Interim Accounts) after having been signed “ne varietur” by the proxy-
holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with
such deed with the registration authorities.
The Shareholders resolve that the Repurchase Price shall be allocated in the accounts of the Company, as follows:
(i) two hundred thousand British Pounds (GBP 200,000.00) shall correspond to the share capital reduction following
the cancellation of the Repurchased Shares pursuant to this present resolution; and
(ii) four million eight hundred thousand British Pounds (GBP 4,800,000.00), shall be taken out of the share premium
account of the Company.
The Shareholders further note that the Repurchase Price shall be allocated as follows:
Shareholder
Number
of shares
to be
cancelled
Amount
to be paid
(GBP)
EIG Energy Fund XIV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,023,825 1,050,595.63
EIG Energy Fund XIV-A L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,030,063 1,175,751.56
EIG Energy Fund XIV-B L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,799,350
194,983.75
EIG Energy Fund XIV (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,146,762
703,669.06
European Clean Energy Fund L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75,000,000 1,875,000.00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,000,000 5,000,000.00
The Shareholders acknowledge that, in accordance with the Articles and on the basis of the Interim Accounts, the
Company has sufficient available distributable reserves (including share premium and excluding the legal reserve) and
profits to proceed to (i) the repurchase of the Repurchased Shares for the Repurchase Price and (ii) the above allocation.
3. The Shareholders resolve to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it shall
henceforth read as follows:
120935
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at one million six hundred and twenty-eight thousand
five hundred and eighty British Pounds (GBP 1,628,580.00) divided into one billion six hundred and twenty-eight million
five hundred and eighty thousand (1,628,580,000) Shares with a nominal value of one thousandth of a British Pound (GBP
0.001) each, which are divided into:
- two hundred twenty-eight million five hundred eighty thousand (228,580,000) class A shares (the “Class A Shares”),
all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class B shares (the “Class B Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class C shares (the “Class C Shares”) all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class D shares (the “Class D Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class E shares (the “Class E Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class F shares (the “Class F Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class G shares (the “Class G Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two hundred million (200,000,000) class H shares (the “Class H Shares”), all subscribed and fully paid up.
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Association or by the Companies Act.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”
4. The Shareholders resolve to amend article 6, section 5, of the Articles in order to reflect the above resolution so
that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. Shares.
Section 5. Repurchase of Shares
The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of one or more entire
Classes of Shares provided however that the Company may not at any time purchase and cancel the Class A Shares. In
the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made
in the following order:
(i) Class H Shares;
(ii) Class G Shares;
(iii) Class F Shares;
(iv) Class E Shares;
(v) Class D Shares;
(vi) Class C Shares; and
(vii) Class B Shares.
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of any Class of Shares (in the
order provided for above), each such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such Class
of Shares) to such portion of the Total Cancellation Amount as is determined by the Board of Managers and approved
by the General Meeting, and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from
the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held
by them and cancelled.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Companies Act.”
5. The Shareholders resolve to authorise and empower any manager of the Company to individually register, in the
share register of the Company, the cancellation of the Repurchased Shares made under first resolution above and to see
to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents
with relevant Luxembourg authorities).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le premier août.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch.
120936
L
U X E M B O U R G
Ont comparu:
1) «EIG Energy Fund XIV L.P.», anciennement dénommée «TCW Energy Fund XIV L.P.», une société de droit de l'Etat
du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social à Washington, DC, 20006 (Etats-Unis d'Amérique), 1700,
Pennsylvania Avenue, N.W., suite 800,
ici représentée par Monsieur Daniel BLEY, employé de banque, demeurant professionnellement à L-1115 Luxembourg,
2, boulevard Konrad Adenauer,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 juillet 2013,
2) «EIG Energy Fund XIV-A L.P.», anciennement dénommée «TCW Energy Fund XIV-A L.P.», une société de droit de
l'Etat du Delaware (Etats- Unis d'Amérique), ayant son siège social à Washington, DC, 20006 (Etats- Unis d'Amérique),
1700, Pennsylvania Avenue, N.W., suite 800,
ici représentée par Monsieur Daniel BLEY, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 juillet 2013,
3) «EIG Energy Fund XIV-B L.P.», anciennement dénommée «TCW Energy Fund XIV-B L.P.», une société de droit de
l'Etat du Delaware (Etats- Unis d'Amérique), ayant son siège social à Washington, DC, 20006 (Etats- Unis d'Amérique),
1700, Pennsylvania Avenue, N.W., suite 800,
ici représentée par Monsieur Daniel BLEY, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 juillet 2013,
4) «EIG Energy Fund XIV (Cayman) L.P.», anciennement dénommée «TCW Energy Fund XIV (Cayman) L.P.», une
société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Grand Cayman (Iles Cayman), 4
th
Floor, Century Yard, Cricket
Square, Hutchins Drive,
ici représentée par Monsieur Daniel BLEY, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 juillet 2013,
5) «European Clean Energy Fund L.P.», une société de droit anglais, ayant son siège social à BS1 6BU Bristol (Royaume-
Uni), 1, Mitchell Lane,
ici représentée par Monsieur Daniel BLEY, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 juillet 2013,
(chacun étant individuellement un Associé et ensemble les Associés).
Les procurations prémentionnées, signées «ne varietur», resteront annexées au présent acte pour être formalisées
avec celui-ci.
Les Associés, agissant par le biais du mandataire, demandent au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
1. «EIG Energy Fund XIV L.P.», «EIG Energy Fund XIV-A L.P.», «EIG Energy Fund XIV-B L.P.», «EIG Energy Fund XIV
(Cayman) L.P.» et «European Clean Energy Fund L.P.», prénommés, sont les associés de «Boreas Holdings S.à r.l.», une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad
Adenauer, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 8
octobre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2162 du 5 novembre 2009, modifiée
suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 2009, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 902 du 30 avril 2010, modifiée suivant acte reçu par le
prédit notaire HELLINCKX en date du 25 février 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 951 du 6 mai 2010, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire HELLINCKX en date du 14 février 2011,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1181 du 1
er
juin 2011, modifiée suivant acte reçu
par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 2011, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 2049 du 3 septembre 2011,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 148.696, au
capital social de deux millions vingt-huit mille cinq cent quatre-vingts Livres Sterling (GPB 2.028.580,00), représenté par
deux milliards vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt mille (2.028.580.000) parts sociales d'une valeur nominale de un
millième de Livre Sterling (GPB 0,001) chacune (la Société).
2. Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent mille Livres Sterling (GBP
200.000,00) de façon à porter le capital social de son montant actuel de un millions huit cent vingt-huit mille cinq cent
quatre-vingts Livres Sterling (GPB 1.828.580,00), représenté par un milliards huit cent vingt-huit millions cinq cent quatre-
vingt mille (1.828.580.000) parts sociales d'une valeur nominale de un millième de Livre Sterling (GPB 0,001) chacune, à
un montant de un million six cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingts Livres Sterling (GBP 1.628.580,00), représenté
par un milliard six cent vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt mille (1.628.580.000) parts sociales d'une valeur nominale
de un millième de Livre Sterling (GPB 0,001) chacune, par le rachat et l'annulation subséquente de toutes les parts sociales
de classe I détenues par les Associés dans le capital social de la Société (les Parts de Rachat) pour un prix de rachat de
cinq millions de Livres Sterling (GBP 5.000.000,00) (le Prix de Rachat).
Les Associés décident, en accord avec les dispositions prévues par les Statuts et les recommandations faites par le
conseil de gérance de la Société, de fixer le Montant Total d'Annulation (tel que défini dans les Statuts) pour les Parts de
120937
L
U X E M B O U R G
Rachat à cinq millions de Livres Sterling (GBP 5.000.000,00) et les Associés prennent acte de la Valeur d'Annulation par
Part Sociale, d'un montant de zéro virgule zéro deux cinq Livre Sterling (GBP 0.025).
Les comptes intérimaires en date du 31 juillet 2013 (les Comptes Intérimaires), après avoir été signés «ne varietur»
par le mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte, pour être
soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Associés décident que le Prix de Rachat doit être alloué au bilan de la Société, comme suit:
(i) deux cent mille Livres Sterling (GBP 200.000,00) correspondent à la réduction de capital social suite à l'annulation
des Parts de Rachat comme le dispose cette présente résolution; et
(ii) quatre millions huit cent mille Livres Sterling (GBP 4.8000.000,00) doivent être prélevés du compte de primes
d'émission de la Société.
Les Associés décident que le Prix de Rachat doit être alloué comme suit:
Associés
Nombre
de parts
devant être
annulées
Montant
devant
être payé
EIG Energy Fund XIV L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.023.825 1.050.595,63
EIG Energy Fund XIV-A L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.030.063 1.175.751,56
EIG Energy Fund XIV (Cayman) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.146.762
703.669,06
EIG Energy Fund XIV-B L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.799.350
194.983,75
European Clean Energy Fund L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000.000 1.875.000,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000 5.000.000,00
Les Associés reconnaissent que, en accord avec les dispositions prévues par les Statuts et sur la base des Comptes
Intérimaires, la Société a suffisamment de réserves distribuables disponibles (y compris les primes d'émission et excluant
la réserve légale) et de profits pour procéder au (i) rachat des Parts de Rachat au Prix de Rachat et (ii) l'allocation telle
que définie ci-dessus.
3. Les Associés décident de modifier l'article 5 des Statuts de façon à refléter la résolution ci-dessus afin qu'il se lise
par la suite comme suit:
« Art. 5. Capital social émis. Le capital social émis de la Société est fixé à un million six cent vingt-huit mille cinq cent
quatre-vingts Livres Sterling (GBP 1.628.580,00), représenté par un milliard six cent vingt-huit millions cinq cent quatre-
vingt mille (1.628.580.000) Parts Sociales ayant chacune une valeur nominale de un millième de Livre Sterling (GBP 0,001),
divisées en:
- deux cent vingt-huit millions cinq cent quatre-vingt mille (228.580.000) de parts sociales de catégorie A (les «Parts
Sociales de Catégorie A»), intégralement souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), intégralement
souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») intégralement
souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), intégralement
souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), intégralement
souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), intégralement
souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), intégralement
souscrites et libérées;
- deux cent millions (200.000.000) de parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), intégralement
souscrites et libérées.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales sont identiques, sauf disposition contraire des Statuts ou de la Loi
sur les Sociétés.
En sus du capital social émis, un compte de primes d'émission peut être créé sur lequel seront versées les éventuelles
primes d'émission payées sur les Parts Sociales en sus de leur valeur nominale. Les sommes figurant au crédit du compte
de prime d'émission peuvent être utilisées pour financer les Parts Sociales que la Société souhaiterait racheter à son ou
ses Associés, pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, faire des distributions à leur profit sous forme de
dividende ou affecter des sommes d'argent à la Réserve Légale.»
4. Les Associés décident de modifier l'article 6, section 5, des Statuts de façon à refléter la résolution ci-dessus afin
qu'il se lise par la suite comme suit:
120938
L
U X E M B O U R G
« Art. 6. Parts Sociales.
Section 5. Rachat de Parts Sociales
Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation de l'intégralité d'une ou plusieurs Catégories
de Parts Sociales, étant précisé cependant que la Société ne peut, en aucun cas, acheter et annuler les Parts Sociales de
Catégorie A. En cas de rachats et annulations de Catégories de Parts Sociales, ces annulations et rachats seront effectués
dans l'ordre suivant:
(i) Parts Sociales de Catégorie H;
(ii) Parts Sociales de Catégorie G;
(iii) Parts Sociales de Catégorie F;
(iv) Parts Sociales de Catégorie E;
(v) Parts Sociales de Catégorie D;
(vi) Parts Sociales de Catégorie C; et
(vii) Parts Sociales de Catégorie B.
En cas de réduction du capital social par rachat et annulation d'une Catégorie de Parts Sociales (dans l'ordre prévu ci-
dessus), chaque Catégorie de Parts Sociales donne à ses détenteurs le droit (proportionnellement à leur participation
dans la Catégorie de Parts Sociales concernée) à une fraction du Montant Total d'Annulation fixé par le Conseil de Gérance
et approuvé par l'Assemblée Générale, et, la Société verse aux détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie de Parts
Sociales rachetée et annulée un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la
Catégorie de Parts Sociales concernée qu'ils détenaient et qui a été annulée.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites prescrites par la Loi sur les Sociétés.»
5. Les Associés décident de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société de procéder, individuellement, au
nom de la Société, sur le registre des parts sociales de la Société, à l'annulation des Parts de Rachat décidée sous la
première résolution ci-dessus et de pourvoir aux formalités y relatives (y compris, pour écarter tout doute, le dépôt et
la publication des documents avec les autorités luxembourgeoises compétentes).
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de
divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire,
l'original du présent acte.
Signé: Bley, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 6 août 2013. Relation: RED/2013/1312. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 19 août 2013.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2013120383/296.
(130146417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
S&B Minerals S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 178.470.
EXTRAIT
En date du 13 août 2013, l’actionnaire unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Jacques de Patoul, en tant qu’administrateur B (Verwaltungsratsmitglied der Klasse B) de la Société,
est acceptée avec effet au 22 août 2013.
- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu
nouvel administrateur B (Verwaltungsratsmitglied der Klasse B) de la Société avec effet au 22 août 2013 et jusqu’à l’as-
semblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2013.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120821/16.
(130146366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
120939
L
U X E M B O U R G
Zen Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 179.628.
STATUTS
In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of August.
Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Mr Philippe LAMBILLIOTTE, entrepreneur, residing at B-1180 Bruxelles, 83, avenue du Gui, born in Brussels (B) on
31 October 1964,
2. Mr Fabrizio VERDIANI, entrepreneur, residing at B1170 Bruxelles Rue de l'Abreuvoir 7, born in Uccle (B) le 4 juin
1964,
3. Mr Francesco FIORE, entrepreneur, residing at Schoeneggstrasse 29, CH-8004, Zurich, born in Roma (Italy) on 29
November 1973,
here represented by Mrs Aline CHAIDRON, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of three proxies given on 30 July 2013.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of intellectual property assets, industrial property assets, stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also
hold interests in partnerships.
The Company may borrow in any form and may issue bonds, without a public offer, which may be convertible and
may issue debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions in
relation to real estate or in relation to tangible or intangible property and especially in relation with intellectual property
or industrial property.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “ZEN PARTNERS S.à r.l.”
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at SIXTY-NINE THOUSAND EURO (69,000.- EURO) represented
by SIXTY-NINE THOUSAND (69,000) shares with a par value of ONE EURO (1.- EURO) each, all subscribed and fully
paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
120940
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partici-
pation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken
insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31
st
of December of every year.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
120941
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said parties,
represented as stated here above, declares to subscribe as follow:
- Mr Philippe LAMBILLIOTTE, prenamed, twenty-three thousand (23,000),
- Mr Fabrizio VERDIANI, prenamed, twenty-three thousand (23,000),
- Mr Francesco FIORE, prenamed, twenty-three thousand (23,000)
Total: Sixty-nine thousand shares (69,000).
All the shares have been fully paid up in cash including a payment of a share premium of THIRTY-SEVEN THOUSAND
EURO (EUR 37,000) by Mr Philippe LAMBILLIOTTE for a total amount of ONE HUNDRED SIX THOUSAND EURO
(EUR 106,000).
Proof of a payment of ONE HUNDRED SIX THOUSAND EURO (EUR 106,000) has been given to the undersigned
notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, as amended, have been observed.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately ONE THOUSAND TWO HUNDRED EURO (1,200.EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1) The Company will be administered by the following manager for an unlimited period:
Mr Fabrizio VERDIANI, entrepreneur, residing at B-1170 Bruxelles Rue de l'Abreuvoir 7, born in Uccle (B) on 4 June
1964.
2) The address of the corporation is fixed at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le cinq août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Philippe LAMBILLIOTTE, entrepreneur, demeurant au 83, avenue du Gui, B-1180 Bruxelles, né à Bruxelles
(B) le 31 octobre 1964,
2. Monsieur Fabrizio VERDIANI, entrepreneur, demeurant au 7, rue de l'Abreuvoir, B-1170 Bruxelles, né à Uccle (B)
le 4 juin 1964,
3. Monsieur Francesco FIORE, entrepreneur, demeurant au Schoeneggstrasse 29, CH-8004, Zurich, né à Rome (Italie)
le 29 novembre 1973,
tous trois ici représentés par Madame Aline CHAIDRON, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de trois procurations datées du 30 juillet 2013.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
120942
L
U X E M B O U R G
Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par
vente, échange ou autre, d’actifs de propriété intellectuelle, d’actifs de propriété industrielle, d’actions, d’obligations, de
reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le
développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés
de personnes.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être convertibles
(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes.
D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et
de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers et spécialement de propriété intellectuelle ou industrielle.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “ZEN PARTNERS S.à r.l.”
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand- Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (69.000.- EUR) représenté par SOIXANTE-NEUF
MILLE (69.000) parts sociales d’une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature de
n'importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
120943
L
U X E M B O U R G
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêtés les Statuts de la Société, les parties comparantes ici représentées comme
indiqué ci-dessus, ont déclaré souscrire comme suit:
- M. Philippe LAMBILLIOTTE, prénommé, vingt-trois mille (23.000) parts sociales,
- Mr Fabrizio VERDIANI, prénommé, vingt-trois mille (23.000) parts sociales,
- Mr Francesco FIORE, prénommé, vingt-trois mille quarante six (23.000) parts sociales.
Total: Soixante neuf mille (69.000) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été libérées en espèces incluant le paiement d'une prime d'émission de TRENTE SEPT
MILE EUROS (EUR 37.000) par M. Philippe LAMBILLIOTTE pour un montant total de CENT SIX MILLE EUROS (106.000.-
EUR).
La preuve de tous ces paiements pour un montant total de CENT SIX MILLE EUROS (106.000.- EUR) a été rapportée
au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200.-EUR).
<i>Décisions des associési>
1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée illimitée:
- Monsieur Fabrizio VERDIANI, entrepreneur, demeurant au 7, rue de l'Abreuvoir, B-1170 Bruxelles, né à Uccle (B)
le 4 juin 1964.
120944
L
U X E M B O U R G
2) L'adresse de la Société est fixée au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. CHAIDRON, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 août 2013. Relation: LAC/2013/37070. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Référence de publication: 2013120258/279.
(130145472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Run Out Kletterschule S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 6, Azéngen.
R.C.S. Luxembourg B 179.662.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend dreizehn.
Den dreizehnten August.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Frau Dagmar Elisabeth WINTER, geborene SCHÄFER, Erzieherin, wohnhaft in D-54426 Naurath/Wald, Birkenweg, 7.
Welche Komparentin, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Run Out Kletterschule S.à r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Greiveldange. Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesell-
schafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Kletterschule, das Organisieren von Kletterreisen sowie der Handel
und Verleih von Kletterausrüstungen.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck die Beratung, Gestaltung, den Bau sowie den Verleih und Betrieb von künst-
lichen Kletteranlagen, sowie Seilunterstützendes Arbeiten.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-
Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der
Gesellschaft förderlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN
HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), alle zugeteilt Frau Dagmar
Elisabeth WINTER, geborene SCHÄFER, Erzieherin, wohnhaft in D-54426 Naurath/Wald, Birkenweg, 7.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
120945
L
U X E M B O U R G
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er
Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsge-mässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.
Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Einzahlung des gesellschaftskapitalsi>
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2013.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).
120946
L
U X E M B O U R G
<i>Erklärungi>
Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Volker WINTER, Automechaniker, geboren in Lichtenstein, am 30. Juni 1966, wohnhaft in D-54426 Naurath/
Wald, Birkenweg, 7.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5427 Greiveldange, 6, Azéngen.
WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. E. WINTER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 14 août 2013. Relation: ECH/2013/1546. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M- MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 21. August 2013.
Référence de publication: 2013120150/110.
(130146025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2013.
Fluxen S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 133.660.
L'an deux mille treize, le premier août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FLUXEN S.A., une société anonyme
ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 8 novembre 2007 aux
termes d'un acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2912 du 14 décembre 2007, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 133660.
Les statuts de la société ont été modifiés en date du 29 octobre 2009 aux termes d'un acte reçu par Me Jacques
DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2559 du 31 décembre 2009.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant profession-
nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Myriam WAGNER, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision sur la mise en liquidation de la société.
2. Nomination de ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, resteront aussi annexées au présent acte.
120947
L
U X E M B O U R G
III) Il appert de la liste de présence que les 3.200 (trois mille deux cents) actions, représentant l'intégralité du capital
social, sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.
IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide
de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53
rd
Street East, Panama, République
du Panama.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ 950,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec
Nous notaire le présent acte.
Signé: Gentiane PREAUX, Myriam WAGNER, Sonia BOULARD, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 08 août 2013. Relation GRE/2013/3272. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013120555/68.
(130146630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Prime Credit 5, Société à responsabilité limitée,
(anc. Idem Luxembourg (No. 6)).
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 168.559.
In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of August,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (hereinafter "Lu-
xembourg"), undersigned,
There appeared the following:
Prime Credit 4 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at L- 5365 Munsbach, Parc d'Activite Syrdall,
6 rue Gabriel Lippmann, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 13,000, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 178.479,
represented by Mrs. Lou Venturin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal;
120948
L
U X E M B O U R G
The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party declares that it is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Idem Luxembourg (No. 6) S.à
r.l. a private limited liability company (société à responsabilitée limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having a share capital of GBP 12,500.-, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 168.559, incorporated by a deed
of Maître Henri Beck, notary residing in Luxembourg, dated 2 May 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1463 dated 12 June 2012 (the "Articles of Association"). The Articles of Association have not
been amended so far.
The appearing party, duly represented, has acknowledged to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1) To change the name of the Company to "Prime Credit 5" and amend article 4 of the Articles of Association
accordingly.
2) To transfer the registered office of the Company to L- 5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel
Lippmann, Grand-Duchy of Luxembourg.
3) To amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association, which shall read as follows: "The registered
office of the Company is established in Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg."
4) To amend article 19 of the Articles of Association so as to change the financial year which shall now begin on the
first day of the month of January.
5) To change the next financial year of the Company so that it runs from 1 October 2013 to 31 December 2013.
6) To accept and acknowledge the resignation of Richard James Woodman as manager of the Company with immediate
effect.
7) To accept and acknowledge the resignation of Richard Dominic Shelton as manager of the Company with immediate
effect.
8) To accept and acknowledge the resignation of Aidan Foley as manager of the Company with immediate effect.
9) To appoint Ms Audrey Lewis, born in Glasgow, Scotland, on 28 August 1968, with professional address at 25, rue
Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour, Grand Duchy of Luxembourg; as new manager of the Company with immediate
effect for an unlimited period.
10) To appoint Mr. Hugo Neuman, born in Amsterdam, the Netherlands, on 21 October 1960, with professional
address at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; as new manager of the Company with
immediate effect for an unlimited period.
11) To appoint Mr. Malcolm Lindsay Wilson, born in Nairobi, Kenya on 10 April 1957, with professional address at
L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, Grand Duchy of Luxembourg, as new manager of the
Company with immediate effect for an unlimited period.
12) Miscellaneous.
The appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company to "Prime Credit 5" and amend article 4 of the
Articles of Association, which shall forthwith read as follows:
" Art. 4. Name. The Company will have the name of Prime Credit 5"
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company to, L- 5365 Munsbach, Parc d'Activité
Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann, Grand-Duchy of Luxembourg and to a amend the first paragraph of article 5 of the
Articles of Association, which shall forthwith read as follows:
" Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand-Duchy of Luxem-
bourg."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 19 of the Articles of Association so as to change the financial year
which shall now begin on the first day of the month of January and which which shall forthwith read as follows:
" Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on 1 January and ends on 31 December of each year."
120949
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the next financial year of the Company so that it runs from 1 October 2013
to 31 December 2013.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept and acknowledge the resignation of Richard James Woodman as manager of
the Company with immediate effect.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept and acknowledge the resignation of Richard Dominic Shelton as manager of
the Company with immediate effect.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept and acknowledge the resignation of Aidan Foley as manager of the Company
with immediate effect.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint Ms Audrey Lewis, born in Glasgow, Scotland, on 28 August 1968, with
professional address at 25, rue Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour, Grand Duchy of Luxembourg; as new manager of
the Company with immediate effect for an unlimited period.
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Hugo Neuman, born in Amsterdam, the Netherlands, on 21 October
1960, with professional address at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; as new manager
of the Company with immediate effect for an unlimited period.
<i>Tenth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Malcolm Lindsay Wilson, born in Nairobi, Kenya on 10 April 1957, with
professional address at L-5365 Munsbach,Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, Grand Duchy of Luxembourg,
as new manager of the Company with immediate effect for an unlimited period.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons' proxy holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons'
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil treize, le neuf août,
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Prime Credit 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège
social à L- 5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de GBP 13.000, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
178.479,
représentée par Lou Venturin, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé le 8 août 2013.
La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant, représenté comme décrit ci-dessus déclare être l'associé unique (l'"Associé Unique") de Idem Luxem-
bourg (No. 6) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, ayant un capital social
de GBP 12.500, ayant son siège social à 237, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.559, constituée suivant acte de Maître Henri Beck,
120950
L
U X E M B O U R G
notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1463 du 12 juin 2012 (les "Statuts"). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.
Le comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être entièrement informé des résolutions à prendre sur
base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changer le nom de la Société en "Prime Credit 5" et modifier l'article 4 des Statuts.
2. Transférer le siège social de la Société à L- 5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann, Grand-
Duché de Luxembourg.
3. Modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante: "Le siège social est
établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg".
4. Modifier l'article 19 des Statuts afin de modifier l'année sociale qui débutera désormais le premier jour du mois de
janvier.
5. Modifier l'année sociale à venir qui débutera le 1
er
octobre 2013 et se terminera le 31 décembre 2013.
6. Accepter et approuver la démission de Richard James Woodman comme gérant de la Société avec effet immédiat.
7. Accepter et approuver la démission de Richard Dominic Shelton comme gérant de la Société avec effet immédiat.
8. Accepter et approuver la démission de Aidan Foley comme gérant de la Société avec effet immédiat.
9. Nommer Mme Audrey Lewis, née à Glasgow, Ecosse, le 28 août 1968, ayant son adresse professionnelle au 25, rue
Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouvelle gérante de la Société avec effet
immédiat et pour une période indéterminée.
10. Nommer M. Hugo Neuman, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, ayant son adresse professionnelle au
16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouveau gérant de la Société avec effet
immédiat et pour une période indéterminée.
11. Nommer M. Malcom Lindsay Wilson, né à Nairobi, Kenya le 10 avril 1957, ayant son adresse professionnelle au
25 Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouveau
gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
12. Divers.
Le comparant a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de changer le nom de la Société en "Prime Credit 5" et modification de l'article 4 des Statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination 'Prime Crédit 5".
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de transférer le siège social de la Société L- 5365 Munsbach, à Parc d'Activité Syrdall, 6, rue
Gabriel Lippmann, Grand-Duché de Luxembourg et de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg"
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 19 des Statuts afin de modifier l'année sociale qui débutera désormais
le premier jour du mois de janvier qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 19. Année Sociale. L'année commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année".
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'année sociale à venir qui débutera le 1
er
octobre 2013 et se terminera le 31
décembre 2013.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'accepter et approuver la démission de Richard James Woodman comme gérant de la
Société avec effet immédiat.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'accepter et approuver la démission de Richard Dominic Shelton comme gérant de la
Société avec effet immédiat.
120951
L
U X E M B O U R G
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'accepter et approuver la démission de Aidan Foley comme gérant de la Société avec effet
immédiat.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer Mme Audrey Lewis, née à Glasgow, Ecosse, le 28 août 1968, ayant son adresse
professionnelle au 25, rue Schlammestee, L-5770 Weiler la Tour, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouvelle gérante
de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer M. Hugo Neuman, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, ayant son
adresse professionnelle au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme nouveau gérant
de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
<i>Dixième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer M. Malcom Lindsay Wilson, né à Nairobi, Kenya le 10 avril 1957, ayant son
adresse professionnelle au 25 Parc d'Activité Syrdall, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Lu-
xembourg, comme nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à mille trois cents euro (EUR 1.300,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par
nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Venturin, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 août 2013. Relation: LAC/2013/37872. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120620/200.
(130146437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Lipizzaner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 312.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.777.
In the year two thousand and thirteen, on the 2
nd
August.
Before Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notary residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLS Luxembourg S.à r.l. a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, having a share capital of EUR 5,200,000.-, registered with the Registre de commerce et des sociétés, Lu-
xembourg under the number B 110163
(the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder of Lipizzaner S.à r.l.
a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, having
a share capital of EUR 312,500.-, registered with the Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg under the
number B 115777, incorporated by a notarial deed by Maître André Jean-Joseph SCHWACHTGEN residing that time in
Luxembourg enacted on 13 April 2006, published in the Memorial C, number 1255 of 29 June 2006, on page 60219,
120952
L
U X E M B O U R G
whose articles of association have been amended for the last time by a notarial deed by Maître Jean-Joseph WAGNER,
residing in Sanem, enacted on 24 September 2012, published in the Memorial C, number 2763 of 14 November 2012, on
page 132603
hereby represented by Mr Samuel Haas, Manager, with professional address at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Lu-
xembourg,
by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on 1 August 2013.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall read as
follows:
" Art. 2. The Company has as its main corporate object the investment in real estate or real estate related assets,
situated in Luxembourg or abroad, in order to derive income from its rental and management. This will be undertaken
through acquisition, option of purchase, development and construction of real estate or by any other means. The Company
may, from time to time, realise its investments in real estate by sale or any other means.
The Company may, by acquisition of holdings in whatever form or by any other type of investment or security, take
part in the establishment and development of any company, registered in Luxembourg or abroad, manufacturer or com-
mercial, having an identical, similar or related corporate purpose than the corporate purpose of the Company or which
can facilitate or promote the development of the Company, as well as administer, manage, develop financially, improve,
oversee and liquidate, permanently or temporarily, those interests or holdings. The Company can also give assistance to
any such company as well as to any company being part of the same group of companies as the Company by means of
loans, advances, guarantees or otherwise.
Finally, the Company may carry out, both in Luxembourg and abroad, any kind of general, industrial, commercial,
financial, movable or real estate operations as well as any measures of control or supervision relating directly or indirectly,
in all or in part, to the fulfillment of its corporate purpose as referred to in the above 2 paragraphs, including to request
financing in its favour from any Luxembourg or foreign credit institutions or from a different company or natural person
by means of loans, advances, guarantees or by any other means."
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately seven hundred and seventy Euro (EUR 770.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said person signed, together with
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille treize, le deux août.
Par-devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CLS Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social 55, Avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 5.200.000,-, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés
sous le numéro B 110163
(l'«Associé Unique»), associé unique de Lipizzaner S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, ayant un
capital social de EUR 312.500,-, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 115777,
constituée suivant acte notarié reçu en date du 13 avril 2006 par Maître André Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1255 du 29 juin 2006,
page 60219,
120953
L
U X E M B O U R G
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Maître Jean-Joseph WAGNER, de
résidence à Sanem en date du 24 septembre 2012, publié au Memorial C sous le numéro 2763 en date du 14 novembre
2012, page numéro 132603,
ici dûment représentée par Monsieur Samuel Haas, gérant, résidant professionnellement au 55, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé avec pouvoir de substitution donné le 1 août 2013.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
L'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société de la façon suivante:
« Art. 2. La Société a comme objet social principal l'investissement dans l'immobilier ou dans les actifs liés à l'immobilier,
situés à Luxembourg ou à l'étranger, afin de générer des revenus provenant de leur location et leur gestion. Cela pourra
se réaliser par l'acquisition, l'option d'achat, le développement et la construction d'immeubles ou par tout autre moyen.
La Société peut, de temps à autre, effectuer des investissements dans l'immobilier par la vente ou tout autre moyen.
La Société peut, par la prise de participations de quelque forme que ce soit ou par toute autre forme de placement
ou valeurs mobilières, prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise, immatriculée au Luxem-
bourg ou à l'étranger, industrielle ou commerciale, ayant un objet social identique, analogue ou connexe à l'objet social
de la Société ou qui est de nature à favoriser ou faciliter le développement de la Société, ainsi qu'administrer, gérer,
développer financièrement, mettre en valeur, superviser et liquider, à titre permanent ou temporaire, ces intérêts ou
participations. La Société peut également prêter assistance à une telle entreprise ainsi qu'à toute société faisant partie du
même groupe de sociétés que la Société au moyen de prêts, avances, garanties ou autrement.
Pour finir, la Société peut accomplir, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ainsi que toutes mesures de contrôle ou de surveil-
lance se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'accomplissement de son objet social tel que
défini aux deux paragraphes ci-dessus, parmi lesquelles solliciter des financements en sa faveur auprès de tout établisse-
ment de crédits luxembourgeois ou étranger ou de toute autre société ou personne physique au moyen de prêts, avances,
garanties ou de tout autre manière.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge
à raison du présent acte s'élève à environ sept cent soixante-dix euros (EUR 770,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: Haas, Joëlle SCHWACHTGEN.
Enregistré à Wiltz, le 6 août 2013. Relation: WIL/2013/506. Reçu soixante-quinze euros (75,- €),
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Zeimes.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations..
Wiltz, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120686/115.
(130146313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
International Administration Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 179.676.
STATUTES
In the year two thousand thirteen, on the thirteenth of August.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
120954
L
U X E M B O U R G
THERE APPEARED:
1) The company CD CONSULTING S.à r.l., with its registered office at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
here represented by Mr Denis Brever, private employee, with professional address at 18, rue de l'Eau, L-1449 Lu-
xembourg,
by virtue of a proxy given on 25
th
of July 2013 in Luxembourg.
2) The company IAG HOLDINGS LIMITED, with registered office at Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter
Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1WW,
here represented by Mr Denis Brever, above qualified,
by virtue of a proxy given on 6
th
of August 2013 in Guernsey.
The aforesaid proxies, being initialled “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following deed of incorporation of a “société à
responsabilité limitée” which he declares to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
Art. 1. There is hereby established a company in the form of a “société à responsabilité limitée” which will be governed
by the laws relative to such an entity (below “The Company”), and in particular the law of August 10
th
, 1915 regarding
commercial companies, as amended (below “The Law”), as well as by the articles of association of the Company (below
“the articles of association”), which specify in their articles 7, 10, 11 and 14, the exceptional rules applying to the sole
limited liability company.
Art. 2. The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form the execution of any accounting
expertise, execution of any accounting, tax and administrative activities as well as in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, estate or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with its
object or subject to favor its realization.
The company may also take interests in any way in all affaires, enterprises, or companies which have an identical,
analogous, or relating purpose, or which are liable to promote the development of its enterprise or to ease it.
Art. 3. The company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The company will have the name: “International Administration Group (Luxembourg) SARL”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg through a resolution of an extraordinary general meeting of partners deliberating in the manner provided
for amendments to these articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the same borough by a resolution of the board of
managers.
The company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred shares (12,500) having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
The company may repurchase its own shares.
However, if the repurchase price exceeds the nominal value of the shares to be repurchased, the repurchase may be
decided only insofar as distributable reserves are available for the surplus of the purchase price. The resolution of the
partners to repurchase the shares will be taken by an unanimous vote of the partners representing all the share capital,
gathered in shareholder's meeting and will involve a reduction of the share capital by cancellation of the repurchased
shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the share capital may be changed at any time by a resolution
of the sole partner or by a resolution of the general shareholder's meeting, in accordance with provisions of article 14
of the present articles of association.
Art. 8. Each share gives its holder a right over the assets and the profit of the company, in proportion with the total
of shares representing the corporate capital.
Art. 9. The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
The shares of the Company are indivisible, since only 1 (one) owner is admitted per share. Co-owners have to appoint
a sole person as their representative in the Company.
Art. 10. Supposing there is only a sole partner the shares held by this one are freely transferred.
Supposing there are several partners, the shares held by each of them are freely only for the application of what is
prescribed by the article 189 of the Law.
Art. 11. The company shall not be dissolved following the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder or of one of the shareholders.
120955
L
U X E M B O U R G
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The managers are not necessarily managing partners. The managers are revocable “ad
nutum”.
The managers will be part of class A or class B. The relevant power of signature A or B will be given by the shareholders'
meeting at the same time of the appointment.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall
within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented, each decision to be adopted being subject to the affirmative vote of a class A manager
and of a class B manager.
The managers may vote in writing including letter, telegram, telefax, e-mail as well as by teleconference. If resolutions
are taken by teleconference, they shall be recorded in minutes and signed by all managers participating at the meeting. A
written resolution, approved and signed by all the managers shall have the same effect as a resolution taken at a meeting
of the board of managers. Resolutions of the Board of Managers may also be taken by circular way.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The company shall be bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager.
Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company.
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares he/she owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares she/he holds.
The collective decisions are only validly taken insofar they are adopted by shareholders representing more than half of
the share capital.
However, resolutions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
Art. 15. The Company's financial year shall begin on the first of July and end on the thirtieth of June of each year.
Art. 16. Each year, as of the 30
th
of June, the manager or in case of plurality of managers, the board of managers
prepares the inventory, the balance sheet and the profit and loss account of the Company in accordance with the Law.
Each shareholder may inspect the inventory, the balance sheet and the profit and loss account at the registered office
of the Company.
Art. 17. The gross profits of the Company resumed in the balance sheet, after deduction of the general expenses,
depreciation and charges represents the net profit of the Company. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for
the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partners in proportion to the amount of Company's share
capital held.
Interim dividends may be paid at any time, subject to the respect of the following conditions:
1. Interim accounts shall be drawn-up by the manager or the board of managers;
2. Interim accounts, profits carried or allocated to an extraordinary reserve y including, shows a benefit;
3. Only the sole shareholder or the general meeting of partners is competent to decide for the distribution of interim
dividends;
4. The payment is made by the Company only after assuring that the rights of creditors are not threatened.
Art. 18. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Art. 19. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law as
such as this Law has been or may be amended from time to time.
120956
L
U X E M B O U R G
<i>Subcription - Paymenti>
The above-mentioned parties have subscribed the shares created as follows:
1) The company CD CONSULTING S.à r.l., above qualified, six thousand three hundred and seventy-five
shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,375
2) The company IAG HOLDINGS LIMITED, above qualified, six thousand one hundred and twenty-five
shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,125
Total: Twelve thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
All the shares were fully subscribed and fully paid-up by payment in cash, so that the amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred euro) is now at the disposal of the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR
1,300.-).
<i>Resolutions of the Partnersi>
The Company is managed by the following managers:
1) Are appointed as managers of class A:
a) Mr. Raymond Lee Page, chartered accountant, born on 26 September 1964, in Leigh - United Kingdom, with pro-
fessional address at Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1WW
b) Mr. Martin James Scott, chartered certified accountant, born on 19 November 1975, in Newcastle-upon-Tyne -
United Kingdom, with professional address at Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, Channel
Islands, GY1 1WW
2) Are appointed as managers of class B:
a) Mr. Christophe DERMINE, chartered accountant, born on March 5
th
, 1969 in Couvin - Belgium with professional
address at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Mr. Sébastian COYETTE, chartered accountant, born on September 4
th
, 1965 in Arlon - Belgium with professional
address at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Mr. Laurent PECHEUR, chartered accountant, born on May 6
th
,1977 in Messancy - Belgium with professional
address at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Their mandate will fall due during the general meeting of partners to be held in the year 2018.
3) The registered office is located at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and explained to the mandatory of the appearing persons all known by the undersigned
notary, said mandatory signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le treize août.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) La société CD CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Denis BREVER, employé privé, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 25 juillet 2013.
2) La société IAG HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port,
Guernsey, Channel Islands, GY1 1WW,
ici représentée par Monsieur Denis BREVER, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée à Guernsey, le 6 août 2013.
Lesdites procurations paraphées «ne varietur» par la partie comparaissant et par le notaire soussigné resteront an-
nexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.
120957
L
U X E M B O U R G
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer
entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, l'expertise comptable, la prestation de tous travaux
comptables, de conseils fiscaux et de tout travail administratif généralement quelconque ainsi que toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: «International Administration Group (Luxembourg) SARL».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.
Les gérants seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d'un gérant, l'assemblée générale lui
donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés, chaque décision devant pour être adoptée recueillir le vote favorable d'un gérant de catégorie A et d'un
gérant de catégorie B.
Les gérants peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si
les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les gérants qui y
ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les gérants auront les mêmes effets que les réso-
lutions adoptées lors des réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut également prendre ses décisions
par voie circulaire.
120958
L
U X E M B O U R G
Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents
ad hoc.
Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs
mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de la catégorie A avec un gérant de la catégorie B.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le 30 juin de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes;
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux parts sociales créées de la manière suivante:
1) La société CD CONSULTING S.à r.l., préqualifiée, six mille trois cent soixante-quinze parts sociales . . .
6.375
2) La société IAG HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, six mille cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . .
6.125
TOTAL: douze mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentais qui le constate
expressément.
120959
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions des Associési>
La Société est administrée par les gérants suivants:
1) Sont nommés gérants de la catégorie A:
a) Monsieur Raymond Lee Page, expert-comptable, né le 26 septembre 1964 à Leigh - Royaume-Uni et domicilié
professionnellement au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1WW;
b) Monsieur Martin James Scott, expert-comptable, né le 19 novembre 1975 à Newcastle-upon-Tyne - Royaume-Uni
et domicilié professionnellement au Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1
1WW.
2) Sont nommés gérants de la catégorie B:
a) Monsieur Christophe DERMINE, expert-comptable, né le 5 mars 1969 à Couvin - Belgique et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Sébastian COYETTE, expert-comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Laurent PECHEUR, expert-comptable, né le 6 mai 1977 à Messancy - Belgique et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale des associés qui se tiendra en l'an 2018.
3) L'adresse de la Société est fixée au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate ici que les parties comparantes ont requis de
documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdites parties, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: D. Brever et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 août 2013. LAC/2013/38072. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2013.
Référence de publication: 2013120631/307.
(130146260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Fondalux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R.C.S. Luxembourg B 82.446.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120556/9.
(130146358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Influence S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 37.790.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013120643/9.
(130146903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
120960
Boreas Holdings S.à r.l.
Cassiopea Investment S.A.
Centre Equestre Lippert s.à r.l.
Chaos S.A.
Christine de Monbel S.A.
Clearinvest S.A.
Cofimag S.A.
Columbian Chemicals (Weifang) Holdings S.àr.l.
CommCapital S.à r.l.
Crakoukass S.A.
DMA Holdings S.A.
Domaines Invests S.A.
Dust Fiduciaire S.à r.l.
Dynamo Studio Graphique Sàrl
Earth Finance S.à r.l.
FAM Energy Consulting S.à r.l.
Farena Invest S.à r.l.
First Data International Luxembourg II S.à r.l.
Fluxen S.A.
Fondalux S.àr.l.
Fulham Broadway S.à r.l.
Gemplus International S.A.
Idem Luxembourg (No. 6)
Influence S.A.
International Administration Group (Luxembourg) S.à r.l.
Lipizzaner S.à r.l.
Nix Investment S.à r.l.
Prime Credit 5
Run Out Kletterschule S.à r.l.
SAIC Lux, S.à r.l.
Sant Topco Holdings II S.à r.l.
Sant Topco Holdings I S.à r.l.
S&B Minerals S.A.
SD Distribution S.à r.l.
Sedlen Holding S.à r.l.
SEI-Société Européenne d'Investissements S.A.
Sigma Fin International S.à.r.l.
Silverex Holding S.A.
Socalux S.A.
Société de Développement International et de Capitaux S.A.
Sommelier-Conseil
Sorep S.A.
Station SA
Stratego Managing S.à r.l.
Substantial Services S.à r.l.
Sun Sail S.A.
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
Sydney International Properties S.A.
Système de Développement Européen S.A.
Taygeta Investments S.à r.l.
Teroko S.à r.l.
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
Threadline Capital S.A.
Tivolex S.A.
TK SEI Luxembourg S.à r.l.
TS Koenigsallee Holdings (GP) S.à r.l. & Partners, S.C.S
Tunon S.à r.l.
Tusculanum SPF
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l.
Umeco Luxembourg S.à r.l.
Zen Partners S.à r.l.