logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2136

3 septembre 2013

SOMMAIRE

AIP Issuance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102499

Assenagon Asset Management S.A. . . . . . .

102499

Assenagon Asset Management S.A. . . . . . .

102505

CP Valentine International S.A. - SPF . . . .

102482

Hipergest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102483

HPL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102498

Hyadinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102483

Imedia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102506

Immo MC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102506

Immo MC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102507

Immo MC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102506

ING (L) FLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102507

ING (L) Protected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102507

Internationale Beteiligungen Holding AG

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102508

Isiwis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102508

IST International Holding S.A.  . . . . . . . . . .

102508

King David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102508

Kusan Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102507

LaSalle Investment (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102509

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR  . . . . . . . .

102521

Libertim Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

102521

Litoine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102520

Lombard Financial Investments S.A.  . . . . .

102520

Luxevents S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102509

LVS II Lux VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102510

M.A.F. Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102509

Maison Stemper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102522

Management Marketing IT & Trading S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102509

Maniola S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102511

Marengo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102510

Mecactiv S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102521

Mellinckrodt 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102484

Mellinckrodt 1 SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . .

102484

Metropolica Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

102520

M&F Investissement III S.A.  . . . . . . . . . . . . .

102522

M Luxembourg SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102522

Monitor Capital Investors S.à.r.l.  . . . . . . . .

102511

OZ International Trading Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102528

Pioneer Institutional SIF  . . . . . . . . . . . . . . . .

102505

Point Blank Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . .

102519

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102528

Proteus Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102519

Q.I.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102519

Regata S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102527

Resort Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102527

RPTRE I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102523

RREEF Pan-European Infrastructure Lux

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102524

RREEF RVK 1 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102524

S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102523

Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102500

Sireo Immobilienfonds No. 4 London 10 St.

Bride Street S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102500

Sireo Immobilienfonds No. 4 London East-

cheap Court S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102500

Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102500

SOP I SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102482

UniSector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102483

UniSector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102484

UniSector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102484

UniSector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102505

UniSector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102499

WALSER Absolute Return  . . . . . . . . . . . . . .

102506

Xirom Investments SICAV . . . . . . . . . . . . . .

102482

102481

L

U X E M B O U R G

CP Valentine International S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 42.702.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>19 septembre 2013 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2012.
3. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013123457/14.

Xirom Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 115.196.

We hereby invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company to be held in Luxembourg at 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, on <i>September

<i>19, 2013 at 3 p.m. to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors and report of the auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account as at 30 June 2013 submitted by the board.
3. Allocation of the year end result.
4. Discharge of the directors and auditor in respect of the financial year ended.
5. Composition of the board and duration of terms of office.
6. Ratification of fund documents and the decisions met by the board of directors.
7. Appointment of the auditor for the new financial year.
8. Miscellaneous.
Each shareholder - individually or by proxy - will be able to participate in the annual general meeting if his shares have

been deposited up to Monday, 16 September 2013 at the latest at the registered office of the Company or at HSBC
Trinkaus &amp; Burkhardt (International) SA, Luxembourg and left there until the end of the annual general meeting. Each
shareholder, who complies with the requirements, will be admitted to the annual general meeting.

Luxembourg, August 2013.

Xirom Investments SICAV
<i>Board of Directors

Référence de publication: 2013124029/755/26.

SOP I SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 168.325.

The board of directors herewith invites the shareholders, in accordance with article 24 of the Company's articles of

association (the “Articles”) to the

ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to take place on <i>11 September 2013 at 11.00 a.m. at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Capitalised terms not defined herein have the meaning assigned to them in the Prospectus of the Company.

The agenda is as follows:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the Auditor on the financial statements for the financial year as per 30 April

2013.

2. Approval of the balance sheet as per 30 April 2013 and the profit and loss statement.

102482

L

U X E M B O U R G

3. Remuneration of the members of the Board of Directors.
4. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year that elapsed.
5. Re-election of the Board of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.
In order to attend the Ordinary General Meeting and for the proper execution of the voting rights, the shareholders

will have to deposit their shares at least five (5) days before the meeting. Only those who have submitted written notice
of the deposit to the company are admitted to attend the meeting. Each shareholder may be represented by a person
who is duly authorized by proxy.

If you cannot attend this meeting, please return the form of proxy duly dated and signed to the Company to the

attention of the Fund Set-Up Department, Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., at 4, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Fax: 00352.22.15.22-500, prior to 5 September 2013. Proxy forms can be
obtained from the registered office of the Company.

Luxembourg, August 2013.

<i>By order of the board of directors
Board of Directors

Référence de publication: 2013120262/1999/32.

Hipergest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 30.417.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 septembre 2013 à 11:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013120968/795/16.

Hyadinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 164.253.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>17 septembre 2013 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 mai 2013 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au

plus tard en séance, le jour de l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013119671/755/18.

UniSector, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschafts-

register von Luxemburg hinterlegt.

102483

L

U X E M B O U R G

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013089086/10.
(130109951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

UniSector, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement der UniSector: Klimawandel, welches am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wurde beim Han-

dels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013089082/10.
(130109930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

UniSector, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement der UniSector: HighTech, welches am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels-

und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013089083/10.
(130109931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Mellinckrodt 1 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécia-

lisé,

(anc. Mellinckrodt 1).

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 153.466.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Henri

HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,

sind  die  Aktionäre  der  Investmentgesellschaft  mit  variablem  Kapital  („société  d'investissement  à  capital  variable“)

„Mellinckrodt 1“, mit Sitz in Strassen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 153.466,
zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 26. Mai 2010, veröffentlicht im

Mémorial C Nummer 1273 vom 18. Juni 2010. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des Notars Henri Hellinckx
vom 28. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 262 vom 4. Februar 2013.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-

Strassen, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Susanne MOHN, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxem-

bourg-Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Gisela WENZ, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Lu-

xembourg-Strassen.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Einladungen mit der hiernach angegebenen Tage-

sordnung veröffentlicht:

- im Mémorial C, vom 13. Juli 2013 und vom 22. Juli 2013
- in der Tageszeitung „Tageblatt“ am 13. Juli 2013 und am 22. Juli 2013.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und
dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste und gegebenenfalls die Vollmachten bleiben gegenwärtiger
Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

102484

L

U X E M B O U R G

III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung der Art der Investmentgesellschaft: Die Investmentgesellschaft wird von einer Luxemburger Investment-

gesellschaft gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz von 2010“) in eine Investmentgesellschaft gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über die
Spezialfonds in der geänderten Fassung vom 26. März 2012 (das „Gesetz von 2007“) mit Umbrella-Struktur umgewandelt.
Vor diesem Hintergrund erfolgt eine umfangreiche Anpassung des Verkaufsprospektes und der Satzung der Investment-
gesellschaft an die Vorgaben gemäß dem Gesetz von 2007.

2. Der Name der Investmentgesellschaft wird von Mellinckrodt 1 in Mellinckrodt 1 SICAV-FIS geändert.
3. Wahl eines neuen Verwaltungsrates.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
IV.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 113.804 sich im Umlauf befindenden Aktien,

welche das gesamte Kapital von EUR 67.925.527,14 vertreten, 4.810 Aktien, welche EUR 54.663.310,80 Kapital vertreten,
d.h. mehr als die Hälfte des Kapitals, in gegenwärtiger Versammlung vertreten sind, so dass diese ordnungsgemäß zu-
sammengesetzt ist und rechtsgültig über die Punkte der Tagesordnung beraten kann.

Alsdann fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Art der Investmentgesellschaft zu ändern: Die Investmentgesellschaft wird

von einer Luxemburger Investmentgesellschaft gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010“) in eine Investmentgesellschaft gemäß dem Luxemburger Gesetz
vom 13. Februar 2007 über die Spezialfonds in der geänderten Fassung vom 26. März 2012 (das „Gesetz von 2007“) mit
Umbrella-Struktur umgewandelt. Infolgedessen erfolgt eine umfangreiche Anpassung des Verkaufsprospektes und der
Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben gemäß dem Gesetz von 2007.

<i>Zweiter Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft von Mellinckrodt 1 in Mellinckrodt 1 SICAV-FIS zu

ändern.

<i>Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung der Gesellschaft wie folgt neuzufassen:

Art. 1. Name. Zwischen den erschienenen Parteien und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgege-

benen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) gemäß dem
Gesetz vom 13. Februar 2007 über die Spezialfonds in der geänderten Fassung vom 26. März 2012 (das „Gesetz von
2007“) unter dem Namen Mellinckrodt 1 SICAV-FIS („Investmentgesellschaft“ oder „Fonds“).

Art. 2. Sitz der Investmentgesellschaft. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Strassen, Großherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde Strassen verlegt
werden sowie zusätzliche Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im
Ausland  gegründet  werden.  Sofern  und  soweit  gesetzlich  zulässig,  kann  der  Verwaltungsrat  beschließen,  den  Gesell-
schaftssitz in eine andere Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

Sofern nach Ansicht des Verwaltungsrats außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden ha-

ben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Investmentgesellschaft an ihrem Sitz
oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen
Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszuge-
hörigkeit der Investmentgesellschaft keinen Einfluss haben. Die Investmentgesellschaft wird eine Luxemburger Gesell-
schaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Die Investmentgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann zu jeder Zeit wie in Artikel 27

festgelegt, aufgelöst und liquidiert werden.

Art. 4. Gegenstand der Investmentgesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage des

Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der
Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen
zu lassen.

Die Investmentgesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung

und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz
von 2007.

102485

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Investmentgesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und

wird zu jeder Zeit dem Gesamtnettovermögen der Investmentgesellschaft gemäß nachfolgendem Artikel 11 entsprechen.
Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Investmentgesellschaft oder des
Rückkaufs von Aktien durch die Investmentgesellschaft erhöhen oder vermindern. Das Gesellschaftskapital wird in Euro
ausgedrückt und hat sich zu jedem Zeitpunkt mindestens auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,-
Euro) zu belaufen. Das Anfangskapital der Investmentgesellschaft betrug bei Gründung 31.000 Euro zu 31 Aktien ohne
Nennwert.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Investmentgesellschaft verschiedenen Aktienklas-

sen angehören können, welche mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüt-
tungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifischen Merkmale, die jeweils
vom Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft beschrieben werden.

Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes der Invest-

mentgesellschaft in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, entsprechend der durch
den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich festgelegten oder durch den Verwal-
tungsrat aufgestellten Anlagegrenzen.

Art. 6. Aktien und Aktienzertifikate. Der Verwaltungsrat entscheidet, ob Aktien der Investmentgesellschaft als Namens-

und  oder  Inhaberaktien  ausgegeben  werden.  Namensaktien  und  Inhaberaktien  werden  bis  auf  drei  Dezimalstellen
ausgegeben. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht weder bei der Ausgabe von Inhaberaktien noch bei
der Ausgabe von Namensaktien. Die Arten der Aktien werden in den teilfondsspezifischen Informationen zum Verkaufs-
prospekt angegeben.

Für Namensaktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Investmentgesellschaft geführt. Dieses Register enthält

den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum
der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat
bestimmte Person(en) unterzeichnet und gilt als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs an solchen Namensaktien.

Aktien werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben, d.h.

an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung
als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens 125.000 Euro in die Investmentgesellschaft investieren oder (2)
eine Beurteilung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne
der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihren Sachverstand,
ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Investmentgesellschaft angemessen beurteilen zu können,
vorlegen.

Eine Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung der Investmentgesellschaft und ist nur möglich, wenn

der Käufer ein sachkundiger Anleger im Sinne Gesetzes von 2007 ist und wenn er voll und ganz etwaige restliche Verp-
flichtungen gegenüber der Investmentgesellschaft übernimmt.

Falls ein Aktionär Aktien der Investmentgesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines

Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.

Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Investmentgesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsre-

gister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen.
Alle  Mitteilungen  und  Ankündigungen  der  Investmentgesellschaft  zugunsten  von  Inhabern  von  Namensaktien  können
rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Invest-
mentgesellschaft die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung eingegangen ist.
Namensaktien  kann  die  Investmentgesellschaft  als  Aktienbruchteile  bis  zur  dritten  Dezimalzahl  ausgeben.  Aktien-

bruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Investmentgesellschaft auf
einer pro rata - Basis.

Art. 7. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Investmentgesellschaft sind sachkundigen Anlegern

im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Darüber hinaus kann die Investmentgesellschaft nach eigenem Ermessen
den Besitz oder Erwerb ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der
Ansicht ist, dass ein solcher Besitz oder Erwerb:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Investmentgesellschaft geht; oder
- unter Ausnutzung von Market Timing, Late Trading oder sonstigen Markttechniken betrieben wurde, die der Ge-

samtheit der Aktionäre schaden könnte; oder

- der Aktionär nicht die Bedingungen für den Erwerb der Aktien erfüllt; oder
- die Aktien in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person erworben worden sind, in dem

die Investmentgesellschaft zum Vertrieb oder der Erwerb von Aktien an solche Personen nicht zugelassen ist; oder

- ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung der Investmentgesellschaft führt; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder

102486

L

U X E M B O U R G

- bewirken kann, dass die Investmentgesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerp-

flichtig wird; oder

- den Interessen der Investmentgesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.
Zu diesem Zweck kann die Investmentgesellschaft:
a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern,
b) Aktien zwangsweise zurücknehmen,
c) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Investmentgesellschaft zu besitzen,

das Stimmrecht aberkennen.

Art. 8. Ausgabe von Aktien. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbe-

zahlter Aktien zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszuge-
bender Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse Einschränkungen unterwerfen; er

kann insbesondere entscheiden, dass Aktien einer Aktienklasse ausschließlich während einer oder mehrerer Zeichnungs-
fristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Investmentgesellschaft ausgegeben
werden.

Der Ausgabepreis ist bei Ausgabe der Aktien gänzlich oder teilweise auf die Weise zu entrichten, wie sie der Verwal-

tungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt nennt und ausführlich beschreibt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise Mindestzeich-

nungsbeträge, die Zahlung von Ausgabeaufschlägen oder Ausgleichszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschrän-
kungen. Diese Bedingungen werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben.

Der Verwaltungsrat kann an jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen

ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis
neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern.

Aktien müssen voll eingezahlt werden. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage

der Aktienausgabe in Umlauf waren.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder je-

derzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen.

Art. 9. Rücknahme von Aktien. Jeder Aktionär kann innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen

Grenzen die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Investmentgesellschaft nach den Bestimmungen
und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen festgelegt werden, verlangen. Der Rücknah-
mepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche fünf Werktage ab
dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Verwaltungsrates
und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Inhaberaktien und sonstige Unterlagen zur Übertragung von Aktien
bei der Investmentgesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 dieser Satzung.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert pro Aktie der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel

11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkauf-
sunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder
abgerundet werden, gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.

Sofern die Zahl oder der gesamte Nettoinventarwert von Aktien, welche durch einen Aktionär in einer Aktienklasse

gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom Verwal-
tungsrat  als  Mindestzahl  bzw.  -wert  festgelegt  wurden,  kann  dieser  Antrag  als  Antrag  auf  Rücknahme  des  gesamten
Aktienbesitzes des Aktionärs in dieser Aktienklasse behandelt werden.

Wenn des weiteren an einem Bewertungstag die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß

Artikel 10 dieser Satzung gestellten Umtauschanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwal-
tungsrat festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder
Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat unter Berück-
sichtigung der Interessen aller Aktionäre für erforderlich gehalten wird. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden in
diesen Fällen am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.

Der Verwaltungsrat kann eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn er der Ansicht

ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betroffenen Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der
Investmentgesellschaft geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich
ziehen kann (insbesondere, wenn es sich bei dem betroffenen Aktionär nicht oder nicht mehr um einen Anleger im Sinne
des Artikels 2 Absatz 1 des Gesetzes von 2007 handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Investmentgesellschaft in einem
anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Investmentgesellschaft
in einer anderen Art und Weise schadet.

Des Weiteren kann der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der

Investmentgesellschaft zurückzukaufen, um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten zur Be-

102487

L

U X E M B O U R G

friedigung der Rücknahmebegehren der Aktionäre zu verwenden. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle
Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Investmentgesellschaft.

Der Rücknahmepreis entspricht in diesen Fällen dem Nettoinventarwert pro Aktie am Tag der Rücknahme.
Die von der Investmentgesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Investmentge-

sellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag
der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Art. 10. Umtausch von Aktien. Sofern durch den Verwaltungsrat im Verkaufsprospekt nicht anderweitig festgelegt, ist

jeder Aktionär berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse zu
verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Um-
tauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und
Provisionen abhängig machen.

Der Preis für den Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen Aktienklasse wird auf der Grundlage

des jeweiligen Nettoinventarwertes pro Aktie der beiden Aktienklassen an demselben Bewertungstag beziehungsweise
zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.

Sofern die Zahl der von einem Aktionär in einer Aktienklasse gehaltenen Aktien oder der gesamte Nettoinventarwert

pro Aktie der von einem Aktionär in einer Aktienklasse gehaltenen Aktien aufgrund eines Umtauschantrages unter eine
Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Investmentgesellschaft ent-
scheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Aktionär in einer solchen Aktienklasse
gehaltenen Aktien behandelt wird.

Art. 11. Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie. Der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird

in der Währung der Investmentgesellschaft - wie im Verkaufsprospekt festgesetzt - in dem vom Verwaltungsrat bes-
timmten  und  im  Verkaufsprospekt  aufgeführten  Rhythmus,  mindestens  jedoch  einmal  pro  Monat  („Bewertungstag“)
berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Aktienklassen ausgedrückt.

Er wird durch Division der Nettovermögenswerte der Investmentgesellschaft, das heißt der einer solchen Aktienklasse

zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten, durch die Zahl der
an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der entsprechenden Aktienklasse gemäß den nachfolgend bes-
chriebenen Bewertungsregeln berechnet. Der Nettoinventarwert pro Aktie kann auf die nächste gängige Untereinheit
der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern
seit Bestimmung des Nettoinventarwertes pro Aktie wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten
erfolgten, auf denen ein wesentlicher Anteil der jeweiligen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt
oder notiert wird, kann der Verwaltungsrat im Interesse der Aktionäre und der Investmentgesellschaft die erste Bewer-
tung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

Die Bewertung des Nettoinventarwertes pro Aktie der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt vorgenommen:
I. Die Vermögenswerte der Investmentgesellschaft beinhalten:
(1) Die im Vermögen der Investmentgesellschaft enthaltenen Zielfondsanteile;
(2) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
(3) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Ent-

gelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);

(4) alle Aktien und gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschrei-

bungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Ver-
mögenswerte,  welche  im  Eigentum  der  Investmentgesellschaft  stehen  oder  für  sie  gehandelt  werden  (wobei  die
Investmentgesellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen
kann, um Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche
Praktiken gerecht zu werden);

(5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Investmentgesellschaft eingefordert werden

können, vorausgesetzt, dass die Investmentgesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;

(6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Investmentgesellschaft stehen, soweit

diese nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag wider-
gespiegelt werden;

(7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Investmentgesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und

Auslieferung von Aktien an der Investmentgesellschaft;

(8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer

Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewähr-
leistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente,
abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind,
ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

102488

L

U X E M B O U R G

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht

an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht
repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet,
der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handels-
tages sein darf und den die Investmentgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmark-
tinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.

c) Bei Anleihen oder vergleichbaren Finanzinstrumenten, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die

nicht an einem anderen geregelten Markt und die nicht am Zweitmarkt (OTC) gehandelt werden, erfolgt die Bewertung:

1. anhand eines Modells, durch welches der wahrscheinliche Realisierungswert ermittelt werden soll. Dabei erfolgt die

Bewertung einer nicht notierten Anleihe oder eines vergleichbaren Finanzinstruments allgemein durch die risikoadäquate
Diskontierung der zu erwartenden Zahlungsströme. Die zu erwartenden Zahlungen ergeben sich dabei aus allen in den
nicht notierten Anleihen vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen und werden gemäß ihrem zeitlichen Anfall
bei der Diskontierung erfasst. Sobald die Verwaltungsgesellschaft Kenntnis vom möglichen Ausbleiben vertraglich zuge-
sicherter Zahlungen erlangt, wird der Zahlungsstrom und damit auch die Bewertung entsprechend angepasst. Da der
zukünftige Zahlungsstrom unsicher ist, erfolgt die Diskontierung der Zahlungen mit einem risikoadäquaten Zins. Dieser
Zins setzt sich zusammen aus einer „risikofreien Verzinsung“ und einem Aufschlag (Spread) für das übernommene Risiko.
Der „risikofreie Zins“ wird dabei definiert als Swap-Satz, der kongruent zur Laufzeit der zu bewertenden nicht notierten
Anleihe gewählt wird. Der Spread enthält verschiedene Komponenten, die aus Marktdaten und empirischen Daten ab-
geleitet werden. Im Einzelnen kompensiert dieser Aufschlag das Ausfallrisiko des Emittenten, eine eventuell besondere
Ausgestaltung der Anleihe und die damit zu erwartenden geringeren Verwertungserlöse im Insolvenzfall des Emittenten
von nicht notierten Anleihen oder vergleichbaren Finanzinstrumenten sowie die Illiquidität der nicht notierten Anleihe
oder der vergleichbaren Finanzinstrumente. Der Aufschlag für das Ausfallrisiko wird basierend auf liquiden Marktindizes
laufzeitkongruent bestimmt. Weiterhin kann zur Bestimmung des Ausfallrisikos das Rating von anerkannten Ratingagen-
turen hinzugezogen werden. Die Kompensation für geringere Verwertungserlöse sowie die Illiquidität ergibt sich auf Basis
diverser empirischer Beobachtungen. Insgesamt erfolgt die Bewertung vor allem anhand empirischer Daten, wobei aber
bei gewissen Annahmen auch subjektive Komponenten in die Bewertung einfließen.

oder
2. anhand von vergleichbaren Anleihen und deren vereinbarten Preisen. Gegebenenfalls werden die Kurswerte von

Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag
zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

d) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf

Tagesbasis bewertet.

e) OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis an-

gesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Invest-
mentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso
wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu
und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

f) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und d) genannten

Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich
zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und
Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berück-
sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

g) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
h) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert ange-

setzt.

i) Der Marktwert von Wertpapieren Geldmarktinstrumenten, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) und sonsitgen,

Anlagen und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter
Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem
Bewertungstag vorhergehenden Börsentages die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Wenn solche Kurse
nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten
Verfahren bestimmt. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

j) Der Wert der Beteiligungsprogramme wird an Hand der letzten zur Verfügung stehenden Berichte bestimmt, die i.

d. R. nach den Bestimmungen der jeweiligen nationalen oder supranationalen Venture Capital und Private Equity-Verbände
erstellt werden. Diese basieren im Wesentlichen auf folgender Vorgehensweise:

- Beteiligungsunternehmen werden zu Einstandskosten („at cost“) bewertet, solange kein Bewertungsereignis statt-

gefunden hat;

- Als Bewertungsereignisse qualifizieren Ausschüttungen, Nachfinanzierungsrunden durch Drittinvestoren, der Teil-

verkauf oder Verkauf des Unternehmens („trade sale“), die Börseneinführung, das wesentliche negative Abweichen von
den Planzahlen oder der Konkurs. Die Neubewertung kann im Ergebnis eine Höherbewertung, eine Teilabschreibung
oder Vollabschreibung sein;

102489

L

U X E M B O U R G

- Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurch-

führbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien
anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

k) Direktbeteiligungen werden anhand der unter j) genannten Grundsätze bewertet.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse

einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Investmentgesellschaft für angebracht hält.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Ak-

tienklasse separat. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer für die Investmentgesellschaft.

II. Die Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft beinhalten:
(1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fällige Forderungen;
(2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Investmentgesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
(3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Ma-

nagementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Investmentgesellschaft);

(4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlich-

keiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter
Ausschüttungen der Investmentgesellschaft);

(5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am

Bewertungstag entsprechend der Bestimmung durch die Investmentgesellschaft sowie sonstige eventuelle Rückstellungen,
welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der Verwaltungs-
rat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft für angemessen hält;

(6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter

Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Be-
trages solcher Verbindlichkeiten wird die Investmentgesellschaft sämtliche von der Investmentgesellschaft zu zahlenden
Kosten berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für
die Buchführung, Gebühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und
Domizilierungsstelle, Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an
Zahl- oder Vertriebsstellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Investment-
gesellschaft, Gebühren für sämtliche sonstigen von der Investmentgesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für
die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren angemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang
mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren und Kosten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Gebühren im Zu-
sammenhang  mit  der  Registrierung  und  der  Aufrechterhaltung  dieser  Registrierung  der  Investmentgesellschaft  bei
Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentli-
chungskosten,  einschließlich  der  Kosten  für  die  Vorbereitung,  den  Druck,  die  Ankündigung  und  die  Verteilung  von
Verkaufsprospekten, Werbeschriften, periodischen Berichten oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung,
die Kosten sämtlicher Berichte an die Aktionäre, Steuern, Gebühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen
Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermö-
genswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für Post, Telefon und Telefax. Die Investmentgesellschaft kann
Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich
oder für andere Zeitabschnitte berechnen.

III. Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:
Innerhalb der Investmentgesellschaft können eine oder mehrere Aktienklassen eingerichtet werden:
(1) Sofern mehrere Aktienklassen ausgegeben sind, werden die diesen Aktienklassen zuzuordnenden Vermögenswerte

gemeinsam  entsprechend  der  spezifischen  Anlagepolitik  angelegt,  wobei  der  Verwaltungsrat  Aktienklassen  definieren
kann, um (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung
unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung von Verkaufs- und Rücknahmeprovision und/oder (iii) einer
bestimmten  Gebührenstruktur  im  Hinblick  auf  die  Verwaltung  oder  Anlageberatung  und/oder  (iv)  einer  bestimmten
Zuordnung von Dienstleistungsgebühren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Aktionäre oder sonstiger Gebühren
und/oder (v) unterschiedlichen Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Aktienklasse lauten soll
und welche unter Bezugnahme auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Währung der Investmentgesellschaft gerechnet
werden, und/oder (vi) der Verwendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche
auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Währung der In-
vestmentgesellschaft abzusichern und/oder (vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat
im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, zu entsprechen;

(2) Die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse werden in den Büchern der Investmentgesellschaft der

Aktienklasse beziehungsweise den Aktienklassen zugeordnet und der betreffende Betrag soll den Anteil der Netto-Ver-
mögenswerte der Investmentgesellschaft, welche der auszugebenden Aktienklasse zuzuordnen sind, erhöhen;

(3) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre einer Aktienklasse wird der Nettoinventarwert pro Aktie

dieser Aktienklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.

102490

L

U X E M B O U R G

Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu

treffen und auszulegen.

Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang

mit der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie, welche vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Investment-
gesellschaft  oder  sonstigen  Stelle,  die  der  Verwaltungsrat  mit  der  Berechnung  des  Nettoinventarwertes  pro  Aktie
beauftragt, getroffen wird, endgültig und für die Investmentgesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Aktionäre
bindend.

IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:
(1) Zur Rücknahme ausstehende Aktien der Investmentgesellschaft gemäß Artikel 9 dieser Satzung werden als beste-

hende Aktien behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entspre-
chenden Bewertungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von
diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Investmentgesellschaft besteht eine entsprechende
Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft;

(2) Auszugebende Aktien werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag,

an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Aktien behandelt. Von diesem Zeitpunkt
an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Investmentgesellschaft besteht eine Forderung zu Gunsten der Invest-
mentgesellschaft;

(3) sofern an einem Bewertungstag die Investmentgesellschaft sich verpflichtet hat
- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbind-

lichkeit der Investmentgesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Invest-
mentgesellschaft als Vermögenswert der Investmentgesellschaft verzeichnet;

- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung

der Investmentgesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten
der Investmentgesellschaft aufgeführt;

wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden

Bewertungstag nicht bekannt ist, dieser Wert von der Investmentgesellschaft geschätzt wird.

Art. 12. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Be-

rechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Investmentgesell-

schaft  fallen,  eine  normale  Verfügung  über  das  Nettovermögen  unmöglich  wird,  ohne  die  Interessen  der  Aktionäre
schwerwiegend zu beeinträchtigen;

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträcht-

lichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;

- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte der Investmentgesellschaft

verhindern;

- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Investmentgesellschaft zu liquidieren.
Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird den Aktionären per Post oder E-Mail an die

im Aktionärsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Art. 13. Verwaltungsrat. Die Investmentgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei

Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär an der Investmentgesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder
werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen
der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder,
ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gene-

ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates

die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Ent-
scheidung über die Ernennung treffen.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-

und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel
19 dieser Satzung vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-

halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen

Geschäftsführung der Investmentgesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Invest-
mentgesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und

102491

L

U X E M B O U R G

des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen
nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt wer-
den und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Investmentgesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Investmentgesell-

schaft beschrieben, einen Anlageberatungsvertrag oder Fondsmanagervertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en)
abschließen. Der Verwaltungsrat kann Investmentbeiräte berufen und deren Vergütung festsetzen. Diese Beiräte sollen
aus fachkundigen Personen mit entsprechender Erfahrung bestehen. Die Beiräte haben lediglich eine beratende Funktion
und treffen keinerlei Anlageentscheidungen. Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder pri-
vatschriftliche Urkunden übertragen.

Art. 16. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er

kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwe-

senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder
im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens acht Tage vor dem entspre-

chenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt
wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder ähnliche Kommuni-
kationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten
abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung mit schriftlich, per Telegramm, Telefax

oder ähnliche Kommunikationsmittel erteilter Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere
Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenz-

schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Sofern sämtliche

Verwaltungsratsmitglieder  anwesend  oder  vertreten  sind  und  sich  damit  einverstanden  erklären,  kann  auf  die
ordnungsgemäße Einberufung verzichtet werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder können die Investmentgesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer

im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Meh-

rheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten
sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Verwaltungsrat unterzeichnet. Aus-

züge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind
vom Verwaltungsrat rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei

Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-

zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse  schriftlich,  durch  Telegramm,  Telefax  oder  ähnliche  Kommunikationsmittel  billigen.  Diese  Billigung  wird
schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Investmentgesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaft-

liche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift
von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 18. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der General-

versammlung  festgelegt.  Sie  umfassen  auch  Auslagen  und  sonstige  Kosten,  welche  den  Verwaltungsratsmitgliedern  in
Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn,
solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 19. Allgemeine Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Investmentgesellschaft werden nach dem Grundsatz der

Risikostreuung in Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele
und  Anlagegrenzen  der  Investmentgesellschaft,  wie  sie  in  dem  von  der  Investmentgesellschaft  herausgegebenen  Ver-
kaufsprospekt beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007.

Art. 20. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Investment-

gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit
der Geschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

102492

L

U X E M B O U R G

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,

zusammentreten.

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg-

Strassen an einem in der Einladung angegebenen Ort am 1. Dienstag des Monats April eines jeden Jahres um 10.00 Uhr
abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg, wird die jährliche Generalversamm-
lung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu
solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage

vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse
versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht
nachgewiesen  werden.  Die  Tagesordnung  wird  vom  Verwaltungsrat  vorbereitet,  außer  in  den  Fällen,  in  welchen  die
Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.

Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die

Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die

Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind

(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).

Grundsätzlich ist jede Aktie stimmberechtigt. Das Stimmverhältnis der Aktien kann der Verwaltungsrat bestimmen

und weist die entsprechende Regelung im jeweiligen teilfondsspezifischen Anhang aus.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche

kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Investmentgesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-

neralversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 21. Generalversammlungen der Aktionäre eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse. Die Aktionäre der Teilfonds

bzw. der Aktienklassen können zu jeder Zeit eine Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden,
welche ausschließlich einen Teilfonds bzw. eine Aktienklasse betreffen.

Darüber hinaus, können die Aktionäre eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen

im Hinblick auf alle Fragen, welche diesen Teilfonds bzw. diese Aktienklasse betreffen, abhalten.

Die relevanten Bestimmungen in Artikel 20 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.
Grundsätzlich ist jede Aktie stimmberechtigt. Das Stimmverhältnis der Aktien kann der Verwaltungsrat bestimmen

und weist die entsprechende Regelung im jeweiligen teilfondsspezifischen Anhang aus.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der Aktionäre eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse durch

eine  schriftliche  Vollmacht  an  eine  andere  Person,  welche  kein  Aktionär  sein  muss  und  Verwaltungsratsmitglied  der
Investmentgesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalver-

sammlung eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst.

Art. 22. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Investmentgesellschaft einen Depotbankvertrag

mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor („Depotbank“) abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch die Investmentgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Ein-

klang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen,
um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank
zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der
Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Art. 23. Wirtschaftsprüfer.  Die  Rechnungsdaten  im  Jahresbericht  der  Investmentgesellschaft  werden  durch  einen

Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der In-
vestmentgesellschaft bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 01. Januar jeden Jahres und endet

am 31. Dezember.

102493

L

U X E M B O U R G

Der Jahresabschluss der Investmentgesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung auf-

gestellt.

Art. 25. Ausschüttungen. Die Generalversammlung einer Aktienklasse wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und

innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit
Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.

Auf jede ausschüttungsberechtigte Aktienklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den

gesetzlichen Bestimmungen beschließen.

Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensaktien erfolgt an deren im Aktionärsregister vermerkte

Adressen.

Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der

Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Guns-

ten der jeweiligen Aktienklasse(n).

Auf Ausschüttungen, welche von der Investmentgesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten

werden, erfolgen keine Zinszahlungen.

Art. 26. Verschmelzung der Investmentgesellschaft und der Teilfonds. Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss

der Generalversammlung beschließen, einen oder mehrere Teilfonds zusammenzulegen. Die Investmentgesellschaft kann
durch Beschluss der Generalversammlung ebenfalls beschließen, die Investmentgesellschaft bzw. einen Teilfonds der In-
vestmentgesellschaft mit einer/m anderen spezialisierten Investmentgesellschaft/Fonds nach dem Gesetz von 2007 oder
einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds einer/s solchen spezialisierten Investmentgesellschaft/Fonds
oder eines solchen OGA zu verschmelzen. Die Beschlüsse der Generalversammlung im Rahmen einer Verschmelzung
bedürfen mindestens der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Verschmelzungen, bei denen die
übertragende Investmentgesellschaft durch die Verschmelzung erlischt, muss das Wirksamwerden der Verschmelzung
notariell beurkundet werden.

Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:
- sofern das Netto-Vermögen der Investmentgesellschaft oder eines Teilfonds an einem Bewertungstag unter einen

Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um die Investmentgesellschaft in wirtschaftlich sinnvoller Weise
zu verwalten; oder

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-

schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, die Investmentgesellschaft zu verwalten; oder

- im Rahmen einer Rationalisierung.
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik der/s einzubringenden Investmentgesell-

schaft/Fonds/Teilfonds  nicht  gegen  die  Anlagepolitik  der/s  aufnehmenden  Investmentgesellschaft/Fonds/Teilfonds
verstößt.

Liegt eine Verschmelzung mit einem OGA nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 oder einem Teilfonds eines

solchen OGA vor, ist es den betroffenen Aktionären erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum
der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien
zu dem anwendbaren Nettoinventarwert pro Aktie zu beantragen. Nach Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für
alle verbleibenden Aktionäre bindend.

Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung der/s einzubringenden Investmentgesellschaft/

Fonds/Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch die/den aufnehmenden In-
vestmentgesellschaft/Fonds/Teilfonds.

Der Beschluss, die Investmentgesellschaft oder den Teilfonds mit einer ausländischen Investmentgesellschaft/Fonds/

Teilfonds zu verschmelzen, obliegt der Versammlung der Aktionäre der/s einzubringenden Investmentgesellschaft/Fonds/
Teilfonds. Die Einladung zur Versammlung der Aktionäre der einzubringenden Investmentgesellschaft/Fonds/Teilfonds
erfolgt per Einschreiben an jeden Aktionär mindestens acht Tage vor der Versammlung. Nur die Aktionäre sind an den
Beschluss der Aktionärsversammlung gebunden, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Bei den Aktionären, die nicht
an der Versammlung teilgenommen haben sowie bei allen Aktionären, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben,
wird davon ausgegangen, dass sie ihre Aktien zum Rückkauf angeboten haben. Im Rahmen dieser Rücknahme dürfen den
Aktionären keine Kosten berechnet werden.

Art. 27. Auflösung und Liquidation der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds. Die Investmentgesellschaft kann

zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen
Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 20 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Sa-

tzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalver-
sammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der auf dieser Versammlung vertretenen
Aktien.

102494

L

U X E M B O U R G

Die Frage der Auflösung der Investmentgesellschaft wird der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat auch

dann vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser
Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung
kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimm-
berechtigten Aktien halten.

Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der

Tatsache, dass das Gesellschaftskapital unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gefallen
ist, abgehalten werden kann.

Die Auflösung der Investmentgesellschaft erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
- wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue Depotbankbestellung innerhalb von zwei Mo-

naten erfolgt;

- wenn das Vermögen der Investmentgesellschaft während mehr als sechs Monaten unter einem Betrag 312.500 Euro

bleibt;

- in anderen, im Gesetz vom 13. Februar 2007 vorgesehenen Fällen.
Sofern das Nettovermögen der Investmentgesellschaft zwei Drittel des gesetzlichen Mindestbetrages unterschreitet,

kann die CSSF unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände den Verwaltungsrat dazu verpflichten, die Investmentge-
sellschaft aufzulösen.

Soweit der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft nichts anderes beschließt, wird für den Fall, dass ein Tatbestand

eintritt, der zur Auflösung der Investmentgesellschaft führt, die Ausgabe und die Rücknahme von Aktien eingestellt.

Die Investmentgesellschaft hat die Aktionäre durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Ver-

waltungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Aktionäre und ihre Adressen der
Investmentgesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.

Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische

Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung ent-
scheidet, ernannt werden.

Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung des Ver-

waltungsrates oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbe-
hörde  ernannten  Liquidatoren  unter  den  Aktionären  nach  deren  Anspruch  verteilen.  Der  Verwaltungsrat  kann  im
Verkaufsprospekt genauer regeln, wie in Hinblick auf die verschiedenen Aktienklassen verfahren wird. Nettoliquidation-
serlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Aktionären eingezogen worden sind, werden von der
Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des Con-
signations  im  Großherzogtum  Luxemburg  hinterlegt,  bei  der  diese  Beträge  verfallen,  wenn  sie  nicht  innerhalb  der
gesetzlichen Frist von 30 Jahren geltend gemacht werden.

Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft kann jederzeit durch Beschluss Generalversammlung insbesondere in folgen-

den Fällen liquidiert werden:

- sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindest-

betrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Die Investmentgesellschaft hat diesen
Betrag mit 5 Mio. Euro festgesetzt; oder

- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-

schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Teilfonds zu verwalten; oder

- im Rahmen einer Rationalisierung.
Die Investmentgesellschaft hat die Aktionäre durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Ver-

waltungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Aktionäre und ihre Adressen der
Investmentgesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.

Soweit der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft nichts anderes beschließt, wird für den Fall, dass ein Tatbestand

eintritt, der zur Liquidation eines Teilfonds führt, die Ausgabe und die Rücknahme von Aktien für diesen Teilfonds ein-
gestellt.

Art. 28. Kosten. Die Investmentgesellschaft bzw. die Teilfonds tragen neben den Kosten, die für die einzelnen Teilfonds

in dem betreffenden Anhang festgelegt sind, die folgenden Kosten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen

anfallen,  insbesondere  bankübliche  Spesen  für  Transaktionen  in  Wertpapieren  und  sonstigen  Vermögenswerten  und
Rechten der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds und deren Verwahrung, die banküblichen Kosten für die Ver-
wahrung von ausländischen Investmentanteilen im Ausland;

b) die direkt zuordenbaren Kosten im Zusammenhang mit einem nicht zur Ausführung gelangenden Erwerb oder der

Veräußerung von Vermögensgegenständen, soweit diese nicht von Dritten zu zahlen sind;

c) die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Namens- und Inhaberaktien;

102495

L

U X E M B O U R G

d) darüber hinaus werden der Depotbank, der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Transferstelle die im

Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallenden eigenen Auslagen und sonstigen Kosten sowie die
durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet;

e) Steuern, die auf das Vermögen der Investmentgesellschaft bzw. Teilfondsvermögen, deren Einkommen und die

Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben werden;

f) Kosten für die Rechtsberatung, die der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft (sofern ernannt) oder

der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der Aktionäre des jeweiligen Teilfonds handelt;

g) Kosten des Wirtschaftsprüfers der Investmentgesellschaft;
h) Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck und den Versand sämtlicher

Dokumente für die Investmentgesellschaft, insbesondere des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen), der Satzung, der
Jahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre und der Einberufungen zu Generalver-
sammlungen;

i) Die Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bzw. einen Teilfonds bei der Luxemburger Aufsichts-

behörde und zu entrichten sind, sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der Investmentgesellschaft;

j) Versicherungskosten:
k) Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen;
l) etwaige Honorare und Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;
m) etwaige Honorare und Auslagen des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft;
n) Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft bzw. einzelner Teilfonds und die Erstausgabe von Aktien;
o) Kosten zur Ermittlung der Aufspaltung des erzielten Anlageergebnisses in seine Erfolgsfaktoren (sog. „Performance-

Attribution“);

p) Gebühren, die die Investmentgesellschaft bzw. ein Teilfonds an Dritte für die Einführung bei Portfoliogesellschaften

bezahlen muss;

q) Kosten, welche durch die Bewertung von Portfoliogesellschaften entstehen;
r) nachgewiesene Reisekosten je eines Verwaltungsratsmitgliedes bzw. dessen Vertreters für Reisen zwecks Überwa-

chung der Verwalter der Portfoliogesellschaften, in die die Investmentgesellschaft bzw. ein Teilfonds investiert hat;

s) angefallene Zinsen, für die bereits vor dem ersten Zeichnungsschluss eines Teilfonds vorfinanzierten Einzahlungen

auf Portfoliogesellschaften; und

t) Steuerberatungskosten.
Sämtliche Kosten werden zunächst den ordentlichen Erträgen und den Kapitalgewinnen und zuletzt dem jeweiligen

Teilfondsvermögen angerechnet.

Die Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft, einschließlich der Ausarbeitung und der Veröffentlichung des

ersten Verkaufsprospektes und der Steuern, Abgaben und Veröffentlichungskosten, werden den bei Gründung beste-
henden Teilfonds zugeordnet und können über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren abgeschrieben werden. Die Kosten
im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds zugeordnet und
dort innerhalb einer Periode von längstens fünf Jahren nach Auflegung abgeschrieben.

Als Vergütung für ihre Tätigkeit können Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltungsstelle, Register- und Transfers-

telle, Depotbank und Zahlstelle sowie etwaige Fondsmanager und/oder Anlageberater von der Investmentgesellschaft
eine Vergütung erhalten, deren Höhe und Auszahlungsmodalitäten, in dem betreffenden Anhang für die einzelnen Teil-
fonds beschrieben ist. Hierbei ist sowohl eine feste als auch eine erfolgsbezogene Vergütung möglich.

Die Kosten werden den einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet; ansonsten werden die

Kosten den einzelnen Teilfonds gemäß dem Wert der Netto-Teilfondsvermögen belastet.

Art. 29. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserforder-

nissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen (das „Gesetz von 1915“) unterliegt, geändert werden.

Art. 30. Interessenkonflikte.
1. Kein Vertrag, kein Vergleich oder sonstiges Rechtsgeschäft, das die Gesellschaft mit anderen Gesellschaften schließt,

wird durch die Tatsache ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäftsleiter der Gesellschaft
Interessen in oder Beteiligungen an einer anderen Gesellschaft haben, oder durch die Tatsache, dass sie Verwaltungs-
ratsmitglied, Teilhaber, Direktor, Geschäftsleiter, Bevollmächtigter oder Angestellter der anderen Gesellschaft sind.

2.  Dieses(r)  Verwaltungsratsmitglied,  Direktor,  Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigter  der  Investmentgesellschaft,

welches(r) zugleich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen
Gesellschaft ist, mit der die Investmentgesellschaft Verträge abgeschlossen hat oder mit der sie in einer anderen Weise
in geschäftlichen Beziehungen steht, wird dadurch nicht das Recht verlieren, zu beraten, abzustimmen und zu handeln,
was die Angelegenheiten, die mit einem solchen Vertrag oder solchen Geschäften in Verbindung stehen, anbetrifft.

3. Falls ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in einer Angelegenheit

der Investmentgesellschaft hat, muss dieses Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Investmentge-

102496

L

U X E M B O U R G

sellschaft den Verwaltungsrat über dieses persönliche Interesse informieren, und er wird weder mitberaten noch am
Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse
des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder Bevollmächtigten muss bei der nächsten Generalversammlung erstattet
werden.

4. Der Begriff „persönliches Interesse“, wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine Anwendung auf

eine Beziehung oder ein Interesse, die nur deshalb entstehen, weil das Rechtsgeschäft zwischen der Investmentgesellschaft
einerseits und dem Fondsmanager, der Zentralverwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, einer etwaigen Ver-
triebsstelle (bzw. ein mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder jeder anderen von der
Investmentgesellschaft benannten Gesellschaft andererseits geschlossen wird.

5. Die vorhergehenden Bestimmungen sind in Fällen, in denen die Depotbank Partei eines Vertrages, Vergleiches oder

sonstigen Rechtsgeschäftes ist, nicht anwendbar. Die Geschäftsleiter und die zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtig-
ten  Generalbevollmächtigten  der  Depotbank  dürfen  nicht  gleichzeitig  als  Verwaltungsräte  oder  Geschäftsleiter  der
Investmentgesellschaft zur täglichen Geschäftsführung bestellt sein. Geschäftsleiter, Verwaltungsräte und die zum gesam-
ten Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten der Investmentgesellschaft dürfen nicht gleichzeitig als
Geschäftsleiter oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Generalbevollmächtigten der Depotbank zur täglichen
Geschäftsführung bestellt sein.

Art. 31. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
1. Die Satzung der Investmentgesellschaft unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt für die

Rechtsbeziehung zwischen den Aktionären, der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Reglungen dieser Satzung die Vorschriften des Gesetzes vom 13. Februar 2007
einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen. Die Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in
Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Aktionären, der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft
und der Depotbank unterliegt der Gerichtbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großher-
zogtum Luxemburg. Die Investmentgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst
der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Ak-
tionäre handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds
beziehen.

2. Der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements ist maßgeblich.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Thomas Bernard und Clemens von Ber-

ger an und erteilt diesen Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung für die Ausübung ihres Amtes.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Matthias Schirpke, beruflich ansässig in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas

Edison, als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit ab 1. August 2013 bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr

2014 wie folgt zusammen:

Dr. Georg Oehm, geb. 24.08.1965 in Meppen, Deutschland
Dörthe Hirschmann, geb. 12.1974 in Braunschweig, Deutschland
Matthias Schirpke, geb. 04.08.1965 in Göttingen, Deutschland

Die gefassten Beschlüsse treten ab dem 1. August 2013 in Kraft.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxembourg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG, S. MOHN, G. WENZ und C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1 

er

 août 2013. Relation: LAC/2013/36117. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 12. August 2013.

Référence de publication: 2013114875/768.
(130139498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2013.

102497

L

U X E M B O U R G

HPL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 155.537.

L'an deux mille treize, le vingt-sept juin,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme «HPL S.A.» (la «Société»), ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 155.537, constituée suivant acte notarié, en date du 9 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2313 du 28 octobre 2010.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 4 mars

2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 548 du 24 mars 2011.

L'assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Madame Marie KAISER, employée privée, avec adresse

professionnelle à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Maxime TOQUE, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2086 Lu-

xembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, avec adresse professionnelle à

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel de cent dix-sept millions d'euros (EUR 117.000.000,-) à quarante-sept millions d'euros
(EUR 47.000.000,-) par annulation de sept mille (7.000) actions et par remboursement à due concurrence à l'actionnaire
unique de la Société;

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à quarante-sept millions d'euros (EUR 47.000.000,-) représenté par quatre mille sept

cents (4.700) actions d'une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000,-) chacune.»;

3. Divers.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire unique représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations  d'usage,  l'actionnaire  unique  représenté  se  reconnaît  dûment  convoqué  et  déclarant  par  ailleurs  avoir  eu
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de soixante-dix millions d'euros

(EUR 70.000.000,-) pour le ramener de son montant actuel de cent dix-sept millions d'euros (EUR 117.000.000,-) re-
présenté par onze mille sept cents (11.700) actions d'une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000,-) chacune, à
quarante-sept millions d'euros (EUR 47.000.000,-) par annulation de sept mille (7.000) actions et par remboursement à
due concurrence à l'actionnaire unique de la Société, selon les modalités convenues entre l'actionnaire unique et la Société.

La présente réduction de capital est régie par l'article 69 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la

Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

102498

L

U X E M B O U R G

« Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à quarante-sept millions d'euros (EUR 47.000.000,-) représenté par quatre mille

sept cents (4.700) actions d'une valeur nominale de dix mille euros (EUR 10.000,-) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KAISER, M. TOQUE, P. MESTDAGH et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 28 juin 2013. LAC/2013/30053. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Référence de publication: 2013103297/68.

(130125037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

UniSector, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement der UniSector: BasicIndustries, welches am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013089085/10.

(130109933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Assenagon Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 129.914.

Das Verwaltungsreglement HELLAS Opportunities Fund wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-

burg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Référence de publication: 2013115858/11.

(130140973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2013.

AIP Issuance S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 150.271.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013123505/10.

(130150206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

102499

L

U X E M B O U R G

Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 100.893.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 103.539.

Sireo Immobilienfonds No. 4 London 10 St. Bride Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.164.600,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 118.083.

Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.729.

<i>Draft Terms of Merger

In the year two thousand and thirteen, on the ninth of August.
Before Maître Marc Loesch, notary public residing at Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS, an investment company with variable capital (société d'investissement à

capital variable) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 100.893, incor-
porated by a deed enacted on 24 May 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
595 of 10 June 2004, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a notarial
deed dated 26 June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1901 of 31 July 2012,
hereinafter the “Absorbing Company”,

duly represented by Lydie Beuriot, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse,
acting as representative of the Absorbing Company, duly authorized and empowered by proxy given by the Absorbing

Company on August 8, 2013.

2) Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under number B 103.539, incorporated by a deed enacted on 12 October 2004 published in the Mémorial
C, Receuil des Sociétés et Associations number 1294 of 16 December 2004, which articles of association have been
subsequently amended and for the last time by a notarial deed dated 14 November 2011, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 180 of 21 January 2012, hereinafter the “Absorbed Company 1”,

duly represented by Lydie Beuriot, prenamed,
acting as representative of the Absorbed Company 1, duly authorized and empowered by proxy given by the Absorbed

Company 1, on August 8, 2013.

3) Sireo Immobilienfonds No. 4 London 10 St. Bride Street S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg
trade and companies register under number B 118083, incorporated by a deed enacted on 19 July 2006 published in the
Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations number 1813 of 28 September 2006, which articles of association have
been subsequently amended and for the last time by a notarial deed dated 24 November 2011, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 579 of 6 March 2012, hereinafter the “Absorbed Company 2”,

duly represented by Lydie Beuriot, prenamed,
acting as representative of the Absorbed Company 2, duly authorized and empowered by proxy given by the Absorbed

Company 2, on August 8, 2013.

4) Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court S.à r.l., a
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 4A, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 115 729, incor-
porated by a deed enacted on 7 April 2006 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1291 of 4 July 2006, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a notarial deed

102500

L

U X E M B O U R G

dated 24 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 581 of 6 March
2012, hereinafter the “Absorbed Company 3”,

duly represented by Lydie Beuriot, prenamed,
acting as representative of the Absorbed Company 3, duly authorized and empowered by proxy given by Absorbed

Company 3, on August 8, 2013.

The Absorbed Company 1, the Absorbed Company 2 and the Absorbed Company 3 will hereinafter together be

referred to as the “Absorbed Companies” or separately as to the “Absorbed Company”.

The Absorbing Company and the Absorbed Companies are hereinafter collectively referred to as the “Merging Parties”

or the “Companies”.

Copies of the aforementioned proxies, having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing parties

and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The appearing parties, represented as here above stated, have required the undersigned notary TO RECORD THE

FOLLOWING AND PASS the present notarial deed in full compliance with the requirements of article 271 of the Lu-
xembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Companies Law”).

WHEREAS
(A) The Absorbing Company exists as a Specialised Investment Fund (SIF) under the law of 13 February 2007 relating

to specialised investment funds.

(B) The Absorbed Companies are limited liability companies (sociétés à responsabilité limitée), with the following

capital:

- Sireo Immobilienfonds No.4 Alpha S.à r.l. has a fully paid up share capital of EUR 12,500.-, represented by one hundred

twenty-five (125) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

- Sireo Immobilienfonds No. 4 London 10 St. Bride Street S.à r.l. has a fully paid up share capital of EUR 2,164,600.-,

represented by twenty-one thousand six hundred forty-six (21.646) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

- Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court S.à r.l. has a fully paid up share capital of EUR 12,500,000.-,

represented by one hundred twenty-five thousand (125,000) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

(C) At the date hereof, the Absorbing Company holds all issued shares and related voting rights of each of the Absorbed

Companies.

(D) For sound economical reasons and in order to reduce the administrative and running costs, the directors of the

Absorbing Company and the managers of each of the Absorbed Companies approved by circular written resolutions the
present draft terms of merger.

(E) Considering that the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the share capital of each of the

Absorbed Companies, the Merging Companies have decided to perform a simplified merger as set forth by articles 278
et seq. of the Companies Law and have approved the present draft terms of merger by circular written resolutions.

(F) The present draft terms of merger is subject to the shareholders of the Absorbing Company not requesting the

convening of a meeting pursuant to article 279 c) of the Companies Law and as further set forth under paragraph 5 below.

Thereupon, the following has been acknowledged and agreed among the Merging Parties:

1. Merger. The Absorbing Company absorbs each of the Absorbed Companies with effect on 30 September 2013 (the

“Effective Date”). The absorption by the Absorbing Company of each of the Absorbed Companies with effect on 30
September 2013 will hereinafter be referred to as the “Merger”.

As of the Effective Date, the Merger between the Merging Parties will become effective and definitive and will carry

the legal effects set out in article 274 of the Companies Law.

As of the Effective Date, each of the Absorbed Companies will be dissolved, without liquidation, their shares will be

immediately cancelled and all of their assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company.

As of the Effective Date, each of the Absorbed Companies will cease to exist, the Absorbing Company will be the sole

and full owner of the assets of each of the Absorbed Companies and will assume all of the liabilities, pay off the creditors
and execute all ongoing agreements of each of the Absorbed Companies. The rights and claims comprised in the trans-
ferred assets of each of the Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing Company with all securities,
either in rem or personal, attached thereto.

As of the Effective Date, the Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of whatever kind of the

Absorbed Companies and will be subrogated to all rights and obligations thereunder.

As of the Effective Date, the Absorbing Company will take over all liabilities of any kind whatsoever of each of the

Absorbed Company in particular but not limited to will pay all taxes, contributions, duties and assessments, due or that
may become due with respect to the property of the assets transferred.

Between the Merging Parties and from an accounting point of view as set forth under article 261 (e) of the Companies

Law, all operations and transactions of the Absorbed Companies will be considered for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Company as at the Effective Date.

102501

L

U X E M B O U R G

The Absorbing Company being the owner of all the shares of each of the Absorbed Company, no increase of share

capital of the Absorbing Company is required.

2. Special rights and advantages (article 261 (f) and (g) of the Companies Law). In accordance with article 261 (f) no

special rights are granted by the Absorbing Company to shareholders having special rights.

In accordance with article 261 (g) no special advantage is granted to the members of the board of directors respectively

board of managers or to the statutory auditor of the Merging Parties.

3. Termination of mandates and discharge. The mandates of the managers of each of the Absorbed Companies will be

terminated with effect on the Effective Date and the Absorbing Company, in its capacity as sole shareholder of each of
the Absorbed Companies, hereby grants discharge to the managers of each of the Absorbed Companies for the perfor-
mance of their mandate until the Effective Date.

4. Information of the Absorbing Company's shareholders (article 279 (b) of the Companies Law). The shareholders

of the Absorbing Company have the right one month before the Effective Date to consult the documents listed under
article 267 (1) a., b. and c. of the Companies Law at the registered office of the Absorbing Company.

The documents listed under article 267 (1) a., b. and c. are namely: the present draft terms of merger, the annual

accounts and management reports of the Merging Parties for the last three financial years and the interim accounts of
the Merging Parties as of 30 June 2013.

All shareholders of the Absorbing Company may obtain copies of the documents thereof free of charge upon request.

5. Right of the shareholders of the Absorbing Company to require the holding of a meeting of the shareholders of the

Absorbing Company (article 279 (c) of the Companies Law). One or more shareholders of the Absorbing Company
holding at least 5% of the shares of the subscribed capital of the Absorbing Company are entitled one month before the
Effective Date to require that a general meeting of the shareholders of the Absorbing Company be called in order to
resolve whether to approve the Merger. The meeting must be convened so as to be held within one month of requesting
the holding of the meeting.

6. Bookkeeping of the Absorbed Companies. The books and records of the Absorbed Companies (including related

archives, originals of all deeds, agreements, accounting documents, titles of ownership) will be kept at the registered office
of the Absorbing Company.

7. Publication in the Mémorial of the Notarial certificate. The Absorbing Company shall carry out the publication of

the Notarial certificate required under article 273 (2) of the Companies Law in respect of the Absorbed Companies.

8. Fees and Duties. Any charge, duties or fees owed as a result of the Merger shall be borne by the Absorbing Company.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the present draft terms of merger and of all acts,

documents and formalities incumbent on the Merging Parties pursuant to the Companies Law.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the proxyholder

of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned in the beginning of this

document.

After reading and interpretation to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together

with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le neuf août.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, ayant

son siège social sis à 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.893, constituée en vertu d'un acte notarié du 24 mai 2004, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 595 du 10 juin 2004, lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois par acte notarié en date du 26 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1901 le 31 juillet 2012, ci-après dénommée la «Société Absorbante»,

dûment représentée par Lydie Beuriot, avocat à la cour, résidant au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
agissant en qualité de représentant de la Société Absorbante, dûment autorisée par procuration du 8 août 2013.
2) Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social sis au 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le matricule B 103.539, constituée en vertu d'un acte notarié du 12 octobre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1294 du 16 décembre 2004, lesquels statuts ont été modifiés à plusieurs

102502

L

U X E M B O U R G

reprises et pour la dernière fois par acte notarié daté du 14 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 180 le 21 janvier 2012, ci-après dénommée la «Société Absorbée 1»,

dûment représentée par Lydie Beuriot, prénommée,
agissant en qualité de représentant de la Société Absorbée 1, dûment autorisée par procuration du 8 août 2013.
3) Sireo Immobilienfonds No. 4 London 10 St. Bride Street S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois, ayant son siège social sis au 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 118.083, constituée en vertu d'un acte notarié du 19
juillet 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1813 du 28 septembre 2006, lesquels
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte notarié en date du 24 novembre 2011, publié
au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  numéro  579  du  6  mars  2012,  ci-après  dénommée  la  «Société
Absorbée 2»,

dûment représentée par Lydie Beuriot, prénommée,
agissant en qualité de représentant de la Société Absorbée 2, dûment autorisée par procuration du 8 août 2013.
4) Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social sis au 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 115.729, constituée en vertu d'un acte notarié du 7 avril
2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1291 du 4 juillet 2006, lesquels statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte notarié reçu en date du 24 novembre 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 581 du 6 Mai 2012, ci-après dénommée la «Société Absorbée
3»,

dûment représentée par Lydie Beuriot, prénommée,
agissant en la qualité de représentant de la Société Absorbée 3, dûment autorisée par procuration du 8 août 2013.
La Société Absorbée 1, la Société Absorbée 2 et la Société Absorbée 3 seront ci-après dénommées ensemble les

«Sociétés Absorbées» ou séparément la «Société Absorbée».

La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont ci-après dénommées collectivement les «Sociétés Fusionnantes»

et les «Sociétés».

Une copie des procurations mentionnées ci-dessus, ayant été signées «ne varietur» par le mandataire des parties

comparantes et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte avec lequel ils seront soumis aux formalités de
l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme ci-dessus exposé, ont requis le notaire instrumentant d'enregistrer

l'acte qui suit dans le respect intégral des exigences de l'article 271 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
comme amendée (ci-après la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Attendu que:
(A) La Société Absorbante existe en tant que Fonds d'Investissement Spécialisé (FIS) sous la loi du 13 Février 2007

concernant les fonds d'investissement spécialisés.

(B) Les Sociétés Absorbées sont des sociétés à responsabilité limitée avec la capital suivant:
- Sireo Immobilienfonds No.4 Alpha S.à r.l. a un capital intégralement libéré de EUR 12,500.-, représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales de 100 euros (EUR 100.-) chacune.

- Sireo Immobilienfonds No.4 London 10 St. Bride Street S.à r.l. a un capital intégralement libéré de EUR 2,164,600.-,

représenté par vingt et un mille six cent quarante-six (21,646) parts sociales de 100 euros (EUR 100.-) chacune.

- Sireo Immobilienfonds No.4 London Eastcheap Court S.à r.l a un capital intégralement libéré de EUR 12,500,000-,

représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de 100 euros (EUR 100.-) chacune.

(C) En date de la présente, la Société Absorbante détient toutes les actions émises et les droits de vote attachés de

chaque Société Absorbée.

(D) Pour des raisons économiques et afin de réduire les coûts administratifs et de gestion, les directeurs de la Société

Absorbante et les gérants de chaque Société Absorbée ont approuvé par résolutions circulaires écrites le présent projet
de fusion.

(E) Considérant que la Société Absorbante détient cent pourcent (100%) du capital social de chacune des Sociétés

Absorbées, les Sociétés Fusionnantes ont décidé d'accomplir une fusion simplifiée telle que prévue par les articles 278 et
suivants de la Loi sur les Sociétés Commerciales et ont approuvé le présent projet de fusion par résolutions circulaires
écrites.

(F) Le présent projet de fusion est conditionné à l'absence de demande de convocation par les actionnaires de la Société

Absorbante d'une assemblée en application de l'article 279 c) de la Loi sur les Sociétés Commerciales et tel que ci-après
prévu au paragraphe 5.

Sur ce, ce qui suit a été reconnu et approuvé par les Parties Fusionnantes:

102503

L

U X E M B O U R G

1. Fusion. La Société Absorbante absorbe chacune des Sociétés Absorbées avec effet au 30 septembre 2013 (la «Date

de prise d'Effet»). L'absorption par la Société Absorbante de chacune des Sociétés Absorbées avec effet au 30 septembre
2013 sera ci-après désignée par la «Fusion».

A compter de la Date de prise d'Effet, la Fusion entre les Parties Fusionnantes deviendra effective et définitive et

engendrera les conséquences légales mentionnées à l'article 274 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

A compter de la Date de prise d'Effet, chacune des Sociétés Absorbées sera dissoute, sans liquidation, leurs parts

seront immédiatement annulées et tous leurs actifs et passifs seront transférés à la Société Absorbante.

A compter de la Date de prise d'Effet, chacune des Sociétés Absorbées cessera d'exister, la Société Absorbante sera

l'unique et le plein propriétaire des actifs de chacune des Sociétés Absorbées et en assumera l'entier passif, désintéressera
les créanciers et exécutera tous les engagements en cours de chacune des Sociétés Absorbées. Les droits et prétentions
compris dans les actifs transférés de chacune des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante avec
toutes les garanties, tant réelles que personnelles, attachées à ceux-ci.

A compter de la Date de prise d'Effet, la Société Absorbante reprendra tous les accords et les obligations de tout type

des Sociétés Absorbées et sera subrogée dans tous les droits et obligations afférents.

A compter de la Date de prise d'Effet, la Société Absorbante assumera tous les passifs de quelque nature que ce soit

de chacune des Sociétés Absorbées, notamment mais pas uniquement, le paiement de toutes les taxes, contributions,
obligations et estimations, dues ou qui pourront être dues en relation avec la propriété des actifs transférés.

Entre les Parties Fusionnantes et d'un point de vue comptable tel qu'établit à l'article 261 (e) de la Loi sur les Sociétés

Commerciales, toutes les opérations et transactions des Sociétés Absorbées seront considérées à des fins comptables
comme ayant été réalisées pour le compte de la Société Absorbante à la Date de prise d'Effet.

La Société Absorbante étant le propriétaire de toutes les parts de chacune des Sociétés Absorbées, aucune augmen-

tation de capital social de la Société Absorbante n'est requise.

2. Droits et avantages spéciaux (article 261 (f) et (g) de la Loi sur les Sociétés Commerciales). Conformément à l'article

261 (f) aucun droit spécial n'est accordé, par la Société Absorbante, aux actionnaires ayant des droits spéciaux.

Conformément à l'article 261 (g) aucun avantage spécial n'est accordé aux membres du conseil d'administration res-

pectivement aux membres de la gérance ou au commissaire aux comptes des Sociétés Fusionnantes.

3. Résiliation de mandats et décharge. Les mandats des gérants de chacune des Sociétés Absorbées prendront fin avec

effet à la Date de prise d'Effet et la Société Absorbante, en qualité d'associé unique de chacune des Sociétés Absorbées,
donne par les présentes décharge aux gérants de chacune des Sociétés Absorbées pour l'exécution de leurs mandats
jusqu' à la Date de prise d'Effet.

4. Information des actionnaires de la Société Absorbante (article 279 (b) de la Loi sur les Sociétés Commerciales). Les

actionnaires de la Société Absorbante ont le droit un mois avant la Date de prise d'Effet de consulter les documents
énumérés sous l'article 267 (1) a., b. and c. de la Loi sur les Sociétés Commerciales, au siège social de la Société Absorbante.

Les documents énumérés à l'article 267 (1) a., b. et c. sont les suivants: le présent projet de fusion, les comptes annuels

et les rapports de gestion des Sociétés Fusionnantes des trois dernières années financières et les comptes intérimaires
des Sociétés Fusionnantes au 30 juin 2013.

Tous les actionnaires de la Société Absorbante peuvent obtenir copies des documents précités sur demande sans frais.

5. Droit des actionnaires de la Société Absorbante de solliciter la tenue d'une assemblée générale des actionnaires de

la Société Absorbante (article 279 (c) de la Loi sur les Sociétés Commerciales). Un ou plusieurs actionnaires de la Société
Absorbante détenant au moins 5% des actions du capital souscrit de la Société Absorbante sont en droit un mois avant
la Date de prise d'Effet de solliciter qu'une assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante soit convoquée
pour décider l'approbation de la Fusion. L'assemblée doit être convoquée dans le mois de la demande de convocation de
l'assemblée par les actionnaires.

6. Comptabilité des Sociétés Absorbées. Les livres et registres des Sociétés Absorbées (incluant les archives corres-

pondantes, tous les originaux des actes, les contrats, les documents comptables, les titres de propriété) seront conservés
au siège social de la Société Absorbante.

7. Publication au Mémorial du certificat du notaire. La Société Absorbante publiera le certificat de notaire requis à

l'article 273 (2) de la Loi sur les Sociétés Commerciales concernant les Sociétés Absorbées.

8. Frais et taxes. Toute charge, taxe ou frais résultant de la Fusion sera pris en charge par la Société Absorbante.
Le notaire soussigné par la présente certifie l'existence et la légalité du présent projet de fusion et de tous les actes,

documents et formalités incombant aux Parties Fusionnantes conformément à la Loi sur les Sociétés Commerciales.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire

des comparantes, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même
mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

102504

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire soussigné

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: L. Beuriot, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 22 août 2013. REM/2013/1505. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013123822/285.
(130150348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

Assenagon Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 129.914.

BERICHTIGUNG

der Hinterlegung L130140973 vom 12/08/2013

Das Verwaltungsreglement der HELLAS Opportunities Fund wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Lu-

xemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Référence de publication: 2013116461/13.
(130141614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

Pioneer Institutional SIF, Fonds Commun de Placement.

<i>Closure of the liquidation

The liquidation of the fund PIONEER INSTITUTIONAL SIF (the "Fund"), which has never received any subscriptions,

was closed on 11 December 2009 by decision of the board of directors of Pioneer Asset Management S.A. acting as
management company and liquidator of the Fund.

No amount was deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg as no units of the Fund have never been

issued.

<i>Clôture de liquidation

La liquidation du fonds commun de placement PIONEER INSTITUTIONAL SIF (le "Fonds"), qui n'a jamais reçu aucune

souscription, a été clôturée le 11 décembre 2009 par décision du conseil d'administration de Pioneer Asset Management
S.A. en sa qualité de société de gestion et de liquidateur du Fonds.

Aucun montant n'a été déposé à la Caisse de Consignation à Luxembourg comme aucune part du Fonds n'a jamais été

émise.

Pioneer Asset Management S.A.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au Luxembourg.
Référence de publication: 2013123971/250/18.

UniSector, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement der UniSector: BioPharma, welches am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels-

und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Juli 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013089084/10.
(130109932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

102505

L

U X E M B O U R G

WALSER Absolute Return, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 161.844.

<i>Bekanntmachung für den Umbrella-Fonds WALSER Absolute Return

<i>mit dem Teilfonds

<i>WALSER Absolute Return Fund of Fund: LU0642794910

Die Anteilinhaber des einzigen Teilfonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich der Seedmoney-Geber

aus dem Investment zurückziehen möchte.

Demzufolge hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, den einzig bestehenden Teilfonds sowie die Gesell-

schaft schnellstmöglich zu schließen.

Vor diesem Hintergrund wird zum Schutze der Interessen der Anleger die Ausgabe und Rücknahme von Aktien sowie

die Berechnung des Nettoinventarwertes mit Wirkung zum 30. August 2013 eingestellt, sodass der letzte offizielle Net-
toinventarwert des Teilfonds per 30. August 2013 ermittelt wird.

Die Kosten, welche im Zuge der Liquidation anfallen, werden vor Berechnung des Liquidationserlöses dem Fonds

belastet.

Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens und Prüfung des Liquidationserlöses wird den Anteilinhabern der eventuelle

Restbetrag aus dem Liquidationserlös ausgezahlt.

Als Liquidator des Fonds fungiert die Walser Privatbank Invest S.A., die in diesem Zusammenhang durch die Ge-

schäftsführerin Silke Büdinger repräsentiert wird.

Luxemburg, im August 2013.

<i>Im Auftrag des Verwaltungsrats
WALSER Absolute Return

Référence de publication: 2013124133/755/25.

Imedia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 26, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 30.052.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMEDIA S.à r.l.
Fiduciaire des Classes Moyennes

Référence de publication: 2013096991/11.
(130117220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Immo MC, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 56.998.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013096992/11.
(130117856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Immo MC, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 56.998.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

102506

L

U X E M B O U R G

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013096993/11.
(130117857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Kusan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 153.717.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 14 juin 2013

- Il est pris acte de la démission de Madame Isabelle SCHUL de son mandat de gérant avec effet au 14 juin 2013.
- Monsieur Ahcène BOULHAIS, né le 12 décembre 1977 à Thionville (France), employé privé, demeurant profession-

nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé en tant que gérant en remplacement de Madame Isabelle
SCHUL, démissionnaire, avec effet au 14 juin 2013, et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 14 juin 2013.

KUSAN HOLDING S.A.R.L.
Signatures
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2013097043/17.
(130117487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Immo MC, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 56.998.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013096994/11.
(130117858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

ING (L) FLEX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 41.873.

Le bilan au 31 mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2013.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Par délégation

Référence de publication: 2013096999/12.
(130117632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

ING (L) Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 82.219.

Le bilan au 31 mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2013.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Par délégation

Référence de publication: 2013097000/12.
(130117629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

102507

L

U X E M B O U R G

King David, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 94.459.

En remplacement de la 1 

ère

 version du dépôt initial au RCS L130115094

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 03 juillet 2013, enregistrée

à Esch/Alzette A.C., le 08 juillet 2013; Relation: EAC/2013/8757, que l'AGE a pris les décisions suivantes:

L'assemblée générale prend la décision de révoquer tous les administrateurs de leur fonction avec effet au jour des

présentes.

L'assemblée générale constate qu'il existe actuellement un seul actionnaire et dès lors prend à l'unanimité des voix la

décision de nommer à la fonction d'administrateur unique, Maître Roy REDING, né le 17 juillet 1965 à Luxembourg,
demeurant professionnellement à L-1449 Luxembourg, 20 rue de l'Eau.

La société sera valablement engagée à l'égard des tiers, et ce en toutes circonstances y compris toutes opérations

bancaires, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Pour extrait

Référence de publication: 2013097038/19.
(130117530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Internationale Beteiligungen Holding AG SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 86.940.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2012 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2013097006/12.
(130117864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

Isiwis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.465.003,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

En date du 13 juin 2013, et avec effet au 1 

er

 janvier 2013, l'associé ISIWIS Research S.à r.l., avec siège social au 7A,

rue Stümper, L-2557 Luxembourg, a cédé l'intégralité des 4.465.003 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société
Alter Domus Group S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.

Suite à cette cession de parts sociales, Alter Domus Group S.à r.l., précité, est l'associé unique de la Société en détenant

l'intégralité des 4.465.003 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Référence de publication: 2013097012/15.
(130117577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

IST International Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.943.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013097014/10.
(130117625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

102508

L

U X E M B O U R G

LaSalle Investment (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 232.400,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.524.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 1 

er

 juillet 2013 que:

- Monsieur Kimball Woodrow a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 juillet 2013.

- A été nommé aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 juillet 2013 et ce pour une durée indéterminée:

* Madame Virginie Vely résidant professionnellement au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013097052/17.
(130117288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.

M.A.F. Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 42.715.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013098121/14.
(130118686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

MMIT SA, Management Marketing IT &amp; Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 675, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 177.418.

<i>Extrait du 03 mai 2013

L'administrateur unique, Madame Tanja DEWITTE, décide de nommer Monsieur Joachim DEWITTE, chef d'entreprise,

né le 05 novembre 1980 à B-Temse et demeurant à B-2520 Oelegem au 13 Van Edinghenlaan, Directeur afin de prendre
la gestion journalière de la société pour une durée indéterminée et la société sera engagée par la signature individuelle
de Monsieur Joachim DEWITTE.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 mai 2013.

Tanja DEWIITE
<i>Administrateur-unique

Référence de publication: 2013098124/16.
(130118986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.

Luxevents S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 4, ZAE Robert Steichen, rue Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 50.742.

Lors de l’assemble générale ordinaire du 4 juin 2012, les décisions suivantes sont prises à l’unanimité:
1) Les mandats d’administrateurs sont confirmés:

102509

L

U X E M B O U R G

- Madame Danielle SALES, ZAE Robert Steichen, rue Laangwiss, 4 à L-4940 Bascharage jusqu’à l’assemblée générale

qui se tiendra en 2016

- Monsieur Marc SALES, ZAE Robert Steichen, rue Laangwiss, 4 à L-4940 Bascharage jusqu’à l’assemblée générale qui

se tiendra en 2014

- Monsieur Jos SALES, ZAE Robert Steichen, rue Laangwiss, 4 à L-4940 Bascharage jusqu’à l’assemblée générale qui se

tiendra en 2014

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur jusqu’à hauteur d’un montant de

cinquante-mille euros (50.000.-€); la signature de deux administrateurs est nécessaire pour tout engagement dépassant
le montant de cinquante-mille euros (50.000.-€)

2) Est nommée réviseur d’entreprises la société BDO AUDIT SA, inscrite au RCSL sous le n° B147570, 2 Avenue

Charles de Gaulle à L – 1653 Luxembourg (ex-Compagnie Fiduciaire, RCSL n° B71178) jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en l’année 2013

3) L’adresse du siège social est modifiée en: ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss à L-4940 Bascharage.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 22 juillet 2013.

Référence de publication: 2013103397/24.
(130125318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Marengo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 170.185.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 9 juillet 2013

En date du 9 juillet 2013, l'actionnaire unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Stephen Oxenbridge en tant qu'administrateur de classe A de la Société et ce avec effet

immédiat;

Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Administrateur de classe A:

- Christopher Grindal

<i>Administrateurs de classe B:

- Johanna van Oort
- Claudine Schinker
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., ayant comme représentant permanent Johanna van Oort
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2013.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013103411/22.
(130125332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

LVS II Lux VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 178.079.

EXTRAIT

En date du 10 juillet 2013 l'associé unique de la Société a décidé avec effet immédiat de nommer Monsieur John Murray,

né le 8 octobre 1972 à West Point, New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 840 Newport
Center Drive, Newport Beach, CA 92660, Californie, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant A de la Société, pour
une période indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:
- Monsieur Lee Galloway, gérant A,
- Monsieur John Murray, gérant A et
- Monsieur Sansal Ozdemir, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

102510

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 22 juillet 2013.

<i>Pour LVS II Lux VII S.à r.l.

Référence de publication: 2013103406/20.
(130125840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Monitor Capital Investors S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 748.752,91.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 135.764.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2013.

Julien FRANCOIS
<i>Gérant

Référence de publication: 2013103414/12.
(130125281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Maniola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 178.831.

STATUTS

L'an deux mille treize, le cinq juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU

SGG S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 65906,

ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, (le Man-

dataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur"
par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MANIOLA S.à r.l.» (la

Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

102511

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant  sur  toute ou partie  de  ses  avoirs  afin  de garantir ses  propres obligations et  engagements  et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.

3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de

catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

102512

L

U X E M B O U R G

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas

de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),

la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

102513

L

U X E M B O U R G

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires

aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2013.

<i>Souscription - Libération

Et à l'instant, SGG S.A., prédésignée et représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entièreté du capital

social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq (125) parts sociales par versement en espèces, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros
(EUR 900,-).

<i>Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, employé, né le 10 novembre 1962 à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg),

avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

102514

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and thirteen, on the fifth of July;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED

SGG S.A., a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having

its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and registered with the Trade and Companies' Register
of Luxembourg under number B 65906,

here represented by Mrs Alexia UHL, private employee, residing professionally in Luxembourg, (the Proxyholder), by

virtue of a proxy given under private seal; such proxy after signature "ne varietur" by the Proxyholder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

"MANIOLA S.à r.l." (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests

in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.

3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a

portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

102515

L

U X E M B O U R G

3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500) represented by one

hundred twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»

and «Category B Managers».

7.3 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

102516

L

U X E M B O U R G

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented

and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and

by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.

10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the

Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.

10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory

power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of each year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the

Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,

102517

L

U X E M B O U R G

realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholders.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.

VII. General provision

Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2013.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, SGG S.A., prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the whole

share capital of the Company and to have fully paid up all one hundred twenty-five (125) shares by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euros (EUR 900,-).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:

- Mr. Jean-Robert BARTOLINI, employee, born on November 10 

th

 , 1962 in Differdange (Grand Duchy of Luxem-

bourg), with professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2013. LAC/2013/31747. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Référence de publication: 2013103420/411.
(130125794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

102518

L

U X E M B O U R G

Point Blank Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 20.592.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration en date du 27 juin 2013, les

décisions suivantes ont été prises:

Sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les Comptes Annuels clôturant au 31 décembre 2015:
- Luc BRAUN, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d'administration

- Jean-Marie POOS, demeurant professionnellement 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Ad-

ministrateur-Délégué

- FIDESCO S.A., avec siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur
- EURAUDIT SARL, avec siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale

ordinaire du 27 juin 2013 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame Evelyne
GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013099299/21.
(130120405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

Proteus Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 48.602.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2013

<i>Conseil d'Administration

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs de MM. VAN DEN BERGHE Guido et

MANGEN Fons pour une durée de 3 ans. D'autre part, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat d'admi-
nistrateur et de dirigeant maritime de Mme Rebecca ANDRIES pour une durée de 3 ans. Suite à ces décisions le Conseil
d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2016 est composé comme suit:

- ANDRIES Rebecca, 16 cité Riedgen, L-8071 Bertrange, Dirigieant Maritime
- VAN DEN BERGHE Guido, 15 Ter Beke, B-2650 Edegem
- MANGEN Fons, 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck

<i>Commissaire aux Comptes

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans. Suite

à cette décision le Commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2016 est RAMLUX S.A., 9b bd
Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2013099305/23.
(130119974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

Q.I.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.617.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 12 juillet 2013

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Juin 2014, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean-Baptiste
TOULOUSE, Laurent POINSOT, François POTIER, et Market Overview S.A., représenté par M. Patrick ABADIE.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013099308/12.
(130119790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.

102519

L

U X E M B O U R G

Metropolica Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 118.997.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 11 juillet 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 aout 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

Metropolica Capital S.à r.l, avec siège social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, dénoncé en date du 8 octobre

2010,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT juge, et liquidateur Maître Ibtihal EL BOUYOUF-

SI, avocat demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 1 

er

 août 2013 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme
Me Ibtihal EL BOUYOUFSI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013100800/19.
(130122676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Lombard Financial Investments S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 250.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 68.401.

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2011:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social

60 Grand Rue, 1 

er

 étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur pour une durée

indéterminée.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

<i>Pour LOMBARD FINANCIAL INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2013100769/14.
(130122672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Litoine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 174.631.

<i>Extrait des résolutions de l’Associée unique prises le 16 juillet 2013:

- La démission de Monsieur Francesco ABBRUZZESE en sa qualité de gérant de catégorie B de la Société avec effet

immédiat a été acceptée;

- La décision a été prise de nommer avec effet immédiat Monsieur Marc LIBOUTON, né le 19 février 1971 à Libramont

(Belgique), demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en qualité de gérant de catégorie B de
la Société pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Le 17 juillet 2013.

Référence de publication: 2013100767/17.
(130121795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

102520

L

U X E M B O U R G

Mecactiv S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4316 Esch-sur-Alzette, 13, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 132.461.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2013

Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité:
- de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de:
* M. DEGRADI Daniel
* Mme DEGRADI Marie-Louise
- de renouveler le mandat d'administrateur de:
* Monsieur FIORAMONTI Gilles, domicilié au 5 rue Henri Panetti à F-54190 TIERCELET
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de:
* Monsieur GETTO Didier
- la nomination des administrateurs de catégorie A suivants:
*  Monsieur  Quentin  IMPERIALE,  né  le  25/3/1991  à  Mont-Saint-Martin  (France),  demeurant  professionnellement  à

L-4316 Esch-sur-Alzette 13 rue de Schifflange

* Monsieur Sylvain IMPERIALE, né le 17/2/1962 à Villerupt (France) demeurant à F-54880 THIL au 2 rue St Georges.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2019
POUR EXTRAIT CONFORME

Luxembourg, le 3/6/2013.

Référence de publication: 2013100816/23.
(130121764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Libertim Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.611.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date 17 Juillet 2013, que les décisions suivantes

ont été prises:

- Accepter la démission de M. Benjamin Penaliggon en tant que administrateur de la Société avec effet au 12 Juillet

2013;

- Reconnaître que le conseil d'administration est dès lors composé de:
* M. Enrico Baldan;
* Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.àr.l.; et
* M. Max Kreuter.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Juillet 2013.

Référence de publication: 2013100762/18.
(130122108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.959.

EXTRAIT

Il ressort du Conseil de Gérance de la Société tenu en date du 19 juin 2013 que 785 parts sociales ordinaires de

catégorie O ont été rachetées par la Société puis annulées.

Dès lors, depuis le 19 juin 2013 les 134 536 parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

102521

L

U X E M B O U R G

Associé

Adresse

Numéro

d’enregistrement

Nombre de parts

LBREP III Europe

Holdings, L.P

c/o Aird &amp; Berlis LLP,

1800-1 Bay Street,

Toronto, ON M5J 2T9,

Canada

180360430

148 Classe B, 256 Classe F, 26 Classe

G, 1 429 Classe H, 44 Classe N, 550

Classe O, 74 616 Classe P, 6 986

Classe PA, 3 228 Classe Q, 58 Classe

R, 47 195 Classe AA

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
LBREP III Europe S.à. r.l., SICAR

Référence de publication: 2013100758/22.
(130121832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

M&amp;F Investissement III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 175.199.

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2013

L’Assemblée Générale décide avec effet immédiat de transférer le siège social de la société du 55-57, avenue Pasteur

à L-2311 Luxembourg au 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

L’Assemblée Générale constate le changement d’adresse professionnelle de Monsieur Nico HANSEN:
- Monsieur Nico HANSEN demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg L’Assemblée

Générale constate également le changement d’adresse du commissaire aux comptes:

- MGI FISOGEST S.àr.l. sise 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.
Référence de publication: 2013100790/14.
(130121709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

M Luxembourg SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 171.539.

L’assemblée générale du 19 juin 2013 a décidé de renouveler les mandats de M. Antonio Hormigos, M. Raphael Spahr

et M. Jérôme Wigny en tant que membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se compose dès lors, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en 2014, comme suit:

- Antonio Hormigos, Président du Conseil d’Administration
7, Pl. Francesc Macià - E-08029 Barcelona
- Raphael Spahr, Membre du Conseil d’Administration
13, avenue Hoche - F-75008 Paris
- Jérôme Wigny, Membre du Conseil d’Administration
2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg
Ernst &amp; Young 7, rue Gabriel Lippmann L-5365 Münsbach, est réélu comme réviseur d’entreprises et ce jusqu’à la fin

de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2013100789/22.
(130121940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

Maison Stemper, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7562 Mersch, 2, Um Iecker.

R.C.S. Luxembourg B 10.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

102522

L

U X E M B O U R G

Paul BESCH
<i>Le gérant
2 um Iecker
L-7562 Mersch

Référence de publication: 2013100791/13.
(130122696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.

S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 14, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 63.173.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 juillet 2013

<i>4 

<i>e

<i> Résolution

L'assemblée  accepte  la  démission  de  Madame  Wanlin  Bernadette,  comptable,  demeurant  à  B-6724  Marbehan  71,

Grand-Rue en tant qu'administrateur au conseil d'administration.

L'assemblée décide de nommer Mademoiselle Tess Henn, étudiante, née le 10 septembre 1994 à Luxembourg, de-

meurant à L-8720 Rippweiler, 5, an der Bremchen, administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2018.

<i>5 

<i>e

<i> Résolution

L'assemblée décide de prolonger le mandat de Madame Bernard Brigitte, administrateur de sociétés, demeurant à

L-8720 Rippweiler 5, an der Bremchen, en tant qu'administrateur-délégué à durée indéterminée.

Pour extrait conforme
<i>Le président de l'assemblée générale ordinaire

Référence de publication: 2013108385/19.
(130130738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2013.

RPTRE I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 140.024.

Veuillez noter que, suite à la décision des Associés de la Société, intervenue en date du 23 Juillet 2013,
- M. Patrick K. Fox démissionne du poste de gérant de type B avec effet au 23 Juillet 2013;
- M. Ronald Jay Hoyl démissionne du poste de gérant de type B avec effet au 23 Juillet 2013;
- M. Herman-Gtinther Schommarz démissionne du poste de gérant de type A avec effet au 23 Juillet 2013;
- Mme Amy Kelly, née le 3 Avril 1978 à Dublin, Irlande, et résidant au 40 Seaford Road, Londres, W13 9HT, Royaume-

Uni est nommée au poste de gérant de catégorie A avec effet au 23 Juillet 2013 et pour une durée illimitée;

- M. Nikhil Gupta, né le 14 Août 1984 à New Delhi, Inde, et résidant au 5b, Angelgasse, CH-6317 Oberwii, Zug, Suisse

est nommé au poste de gérant de catégorie A avec effet au 23 Juillet 2013 et pour une durée illimitée;

- M. Gerald Olivier Welvaert, né le 15 Juillet 1977 à Uccie, Belgique, et résidant professionnellement au 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg est nommé au poste de gérant de catégorie B avec effet au 23 Juillet 2013 et pour une
durée illimitée;

- M. Jean-Jacques Patrick Gustave Josset, né le 12 Juin 1974 à Saint-Quentin, France, et résidant professionnellement

au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg est nommé au poste de gérant de catégorie B avec effet au 23 Juillet
2013 et pour une durée illimitée.

Par conséquent, à partir du 23 Juillet 2013, le conseil de gérance de la Société est constitué de la manière suivante:
- Amy Kelly, gérant de catégorie A;
- Nikhil Gupta, gérant de catégorie A;
- Gerald Welvaert, gérant de catégorie B;
- Jean-Jacques Josset, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

102523

L

U X E M B O U R G

Jean-Jacques Josset
<i>Gérant A

Référence de publication: 2013108379/30.
(130130773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2013.

RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 117.671.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 29 juillet 2013:

- Le mandat de Mons. Simon Radford, employée privée, résidant professionnellement au La Marmotte, Mont Gras

d'Eau, JE - JE3 8ED St Brelade, gérant de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons. Simon Radford prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016

statuant sur les comptes annuels de 2015.

- Le mandat de Mons. Rolf Caspers, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer,

L-1115 Luxembourg, gérant de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons. Rolf Caspers prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016

statuant sur les comptes annuels de 2015.

- Le mandat de Mons. Tony Whiteman, employée privée, résidant professionnellement au 14, Rue Jean Mercatoris,

L-7237 Helmsange, gérant de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons. Tony Whiteman prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2016 statuant sur les comptes annuels de 2015.

Luxembourg, le 29 juillet 2013.

Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013108380/24.
(130131176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2013.

RREEF RVK 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.532.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared the following:

RREEF Spezial Invest GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Mainzer

Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register at the local court of
Frankfurt am Main under the number 44003 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sofia Da Chao, residing professionally in L-4030 Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by RREEF RVK

1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 164532, and with a share capital of one hundred and twelve thousand five hundred euro (EUR
112,500.-), incorporated by a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, on 8 November 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 3136 dated 21 December 2011 (the
"Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Léonie
Grethen, notary residing in Luxembourg, on 28 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under the number 118 dated 14 January 2012 (the "Articles of Assocation").

The appearing party, represented as above mentioned, has been fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To decrease the Company's subscribed and paid-up share capital by an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-)

by way of redemption and cancellation of all ten thousand (10,000) class J shares having a par value of one euro (EUR 1.-)

102524

L

U X E M B O U R G

each in accordance with the Company's Articles of Association, so as to reduce the Company's share capital from its
current amount of one hundred and twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500.-), divided into twelve thousand
five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten
thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand
(10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares, ten thousand (10,000)
class I shares and ten thousand (10,000) class J shares with a par value of one euro (EUR 1) each to an amount of one
hundred and two thousand five hundred euro (EUR 102,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary
shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares,
ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten
thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares and ten thousand (10,000) class I shares with a
par value of one euro (EUR 1.-) each and to pay a redemption price of EUR 1.885.385,90 to the Company's Sole Share-
holder.

2. To amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the resolution to be

adopted under item 1 above.

3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company
with the registration of the redemption of the shares in the register of shareholders of the Company.

4. Miscellaneous.
The appearing party, represented as above mentioned, in its capacity of sole shareholder of the Company, has re-

quested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to decrease the Company's subscribed and paid-up share capital by an amount of ten

thousand euro (EUR 10,000.-) by way of redemption and cancellation of all ten thousand (10,000) class J shares having a
par value of one euro (EUR 1.-) each in accordance with the Company's Articles of Association, so as to reduce the
Company's share capital from its current amount of one hundred and twelve thousand five hundred euro (EUR 112,500.-),
divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand
(10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000)
class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H
shares, ten thousand (10,000) class I shares and ten thousand (10,000) class J shares with a par value of one euro (EUR
1.-) each to an amount of one hundred and two thousand five hundred euro (EUR 102,500.-) divided into twelve thousand
five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten
thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand
(10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares and ten thousand
(10,000) class I shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each and to pay a redemption price of EUR 1.885.385,90
to the Company's Sole Shareholder.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, which

shall forthwith read as follows:

"The share capital of the Company is set at one hundred and two thousand five hundred Euro (EUR 102,500.-) divided

into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000)
class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E
shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares
and ten thousand (10,000) class I shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any manager, each individually, to proceed in the name and on behalf of the
Company with the registration of the redemption of the shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

<i>Declaration

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is

drafted in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German
text, the English text shall prevail.

102525

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am sechsundzwanzigsten Juni.
Vor Uns, Maître Francis Kesseler, Notarin, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

RREEF Spezial Invest GmbH, eine unter deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in der Main-

zer  Landstraße  178-190,  60327  Frankfurt  am  Main,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts
Frankfurt am Main unter der Nummer 44003 (hiernach als die "Alleingesellschafterin" bezeichnet),

hierbei vertreten durch Frau Sofia Da Chao, berufsansässig in rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, (Groß-

herzogtum Luxemburg), aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht bleibt zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärte, dass sie gegenwärtig alle von RREEF RVK 1 S.à r.l., eine

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-
sabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),
eingetragen  im  luxemburgischen  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B  164.532,  und  mit  einem
Stammkapital von einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 112.500,-), gegründet gemäß notarieller Urkunde von
Léonie Grethen, Notarin ansässig in Luxemburg, vom 8. November 2011, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations Nummer 3136 vom 21. Dezember 2011 veröffentlicht (die "Gesellschaft"), ausgegebenen Anteile hält.Die Satzung
der Gesellschaft ist das letzte Mal gemäß notarieller Urkunde von Léonie Grethen, Notarin ansässig in Luxemburg, vom
28. November 2011, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 118 vom 14. Januar 2012 veröffent-
licht, abgeändert worden (die "Satzung").

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, ist vollständig von den auf Grundlage folgender Tagesordnung

zu treffenden Beschlüssen informiert worden:

<i>Tagesordnung

1. Herabsetzung des gezeichneten und eingezahlten Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zehntausend

Euro (EUR 10.000,-), durch Rückkauf und Annullierung von sämtlichen zehntausend (10.000) Kategorie J Anteilen mit
einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) gemäß der Satzung der Gesellschaft, um somit das Stammkapital der
Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von einhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 112.500,-), unterteilt
in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Ka-
tegorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend
(10.000)  Kategorie  E  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  F  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  G  Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie I Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie
J Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), auf einen Betrag von einhundertzweitausendfünfhundert Euro
(EUR 102.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie
D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000)
Kategorie G Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie I Anteile mit einem
Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), und einen Rückkaufpreis von EUR 1.885.385,90 an die Alleingesellschafterin der
Gesellschaft zu zahlen.

2. Abänderung des den Absatzes 1 Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, um den nach dem vorstehenden Punkt 1 zu

fassenden Beschluss widerzuspiegeln.

3. Abänderung des Gesellschafterregisters der Gesellschaft, um die obengenannten Änderungen widerzuspiegeln und

Erteilung von Vollmacht an die Geschäftsführer, um jeder einzeln, die Eintragung des Rückkaufs der Anteile im Gesell-
schafterregister vornehmen zu können.

4. Verschiedenes.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, hat, in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Gesellschaft,

den unterzeichnenden Notar gebeten, folgende Beschlüsse schriftlich festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, das gezeichnete und eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag

von  zehntausend  Euro  (EUR  10.000,-)  herabzusetzen,  durch  Rückkauf  und  Annullierung  von  sämtlichen  zehntausend
(10.000) Kategorie J Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) gemäß der Satzung der Gesellschaft, um
somit das Stammkapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von einhundertzwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 112.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie
D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000)
Kategorie G Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie I Anteile und zehntau-

102526

L

U X E M B O U R G

send (10.000) Kategorie J Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), auf einen Betrag von einhundert-
zweitausendfünfhundert Euro (EUR 102.500), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend
(10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F
Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile und zehntausend (10.000)
Kategorie I Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu verringern und einen Rückkaufpreis von EUR
1.885.385,90 an die Alleingesellschafterin der Gesellschaft zu zahlen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, den Absatz 1 Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun wie folgt

lautet:

"Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhundertzweitausendfünfhundert Euro (EUR 102.500,-), unterteilt in

zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kate-
gorie  B  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  C  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  D  Anteile,  zehntausend
(10.000)  Kategorie  E  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  F  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  G  Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie I Anteile mit einem Nennwert von je
einem Euro (EUR 1,-)."

<i>Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, den Gesellschafterregister der Gesellschaft abzuändern, um die obengenanten

Änderungen widerzuspiegeln und bevollmächtigt die Geschäftsführer der Gesellschaft, jeder einzeln, die Eintragung des
Rückkaufs der Anteile im Gesellschafterregister vorzunehmen.

<i>Kosten und Auslagen

Die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu tragenden Auslagen, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwen-

dungen jedweder Art werden auf eintausend dreihundert euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

<i>Erklärung

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Esch/Alzette aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei

diese notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss und dass im Falle
einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgeben ist.

Nach Vorlesung der Urkunde gegenüber dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, die dem Notar nach Namen,

Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar diese Originalurkunde un-
terschrieben.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 juillet 2013. Relation: EAC/2013/8682. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013108383/178.
(130131685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2013.

Resort Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 90.270.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013108370/9.
(130131021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2013.

Regata S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 144.702.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

102527

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013108368/9.
(130131203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2013.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 68.857.

Le Conseil d’Administration de la sicav
I. a pris note de la démission avec effet au 30 juin 2013 de
- Monsieur Giovanni RUFFINI, 24, Lungo Mallero Cadorna, I – 23100 Sondrio
- Monsieur Mario ERBA, 24, Lungo Mallero Cadorna, I – 23100 Sondrio
- Monsieur Arnaud DUBOIS, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
II. a coopté
- avec effet au 30 juin 2013 Monsieur Yvon LAURET, 58, rue Glesener, L – 1630 Luxembourg
- avec effet au 1 

er

 juillet 2013 Monsieur Hermann BEYTHAN, 35, Avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxembourg

à la fonction d’administrateur.
Ces cooptations seront ratifiées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice clôturant au 31

mars 2013.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors de:
- Hermann BEYTHAN
- Luigi CARUGO
- Yvon LAURET
- Roberto MASTROMARCHI
- Brunello PERUCCHI

<i>Pour Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2013100045/28.
(130120944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

OZ International Trading Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 132.308.

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 27 décembre 2012 que les

décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1) L’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat de son poste d’administrateur de la société Monsieur Domi-

nique GARELLIS

2) L’assemblée accepte la démission de Monsieur François GARELLIS de son poste d’administrateur et d’administrateur

délégué de la société;

3) L’assemblée nomme comme nouvel administrateur unique, Monsieur Alain POINTEL, né le 11 juillet 1944 à F-

Villeneuve et demeurant professionnellement au 12 rue de Bastogne L-1217 LUXEMBOURG;

4) L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes, la société COMPTASSIT SA, société immatriculée

au RCS de Luxembourg sous le numéro B161086, ayant son siège social situé au 12 rue de Bastogne à L-1217 LUXEM-
BOURG.

Le nouvel administrateur unique aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature individuelle.
Le mandat du nouvel administrateur et du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de l’année 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2012.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2013100039/24.
(130121661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

102528


Document Outline

AIP Issuance S.A.

Assenagon Asset Management S.A.

Assenagon Asset Management S.A.

CP Valentine International S.A. - SPF

Hipergest S.A.

HPL S.A.

Hyadinvest S.A.

Imedia S.à r.l.

Immo MC

Immo MC

Immo MC

ING (L) FLEX

ING (L) Protected

Internationale Beteiligungen Holding AG SPF

Isiwis S.à r.l.

IST International Holding S.A.

King David

Kusan Holding S.à r.l.

LaSalle Investment (Luxembourg) S.à r.l.

LBREP III Europe S.à r.l., SICAR

Libertim Luxembourg S.A.

Litoine S.à r.l.

Lombard Financial Investments S.A.

Luxevents S.A.

LVS II Lux VII S.à r.l.

M.A.F. Consult S.A.

Maison Stemper

Management Marketing IT &amp; Trading S.A.

Maniola S.à r.l.

Marengo S.A.

Mecactiv S.A.

Mellinckrodt 1

Mellinckrodt 1 SICAV-FIS

Metropolica Capital S.à r.l.

M&amp;F Investissement III S.A.

M Luxembourg SIF

Monitor Capital Investors S.à.r.l.

OZ International Trading Company S.A.

Pioneer Institutional SIF

Point Blank Promotions S.A.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV

Proteus Shipping S.A.

Q.I.M. S.A.

Regata S.A.

Resort Finance S.A.

RPTRE I S.à r.l.

RREEF Pan-European Infrastructure Lux S.à r.l.

RREEF RVK 1 S.à.r.l.

S.I.E. - Stratégie Informatique Européenne S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Alpha S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 4 London 10 St. Bride Street S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 4 London Eastcheap Court S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No.4 SICAV-FIS

SOP I SICAV

UniSector

UniSector

UniSector

UniSector

UniSector

WALSER Absolute Return

Xirom Investments SICAV