This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2126
31 août 2013
SOMMAIRE
1665234 Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
102020
3GI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102003
Amabili Software S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
102017
Amstell Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102011
Aquaetanche Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
102007
AXA Redilion ManagementCo S.C.A. . . . .
102019
Banca March S.A., Sucursal en Luxembur-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102020
Bâtiself . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102045
BCSP V CE Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
102008
Bellefontaine Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .
102043
bluO Holding F2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102006
Braga Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102044
Bremonhill Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .
102045
BS Real Estate (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
102008
Capacity Allocation Service Company.eu
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102008
Cave Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102007
Cave S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102007
Cazelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102007
CEREP Uranus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102009
Ceva Freight Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
102008
China-Lux Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102009
Compagnie Financière pour la Gestion
Collective S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102006
Drayton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102009
Dretschler FR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102010
DRS Logistic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102010
EQUI Specialized Asset Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102003
Euro Associates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102006
Gohar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102048
Immobilière du Hameau . . . . . . . . . . . . . . . .
102025
Industrial and Commercial Bank of China
(Europe) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102022
INGENIUM tooling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102027
Inlas Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102046
Inntratec International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
102047
Jaguar Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102026
Jean Claude DECAUX Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102046
Jetlux Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102047
JN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102021
Johnson Controls Luxembourg Invest-
ments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102025
Johnson Controls Luxembourg Metals
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102026
Luxco sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102017
Luxembourg Development S.A. . . . . . . . . .
102005
Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102002
Serco International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
102002
Silverent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102003
SK Property Fund SICAV-SIF . . . . . . . . . . .
102032
STENTOR et Cie SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102004
STENTOR et Cie SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102002
Suez Energy International Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102027
Syberiusconsult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102003
Sydney Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102004
Victoria Foncier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102030
Vilmob S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102019
Weber Steve s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102012
Weinberg Real Estate Holding S.à r.l. . . . .
102011
World Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102012
WP Roaming III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
102002
WW Brand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102012
WX Budget Hotel Holding S.A. . . . . . . . . .
102021
YSA Coiffure S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102004
Zimmer & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102005
Ziwat-IPC.eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102021
102001
L
U X E M B O U R G
Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 151.544.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 juin 2013i>
1. La démission de M. Fabio Gasperoni est acceptée avec effet immédiat.
2. M. Thierry Jacob, né le 7 juillet 1967 à Thionville, France, résidant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086
Luxembourg, est nommé gérant de Catégorie B de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
Référence de publication: 2013096370/12.
(130116168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Serco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 44.885,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.718.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2013.
Référence de publication: 2013096372/11.
(130116301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
STENTOR et Cie SPF S.A., Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 41.163.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013096425/11.
(130116576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
WP Roaming III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 38.759.250,00.
Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 109.535.
EXTRAIT
En date du 28 juin 2013, le transfert de parts sociales suivant a été effectué:
WP Roaming S.à r.l. a transféré l'intégralité des 775.185 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Syniverse
Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 177.983.
Suite à ce transfert, Syniverse Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. est devenu l'associé unique de la Société et détient
désormais l'intégralité des 775.185 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2013.
<i>Pour la Société
i>Maître Alexandre Pol
Référence de publication: 2013096565/20.
(130116851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
102002
L
U X E M B O U R G
EQUI Specialized Asset Management S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 149.923.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Equi Specialized Asset Ma-
nagement S.A. (la «Société»), daté du 28 juin 2013, ce qui suit:
- Allgemeine Management Gesellschaft G.m.b.H., AMG G.m.b.H a été renommée aux fonctions de commissaire aux
comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année sociale se terminant au 31
décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2013.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013096545/16.
(130116701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Syberiusconsult S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 92.925.
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS
B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146
Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et
ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882
Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B
99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
Luxembourg, le 15 avril 2013.
<i>Pour SYBERIUSCONSULT S.A.i>
Référence de publication: 2013096433/23.
(130117001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Silverent S.A., Société Anonyme,
(anc. 3GI S.A.).
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 162.228.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale etraordinaire du 8 juillet 2013i>
L'Assemblée a nommé un nouvel Administrateur en remplacement de Madame Ann VAN WAUWE.
L'Assemblée a nommé:
Monsieur Sylvain KIRSCH, ayant son adresse professionnelle au 31, Grand-Rue L-1661 Luxembourg, aux fonctions
d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes arrêtés aux 31 décembre 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AGIF S.A.
Signature
Référence de publication: 2013096404/15.
(130117065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
102003
L
U X E M B O U R G
Sydney Ventures S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 108.262.
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS
B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146
Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et
ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882
Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B
99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
Luxembourg, le 15 avril 2013.
<i>Pour SYDNEY VENTURES S.A.i>
Référence de publication: 2013096436/23.
(130116998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
STENTOR et Cie SPF S.A., Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 41.163.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013096424/11.
(130116575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
YSA Coiffure S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4633 Differdange, 17, rue de la Grève Nationale.
R.C.S. Luxembourg B 158.242.
EXTRAIT
La société informe le public que Madame THILLOT Isabelle, né le 22.06.1962 à Metz (FR), occupant les mandats
d'administrateur / Gérant ainsi que associée unique de la société YSA COIFFURE Sarl, a changé son domicile qui est
actuellement à
F-54190 TIERCELET- 18, rue Victor Hugo
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 24 juin 2013.
Pour extrait
YSA Coiffure SARL
17RUE DE LA GREVE NATIONAL
4633 DIFFERDANGE
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2013098513/20.
(130118631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
102004
L
U X E M B O U R G
Zimmer & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 151.507.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'actionnaire unique de la société prises en date du 10 juillet 2013i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'Actionnaire Unique de la Société prises en date du 10 juillet 2013 que:
<i>«Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de révoquer les mandats de:
- Monsieur Stéphane ALLART en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat, et
- Monsieur Jean KAYSER en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Claude ZIMMER, né le 18 juillet 1956, à Luxembourg, demeurant
professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, administrateur, au poste d'administrateur unique de la So-
ciété avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2019.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013098514/22.
(130118638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
Luxembourg Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 83.348.
AUSZUG
Auf der Gesellschafter Versammlung am 18.Mai 2013 wurde folgende Punkte festgelegt:
1. Fünfter Beschluss. Frau Katalin UGHY tritt als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung vom Amt
zurück.
Als neues Verwaltungsratmitglied wird Herr Thomas Phieler, Jurist, geboren 20.09.1942 in Hamburg, wohnhaft 12,
Rue Jean Engling L-1466 Luxembourg einstimmig berufen. Das Mandat wurde zunächst bis zur Gesellschafterversammlung
2016 erteilt.
2. Sechster Beschluss. Die ordentliche Generalversammlung hat die Kündigung der Rechnungskommissarin Frau Sonja
HERMES zur Kenntnis genommen.
Als neue Rechnungskommissarin wird Frau Ursula Schmitt-LAUER, Berufsadresse 12, Rue Jean Engling L-1466 Lu-
xembourg gewählt. Das Mandat wird bis zur Gesellschafterversammlung 2016 begrenzt. Die Ernennung erfolgte einstim-
mig
3. Siebter Beschluss. Das Amt des Verwaltungsratmitglied Viktor Herceg wird bis zur Generalversammlung 2016
verlängert
4. Achter Beschluss. Das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrates Frank-Michael PHIELER wird bis zum Jahr 2016
verlängert. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig
5. Achter Beschluss. Das Amt des Verwaltungsratmitglied Frank-Michael Phieler wird weitergeführt. Dieser Beschluss
erfolgte einstimmig.
6. Neunter Beschluss. Das Amt des Verwaltungsratmitglied Frank-Michael Phieler als geschäftsführender Verwaltungs-
rat mit Einzelzeichnungs Vollmacht wird bis zur Generalversammlung 2016 weitergeführt.
Wir bitten um entsprechende Änderung im Register und Zusendung eines neuen Auszugs.
102005
L
U X E M B O U R G
Mit freundlichem Gruß
Luxembourg Development S.A.
Frank-Michael Phieler
<i>Vorsitzender Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2013098534/32.
(130119270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
bluO Holding F2, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 169.494.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 12. Juni 2013 in Luxemburg stattfand:i>
Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die
über den Jahresabschluss der bluO Holding F2 für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder
zum Verwaltungsrat zu ernennen:
- Dr. Stefan Beulertz, Verwaltungsratsmitglied;
- Andreas Cebul, Verwaltungsratsmitglied;
- Mario Warny, Verwaltungsratsmitglied.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 5. Juli 2013.
<i>Ein Beauftragteri>
Référence de publication: 2013098540/17.
(130119710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.
COFIGECO, Compagnie Financière pour la Gestion Collective S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 114.997.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale annuelle de la Compagnie Financière pour la Gestion Collective S.A. en abrégéi>
<i>COFIGECO du 22 mai 2013.i>
L'Assemblée Générale a nommé pour une durée d'un an aux postes d'administrateurs:
La société COFIBOL SA
16 Rue d'Epernay
L-1490 Luxembourg
Représenté par: Mr René Charles Gicquel
Chemin de Crévaz-Tzévaux, 10
CH-1264 Saint-Cergue (Suisse)
Messieurs: Michel Parizel
Jean-Jacques Pire
L'Assemblée Générale a nommé pour une durée d'un an au poste de réviseur:
Deloitte Audit S.à r.l.
<i>L'Assemblée Généralei>
Référence de publication: 2013099702/21.
(130121361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Euro Associates, Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 23.090.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue extraordinairement le 05 juillet 2013i>
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement de la Société que:
5. L'Actionnaire majoritaire décide de nommer au poste d'administrateur:
La société V.E.S CONSULTANCY (U.K) LTD, ayant son siège social au 25, Bruton Lane, London, W1J, 6JQ, numéro
RSC 5953154.
102006
L
U X E M B O U R G
Le mandat de l'administrateur arrivera à échéance à l'assemblée générale à tenir en 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013098532/16.
(130119132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
Cave Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 99.241.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2013099697/11.
(130121254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Cave S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-4873 Lamadelaine, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 95.991.
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2013 que Monsieur Vezio Di Passio, administrateur démis-
sionnaire, est remplacé par Monsieur Ian Ledger, demeurant à 16, boulevard de Belgique, 98000 Monaco.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Fiduciaire comptable B+C s.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2013099696/14.
(130121184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Aquaetanche Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 4, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 77.321.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013096643/9.
(130117608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Cazelia, Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, 5, allée John W. Leonard.
R.C.S. Luxembourg B 147.139.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire le 13 juin 2013.i>
S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme «CAZELIA» ayant son siège à
Beringen, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 147 139.
<i>Première Résolution:i>
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de transférer le siège de l'activité au 5 Allée John W. Leonard à
7526 Mersch en date du 12/6/2013.
<i>Deuxième Résolution:i>
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, accepte la démission de Monsieur Pierre Kaminsky comme commissaire
aux comptes à dater du 10/6/2013.
102007
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième Résolution:i>
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de nommer Monsieur Jean-Paul Legoux, demeurant au 11 rue
Letellier à 1932 Luxembourg, à dater de ce jour à la fonction de commissaire aux comptes, jusqu'à la date du 12/6/2019.
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Référence de publication: 2013097604/20.
(130119208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
Ceva Freight Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center East.
R.C.S. Luxembourg B 159.954.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 juillet 2013i>
En date du 11 juillet 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de révoquer Monsieur Ernst DE KUIPER de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Laurens Remco VAN DER. PIJL, né le 13 septembre 1965 à Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas,
résidant professionnellement à l'adresse suivante: Siriusdreef 20, 2132 WT Hooffdorp, Pays-Bas, en tant que nouveau
gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit;
- Monsieur Michael VÖLLNAGEL
- Monsieur Laurens Remco VAN DER PIJL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Ceva Freight Luxembourg S.a.r.l.
Signature
Référence de publication: 2013097612/21.
(130118906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
Capacity Allocation Service Company.eu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 142.282.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013097598/9.
(130118800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
BS Real Estate (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.870.
En date du 12 Juliet 2013, l'Assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
1. La démission de M. Marco CARPENTIERI, en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet immédiat;
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013097596/11.
(130119224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
BCSP V CE Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 127.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
102008
L
U X E M B O U R G
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2013097569/13.
(130118846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
CEREP Uranus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.269.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- de révoquer, avec effet immédiat, CEREP Management S.à r.l. de sa fonction de gérant unique de la Société; et
- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,
ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant unique de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2013.
Référence de publication: 2013097610/16.
(130119370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
China-Lux Trade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1333 Luxembourg, 3, rue Chimay.
R.C.S. Luxembourg B 173.587.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2012i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme CHINA-LUX TRADE S.A., ayant son siège social à Lu-
xembourg, 3, rue Chimay, R.C.S. Luxembourg B 173.587, a nommé en tant qu’administrateurs supplémentaires de la
Société les personnes suivantes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014:
- Madame Rui XIE, née à Gansu (Chine), le 2 juillet 1977, demeurant au 25 impasse Lempernesse, 93000 Bobigny
(France);
- Monsieur Guy Jean JACQUES, né à Paris (France), le 17 août 1958, 25 impasse Lempernesse, 93000 Bobigny (France);
- Monsieur Yi XIE, né à Tianjin (République Populaire de Chine), le 14 septembre 1973, demeurant à B508M Fujia-
mingzuo, 228, Zhenan Road, Changan, Dong Guan, Guang Dong (Chine).
L’Assemblée Générale Extraordinaire informe que Madame Rui XIE, préqualifiée assumera également la fonction d’ad-
ministrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Référence de publication: 2013097613/20.
(130119162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2013.
Drayton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 41.520.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 21 juin 2013i>
- La démission de Monsieur Fabio GASPERONI de son mandat d'Administrateur es acceptée
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé, domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Lu-
xembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Fabio GASPERONI. Il terminera le mandat
de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2016. La cooptation de Monsieur
Jean-Hugues DOUBET sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
102009
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.
Certifié sincère et conforme
DRAYTON S.A.
A. VIGNERON / C. FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013098796/18.
(130120715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.
DRS Logistic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 176.634.
L'an deux mille treize, le vingt-cinq juin.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Santiago ALCARAZ FAJARDO, gérant, né à Houdeng-Aimeries (Belgique) le 22 juin 1959, demeurant à
L-8011 Strassen, 199, route d'Arlon,
ici représenté par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter
- qu'il est le seul associé actuel (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée «DRS LOGISTIC S.à r.l.»,
établie et ayant son siège social à L-8069 Strassen, 1, rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 176.634, (la «Société»);
- que la Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,
(Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Carlo WERSANDT, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1389 du 12 juin 2013,
- qu'il a décidé de transférer le siège social de L-8069 Strassen, 1, rue de l'Industrie à L-2314 Luxembourg, 2A, place
de Paris, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire du comparant, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et
domicile, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 juin 2013. LAC/2013/29586. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013098799/38.
(130119789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.
Dretschler FR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 127.530.
DISSOLUTION
Pour la S. À R. L. DRETSCHLER FR en Liquidation ayant son siège à CONTERN, constituée, suivant acte reçu par Me
Leon Thomas dit Tom METZLER, Notaire de résidence à Luxembourg, en date du 03 mai 2007
Il a été décidé:
102010
L
U X E M B O U R G
- De la dissolution de la société avec effet de ce jour
- De l'archivage des livres et pièces durant les 5 prochaines années auprès de la société KÜHNE & NAGEL 1, rue
Edmund Reuter -L- 5326 CONTERN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013098797/16.
(130120143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.
Amstell Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 134.921.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 28 juin 2013 que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur
les comptes de l'exercice 2013, le Conseil d'Administration se compose de:
- Fabrice HUBERTY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bra-
gance, Président du Conseil.
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Londres, Standbrook House, 1
st
floor, 2-5
Old Bond Street, W1S 4 PD, Angleterre.
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1804 Vilvoorde, Jean Monnetlaan, Belgique.
- Marcel EGGENKAMP, administrateur de sociétés, 224 Wibautstraat, 1097 DN Amsterdam, Pays-Bas.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l'exercice 2013:
- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2013096632/22.
(130118228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Weinberg Real Estate Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.174.011,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.997.
Suite à la cession de parts sociales en date du 10 Avril 2013, l'associé M. Wandrille Ract Madoux a cédé ses parts
sociales de classe C comme suit:
- Cession de 7.373 parts sociales de classe C au profit de CAP W, société par actions simplifiée dont le siège social
se situe au 8, rue de Massenet, 75116 Paris, France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de paris
sous le numéro 790.115.471.
A compter du 10 Avril 2013 le capital social de la Société est réparti comme suit:
- Weinberg Real Estate Partners #1 SCA détient 1.805.400 parts sociales de classe A;
- L.H. Holding S.à r.l. détient 97.949 parts sociales de classe C;
- Weinberg Real Estate S.à r.l. détient 3.695 parts sociales de classe C;
- M. Sébastien Moxhet détient 7.373 parts sociales de classe C
- M. Charles-Henri Filippi détient 67.870 parts sociales de classe C;
- M. Yann Ballan détient 15.020 parts sociales de classe C;
- Mme. Sophie Château détient 7.373 parts sociales de classe C;
- M. Serge Weinberg détient 84.935 parts sociales de classe C;
- M. Aymeric Plassard détient 11.268 parts sociales de classe C;
- M. Philippe Klocanas détient 47.136 parts sociales de classe C;
- M. Benjamin Teszner détient 182 parts sociales de classe C;
- M. Nicolas Teboul détient 11.064 parts sociales de classe C;
- CAP W détient 7.373 parts sociales de classe C;
- M. Jérôme Louvet détient 7.373 parts sociales de classe C.
102011
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weinberg Real Estate S.à r.l.
Représentée par Gérald Welvaert
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2013101030/32.
(130122661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
World Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.238.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013101041/10.
(130122618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
Weber Steve s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9189 Vichten, 24, rue du Lavoir.
R.C.S. Luxembourg B 108.991.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Steve WEBER
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2013101038/11.
(130122692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
WW Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 178.702.
STATUTS
L'an deux mille treize, le dix mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussi-
gnée.
A COMPARU:
La société SIRIUS FINANCE LIMITED, société de droit anglais ayant son siège social au 788-790, Finchley Road, Londres
NW11 7TJ, Royaume-Uni, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 4251093,
ici représentée par Madame Christelle Langlois, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé lui délivrée en date du 8 mai 2013.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée, dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises
actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée (ci-après
la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée ainsi que par les
présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 5.2., 6.2., 7.4. et 9.7., les règles
exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société prend la dénomination de «WW BRAND S.à r.l.» (la «Société»).
Art. 3.
3.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
102012
L
U X E M B O U R G
3.2. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
3.3. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les
Statuts.
3.4. La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.
3.5. Au cas où le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance estimerait que des événements
extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 4.
4.1. L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, des intérêts et participa-
tions, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce
soit ainsi que la gestion de ces intérêts et participations. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription,
achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce
compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/ga-
ranties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également
participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir
dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par
voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créan-
ces négociables. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts,
d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à
toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au
même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées") ou toute autre entité, étant entendu
que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée
comme une activité réglementée du secteur financier. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses Sociétés Apparentées. Elle peut également consentir des garanties ou
des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses Sociétés Apparentées.
4.3. La Société peut en outre gager, hypothéquer, nantir, céder ou grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs (présents ou futurs). La Société peut
en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur
gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de
fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.
4.4. La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe
ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
4.5. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 5.
5.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de la déconfiture de l'associé unique ou d'un des associés.
Titre II. - Capital - Parts sociales
Art. 6.
6.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un euro (EUR 1,-) chacune.
6.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou par une décision
de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 9.6. des présents Statuts.
Art. 7.
7.1. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels
à sa participation au capital social.
7.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.3. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
102013
L
U X E M B O U R G
7.4. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit aux articles 189 et 190 de la Loi. Ainsi, aucune cession de
parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés. Pour cela
l'associé cédant devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de cession de parts sociales
aux associés ainsi qu'à la Société. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, devra alors convoquer,
dans un délai de huit jours suivant cette notification, l'assemblée générale des associés afin que cette dernière puisse
délibérer sur le projet de cession. L'autorisation d'agrément devra être prise en assemblée générale des associés repré-
sentant au moins les soixante quinze pour cent (75%) du capital social. La décision de l'assemblée générale des associés
devra être notifiée à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l'hypothèse où aucune réponse n'a été donné par l'assemblée générale des associés dans un délai de trois mois
à compter de la notification de cession faite par l'associé cédant, l'agrément sera réputé acquis et la cession sera réalisée
librement. Dans l'hypothèse d'un refus d'agrément, les autres associés ou la Société seront tenus, dans un délai de trois
mois suivant le refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales au prix fixé dans le projet de cession. Néanmoins,
en cas de refus d'agrément par l'assemblée générale des associés, l'associé cédant pourra renoncer à la cession de ses
parts.
7.5. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
7.6. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par
une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit
de la Société.
7.7. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des
scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. Ils doivent pour l'exercice
de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. - Gérance
Art. 8.
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
8.2. Les gérants ne doivent pas forcément être associés. Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale
des associés délibérant à la majorité simple des voix ou, le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine
l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou, le cas
échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
8.3. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les
circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.
8.4. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, à l'associé
unique par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
8.5. En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de son
gérant unique.
8.6. En cas de pluralité de gérants, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de
deux gérants, avec obligatoirement la signature d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
8.7. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de
ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
8.8. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération
(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
8.9. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également
choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction des procès-verbaux de
réunions du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
8.10. Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.
8.11. Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins vingt-
quatre heures (24 heures) avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le
procès-verbal de réunion.
8.12. Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
8.13. Convocation peut être adressée à chaque gérant, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié.
8.14. Le conseil de gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.
8.15. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins
une majorité de gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées
102014
L
U X E M B O U R G
à la majorité des gérants présents ou représentés avec obligatoirement une majorité simple dans chaque catégorie de
gérants.
8.16. Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance par un autre gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration transmise par écrit, par télécopie ou par tout autre
moyen électronique de communication approprié.
8.17. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.
8.18. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par téléphone
ou vidéoconférence, ou par tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes par-
ticipant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une
participation en personne à une réunion du conseil de gérance.
8.19. En cas d'urgence, des résolutions écrites des gérants peuvent être prises et, à condition qu'elles soient signées
par tous les gérants, elles seront valides comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance
dûment convoquée et tenue. De telles décisions peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs
documents ayant le même contenu signé par tous les membres du conseil de gérance.
8.20. Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.
8.21. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.
Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 9.
9.1. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés
représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
9.2. Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.
9.3. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
9.4. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas
être associé.
9.5. Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.
9.6. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
9.7. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la
Loi.
9.8. En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
9.9. Quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq, les résolutions par écrit signées à l'unanimité par
tous les associés sur un ou plusieurs originaux produiront les mêmes effets qu'une résolution des associés prise lors d'une
assemblée générale d'associés. Le texte des résolutions circulaires à prendre devra être envoyé à tous les associés par
écrit, soit en faisant parvenir le document original, soit télécopie ou tout autre moyen électronique de communication
approprié.
Art. 10. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au
plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans
la convocation de cette assemblée.
Titre V. - Année sociale - Comptes annuels - Répartition du bénéfice - Dividende intérimaire
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 12.
12.1. A la clôture de chaque exercice social, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance établira
les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.
12.2. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de
profits et pertes.
Art. 13.
13.1. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
13.2. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
102015
L
U X E M B O U R G
13.3. Ces affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
13.4. L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer
au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.
Art. 14. Nonobstant les dispositions de l'article treize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou
ratification de l'assemblée générale des associés, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut
décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra
ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.
Titre VI. - Surveillance de la société
Art. 15.
15.1. Si le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s), qui peut (peuvent) ne pas être associé(s).
15.2. Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant
sa nomination.
15.3. A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction
(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.
15.4. Lorsque les seuils fixés par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises seront atteints, la Société confiera le contrôle
de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés
ou, le cas échéant, par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
15.5. Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par
résolution de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant
l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.
16.2. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 17.
17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi.
17.2. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 18. Toute question qui n'est pas régie par les présents Statuts est régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle qu'amendée.
<i>Souscriptioni>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par la société SIRIUS FINANCE LIMITED, pré-
désignée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Les Statuts de la Société ayant été arrêtés, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
102016
L
U X E M B O U R G
1.- Le nombre de gérants est fixé à un (1). Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Francesco ZITO, né à Noci (Italie), le 10 décembre 1950, demeurant professionnellement à L-1621 Luxem-
bourg, 24 rue des Genêts, lequel pourra engager la Société sous sa seule signature, y compris toutes opérations bancaires.
2.- Le siège social de la Société est fixé à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: C. Langlois et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mai 2013. LAC/2013/23014. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2013.
Référence de publication: 2013101042/265.
(130121794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
Luxco sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Amabili Software S.à r.l.).
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 130.800.
L'an deux mil treize.
Le vingt-trois mai.
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Guido Emanuele AMABILI, informaticien, né à Luxembourg le 7 novembre 1974 (No. Matricule
19741107115), demeurant à L-2356 Luxembourg, 42, rue Pulvermühle;
ici représenté par:
Monsieur Gieampietro AMABILI, prénommé ci-après;
agissant en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé en date du 23 mai 2013 laquelle procuration a été paraphée
"ne varietur" par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux
formalités de l'enregistrement
2) Monsieur Giampietro AMABILI, salarié, né à Dortmund (Allemagne) le 11 avril 1969 (No. Matricule 19690411116),
demeurant à L-5339 Moutfort, 1, rue de Contern.
3) Monsieur David NUNES LOPES, salarié, né à Metz (France) le 7 mars 1981 demeurant à F-57290 Edange, 66 Avenue
Jeanne d'Arc.
Lesquels comparants déclarent que le nommé sub 1) est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée
«AMABILI SOFTWARE Sàrl» (Matricule No. 20072439822), avec siège social à L-2356 Luxembourg. 42 rue de Pulver-
mühle;
inscrite au Registre aux firmes sous le numéro B 130.800;
constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21
août 2007, publié au Mémorial C de 2007, page 100.437.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Monsieur Guido Emanuele AMABILI, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Giampietro
AMABILI, prédit, CINQUANTE (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée «AMABILI
SOFTWARE sàrl».
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de SIX MILLE TROIS CENTS EURO (Euro 6.300.-), montant que
Monsieur Guido Emanuele AMABILI reconnaît par la présente avoir reçu de Monsieur Giampietro AMABILI, ce dont
quittance et titre pour solde.
102017
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolution:i>
Monsieur Guido Emanuele AMABILI, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur David NUNES
LOPES, prédit, CINQUANTE (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée «AMABILI SOFT-
WARE sàrl».
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de SIX MILLE TROIS CENTS EURO (Euro 6.300.-), montant que
Monsieur Guido Emanuele AMABILI reconnaît par la présente avoir reçu de Monsieur David NUNES LOPES, ce dont
quittance et titre pour solde.
<i>Troisième résolution:i>
Suite aux prédites cessions de parts l'article 6. des statuts est à lire comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EURO (Euro 12.400.-) représenté par CENT
(100) parts sociales de CENT VINGT-QUATRE EURO (Euro 124.-) chacune.
Les CENT (100) parts ont été souscrites comme suit:
Monsieur Giampietro AMABILI, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Monsieur David NUNES LOPES, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total CENT Parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE
QUATRE CENTS EURO (Euro 12.400.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.».
<i>Troisième résolution:i>
Les associés décident de changer la dénomination de la société en «LUXCO sàrl».
<i>Quatrième résolution:i>
Suite au prédit changement de nom, l'article 1
er
des statuts est à lire comme suit:
« Art. 1
er
. La société prend la dénomination de LUXCO sàrl».
<i>Cinquième résolution:i>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-2356 Luxembourg, 42 rue Pulvermühle à L-1818
Howald, 4 rue des Joncs.
<i>Sixième résolution:i>
Suite au prédit transfert de siège social, le premier alinéa de l'article 2. des statuts est à lire comme suit:
« Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Howald».
<i>Septième résolution:i>
Les associés décident de changer l'objet social de la société pour donner au premier alinéa de l'article 3 des statuts la
teneur suivante:
« Art. 3. Premier alinéa. La société a comme objet l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de génie
civile, une exploitation d'entreprise de peinture, de plafonnage et de façade».
<i>Huitième et Dernière résolution:i>
Les associés acceptent la démission du gérant Monsieur Guido Emanuele AMABILI, à compter d'aujourd'hui et lui
donnent décharge.
Est nommé gérant technique de la société Monsieur Manuel FERNANDES, salarié, né à Casteloes/Vale De Cambra
(Portugal) le 24 octobre 1959 (No. Matricule 19591024798), demeurant à L-8367 Hagen, 4 rue Neuve.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique avec celle d'une des deux autres
associés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
<i>Frais:i>
Le montant des frais généralement quelconques qui incombent à la société en raison de la présente assemblée générale,
s'élève à approximativement à MILLE EURO (Euro 1.000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel.
Signé: G. Amabili, Nunes Lopes, C.Doerner.
102018
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 4 juin 2013. Relation: EAC/2013/7064. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés.
Bettembourg, le 27 juin 2013.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2013101063/92.
(130122200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
AXA Redilion ManagementCo S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 1.754.990,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 168.843.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 12 juin 2013:i>
- M. Mirko Dietz, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, né le 20 octobre 1974 à Göppingen, Allemagne, a été renouvelé dans son mandat de membre du conseil
de surveillance avec effet immédiat et cela jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels
au 31 décembre 2013;
- M. Stephan Illenberger, résidant professionnellement au 4, An der Welle, D-60322 Frankfurt, Allemagne, né le 11
avril 1959 à Bremen, Allemagne, a été renouvelé dans son mandat de membre du conseil de surveillance avec effet
immédiat et cela jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013;
- M. Thierry Denoyel, résidant professionnellement au 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, France, né le 5 juillet 1981
à Sainte-Foy-Lês-Lyons, France, a été renouvelé dans son mandat de membre du conseil de surveillance avec effet immédiat
et cela jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.
- La société PricewaterhouseCoopers, société coopérative, régie par les lois du Luxembourg, avec siège social à 400,
Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, enregistrée avec le Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65477,
a été renouvelée dans son mandat de réviseur d'entreprises agréé avec effet immédiat et cela jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.
Le conseil de surveillance se compose dorénavant comme suit:
- M. Mirko Dietz, membre du conseil de surveillance
- M. Thierry Denoyel, membre du conseil de surveillance
- M. Stephan Illenberger, membre du conseil de surveillance
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013101064/31.
(130122377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
Vilmob S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 53.544.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 juillet 2013i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2013:
- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH - 6000 Lucerne, Suisse;
- Monsieur Luca GALLINELLI, demeurant professionnellement au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg;
- Monsieur Frédéric GARDEUR, demeurant professionnellement au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg;
- Madame Rita GOUJON, demeurant professionnellement au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg,
en remplacement de Messieurs Pierre LENTZ et Luc HANSEN, administrateurs démissionnaires en date du 17 juillet
2013.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2013:
102019
L
U X E M B O U R G
- FIN-CONTROLE S.A., Société anonyme, 12, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, en remplacement de AU-
DIEX S.A., commissaire aux comptes démissionnaire en date du 17 juillet 2013.
Le siège social est transféré au 25, avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Référence de publication: 2013101022/23.
(130121883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
Banca March S.A., Sucursal en Luxemburgo, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 168.593.
EFFECTIVE DATE: 26/06/2013
PLEASE UPDATE YOUR RECORDS TO REPLACE OUR PREVIOUS ADDRESS:
26, Bd Royal.
L-2449 LUXEMBOURG
WITH THE FOLLOWING NEW ADDRESS:
21-25, ALLEE SCHEFFER.
L-2520 LUXEMBOURG
Luxembourg, 26/06/2013.
Héctor Estéban
<i>Directori>
DATE EFFECTIVE: 26/06/2013
Veuillez metre à jour vos coordonnées et remplacer notre adresse précédente:
26, Bd Royal.
L-2449 LUXEMBOURG
AVEC NOTRE NOUVELLE ADRESSE:
21-25, ALLEE SCHEFFER.
L-2520 LUXEMBOURG
Luxembourg, le 26/06/2013.
Héctor Esteban
<i>Directori>
Référence de publication: 2013101066/27.
(130122867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
1665234 Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 3.625.900,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 177.269.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 10 mai 2013 entre la société CENOVUS ENERGY INC.et
CENOVUS INTERNATIONAL INVESTMENTS S.à r.l. une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16,
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B176368, que CENOVUS ENERGY INC. a cédé 300 parts sociales de la Société, à CENOVUS INTERNA-
TIONAL INVESTMENTS S.à r.l. avec effet au 10 mai 2013.
Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013101054/17.
(130121730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
102020
L
U X E M B O U R G
Ziwat-IPC.eu, Société Anonyme.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 34, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.050.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013101051/10.
(130122658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
WX Budget Hotel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 134.148.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue au siège social de la Société le 15i>
<i>juillet 2013,i>
Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la Société le 15 juillet 2013, il a été décidé de;
1. réélire en tant qu'administrateur de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013:
- Monsieur Vincent GOY, Administrateur B, résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg;
- Monsieur Raphaël PONCELET, Administrateur B, résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg;
- Monsieur Florian PETROWSKY, Administrateur A, résidant professionnellement au 1, Floridsdorfer Hauptstrasse,
A-1210 Vienne, et
- Monsieur Daniel FOLIAN, Administrateur A, résidant professionnellement au 1, Floridsdorfer Hauptstrasse, A-1210
Vienne.
2. réélire INTERAUDIT S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 119, Avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 29.501, en tant que commissaire aux comptes de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013101043/28.
(130122035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
JN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 95.074.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
En date du 25 juillet 2013, l'actionnaire unique a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Johan DEJANS, en tant que administrateur de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Elizabeth TIMMER, née le 24 juillet 1965 à Zuidelijke IJsselmeerpolder, Pays-Bas, demeurant
professionnellement au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que administrateur de la Société, et ce
avec effet immédiat
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2016.
Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Administrateurs:i>
* Richard BREKELMANS
* Elizabeth TIMMER
* Michael VERHULST
102021
L
U X E M B O U R G
- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes sortant, ALTER AUDIT S.à r.l., avec adresse professionnelle
à 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013107011/26.
(130129899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
ICBC (Europe) S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.320.
In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Industrial and Commercial Bank of China (Europe)
S.A.", in abbreviated form "ICBC (Europe) S.A.", a société anonyme having its registered office in L-2449 Luxembourg,
32, Boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg B 119320,
incorporated by a deed of the undersigned notary, residing then in Remich in replacement of her colleague Notary
André SCHWACHTGEN, notary then in Luxembourg, dated 5 September, 2006, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 2193 of November 23
rd
, 2006
and the Articles of Association have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on
the 3
rd
of December 2010, published. in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 283 of February
11, 2011.
The meeting is presided by Mr Gang LIU, General Manager, with professional address in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Yue ZHANG, Head of General Adm. Department, with professional address in Lu-
xembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Ying ZHAO, Head of Internal Audit, with professional address in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed "ne varietur" by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies will be registered with this deed.
II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of the meeting, of which the shareholders have been
informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Deletion of the indication of the nominal value of the existing ten million four thousand (10.004.000) shares.
2.- Increase the share capital of the Company by an amount of EUR 100,000,000 (one hundred million Euro), in order
to bring the share capital from its current amount of EUR 115,046,000 (one hundred and fifteen million forty-six thousand
Euro) up to EUR 215,046,000 (two hundred and fifteen million forty-six thousand Euro), by the issuance of 8,695,652
(eight million six hundred and ninety-five thousand six hundred and fifty-two) new shares without indication of a nominal
value;
3.- Subscription and full payment by means of contribution in cash by one of the current shareholders for 8,695,652
(eight million six hundred and ninety-five thousand six hundred and fifty-two) new shares without indication of a nominal
value, to be issued by the Company pursuant to this capital increase and corresponding to a value of EUR 100,000,000
(one hundred million Euro) without issue premium;
4.- Waiver by the remaining shareholder of his preferential subscription right;
5.- Replacement of the 18,699,652 (eighteen million six hundred and ninety-nine thousand six hundred and fifty-two)
shares existing after the increase of capital referred under point 3 of the agenda, by seventeen million nine hundred and
twenty thousand five hundred (17,920,500) shares with a nominal value of twelve Euro (EUR 12,00) each, the majority
shareholder holding 17,920,499 shares and the minority shareholder holding 1 share;
6.- Subsequent modification of the provisions of Article 4 of the articles of association of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
102022
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to suppress the indication of the nominal value of the existing ten million four thousand
(10.004.000) shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 100,000,000 (one hundred
million),
in order to bring the share capital from its current amount of EUR 115,046,000 (one hundred and fifteen million forty-
six thousand Euro) up to EUR 215,046,000 (two hundred and fifteen million forty-six thousand Euro),
by the issuance of 8,695,652 (eight million six hundred and ninety-five thousand six hundred and fifty-two) new shares
without indication of a nominal value.
<i>Third resolutioni>
Thereupon appeared the current majority shareholder of the Company, namely INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
BANK OF CHINA LIMITED, a joint stock bank with registered office at 55 Fuxingmennei Dajie, Beijing, 100032, People's
Republic of China,
here represented by Mr. SONG Hanyi, prenamed, by virtue of a proxy established on the 24
th
of June, 2013, attached
to the present deed.
The shareholder, represented as stated hereabove, has declared to subscribe for all the newly 8,695,652 (eight million
six hundred and ninety-five thousand six hundred and fifty-two) shares without indication of a nominal value.
All the newly issued shares have been fully paid-up in cash, so that the amount of EUR 100,000,000 (one hundred
million Euro) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary
by a bank certificate.
<i>Fourth resolutioni>
The remaining shareholder, Mrs GAO Ming, duly represented by Mr LIU Gang, prenamed, expressly waives any pre-
ferential subscription rights concerning the newly issued shares and agrees with the subscription described here above.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to replace the 18,699,652 (eighteen million six hundred and ninety-nine thousand six hundred
and fifty-two) shares existing after the aforesaid increase of capital,
by seventeen million nine hundred and twenty thousand five hundred (17,920,500) shares with a nominal value of
twelve Euro (EUR 12,00) each, the majority shareholder holding 17,920,499 shares and the minority shareholder holding
1 share.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend consequently article 4 as follows:
" Art. 4. Share capital. The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 215,046,000 (two hundred and fifteen
million forty-six thousand Euro), represented by seventeen million nine hundred and twenty thousand five hundred
(17,920,500) shares with a nominal value of twelve Euro (EUR 12,00) each."
Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary, who understands and speaks English, recognizes by the present, that at the request of the
parties hereto, these minutes are drafted in English and followed by a French translation; at the request of the parties
and in case of divergences between the French and the English version, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day noted at the beginning of this document.
This document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the members of the bureau signed with Us, the notary, the present deed, no other
shareholder expressing the request to sign.
Suit la traduction en langue française.
L'an deux mille treize, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois "IN-
DUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (Europe) S.A.", en abrégé «ICBC (Europe) S.A.», ayant son siège
social à L-2449 Luxembourg, 32, Boulevard Royal, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n° 119320
constituée par acte du notaire instrumentant, alors à Remich, ayant instrumenté en remplacement de Maître André
SCHWACHTGEN, alors notaire à Luxembourg, daté du 5 septembre, 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2193 du 23 novembre 2006.
102023
L
U X E M B O U R G
Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 3 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 283 du 11 février 2011.
L'assemblée est présidé par M. Gang LIU, General Manger, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
Laquelle désigne comme secrétaire Mme Yue ZHANG, Head of General Adm. Department, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg,
L'assemblée élit comme scrutateur Mme Ying ZHAO, Head of Internal Audit, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg,
I) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
II) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
III) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés acceptent et confirment les déclarations du pré-
sident.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
IV) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des 10.004.000 (dix millions quatre mille) actions existantes.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 100.000.000 (cent millions d'Euros), afin de le porter de son
montant actuel de EUR 115.046.000 (cent quinze millions quarante-six mille Euro) à EUR 215.046.000 (deux cent quinze
millions quarante-six mille Euros), par l'émission de 8.695.652 (huit millions six cent quatre-vingt-quinze mille six cent
cinquante-deux) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale;
3.- Souscription des 8.695.652 (huit millions six cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-deux) actions nou-
velles et libération intégrale par un versement en espèces par un actuel actionnaire à raison de EUR 100.000.000 (cent
millions d'Euros).
4.- Renonciation par l'autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel.
5.- Remplacement des 18.699.652 (dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante-deux) actions
existantes après l'augmentation de capital dont question au point 3 de l'ordre du jour, par 17.920.500 (dix-sept millions
neuf cent vingt mille cinq cents) actions ayant une valeur nominale de EUR 12,00 (douze Euros) chacune, l'actionnaire
majoritaire détiendra 17.920.499 actions et l'actionnaire minoritaire 1 action;
6.- Modification subséquente de l'article 4 des statuts.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 10.004.000 (dix millions quatre
mille) actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 100.000.000 (cent millions d'Euros),
afin de le porter de son montant actuel de EUR 115.046.000 (cent quinze millions quarante-six mille Euros) à EUR
215.046.000 (deux cent quinze millions quarante-six mille Euros),
par l'émission de 8.695.652 (huit millions six cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-deux) nouvelles actions
sans désignation de valeur nominale;
<i>Troisième résolutioni>
Est ensuite intervenue aux présentes:
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, une société de banque ayant son siège social au 55
Fuxingmennei Avenue, Beijing, 100140, République Populaire de Chine, ici représentée par Mr SONG Hanyi, précité, en
vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 24 juin 2013,
laquelle, souscrit aux 8,695,652 (huit millions six cent quatre-vingt-quinze mille six cent cinquante-deux) actions nou-
vellement émises et les libère moyennant versement en espèces de EUR 100.000.000 (cent millions d'Euros).
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 100.000.000 (cent millions
d'Euros) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, au moyen
d'un certificat bancaire.
102024
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'autre actionnaire de la société, Mme GAO MING, représentée par Mr LIU Gang, précité, renonce expressément à
son droit préférentiel de souscription par rapport à la susdite augmentation de capital.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de remplacer les 18.699.652 (dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cin-
quante-deux) actions existantes après l'augmentation de capital dont question ci-avant,
par 17.920.500 (dix-sept millions neuf cent vingt mille cinq cents) actions ayant une valeur nominale de EUR 12,00
(douze Euros) chacune, l'actionnaire majoritaire détiendra 17.920.499 actions et l'actionnaire minoritaire 1 action
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier l'Article 4 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 4. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 215.046.000 (deux cent quinze millions quarante-
six mille Euros), représenté par 17.920.500 (dix-sept millions neuf cent vingt mille cinq cents) actions ayant une valeur
nominale de EUR 12,00 (douze Euros) chacune.»
N'ayant plus rien à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ EUR 6.500,-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état
civil et domicile, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Liu, Yue Zhang, Ying Zhao et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juillet 2013. Relation: LAC/2013/34077. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Référence de publication: 2013106976/186.
(130130217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Immobilière du Hameau, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 82.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2013106974/10.
(130130105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Johnson Controls Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.976.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 avril 2013i>
1. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. M. David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
102025
L
U X E M B O U R G
3. Monsieur Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né le 13 août 1981, à Dublin (Irlande), demeurant profes-
sionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Vincent REGNAULT, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1982, à Anderlecht (Belgique), de-
meurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé comme
gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 juillet 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Johnson Controls Luxembourg Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013106998/20.
(130129915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Jaguar Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 293, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 12.727.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue ordinairement en date du 7 mai 2013.i>
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué, à savoir:
- Monsieur Willy VAN GORP, administrateur de sociétés, résidant à B-3060 Bertem, Bosstraat 127.
Monsieur Willy VAN GORP est nommé président du conseil d'administration.
- Monsieur Pierre Henriet, administrateur de sociétés, résidant à L-1459 Luxembourg, 4, Ancienne Côte d'Eich.
- Monsieur Jean-Louis RIGAUX, administrateur de sociétés, résidant à L-4971 Dippach-Gare, 15, rue Langert.
Monsieur Jean-Louis RIGAUX est nommé administrateur délégué.
- Monsieur Giovanni ROSSI, administrateur de sociétés, résidant à L-8211 Marner, 87, route d'Arlon.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les résultats de l'exercice se clôturant au
31.12.2013.
L'assemblée décide de nommer, à la fonction de réviseur d'entreprise et jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les
résultats de l'exercice se clôturant au 31.12.2013:
- La société HRT Révision S.A., ayant son siège social au 163, rue du Kiem à L-8030 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
<i>Pour JAGUAR LUXEMBOURG S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2013107002/25.
(130129901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Johnson Controls Luxembourg Metals Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.501.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 avril 2013i>
1. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. M. David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. Monsieur Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né le 13 août 1981, à Dublin (Irlande), demeurant profes-
sionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.
4. Monsieur Vincent REGNAULT, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1982, à Anderlecht (Belgique), de-
meurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé comme
gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
102026
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 26 juillet 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Johnson Controls Luxembourg Metals Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013107000/20.
(130129923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
INGENIUM tooling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5544 Remich, 11, Op der Kopp.
R.C.S. Luxembourg B 134.896.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013106979/9.
(130129827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Suez Energy International Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 97.959.
In the year two thousand thirteen, on the twenty-fifth day of July.
Before Me Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Suez Energy International Luxembourg S.A., having
its registered office in L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under section B number 97.959, incorporated under the name Tractebel EGI Luxembourg S.A., by a deed
of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg-Eich, on December 23
nd
, 2003, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 114 of January 28
th
, 2004. The articles of incorporation of said company
have been last amended by deed of the undersigned notary, on March 13
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1176 of May 17, 2013.
The meeting is presided by Mrs Florence PONCELET, director, residing professionally in Luxembourg, 65, avenue de
la Gare.
The chairman appoints as secretary Mr. Rachid AZOUGHAGH, director, residing professionally in Luxembourg, 65,
avenue de la Gare.
The meeting elects as scrutineer Mr. Rachid AZOUGHAGH, director, residing professionally in Luxembourg, 65,
avenue de la Gare.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty-three millions euro (€53,000,000.-), so as to
raise it from its present amount of thirty-two millions euro (€ 32,000,000.-) to eighty-five million euro (€ 85,000,000.-),
by the creation and the issue of fifty-three millions (53,000,000) new shares of no par value;
2) Waiver of any and all pre-emptive rights with respect to the issuance of the New Shares.
3) Subscription and paying-up of the fifty-three millions (53,000,000) new shares of no par value by INTERNATIONAL
POWER SA, by a payment in cash of the amount of fifty-three millions euro (€53,000,000.-);
4) Amendment of paragraph 1 of Article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed capital increase.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing the shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay
affixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the board
of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
III. It appears from the attendance list that all the five million two hundred thirty-nine thousand six hundred (5,239,600),
representing the whole share capital of thirty-two millions euro (€ 32,000,000.-) are represented at the present ex-
traordinary general meeting.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
102027
L
U X E M B O U R G
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions which were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of fifty-three millions euro
(€53,000,000.-), so as to raise it from its present amount of thirty-two millions euro (€ 32,000,000.-) to eighty-five million
euro (€ 85,000,000.-), by the creation and the issue of fifty-three millions (53,000,000) new shares new shares of no par
value.
<i>Second resolutioni>
The Meeting waived any and all pre-emptive rights in respect of the issuance the New Shares.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription and Paymenti>
The fifty-three millions (53,000,000) new shares of no par value have been subscribed by INTERNATIONAL POWER
SA, with registered office at B-1000 Bruxelles, 34, Boulevard Simon Bolivar, represented by Mrs Florence PONCELET,
prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, and entirely paid up by a payment in cash of the amount of fifty-
three millions euro (€53,000,000.-),
Evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly
so that the amount of fifty-three millions euro (€53,000,000.-), is as of now available to the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, paragraph 1 of Article 5 of the articles of incorporation is amended and
now read as follows:
« Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at eighty-five million euro (€ 85,000,000.-), divided into fifty-eight
million two hundred thirty-nine thousand six hundred (58,239,600) shares of no par value.»
<i>Costsi>
The amount of the costs, expenses, remunerations and charges in any form whatsoever incumbent on the company
or for which it is liable by reason of the present share capital increase is valuated at approximately six thousand seven
hundred euro (€ 6.700,-).
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with us the notary, the present original deed.
Follows the french version:
L'an deux mille treize, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Suez Energy International Luxembourg
S.A., société anonyme, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 97.959 constituée sous la dénomination de Tractebel EGI
Luxembourg S.A., suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 23
décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 114 du 28 janvier 2004. Les statuts
de la société ont été modifiés en dernier lieu, par acte du notaire instrumentant, en date du 13 mars 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1176 du 17 mai 2013
La séance est présidée par Madame Florence PONCELET, administrateur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
65, avenue de la Gare.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Rachid AZOUGHAGH, administrateur, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
102028
L
U X E M B O U R G
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rachid AZOUGHAGH, administrateur, avec adresse professionnelle
à Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
Le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante-trois millions d'euros (€ 53.000.000,-) afin
de le porter de son montant actuel de trente-deux millions d'euros (€ 32.000.000,-) à quatre-vingt-cinq millions d'euros
(€ 85.000.000,-), par la création et l'émission de cinquante-trois millions (53.000.000) de nouvelles actions sans valeur
nominale;
2) Renonciation au droit de souscription préférentiel relative à l'émission des Nouvelles Actions (telles que définies
ci-dessous).
3) Souscription et libération des cinquante-trois millions (53.000.000) nouvelles actions sans valeur nominale par IN-
TERNATIONAL POWER S.A., par paiement en numéraire d'un montant de cinquante-trois millions d'euros (€
53.000.000,-).
4) Modification du paragraphe 1 de l'Article 5 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital proposée;
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que les cinq millions deux cent trente-neuf mille six cents (5.239.600) actions,
représentant l'entièreté du capital de trente-deux millions d'euros (€ 32.000.000,-) sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante-trois millions d'euros
(€ 53.000.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente-deux millions d'euros (€ 32.000.000,¬) à quatre-vingt-
cinq millions d'euros (€ 85.000.000,-), par la création et l'émission de cinquante-trois millions (53.000.000) de nouvelles
actions sans valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée accepte la renonciation par les actionnaires de la Société à leurs droits de souscription préférentiels
relative à l'émission des Nouvelles Actions.
<i>Third resolutioni>
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinquante-trois millions (53.000.000) nouvelles actions sans valeur nominale ont été souscrites par INTERNA-
TIONAL POWER S.A., avec siège social à B-1000 Bruxelles, 34, Boulevard Simon Bolivar, représentée par Madame
Florence PONCELET, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, et entièrement libérées par un paiement en
espèces d'un montant de cinquante-trois millions d'euros (EUR 53.000.000,-).
La preuve du paiement susmentionné a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément de sorte
que le montant de cinquante-trois millions d'euros (EUR 53.000.000,-) est maintenant à la disposition de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Article 5 paragraphe 1 des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 5. Paragraphe 1
er
. Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq millions d'euros (€ 85.000.000,-), représenté
par cinquante-huit millions deux cent trente-neuf mille six cents (58.239.600) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ six mille sept cents
euros (€ 6.700,-).
102029
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de diver-
gence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par
leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Poncelet, Azoughagh, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 août 2013. Relation: EAC/2013/10222. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013113613/162.
(130137124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.
Victoria Foncier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 14, rue de Peppange.
R.C.S. Luxembourg B 179.215.
STATUTS
L'an deux mil treize, le vingt-quatrième jour du mois de juillet.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur Michel LAURETTE, salarié, né à Hayange (France) le 16 février 1961, demeurant à F-57100 Thionville, 19
rue Marcel Carné;
Lequel comparant, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de:
„VICTORIA FONCIER S.à r.l."
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Roeser. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg de l'accord des associés.
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière comportant l'acquisition, la vente, la gérance,
la location, l'administration et la promotion de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg
ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le déve-
loppement.
Elle peut à cet effet affecter ses immeubles en hypothèque, contracter des prêts et ouvertures de crédit ainsi que
mettre à disposition et consentir des sûretés et se porter caution.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société a pour objet la mise en valeur des immeubles dont elle est propriétaire ou à acquérir, que ces biens soient
situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (EUR 12.500.-) représenté par cent parts
sociales (100) de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
102030
L
U X E M B O U R G
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des
associés représentant au moins 75 % du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée
générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la
gérance.
Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour
cent ( 50% ) du capital social.
Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des
associés par la loi ou par les présents statuts.
Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2013.
Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l'intégralité du capital comme suit:
Monsieur Michel LAURETTE, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l'associé unique se donne quittance et décharge:
Le notaire instramentaire constate expressément que dès à présent la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO
(EUR 12.500.-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.
<i>Évaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cent euros (1.100.-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l'associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a
pris les résolutions suivantes:
102031
L
U X E M B O U R G
1) Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel LAURETTE, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de l'associé unique. Il peut déléguer des pouvoirs à des
tiers.
2) Le siège social est établi à L-3378 Livange, 14 rue de Peppange.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
<i>Pouvoirsi>
La personne comparante donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné,
agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Michel Laurette, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 juillet 2013. LAC / 2013 / 35177. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 5 août 2013.
Référence de publication: 2013113669/108.
(130136993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.
SK Property Fund SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.237.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of July,
Before the undersigned, Me Francis Kesseler, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. SK Property, a public company limited by shares (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which registration
with the Luxembourg trade and companies register is pending,
here represented by Rocio Garcia-Santiuste Azcunaga, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Stei-
chen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Moscow, on 24 June 2013,
2. Samvel Karapetyan, entrepreneur, born on 18 August 1965, in Armenia, with professional address at 109028 Russian
Federation, Moscow, Podkolokolny lane 13/5, bldg. 1,
here represented by Rocio Garcia-Santiuste Azcunaga, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Stei-
chen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Moscow, on 21 June 2013.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, the
powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing parties, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state, as follows, the
articles of incorporation of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), which is hereby
incorporated:
I. Name - Types of shareholders - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name / Types of Shareholders. The name of the company is "SK Property Fund SICAV-SIF" (the Fund). The
Fund is a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the 1915
Law), the law of February 13, 2007 on specialised investment funds, as amended (the 2007 Law) and these articles of
incorporation (the Articles).
The Fund's shareholders are (i) SK Property, a public company limited by shares (société anonyme) incorporated under
the laws of Luxembourg (the Managing General Partner) and (ii) the limited shareholders (associés commanditaires) upon
incorporation of the Fund and any person or entity that becomes a limited shareholder (associé commanditaire) from
time to time (collectively the Limited Shareholders).
102032
L
U X E M B O U R G
The Managing General Partner is jointly and severally liable for all liabilities of the Fund to the extent that they cannot
be paid out of the assets of the Fund.
The Limited Shareholders are liable up to the amount of the capital committed by them to the Fund on subscribing
for the shares.
The Limited Shareholders and the Managing General Partner are, in the Articles, collectively referred to as the Sha-
reholders and individually as a Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The Fund's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the Managing General Partner. It may be transferred to any other location in
the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Shareholders (the General Meeting), acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Managing General Partner. If the Managing General Partner determines that extraordinary political or
military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere
with the normal activities of the Fund at its registered office, or with ease of communication between that office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question
have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Fund, which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Fund is to invest the funds available to it in any kind of assets eligible under the 2007 Law with
the aim of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.
3.2 The Fund may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the accomplishment
and development of its purpose to the fullest extent permitted under the 2007 Law.
Art. 4. Duration.
4.1 The Fund is established for an unlimited duration and shall end with the dissolution and liquidation of its last
Compartment (as defined below).
4.2 The Fund shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more Shareholders.
4.3 The Fund shall not come to an end in the event of the resignation, removal, dissolution or bankruptcy or insolvency
of the Managing General Partner. The general meeting of Shareholders may appoint an interim manager, who need not
be a Shareholder, subject to the prior approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF).
4.4 The interim manager shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the holding of a general
meeting of Shareholders, which has to resolve on the continuation or discontinuation of the Fund and in case of a decision
to continue the Fund's activities, the appointment of a replacement managing general partner. The interim manager shall,
within fifteen days of his appointment, convene a General Meeting in accordance with the procedures laid down in Art.
21. below. Failing the appointment of a replacement managing general partner at the General Meeting so convened or,
should the quorum requirement at such General Meeting not be met, at the second General Meeting as set forth under
Article 21.10 below, the Company will be dissolved and liquidated.
4.5 The interim manager shall be liable only for the performance of his mandate.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Fund shall be represented by shares of no nominal value and shall at any time be equal to
the total net assets of the Fund and its Compartments (as defined below), if any. The initial share capital of the Fund upon
incorporation amounts to fifty thousand United States Dollars (USD 50,000), represented by one (1) management share
(the Management Share) and forty-nine (49) ordinary shares (the Ordinary Shares), all in registered form, without nominal
value. The Management Share and the Ordinary Shares are collectively referred to as the Shares and individually as a
Share.
5.2. The Management Share is exclusively reserved to the Managing General Partner. The Ordinary Shares are offered
to well-informed investors within the meaning of article 2 of the 2007 Law (the Well-Informed Investors).
5.3. The minimum capital of the Fund shall be one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000) or
the equivalent in United States Dollars, which must be reached within twelve months after the date on which the Fund
has been authorised in accordance with the 2007 Law.
Art. 6. Compartments.
6.1 The Fund is composed of one or more compartments (the Compartments), in accordance with article 71 of the
2007 Law, each of them constituting a distinct pool of assets, managed in the benefit of the Limited Shareholders of the
relevant Compartment. A first Compartment will be launched by decision of the Managing General Partner. The name
102033
L
U X E M B O U R G
of each Compartment shall comprise the first part of the name of the Fund, followed by the denomination determined
at the discretion of the Managing General Partner.
6.2 The Managing General Partner may, at any time, establish additional Compartment(s) and determine the name and
specific features thereof (including, but not limited to investment objectives, policy, strategy and/or restrictions, specific
fee structure, reference currency) as further set out in the private placement memorandum of the Fund, as amended and
updated from time to time (the Private Placement Memorandum) and which shall be fully described in the relevant Part
II of the Private Placement Memorandum (the Compartment Specifications), which forms an integral part of the Private
Placement Memorandum for purposes of the relevant Compartment.
6.3 The Fund is one single legal entity. However, by way of derogation to article 2093 of the Luxembourg Civil Code
and in accordance with the provisions of article 71 of the 2007 Law, the assets of any given Compartment are only available
for the satisfaction of the debts, obligations and liabilities, which are attributable to such Compartment. Amongst Limited
Shareholders, each Compartment is treated as a separate entity.
Art. 7. Shares.
7.1 The Shares are indivisible and the Fund recognises only one (1) owner per Share.
7.2 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
7.3 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Fund or at the office of the registrar and transfer
agent and may be examined by any Shareholder on request.
7.4 The Managing General Partner may, at any time, issue different classes of Ordinary Shares (each a Class or Classes
as appropriate) in respect of each Compartment, which may carry different rights and obligations inter alia with regard
to eligible investors, income and profit entitlements, redemption features, reporting obligations and/or fee and cost
features as described in the relevant Compartment Specifications.
7.5 The Ordinary Shares may only be subscribed for by investors who comply with the status of Well-Informed
Investor. The compliance of each subscriber with the status of Well-informed Investor will be verified by the Managing
General Partner or any agent to which such function has been delegated by the Managing General Partner. This restriction
is not applicable to the Managing General Partner.
7.6 Investors wishing to subscribe for Shares in a Compartment shall execute a subscription agreement (the Subscrip-
tion Agreement), which upon acceptance will be signed by the Managing General Partner. Investors thus commit
themselves to subscribing and accepting Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set
forth in the Private Placement Memorandum.
7.7 The issue price of Ordinary Shares is determined by the Managing General Partner on a Class by Class basis as
fully described in the relevant Compartment Specifications.
7.8 The Managing General Partner may delegate to any duly authorised director, manager, officer or to any other duly
authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the issue price of any Ordinary Shares and to
deliver the Ordinary Shares.
Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 Ordinary Shares are only transferable between Well-Informed Investors each time and may be subject to such
other transfer conditions as set forth in the relevant Compartment Specifications.
8.2 A transfer of Ordinary Shares shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer,
duly signed and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Fund,
following a notification to, or acceptance by, the Fund, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
8.3 Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Fund as evidence of a share transfer, subject to the concomitant transfer of any undrawn
subscription commitment.
8.4 The Management Share is exclusively and mandatorily transferable upon replacement of the Managing General
Partner.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 Unless otherwise provided for in the relevant Compartment Specifications, a redemption of Ordinary Shares is
only possible at the discretion of the Managing General Partner in accordance with the relevant Compartment Specifi-
cations and the Shareholders are not entitled to request any redemption of their Ordinary Shares.
9.2 The Managing General Partner may, upon serving a repurchase notice, decide to repurchase the Ordinary Shares
of any Shareholder and such Shareholder shall be obliged to sell its Ordinary Shares to the Fund at a price determined
in accordance with the relevant Compartment Specifications. The Managing General Partner shall furthermore cause the
transfer or the repurchase of the Ordinary Shares of any Shareholder, if the Shareholder ceases to qualify as a Well-
Informed Investor.
102034
L
U X E M B O U R G
9.3 No distribution for redemption of Shares may be made as a result of which the capital of the Fund would fall below
the minimum capital amount required by Luxembourg law.
9.4 A redemption of Ordinary Shares shall be subject to such further terms and conditions, including but not limited
to any redemption charges, as set forth in the relevant Compartment Specifications.
9.5 Any Share repurchased by a Compartment cannot be reissued and shall be cancelled.
Art. 10. Conversion of Shares.
10.1 The conversion of Ordinary Shares in a given Compartment into Ordinary Shares of another Compartment or
the conversion of Ordinary Shares of one Class into another Class within the same Compartment or of another Com-
partment may be authorised on a Compartment by Compartment basis as well as on a Class by Class basis as set forth
in the relevant Compartment Specifications.
10.2 The Management Share is not convertible.
III. Net asset value
Art. 11. Calculation of the net asset value.
11.1 Principles of valuation
The reference currency of the Fund is the United States Dollar. Each Compartment may have a different reference
currency.
The NAV of each Compartment's Shares is expressed in the reference currency of the respective Compartment and
within each Compartment the NAV of each Class, if applicable, is expressed in the reference currency of the respective
Class, as further described in the Compartment Specifications in Part II of this Private Placement Memorandum.
The value of the Fund and/or Compartment assets will be determined by the administrative agent under the respon-
sibility of the Managing General Partner at least annually on the last day of the financial year of the Fund and on such other
days as determined from time to time by the Managing General Partner and set out in the relevant Compartment Spe-
cifications (each a Valuation Day). The Managing General Partner may, in its discretion, appoint one or more independent
third party local appraiser(s) selected amongst the highest first rated service providers in respect of the investments of
the Fund to assist the administrative agent in determining the fair value of the Fund and/or Compartment assets. The
value of the Fund and/or Compartment assets shall be exclusively expressed in the currency of the share capital of the
Fund.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the value of the Fund and/
or Compartment assets taken by the Managing General Partner or by any bank, company or other organisation which
the Managing General Partner may appoint for the purpose of calculating the value of the Fund and/or Compartment
assets, shall be final and binding on the Fund and on its Shareholders.
The Managing General Partner has adopted the methodology of valuing the Fund's investments at fair value in accor-
dance with the valuation guidelines described below and in accordance with International Private Equity and Venture
Capital Valuation Guidelines (the INREV Guidelines).
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and applied in accordance with International Financial
Reporting Standards.
11.2 Valuation Policy
The Fund and/or Compartment assets will be determined on each Valuation Date and as often as the Managing General
Partner may think useful, by the administrative agent under the responsibility of the Managing General Partner in accor-
dance with these Articles and the Private Placement Memorandum.
The value of the Fund assets are expressed in United States Dollars by aggregating the value of all Fund assets and
deducting all liabilities of the Fund, as adjusted for items that do not contribute to fair value (such as derivative accounting,
post balance sheet events and deferred amounts that will not materialise).
The Fund reserves the right to suspend the determination of the NAV of a Compartment under circumstances set
forth under Article 12 "Suspension of the Calculation of the NAV" below.
For the purpose of relations between Shareholders, each Compartment is treated as a separate entity, generating
without restriction its own contributions, capital gains and capital losses, fees and expenses. The Fund constitutes a single
legal entity. However with regard to third parties, in particular towards the Fund's creditors, each Compartment shall
be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.
All assets and liabilities of the Fund shall be valued at fair value in compliance with the accounting principles applicable
to the Fund. The Managing General Partner, in its discretion and in good faith, may permit some other method of valuation
to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Fund.
If since the time of determination of the NAV there has been a material change in the quotations in the markets on
which a substantial portion of the investments of the Fund are dealt in or quoted, the Fund may, in order to safeguard
the interests of the Shareholders and the Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
11.3 Assets of the Fund
For the purposes of the valuation of the Fund and/or Compartment assets, the assets are deemed to include:
102035
L
U X E M B O U R G
(i) the value of all properties or property rights registered directly or indirectly in the name of or on behalf of the
Fund;
(ii) the value of unlisted investments as determined by any evaluator as may be appointed from time to time by the
Managing General Partner and relied upon by the administrative agent;
(iii) all cash in hand or on deposit, which may be held on an accessory and temporary basis, including any interest
accrued thereon;
(iv) all bills, invoices and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered),
which may be held on an accessory and temporary basis;
(v) all bonds, time notes, shares, stocks, debenture stocks, subscription rights and other investments and securities
owned or contracted for by the Fund;
(vi) all stocks, stock dividends, cash dividends, cash distributions receivable by the Fund and/or Compartment the
extent information thereon is reasonably available to it;
(vii) all interest accrued on any interest bearing securities owned by the Fund, except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such security; and
(viii) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses such as the management fees, if any.
The value of such assets shall be determined at fair value with due regard to the following principles:
(i) the value of any cash on hand or deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true thereof;
(ii) securities listed and traded primarily on one or more recognised securities exchanges shall be valued at their last
known prices on the Valuation Date;
(iii) investment in underlying undertakings for collective investment or assimilated entities are taken at their last official
net asset value known in Luxembourg at the time of calculating the value of the Fund and/or Compartment assets. If such
price is not representative of the fair value of such assets, then the price shall be determined by the Managing General
Partner on a fair value basis. Investments subject to bid and offer prices are valued at their mid-price, if not otherwise
determined by the Managing General Partner;
(iv) unlisted securities for which over-the-counter market quotations are readily available (included listed securities
for which the primary market is believed to be the over-the-counter-market) shall be valued at a price equal to the last
reported price as supplied by recognised quotation services or broker-dealers;
(i) properties or property rights registered in the name of the Fund, subsidiaries, joint-ventures or affiliates shall be
valued by any valuer as may be appointed from time to time by the Managing General Partner, provided that it may be
deviated from such valuation if deemed in the interest of the Fund and/or Compartment and provided further that such
valuation may be established at the end of the fiscal year and used throughout the following fiscal year unless there is a
change in the general economic situation or in the condition of the relevant properties or property rights held by the
Fund, subsidiaries, joint-ventures or affiliates or by any controlled property companies which requires new valuations to
be carried out under the same conditions as the annual valuations. The names of the valuers appointed by the Managing
General Partner will be disclosed in the annual report;
(ii) all other assets of any kind or nature, including any instruments and techniques used for hedging purposes (with a
view to exclusively hedging currency or interest rate risk), will be valued at fair market value, as determined in good faith
by and under the responsibility of the Managing General Partner acting reasonably having regard to applicable market
standards as applied from time to time such as INREV Guidelines for valuations or any other valuation standard as may
best reflect a fair valuation. For the purpose of determining the fair market value of the assets under this provision, the
Managing General Partner may have regard to all factors that it reasonably considers relevant in relation to such assets
which factors may include (when applicable) inter alia: (i) the characteristics of and fundamental analytical data relating to
the assets including the costs, size, current interest rate, period until next interest rate reset, maturity and lending rate
of the assets, the terms and conditions of the assets' debt structure; (ii) the nature and adequacy of the rights, remedies
and interests of the Fund; (iii) the creditworthiness of the assets business, cash flows, capital structure and future pros-
pects; (iv) information relating to recent relevant market transactions; (v) the reputation and financial condition of the
Fund recent reports relating to the assets; (vi) general economic market conditions affecting the fair value of the assets.
The Managing General Partner is authorised to apply other alternative valuation principles on a consistent basis if the
aforementioned valuation methods appear inadequate in principle or inappropriate in extraordinary circumstances or
upon the occurrence of extraordinary events;
(iii) properties under construction shall be valued at cost until substantial completion, upon which they will be valued
externally at least once annually in accordance with INREV Guidelines in accordance with the above; and
(iv) assets expressed in a currency other than United States Dollars shall be converted on the basis of the rate of
exchange ruling on the relevant Valuation Date. If such rate of exchange is not available, the rate of exchange will be
determined in good faith by or under procedures established by the Managing General Partner.
11.4 Liabilities of the Fund
102036
L
U X E M B O U R G
For the purposes of the valuation of the Fund and/or Compartment assets, the liabilities are deemed to include:
(i) all loans, shareholder loans, bills and accounts payable;
(ii) all accrued or payable administrative expenses, including but not limited to management, advisory and custodian
and paying agent fees;
(iii) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property;
(iv) an appropriate provision for income and deferred taxes based on capital and income to the valuation day, as
determined from time to time by the Managing General Partner, and other reserves, if any, authorised and approved by
the Managing General Partner; and
(v) all other liabilities of the Fund and/or Compartment of whatsoever kind and nature.
In determining the amount of the liabilities of the Fund, the Managing General Partner must take into account all
expenses payable by the Fund, which will comprise formation expenses, fees payable to the Managing General Partner,
the custodian, the administrative agent, and any other agent employed by the Managing General Partner, fees for legal
and auditing services, promotion, printing reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing
and printing constitutional or organisational documents of the Fund, explanatory memoranda or registration statements,
annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling
assets, interest, bank charges, postage, telephone and facsimiles. The Managing General Partner may calculate adminis-
trative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis for yearly or other periods in advance
and may accrue the same in equal proportions over any such period.
For the purposes of the valuation of the Fund and/or Compartment assets:
(i) Shares or Classes in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received are
deemed to be existing;
(ii) Shares or Classes to be redeemed are treated as existing and until paid, the price therefore is deemed to be a
liability of the Fund;
(iii) all investments, cash balances and other assets of the Fund and/or Compartment not expressed in United States
Dollars, will be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for
determination of the value of the Fund and/or Compartment assets; and
(iv) effect must be given as at any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Fund
and/or Compartment on that Valuation Day, to the extent practicable.
11.5 Assets and liabilities of Compartments/Classes
The assets and liabilities of different Compartments or different Classes shall be allocated as follows:
(i) the proceeds to be received from the issue of Ordinary Shares of a Compartment shall be applied in the books of
the Fund to the relevant Compartment;
(ii) where an asset is derived from another asset, such derived asset shall be applied in the books of the Fund to the
same Compartment as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant Compartment;
(iii) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular Compartment or to any action taken in
connection with an asset of a particular Compartment, such liability shall be allocated to the relevant Compartment;
(iv) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on Shares of any Com-
partment, the assets of such Compartment shall be reduced by the amount of such dividends; and
(v) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular
Compartment, such asset or liability shall be allocated to all the Compartments pro rata to the NAV of the relevant
Compartment or in such other manner as determined by the Managing General Partner acting in good faith.
11.6 Net Asset Value Computation
For the purposes of the Net Asset Value computation:
(i) Shares of the Fund to be redeemed hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after
the time specified by the Managing General Partner on the relevant valuation time and from such time and until paid by
the Fund the price therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;
(ii) Shares to be issued by the Fund shall be treated as being in issue as from the time specified by the Managing General
Partner on the valuation time, and from such time and until received by the Fund the price therefore shall be deemed to
be a debt due to the Fund;
(iii) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the NAV
for the relevant Compartment is calculated shall be valued after taking into account the rate of exchange prevailing on
the principal regulated market of each such asset on the dealing day preceding the valuation time; and
(iv) where on any valuation time the Fund has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Fund
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Fund;
102037
L
U X E M B O U R G
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Fund and
the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Fund;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such valuation
time, then its value shall be estimated by the Managing General Partner.
Art. 12. Suspension of the calculation of the net asset value. The Managing General Partner may temporarily suspend
the determination of the net asset value per Share and Class of any Compartment and the issue, conversion and re-
demption of Shares in respect of a given Compartment or a given Class within such Compartment:
(i) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of
the investments of the Fund attributable to such Compartment from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise
than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction
or suspension affects the valuation on the investments of the Fund attributable to a Compartment quoted thereon; or
(ii) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Managing General
Partner as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Fund attributable to such Compartment would
be impracticable; or
(iii) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of such Compartment or the current price or values on any stock exchange or other market in respect
of the assets attributable to such Compartment; or
(iv) when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to any Compartment
cannot promptly or accurately be ascertained; or
(v) during any period when the Managing General Partner is unable to repatriate funds for the purpose of making
payments on the redemption of the Shares of such Compartment or during which any transfer of funds involved in the
realisation or acquisition, of investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Managing
General Partner be effected at normal rates of exchange.
IV. Management - Representation
Art. 13. Management.
13.1 The Fund shall be managed by the Managing General Partner for the duration of the Fund, unless the provisions
of Art. 4.3. apply or the Managing General Partner is dismissed or resigns for legitimate cause.
13.2 All powers not expressly reserved to the Shareholders by the 1915 Law, the 2007 Law or the Articles fall within
the competence of the Managing General Partner, who has all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Fund's corporate object.
13.3 The Managing General Partner is responsible for all investment management of the assets of the Fund and each
of its Compartments, for the day-to-day management of the affairs of the Fund as well as for the administration and
marketing functions related to the Fund and its Compartments. The Managing General Partner retains legal decision-
making power and has the exclusive authority with regard to any decisions not specifically delegated or attributed to
another entity or service provider and supervises the administrative agent, the registrar and transfer agent, the investment
advisor and any other service providers of the Fund in the performance of their duties.
Art. 14. Removal of the Managing General Partner.
14.1 The Managing General Partner may be removed by a majority of 80% (hundred per cent) of the votes cast at a
general meeting of Shareholders where at least 80% (hundred per cent) of the voting rights are represented, on the
occurrence of the following events:
(i) any action by the Managing General Partner, or any person to whom the Managing General Partner has delegated
any part of its duties, which has been determined by an arbitrator or competent court in a final decision to constitute a
fraud and which is not remedied within 60 (sixty) days after notification to or the coming to the Managing General Partner's
attention; or
(ii) the determination by an arbitrator or competent court that the Managing General Partner, or any person to whom
the Managing General Partner has delegated any part of its duties, has/have wilfully or through gross negligence committed
a breach of one or more provisions of the fund documents, and which is not remedied within 60 (sixty) days after
notification to or the coming to the Managing General Partner's attention.
14.2 No consent of the Managing General Partner is required for such Shareholders' resolution.
14.3 Upon removal of the Managing General Partner, a new managing general partner (associe-gerant-commandite)
of the Fund shall be appointed by the Shareholders in a general meeting of Shareholders with the majority requirements
set out in the Articles, which shall substitute, subject to the prior approval of the CSSF, the Managing General Partner as
managing general partner (associe-gerant-commandite) of the Fund by the accomplishment of any relevant and appropriate
formalities, and which shall assume the Managing General Partner's obligations as managing general partner of the Fund.
Art. 15. Representation.
15.1 The Fund shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the Managing General Partner.
102038
L
U X E M B O U R G
15.2 The Fund shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom
special signatory powers have been delegated.
Art. 16. Delegation of powers.
16.1 The Managing General Partner may appoint any officers, including a general manager and any assistant general
managers as well as any other officers that the Fund deems necessary for the operation and management of the Fund or
any Compartment. Such appointments may be cancelled at any time by the Managing General Partner. The officers need
not be Limited Shareholders of the Fund. Unless otherwise provided for by these Articles, the officers shall have the
rights and duties conferred upon them by the Managing General Partner. The Managing General Partner may furthermore
appoint other agents, who need not to be members of the Managing General Partner and who will have the powers
determined by the Managing General Partner.
16.2 The Managing General Partner may, under its full responsibility, be assisted, while managing the Fund's assets by
one or several investment managers and/or investment advisors or, delegate its powers in relation to the management
of the Fund or a specific Compartment to one or several agents.
16.3 The Managing General Partner may establish on a Compartment per Compartment basis an advisory committee
and/or an investors' committee, which shall have those powers as provided for in the relevant Compartment Specifica-
tions.
16.4 The Managing General Partner may be assisted by one or several committees in view of implementing appropriate
risk management systems, minimising the risk of Shareholders' interests being prejudiced by conflicts of interests and
establishing compliance management systems.
Art. 17. Investment policies and Restrictions.
17.1 The Managing General Partner, based upon the principle of risk diversification and in accordance with the Private
Placement Memorandum, has the power to determine the investment policies and strategies of each Compartment of
the Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Fund, within the restrictions as shall
be set forth by the Managing General Partner in compliance with applicable laws and regulations.
17.2 The Fund may employ, for each Compartment as set forth in the relevant Compartment Specifications, techniques
and instruments relating to transferable securities, currencies or any other financial assets or instruments for the purpose
of hedging.
Art. 18. Conflicts of interest.
18.1 No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that any 1 (one) or more of the managers, directors or officers of the Managing General Partner is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager, director or officer of the
Managing General Partner who serves as a manager, director, officer or employee of any company or firm, with which
the Fund shall contract or otherwise engage in business shall, by reason of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
18.2 In the event that any manager, director or officer of the Managing General Partner may have in any transaction
of the Fund an interest different to the interests of the Fund, such manager, director or officer shall make known to the
Managing General Partner such conflict of interest and shall not consider or vote on any such transaction and such
transaction, and such manager's, director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of Shareholders.
18.3 The term conflict of interests, as used in the preceding paragraph, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving the initiator, the investment manager(s), investment advisor(s), the cus-
todian, the administrative agent, the distributors as well as any other person, company or entity as may from time to time
be determined by the Managing General Partner on its discretion.
Art. 19. Indemnification.
19.1 The Fund shall indemnify any member of the board of managers of the Managing General Partner, the Managing
General Partner, the investment manager(s), investment advisor(s), the custodian, the administrative agent and their
affiliates as well as any officer and their heirs, executors and administrators (each an Indemnified Person) against expenses
reasonably incurred by them in connection with any action, suit proceeding to which they may be made a party by reason
of them being or having been a member of the board of managers of the Managing General Partner, the investment
manager(s), the investment advisor(s), the custodian, the administrative agent and their affiliates or officer or, at its request,
being or having been a member of any other entity of which the Fund or a Compartment is an investor or creditor and
from which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters in respect of which they may be finally
declared to be liable for wilful misconduct, bad faith or gross negligence; in the event of a settlement, indemnification shall
be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Fund is advised by counsel
that the person to be indemnified did not commit such a wilful misconduct, bad faith or gross negligence. The indemni-
fication shall be provided only where such person has acted pursuant to the receipt of proper instructions and within the
terms and conditions of any contractual agreement in full force and in effect between the indemnified person and the
Fund. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the Indemnified Person may be entitled.
102039
L
U X E M B O U R G
19.2 An Indemnified Person seeking indemnification pursuant to this clause shall, upon reasonable request, be advanced
by the Fund, expenses (including legal fees and costs) reasonably incurred by such Indemnified Person in defence of any
proceeding against such Indemnified Person prior to the final disposition thereof; provided that such Indemnified Person
has agreed in writing to repay such amount to the Fund within three (3) months of the date it is ultimately determined
that such Indemnified Person is not entitled to be indemnified as authorised in this section.
V. General meetings of shareholders
Art. 20. Powers and Voting rights.
20.1 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting. In accordance with article 111 of the 1915
Law, no decision of a general meeting will be validly taken without the prior approval of the Managing General Partner
except for the decision of Removal of the Managing General Partner.
20.2 Each Share entitles the holder to one (1) vote.
Art. 21. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
21.1 The Limited Shareholders may be convened to General Meetings by the Managing General Partner. The Limited
Shareholders must be convened to a General Meeting following a request from Limited Shareholders representing more
than one-tenth of the share capital.
21.2 Written notice of any General Meeting shall be given to all Limited Shareholders at least eight (8) days prior to
the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be
set out in the notice.
21.3 The convening notices for the General Meeting may set out that the quorum of the presence at the General
Meeting be determined according to the Shares issued and outstanding at midnight on the fifth (5th) day prior to the
relevant General Meeting (the Record Date). The rights of a Shareholder to participate in a General Meeting and to
exercise the voting right attached to his Shares are determined according to the Shares held by this Shareholder at the
Record Date.
21.4 General Meetings shall be held at such place and time as specified in the notices.
21.5 If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
21.6 A Shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a Shareholder) in order
to be represented at any General Meeting.
21.7 Any Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to a participation in person at the meeting.
21.8 Any Shareholder may vote by using the forms provided by the Fund for that purpose. Voting forms must contain
the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the
voting forms to the Fund's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into
account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention
shall be considered void.
21.9 Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the
proportion of the share capital present or represented.
21.10 An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is repre-
sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment
to the Fund's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of
notices published twice in the Memorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results
of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the
capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast, which
shall include the consent of the Managing General Partner unless otherwise specified by these Articles.
21.11 In accordance with article 67-1 of the 1915 Law, any change in the nationality of the Fund and any increase of a
Shareholder's commitment in the Fund shall require the unanimous consent of the Shareholders and bondholders (if any).
Art. 22. General Meetings of Compartment(s).
22.1 The Managing General Partner may at any time convene a general meeting of Shareholders of one or several
specific Compartment(s) in order to decide on any matter, which relate exclusively to such Compartment(s).
22.2 Legal provisions as well as provisions of these Articles relating to the general meetings of Shareholders of the
Fund shall apply to the extent possible mutatis mutandis to the general meetings of Shareholders of one or several specific
Compartment(s).
102040
L
U X E M B O U R G
VI. - Supervision - Annual accounts - Allocation of profits
Art. 23. Auditor.
23.1 The accounting data related in the annual report of the Fund shall be examined by an auditor (réviseur d'entreprises
agréé) appointed by the Managing General Partner and remunerated by the Fund (the Auditor).
23.2 The Auditor shall fulfil the duties prescribed by the 2007 Law.
Art. 24. Reference currency. The Fund shall prepare annual accounts in United States Dollars. For the purpose of
determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Compartment shall, if not denominated in United
States Dollars, be converted into United States Dollars at the rates used in the most recent net asset value calculation
and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Compartments.
Art. 25. Financial year and Approval of annual accounts.
25.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
25.2 Each year, the Managing General Partner must prepare the balance sheet and profit and loss account, together
with an inventory stating the value of the Fund's assets and liabilities, with an annex summarising the Fund's commitments
and the debts owed by the officer(s), the Managing General Partner and the Auditor.
25.3 One month before the annual General Meeting, the Managing General Partner shall provide the Auditor with a
report on, and documentary evidence of, the Fund's operations. The Auditor shall then prepare a report setting out its
proposals.
25.4 The annual General Meeting shall be held at the registered office or any other place within the municipality of the
registered office, as specified in the notice, on the third (3rd) Tuesday of May of each year at 2.00 p.m.. If such day is not
a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
25.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the Managing General Partner's absolute discretion, ex-
ceptional circumstances so require.
Art. 26. Allocation of profits.
26.1 The annual General Meeting shall approve the profit allocation proposed by the Managing General Partner in
accordance with the allocations rules set out in the Private Placement Memorandum and in particular as set forth in each
of the Compartment Specifications.
26.2 The Managing General Partner may in its discretion decide to pay interim dividends at any point in time unless
otherwise provided for in the Private Placement Memorandum and, in particular, as set forth in the relevant Compartment
Specifications.
26.3 Distributions shall be paid in United States Dollars or in the base currency of a Compartment and at such time
and place that the Managing General Partner shall determine from time to time.
26.4 No distribution may be made which would result in the net asset value of the Fund to fall below the minimum
capital required by the 2007 Law, as set out in Art. 5.3 above.
VII. Dissolution - Liquidation
Art. 27. Term, Liquidation and Amalgamation of Compartments
27.1 The Compartments may be created for any undetermined period or for a fixed period as provided for in the
Private Placement Memorandum and, specifically, in the relevant Compartment Specifications. Any Compartment created
for a fixed period will terminate automatically on the expiration date (if any) provided for in the relevant Compartment
Specifications.
27.2 The Managing General Partner may also decide to liquidate one Compartment if the net assets of such Com-
partment have decreased to, or have not reached, an amount determined by the Managing General Partner to be the
minimum level for such Compartment to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic
or political situation relating to the Compartment concerned would justify such liquidation. Limited Shareholders of the
relevant Compartment will be notified by the Managing General Partner of any decision to liquidate the relevant Com-
partment prior to the effective date of the liquidation and the notice will indicate the reasons for, and the procedures
applicable to, the liquidation.
27.3 Unless otherwise provided for in the Compartment Specifications, Limited Shareholders of the relevant Com-
partment may request the redemption of their Shares upon or prior to the liquidation by application of the applicable
liquidation net asset value as determined by the Managing General Partner, as the case may be. Assets which cannot be
distributed to their beneficiaries upon the close of liquidation of the Compartment concerned will be deposited with the
custodian for a period of six months after the end of the liquidation. After such time, the assets will be deposited with
the Caisse des Consignations on behalf of their beneficiaries.
27.4 In the same circumstances as provided in Art. 27.2 above, the Managing General Partner may decide to terminate
one Compartment and contribute its assets into another existing or new Compartment or into another existing or new
collective investment scheme or an assimilated entity. The Managing General Partner may organise the amalgamation of
two or more Compartments or two or more share classes within a Compartment if it believes that such a course of
102041
L
U X E M B O U R G
action is in the best interests of the Limited Shareholders of the relevant Compartments. Affected Limited Shareholders
will be notified of any such decision and relevant information in relation to the new Compartment. Notice will be provided
at least one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable Limited Shareholders
to request that their Shares be redeemed, without any fees or costs, before the amalgamation is completed.
27.5 Where assets are to be contributed to another collective investment vehicle, the amalgamation will be binding
only on Limited Shareholders in the relevant Compartment who expressly consent to such amalgamation. Where the
Managing General Partner does not have the authority to do so or where the Managing General Partner determines that
the decision should be put to the Limited Shareholders for their approval, the decision to liquidate or to merge a Com-
partment shall instead be taken at a general meeting of Shareholders of the relevant Compartment. In such an event, the
general meeting of Shareholders of the Compartment shall be held without any quorum requirements and the dissolution
may be decided by the votes of Shareholders holding 50% of the Shares represented at such general meeting. Shareholders
will be notified by the Fund of any resolution to proceed with liquidation or amalgamation at least one month before the
effective date of the liquidation or amalgamation of the Compartment in order to enable Limited Shareholders to request
redemption or conversion of their Shares, without any fees or costs, before the liquidation or amalgamation of the
Compartment takes place.
27.6 Notwithstanding the foregoing, no amalgamation will take place during any period during which the calculation
of the net asset value and the issue, conversion or redemption of any Shares in any Class involved in the amalgamation
has been suspended, except if the consent of all of the Shareholders holding Shares in each of the involved Compartments
has been obtained.
27.7 As soon as the decision to liquidate or merge a Compartment is taken, the issue of Shares in such Compartment
is prohibited and shall be deemed void.
27.8 Each Compartment may be separately dissolved without impacting any other Compartment. The dissolution of
the last Compartment causes ipso jure the liquidation of the Fund.
Art. 28. Dissolution and Liquidation of the Fund.
28.1 The Fund may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting resolving in the conditions pre-
scribed for the amendment of these Articles. The Fund shall also be dissolved upon dissolution of the last existing
Compartment.
28.2 Whenever the share capital falls below two third of the minimum capital indicated in Art. 5.3 above, the question
of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Managing General Partner. In such an event,
the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of
Shareholders holding 50% of the Ordinary Shares represented at such General Meeting.
28.3 Whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital indicated in Art. 5.3 above, the question
of the dissolution of the Fund shall be referred to the General Meeting by the Managing General Partner. In such an event,
the General Meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by the votes of
Shareholders holding 25% of the Ordinary Shares represented at such General Meeting.
28.4 Where the holding of a General Meeting is required in accordance with Art. 28.2 or 28.3 above, such General
Meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the assessment that the net assets of the
Fund have fallen below two third or one quarter of the legal minimum, as the case may be.
28.5 In the event of dissolution of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding on such dissolution and subject to the
approval of the CSSF. The operations of liquidation will be carried out pursuant to Luxembourg applicable laws.
Art. 29. Liquidation proceeds.
29.1 The net proceeds of liquidation corresponding to each Compartment shall be distributed, including distributions
in kind, by the liquidator(s) to the Shareholders of the relevant Compartment in accordance with the rules applicable to
the allocation of profits in such Compartment as referred to under Art. 26 above.
29.2 Any liquidation proceeds that cannot be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the liqui-
dation will be deposited with the Luxembourg «Caisse de Consignation».
Art. 30. Consolidation and Splitting of Shares.
30.1 The Managing General Partner may decide to consolidate or split the Shares of a Compartment within a given
Share Class.
VIII. General provisions
Art. 31. General Provisions.
31.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, e-
mail or any other means of electronic communication.
31.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above.
31.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
102042
L
U X E M B O U R G
conference may appear on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together,
shall constitute one and the same document.
31.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the Shareholders from time
to time.
<i>Transitory provisioni>
The Fund's first financial year shall begin on the date of this deed and end on the thirty-first (31) of December 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
SK Property, represented as stated above, subscribes for (i) one (1) Management Share in registered form, without
nominal value and agrees to pay it in full by a contribution in cash in the amount of one thousand United States Dollars
(USD 1,000) and (ii) one (1) Ordinary Share in registered form, without nominal value, and agrees to pay it in full by a
contribution in cash in the amount of one thousand United States Dollars (USD 1,000), it being understood that this
Ordinary Share may be reclassified into one (1) share of the first Compartment to be established by the Fund upon its
set-up.
Samvel Karapetyan, represented as stated above, subscribes for forty-eight (48) Ordinary Shares in registered form,
without nominal value, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of forty-eight thousand
United States Dollars (USD 48,000), it being understood that these Ordinary Shares may be reclassified into shares of
the first Compartment to be established by the Fund upon its set-up.
The amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000) is at the Fund's disposal and evidence of such amount
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Fund in connection with its incor-
poration are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Fund, its Shareholders, representing the entire subscribed share capital,
adopted the following resolutions:
1. Deloitte Audit, a private limited liability company (société á responsabilité limitée) incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 67895, is appointed as approved external
auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Fund for a period ending on the next annual general meeting of the Company.
2. The registered office of the Fund is set at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English.
WHEREOF this notarial deed is drawn up in Esch/Alzette, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing parties.
Signé: Rocio Garcia-Santiuste Azcunaga, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 juillet 2013. Relation: EAC/2013/9128. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013113590/643.
(130137508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.
Bellefontaine Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 148.891.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 28 juin 2013 au siège social que:
Suite à l'élection de Mr Marcel Eggenkamp, ainsi qu'à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se
terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2013, le Conseil de Gérance se compose de:
102043
L
U X E M B O U R G
- Fabrice HUBERTY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg;
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Standbrook House, 1
st
Floor, 2-5 Old Bond
Street, Londres, WiS 4PD, Angleterre;
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique.
- Marcel EGGENKAMP, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 224 Wibautstraat, 1097 DN Ams-
terdam, Pays-bas.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l'exercice 2013:
- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2013096656/24.
(130118223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Braga Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 174.856.
Avec effet au 8 juillet 2013, Pedro Maria Guimarães José de Mello actuellement associé unique de la Société a transféré:
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à Maria Teresa Guimarães José de Mello ayant comme adresse le Rua do
Moinho Novo, n.° 42, Quinta da Beloura, Linhó, 2710-704 Sintra, Portugal;
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à Maria Amélia Guimarães José de Mello Bleck, ayant comme adresse le
Av. João Crisóstomo, 8-2° Esq., 1000-178 Lisbonne, Portugal;
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à Maria Cristina Guimarães José de Mello de Azevedo Coutinho ayant
comme adresse le Largo de Santo Estêvão, 15, 1100-505 Lisbonne, Portugal;
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à Vasco Maria Guimarães José de Mello ayant comme adresse le Av. da
República, n° 1910, Quinta Patino - Lote 48 - Alcoitão, 2645-143 Alcabideche, Portugal;
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à Maria Luisa Guimarães José de Mello do Amaral Cabrai ayant comme
adresse le Avenida Sidónio Pais, 10-4° Esq., 1050-214 Lisbonne, Portugal;
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à Maria do Carmo Guimarães José de Mello Amaral Cabrai ayant comme
adresse le Av. D. Afonso Henriques, 959, 2765-186 Estoril, Portugal;
1.042 parts sociales ordinaires de la Société à João Maria Guimarães José de Mello, ayant comme adresse le Rua Quinta
do Pinhal, n.° 2, Casa da Oliveira, 2750-258 Cascais, Portugal;
1.041 parts sociales ordinaires de la Société à Maria João Guimarães José de Mello, ayant comme adresse le Av. da
República, n° 1910, Quinta Patino, Lt 23, E4 - 1° Esq. - Alcoitão, 2645-143 Alcabideche, Portugal;
1.041 parts sociales ordinaires de la Société à Salvador Maria Guimarães José de Mello, ayant comme adresse le Rua
dos Gladíolos, Lote 14, Birre, 2750-235 Cascais, Portugal;
1.041 parts sociales ordinaires de la Société à Filipe Maria Guimarães José de Mello, ayant comme adresse le Rua Mato
da Mina, n° 37, Quinta da Beloura, 2710-692 Sintra, Portugal; et
1.041 parts sociales ordinaires de la Société à Gonçalo Maria Guimarães José de Mello, ayant comme adresse le Estrada
das Neves, 20 - Manique, 2645-481 Alcabideche, Portugal.
Pour extrait conforme et sincère
Braga Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013098667/35.
(130119534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2013.
102044
L
U X E M B O U R G
Bremonhill Investment S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 130.894.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue au siège social de la Sociétéi>
<i>le 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2013.i>
Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 1
er
juillet 2013, il a été décidé de:
1. réélire, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2014 pour statuer sur
l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013, les administrateurs de la Société, à savoir:
- Monsieur Vincent GOY, résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Monsieur Eric BIREN, résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg; et
- Madame Marie-Rose LUGLI, résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320, Luxembourg.
2. réélire Madame Monique Tommasini, résidant professionnellement au 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2014 pour statuer sur l'approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013099685/23.
(130121593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Bâtiself, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 14.375.
Lors de rassemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 juin 2013, les décisions suivantes ont été prises:
1) démission de M. Büdel Norbert en qualité d'administrateur en date du 27.06.2013.
2) démission de M. Herma Roland en qualité d'administrateur en date du 27.06.2013.
3) démission de M. Herma Roland en qualité d'administrateur-délégué en date du 27.06.2013.
4) démission de M. Keth Karl-Heinz en qualité d'administrateur en date du 27.06.2013.
5) démission de M. Scharping Gert en qualité d'administrateur en date du 27.06.2013.
6) prolongation en qualité d'administrateur à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2014 de
M. Weber Horst, demeurant à D-66129 Saarbrücken, Bergstrasse, 11.
7) prolongation en qualité d'administrateur à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2014 de M. Elvinger François, demeurant à L-2324 Luxembourg, Avenue Pescatore, 13.
8) prolongation en qualité d'administrateur à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2014 de M. Elvinger Bernard, demeurant à L-7237 Helmsange, rue Jean Mercatoris, 29.
9) prolongation en qualité d'administrateur-délégué à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2014 de M. Elvinger Bernard, demeurant à L-7237 Helmsange, rue Jean Mercatoris, 29.
10) prolongation en qualité d'administrateur à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2014 de M. Steinhäuser Fernand, demeurant à L-2266 Luxembourg, rue d'Oradour, 38.
11) prolongation en qualité d'administrateur-délégué à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2014 de VI. Steinhäuser Fernand, demeurant à L-2266 Luxembourg, rue d'Oradour, 38.
12) prolongation en qualité d'administrateur à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2014 de M. Steinhäuser Jean, demeurant à L-2241 Luxembourg, rue Tony Neuman, 30.
13) prolongation en qualité d'administrateur à partir du 27.06.2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
l'année 2014 de M. Steinhäuser Paul, demeurant à L-5692 Elvange, rue Nicolas Brucher, 16.
Luxembourg, le 27 juin 2013.
Référence de publication: 2013099659/31.
(130121547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2013.
102045
L
U X E M B O U R G
Jean Claude DECAUX Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Raymond Poincarré.
R.C.S. Luxembourg B 23.212.
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 21.09.2012 que:
- la société JSD Investimenti Sprl, inscrite au registre du moniteur belge sous le numéro BE0464714418, avec siège
social à B-1180 Uccle, Avenue Hamoir, 50 et dont la gérance est assurée par Monsieur Jean-Sébastien Decaux est nommée
administrateur et président du conseil d'administration pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale qui se
tiendra en 2018.
- la société JSD Investimenti Sprl, inscrite au registre du moniteur belge sous le numéro BE0464714418, avec siège
social à B-1180 Uccle, Avenue Hamoir, 50 démissionne de son poste d'administrateur-délégué avec effet immédiat.
- La société MEDIA ADVICE Sprl, inscrite au registre du moniteur belge sous le numéro BE0878.936.301, avec siège
social à B-3120 Tremelo, Jan Boedstraat 25A et dont la gérance est assurée par Monsieur Wim Jansen est nommé
administrateur et administrateur-délégué pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
- La société JBMa Sprl, inscrite au registre du moniteur belge sous le numéro BE0822.386.487 avec siège social à B-1160
Bruxelles, Rue Saint Bernard 142 et dont la gérance est assurée par Monsieur Jérôme Blanchevoye est nommée admi-
nistrateur pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
- Monsieur Lionel BLAISE, né le 16.03.1965 à Courrières (France) et demeurant à B-1410 Waterloo, rue de Caraute
93 est nommé administrateur pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18.07.2013.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2013100675/26.
(130122211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
Inlas Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 176.769.
En date du 17 juillet 2013, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Révocation de Manacor (Luxembourg) S.A. du poste de gérante;
- Nomination de Martin Paul Galliver, né le 15 juin 1980 à Monaco, Monaco, ayant pour adresse professionnelle le
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant A, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée;
- Nomination de Eric David Kogan, né le 07 août 1963 en Floride, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour adresse profes-
sionnelle le 110 E. 59
th
St., Suite 2400, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique, au poste de gérant B, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée;
- Nomination de Matthew Scott Feldman, né le 16 avril 1978 en Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, ayant pour
adresse professionnelle le 110 E. 59
th
St., Suite 2400, New York 10022, Etats-Unis d'Amérique, au poste de gérant B,
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
Suite à une cession des 1,250,000 parts sociales de la Société, en date du 17 juillet 2013, entre International Pyramide
Holdings (Luxembourg) S.A. et ATC Acquisition, Inc., l'Associé Unique de la Société est désormais:
- ATC Acquisition, Inc., une corporation, enregistrée au Registre du Delaware sous le numéro 5355107 et ayant pour
adresse le 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 19808, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, détient les 1,250,000
parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Inlas Holding S.à r.l.
Martin Paul Galliver
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2013100637/28.
(130121906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
102046
L
U X E M B O U R G
Inntratec International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Jetlux Europe S.à r.l.).
Siège social: L-2670 Luxembourg, 22, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 128.170.
L’an deux mil treize, le cinquième jour du mois de juillet.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1° Monsieur Ahmed Nouma, employé, né à Sousse (Tunisie), le 19 juin 1976, demeurant à L-2670 Luxembourg, 22,
boulevard de Verdun;
2° Monsieur Amine Ben Ftima, commerçant, né à Sousse (Tunisie), le 1
er
septembre 1974, demeurant à 4000 Sousse,
6, rue de Palestine (Tunisie), ici représenté par Monsieur Ahmed Nouma, prénommé, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité
limitée „JETLUX EUROPE S.à.r.l.“, avec siège social à L-2670 Luxembourg, 22, boulevard de Verdun, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 128.170, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 4 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1412 du 10 juillet 2007, modifiée en dernier lieu par le
notaire instrumentant en date du 21 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 921 du 15 avril 2008.
Les associés ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de réduire le capital social de la Société à concurrence de trente-sept mille cinq cents euros
(EUR 37.500,-) pour le ramener de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par deux
mille (2.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune à douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), par annulation de mille cinq cents (1500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-
EUR) chacune, et remboursement aux associés prénommés comme suit:
- annulation de 760 pars sociales appartenant à Monsieur Ahmed Nouma, prénommé, et remboursement de dix-neuf
mille euros (EUR 19.000,-).
- annulation de 740 pars sociales appartenant à Monsieur Amine Ben Ftima, prénommé, et remboursement de dix-
huit mille cinq cents euros (EUR 18.500,-).
Les associés donnent pouvoir à la gérance afin de procéder au remboursement dans les termes et conditions fixées
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Suite à la répartition ci-dessus, l’intégralité
des 500 parts sociales sont détenues comme suit:
Monsieur Ahmed Nouma, précité, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Monsieur Amine Ben Ftima, précité, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
TOTAL: CINQ CENTS PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
<i>Deuxième résolutioni>
Suivant la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 5. La Société a un capital souscrit de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (25.-EUR) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’objet social de la Société et en conséquence de modifier l’article 4 de la Société
qui aura la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet conseils informatique, conseils en système informatique, programmation informatique,
le commerce en ligne pour son propre compte et pour le compte des tiers, le commerce d'ordinateurs et autres activités
de réalisation de logiciels, l'exécution de tous mandats d’organisation technique, administrative et commerciale, de conseil
en organisation, en recrutement et de gestion de projet, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir
entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.»
102047
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de modifier la dénomination de la Société de JETLUX EUROPE S.à r.l. en INNTRATEC INTER-
NATIONAL S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de INNTRATEC
INTERNATIONAL S.à r.l..»
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de
l’étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Ahmed Nouma, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 juillet 2013. LAC / 2013 / 32365. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Carole Frising.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 17 juillet 2013.
Référence de publication: 2013100685/77.
(130122080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2013.
Gohar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 107.922.
<i>Extrait de la convention de cession de parts sociales en date du 28 juin 2013i>
Il résulte de la convention de cession que Madame Farinaz GOHARIAN, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean
Engling
Cède
125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la société GOHAR Sàrl, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean
Engling, à Monsieur Manutschehr BAYANI-KEYVANI, ingénieur diplômé, avec adresse à L-8273 Mamer, 33, rue Jean
Wester
Et
125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la société GOHAR Sàrl, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean
Engling, à Madame Jutta SCHUMACHER, sans état, demeurant à L-8273 Mamer, 33, rue Jean Wester
Est remplacé avec effet immédiat le gérant suivant:
Madame Farinaz Goharian, gérante, avec adresse à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling
Est nommé nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Manutschehr Bayani-Keyvani, gérant, avec adresse à L-8273 Mamer, 33, rue Jean Wester.
Les associés décident de changer le pouvoir d'engagement de la société comme suit:
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2013096937/26.
(130118189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
102048
1665234 Luxembourg S.à r.l.
3GI S.A.
Amabili Software S.à r.l.
Amstell Investments S.A.
Aquaetanche Lux S.à r.l.
AXA Redilion ManagementCo S.C.A.
Banca March S.A., Sucursal en Luxemburgo
Bâtiself
BCSP V CE Lux I S.à r.l.
Bellefontaine Properties S.à r.l.
bluO Holding F2
Braga Holding
Bremonhill Investment S.A.
BS Real Estate (Lux) S.à r.l.
Capacity Allocation Service Company.eu S.A.
Cave Participations S.A.
Cave S.A. S.P.F.
Cazelia
CEREP Uranus S.à r.l.
Ceva Freight Luxembourg S.à r.l.
China-Lux Trade S.A.
Compagnie Financière pour la Gestion Collective S.A.
Drayton S.A.
Dretschler FR S.à r.l.
DRS Logistic S.à r.l.
EQUI Specialized Asset Management S.A.
Euro Associates
Gohar S.à r.l.
Immobilière du Hameau
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.
INGENIUM tooling S.A.
Inlas Holding S.à r.l.
Inntratec International S.à r.l.
Jaguar Luxembourg S.A.
Jean Claude DECAUX Luxembourg S.A.
Jetlux Europe S.à r.l.
JN S.A.
Johnson Controls Luxembourg Investments S.à r.l.
Johnson Controls Luxembourg Metals Holding S.à r.l.
Luxco sàrl
Luxembourg Development S.A.
Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l.
Serco International S.à r.l.
Silverent S.A.
SK Property Fund SICAV-SIF
STENTOR et Cie SPF S.A.
STENTOR et Cie SPF S.A.
Suez Energy International Luxembourg S.A.
Syberiusconsult S.A.
Sydney Ventures S.A.
Victoria Foncier S.à r.l.
Vilmob S.A.
Weber Steve s.à r.l.
Weinberg Real Estate Holding S.à r.l.
World Immobilière S.A.
WP Roaming III S.à r.l.
WW Brand S.à r.l.
WX Budget Hotel Holding S.A.
YSA Coiffure S.àr.l.
Zimmer & Partners S.A.
Ziwat-IPC.eu