This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2090
28 août 2013
SOMMAIRE
Bora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100274
C.A.T. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100274
Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100274
C-Rights S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100274
C.RO Ports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100274
Danir B S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100275
DB PEP V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100275
Double Green S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100275
Draconis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100275
DSTI Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100275
Eaglemax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100277
ECH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100277
Edelweiss Property Holding S.à.r.l. . . . . . .
100277
Edinem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100277
Electro Viaduc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100278
Energiae Consult S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100278
Energie Investissements Holding S.A. . . . .
100279
Enim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100278
EPISO Treptowers Berlin S.à r.l. . . . . . . . .
100279
Erdec Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100284
ERGO Insurance, agissant aussi sous la dé-
nomination de "ERGO" . . . . . . . . . . . . . . . .
100279
Erima Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100276
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A. . . .
100278
Etablissements CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100276
Eurolux Créations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100279
Europack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100282
Europe Aciers S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100281
European Carbon Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
100276
European Emerging Economies S.à r.l. . . .
100277
European Investment & Asset Manage-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100279
European Real Estate Opportunities Fund
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100278
Eventsmania S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100276
Ex-Aequo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100276
ExxonMobil Netherlands Holdings . . . . . . .
100280
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A. . . . . .
100281
FDD, Financière de développement S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100281
FD immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100281
Fego S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100282
Fenjefflux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100282
Fidco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100283
Fidesco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100283
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A. . . . . .
100283
Findi S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100283
FirstService International Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100280
Fitema Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
100283
Fondation Lëtzeburger Kannerduerf . . . . .
100316
Fonds Rusnano Capital SA . . . . . . . . . . . . . .
100280
Foodservice & Intellectual Property S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100281
Fragrance Resources Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100280
FRL Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
100284
Global Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100319
Golden Lions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100320
GPO Advisory (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100290
HayFin DLF (GBP Parallel) LuxCo 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100306
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
100297
H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100294
ISIWIS Research S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
100318
Lux-Composition S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100282
Perseus Immobilien Gesellschaft 1 . . . . . . .
100289
Perseus Immobilien Gesellschaft 10 . . . . .
100292
Perseus Immobilien Gesellschaft 11 . . . . .
100293
Perseus Immobilien Gesellschaft 4 . . . . . . .
100295
Perseus Immobilien Gesellschaft 5 . . . . . . .
100296
Perseus Immobilien Gesellschaft 9 . . . . . . .
100319
100273
L
U X E M B O U R G
Bora, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 172.443.
Les comptes annuels, pour la période du 8 octobre 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093092/11.
(130114609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
C.RO Ports S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 149.469.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michel Jadot / Jozef Adriaens
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013093101/11.
(130114019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
C-Rights S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 156.263.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C. DEFOURNY
<i>GERANTEi>
Référence de publication: 2013093104/11.
(130114439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 65.694,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.274.
Les comptes annuels de Charger Lux Holdco II (Onshore) S.à.r.l. B 138.274 au 31 Décembre 2012 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Charger Lux Holdco II (Onshore) S.à.r.l.
Référence de publication: 2013093115/11.
(130114724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
C.A.T. Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 48.429.
Les Comptes Consolidés au 31 décembre 2012, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093100/10.
(130113952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100274
L
U X E M B O U R G
Double Green S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 89.796.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013093214/10.
(130114148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Draconis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 172.453.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013093215/10.
(130114355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
DSTI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.374.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 103.490.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093217/10.
(130114482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Danir B S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.687.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2013093196/11.
(130114154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
DB PEP V, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 159.072.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 5 juin 2013:i>
- Le mandat de KPMG Audit S. à r. l. de 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le réviseur d'entreprise agréé de la
société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de KPMG Audit S. à r. l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014
statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2013.
Luxembourg, le 5 juin 2013.
Référence de publication: 2013093200/13.
(130113860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100275
L
U X E M B O U R G
Etablissements CAR, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 7.426.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Etablissements CAR S.à r.l.
Référence de publication: 2013093222/10.
(130114014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
European Carbon Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 107.556.
<i>Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration en date du 27 septembre 2012i>
En date du 27 septembre 2012, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 14 septembre 2012, de Madame Mireille Barthez, en qualité d'Administrateur,
- de coopter, avec effet au 27 septembre 2012, Monsieur Rodolph Pallier, 1 Passerelle des Reflets, Tour Dexia, 92919
La Défense, France, en qualité d'Administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2013, en rem-
placement de Madame Mireille Barthez, démissionnaire.
Luxembourg, le 8 juillet 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Carbon Fund
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2013093223/17.
(130114374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Erima Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 116, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 103.055.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093248/9.
(130114151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Eventsmania S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 153.829.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093255/9.
(130113908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Ex-Aequo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 61, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 35.109.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093256/9.
(130114163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100276
L
U X E M B O U R G
European Emerging Economies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 135.875.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
European Emerging Economies S.à r.l.
<i>Un Géranti>
Référence de publication: 2013093224/11.
(130113985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Eaglemax S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 93.251.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093229/10.
(130114689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
ECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.467.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2013.
Référence de publication: 2013093230/10.
(130113991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Edelweiss Property Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 113.041.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 9 Juillet 2013.
Référence de publication: 2013093232/10.
(130114741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Edinem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 110.038.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2013093233/13.
(130114420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100277
L
U X E M B O U R G
European Real Estate Opportunities Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SI-
CAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 137.990.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2013.
Référence de publication: 2013093227/11.
(130114512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Electro Viaduc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 6-10, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 22.564.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ELECTRO-VIADUC SARL
Référence de publication: 2013093240/10.
(130113806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Enim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 154.676.
EXTRAIT
Il résulte d'un changement d'adresse que Monsieur Riccardo Moraldi est désormais domicilié au 26/28 rives de Clausen
L-2165 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093245/12.
(130114604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Energiae Consult S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8410 Steinfort, 14, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.365.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013093243/10.
(130114144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 46.338.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2013.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013093249/11.
(130114022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100278
L
U X E M B O U R G
Energie Investissements Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 74.919.
Le Bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/05/2013.
Signature.
Référence de publication: 2013093244/10.
(130114459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
EPISO Treptowers Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 159.709.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093246/10.
(130113888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
ERGO Insurance, agissant aussi sous la dénomination de "ERGO", Succursale d'une société de droit
étranger.
R.C.S. Luxembourg B 58.508.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S. Vanacker.
Référence de publication: 2013093247/10.
(130114282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Eurolux Créations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 10, rue du Puits.
R.C.S. Luxembourg B 167.880.
Le bilan au 31 décembre 2012 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09/07/2013.
Référence de publication: 2013093251/10.
(130114233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
European Investment & Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 157.940.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 28 juin 2013i>
L'Assemblée Générale décide avec effet immédiat de transférer le siège social de la société du 55-57, avenue Pasteur
à L-2311 Luxembourg au 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.
L'Assemblée Générale constate le changement d'adresse professionnelle de l'administrateur:
- Monsieur Nico HANSEN demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
L'Assemblée Générale constate également le changement d'adresse du commissaire aux comptes:
- MGI FISOGEST S.àr.l., sise 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
Référence de publication: 2013093254/14.
(130114518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100279
L
U X E M B O U R G
FirstService International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 170.656.
Les Comptes Annuels du 18 Juillet au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2013.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013093263/12.
(130114109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
ExxonMobil Netherlands Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 136.546.
Une déclaration concernant la non-application des dispositions du chapitre IV de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises a été déposée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, ensemble avec les comptes consolidés au 31 décembre 2012
de la société mère, ExxonMobil Luxembourg et Cie, société en commandite par actions, établie au 20, rue de l'Industrie,
L-8069 Bertrange, immatriculée sous le numéro R.C.S. Luxembourg B72560, conformément a l'article 70 de la même loi.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093257/13.
(130113828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fragrance Resources Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 81.420.
Par résolutions signées en date du 24 juin 2013, les associés ont décidé de renouveler le mandat de réviseur d'entre-
prises agréé pour les comptes annuels et les comptes consolidés de H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093266/14.
(130114001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fonds Rusnano Capital SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 155.461.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle en date du 8 juillet 2013i>
Suivant une décision de l'Assemblée Générale Annuelle des associés du 08.07.2013 de la société Fonds Rusnano Capital
S.A. il à été décidé:
Renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, sise au 400, Route d'Esch, B.P.
1443, L-1014, Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société à compter du 08 juillet 2013 jusqu'à
l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014 chargée d'approuver les comptes annuels de la Société au 31 dé-
cembre 2013.
Luxembourg, le 09.07.2013.
Référence de publication: 2013093264/15.
(130114585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100280
L
U X E M B O U R G
Europe Aciers S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 79.628.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2013093253/12.
(130114504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Foodservice & Intellectual Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 162.587.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093265/9.
(130114229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.493.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66721 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093267/10.
(130113809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
FD immobilier, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 170.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013093269/10.
(130114332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
FDD, Financière de développement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 173.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fidupar
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2013093270/13.
(130113975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100281
L
U X E M B O U R G
Europack S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 68.393.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 3 juillet 2013i>
<i>Résolution:i>
- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'accepter la démission de M. Markus KÖLLMANN avec effet au 4
juin 2013.
- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer M. Dimitrios KOUVATSOS, 15, Thiseos Street, 15236
P. Penteli Attiki, Grèce, en tant qu'administrateur B de la société.
- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer M. Ioannis LENTZOS en tant qu'administrateur A en
remplacement de son mandat d'administrateur B.
Les nominations seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Référence de publication: 2013093252/19.
(130114140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fego S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 66.560.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 9 juillet 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013093271/10.
(130114381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fenjefflux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 144.686.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093272/9.
(130114177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Lux-Composition S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9516 Wiltz, 22, rue du 31 Août 1942.
R.C.S. Luxembourg B 92.444.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège le 21 décembre 1999i>
1. L'assemblée accepte la nomination en qualité d'administrateur de:
Monsieur Patrick HURBAIN, demeurant à B-1470 Genappe, Rue Fosty n°19. Son mandat est valable à partir de ce jour
jusqu'à l'assemblée ordinaire de 2000.
2. L'assemblée accepte la démission en qualité d'administrateur de:
Monsieur Robert HURBAIN, demeurant à B-3090 Overijse, Vuurgatstraat n°17.
Pour extrait conforme
Lux-Composition SA
Stephan SCHMITZ / Paul CALLEBAUT / Léon SCHMITZ / Patrick HURBAIN / Robert HURBAIN
Référence de publication: 2013093449/16.
(130114217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100282
L
U X E M B O U R G
Fidco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 75.289.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2013093273/10.
(130114486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fidesco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 68.578.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2013093274/10.
(130114487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
R.C.S. Luxembourg B 51.515.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013093275/10.
(130114002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Fitema Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 49.026.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013093284/10.
(130114367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Findi S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.315.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date du 10 juin 2013i>
Madame Corinne Bitterlich est remplacée comme Gérant par Monsieur Christiaan Van Houtven, C.O.O., SGG S.A.,
résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Madame Noëlle Piccione est remplacée comme Gérant par Monsieur Pascal Wagner, employé privé, résidant profes-
sionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013093280/14.
(130114238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
100283
L
U X E M B O U R G
FRL Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 98.936.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>M. Julien François
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2013093292/14.
(130114377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Erdec Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.800,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 167.239.
In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Erdec Holding S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 167.239 (the Company). The Company was incorporated on March 1, 2012, pursuant to a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 983 dated April 17, 2012.
The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation of the Company.
There appeared:
Mr. Quinten Dreesmann, born on July 12, 1960 in Amsterdam (the Netherlands), residing at 7, Little Boltons GB - SW
109LJ London, United Kingdom (the Sole Shareholder),
here represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal,
which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all of the twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, the one hundred (100)
class A shares, the one hundred (100) class B shares, the one hundred (100) class C shares, the one hundred (100) class
D shares and the one hundred (100) class E shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1)
each, subscribed and fully paid-up, representing the entirety of the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Decrease of the subscribed share capital of the Company by an amount of two hundred euro (EUR 200), in order
to bring the said share capital from its current amount of thirteen thousand euro (EUR 13,000) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) ordinary shares, one hundred (100) class A shares, one hundred (100) class B shares, one
hundred (100) class C shares, one hundred (100) class D shares and one hundred (100) class E shares, all in registered
form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of twelve thousand eight hundred euro (EUR
12,800), by way of the redemption and cancellation of (i) one hundred (100) class B shares, being the entirety of the class
B shares of the Company, and (ii) one hundred (100) class D shares, being the entirety of the class D shares of the
Company;
3. Amendment to article 5.1. of the Articles in order to reflect the redemption and cancellation of the class B shares
and the class D shares, as proposed above;
4. Amendment to article 15.2. of the Articles;
5. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any
100284
L
U X E M B O U R G
partner or employee of Vistra (Luxembourg) S.a r.l., acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
cancellation of the class B shares and the class D shares in the shareholder's register of the Company; and
6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of two hundred euro
(EUR 200), in order to bring the said share capital from its current amount of thirteen thousand euro (EUR 13,000)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, one hundred (100) class A shares, one hundred
(100) class B shares, one hundred (100) class C shares, one hundred (100) class D shares and one hundred (100) class E
shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of twelve thousand eight
hundred euro (EUR 12,800), by way of the redemption and cancellation of (i) one hundred (100) class B shares, being the
entirety of the class B shares of the Company, and (ii) one hundred (100) class D shares, being the entirety of the class
D shares of the Company, and reimboursement to the shareholder.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles which shall be
reworded as follows:
" 5.1. The Company's corporate capital is set at twelve thousand eight hundred euro (EUR 12,800) represented by
twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR
1) each (the Ordinary Shares), one hundred (100) class A shares in registered form having a nominal value of one euro
(EUR 1) each (the Class A Shares), one hundred (100) Class C shares in registered form having a nominal value of one
euro (EUR 1) each (the Class C Shares) and one hundred (100) Class E shares in registered form having a nominal value
of one euro (EUR 1) each (the Class E Shares, and together with the Ordinary Shares, the Class A Shares and the Class
C Shares, the Shares).
The Company may also create and issue additional classes of shares to be designated distinctively as a class that will
track the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares, the Class A Shares,
the Class C Shares and the Class E Shares constitute separate classes of shares in the Company, but rank pari passu in
all respects save as hereinafter specifically provided.
The Class A Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the indirect investment of the Company through Erdec
Finance S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 92.739 (Erdec Finance) in the share capital of Foncierdec S.A.S., a simplified joint stock
company (société par actions simplifiée), duly incorporated and existing under the laws of France having its registered
office at 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, registered with the Register of Commerce and Companies of Paris
under number 438 458 911 (Foncierdec), and any loans and advances made by Erdec Finance to Foncierdec (the Class A
Investment).
The Class C Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the indirect investment of the Company through Erdec
Finance in the share capital of Nimes Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
duly incorporated and existing under the laws of France having its registered office at 28, rue Cambacérès, 75008 Paris,
France, registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under number 450 931 845 (NH), and any
loans and advances made by Erdec Finance to NH (the Class C Investment).
The Class E Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the indirect investment of the Company through Erdec
Finance in the share capital of Erdec S.A.S., a simplified joint stock company (société par actions simplifiée), duly incor-
porated and existing under the laws of France having its registered office at 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France,
registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under number 433 957 016 (Erdec France), and any
loans and advances made by Erdec Finance to Erdec France (the Class E Investment)."
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting further resolves to amend Article 15.2. of the Articles which
shall be reworded as follows:
100285
L
U X E M B O U R G
" 15.2. After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of
the law, all further profits shall be distributed and paid as follows:
(a) the holders of the shares of each class, pro rata to the capital invested by each of them in respect of their shares
(nominal value and, as the case may be, share premium), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and
income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds
and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription
for the shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined
by the Board;
(b) for the avoidance of any doubt:
- the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its indirect investment in the Class A Investment (the Class A
Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i) and (ii) to
be determined by the Board;
- the holders of the Class C Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class C Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i)
any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its indirect investment in the Class C Investment (the Class C
Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class C Investment Net Income, items (i) and (ii) to
be determined by the Board;
- the holders of the Class E Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class E Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its indirect investment in the Class E Investment (the Class E
Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class E Investment Net Income, items (i) and (ii) to
be determined by the Board;
(c) the general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the remainder (if any) of the profits
which are not derived by the Company from a specific investment which performance and returns are tracked by a
particular class of shares. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve
or carry it forward. In case of declaration of payment by the general meeting of the shareholders of all or part of the
remainder of the profits as dividends, such dividends will be paid to the holders of Ordinary Shares on a pro rata basis
to the number of Ordinary Shares held by them.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Lu-
xembourg and to any partner or employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., acting individually, to proceed on behalf of the
Company with the cancellation of the class B shares and the class D shares in the shareholder's register of the Company.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximatively one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said person signed together with the
notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique d'Erdec Holding S.à r.l., une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 167.239 (la Société). La Société a été constituée le 1
er
mars 2012 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au
100286
L
U X E M B O U R G
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 783 du 17 avril 2012. Les statuts de la Société (les Statuts)
n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A comparu:
Monsieur Quinten Dreesmann, né le 12 juillet 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), dont l'adresse est située à 7, Little Boltons,
GB - SW 109LJ Londres, Royaume-Uni (l'Associé Unique),
ici représenté par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, les cent (100) parts sociales
de classe A, les cent (100) parts sociales de classe B, les cent (100) parts sociales de classe C, les cent (100) parts sociales
de classe D et les cent (100) parts sociales de classe E toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune, souscrites et entièrement libérées, représentant l'intégralité du capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux cent euros (EUR 200) afin de le porter de son
montant actuel de treize mille euros (EUR 13.000), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordi-
naires, cent (100) parts sociales de classe A, cent (100) parts sociales de classe B, cent (100) parts sociales de classe C,
cent (100) parts sociales de classe D et cent (100) parts sociales de classe E, toutes sous forme nominative, ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1) chacune, à douze mille huit cents euros (EUR 12.800) par le rachat et l'annulation de (i) cent (100) parts sociales de
classe B, représentant l'intégralité des parts sociales de classe B et (ii) cent (100) parts sociales de classe D, représentant
l'intégralité des parts sociales de classe D;
3. Modification de l'article 5.1. des Statuts afin de refléter le rachat et l'annulation des parts sociales de classe B et des
parts sociales de classe D tel que mentionné ci-dessus;
4. Modification de l'article 15.2. des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé
ou employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'annulation des parts sociales de classe B et des parts sociales de classe D dans le registre des associés de la Société; et
6. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant
d'enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent euros (EUR 200) afin de le
porter de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13.000), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts
sociales ordinaires, cent (100) parts sociales de classe A, cent (100) parts sociales de classe B, cent (100) parts sociales
de classe C, cent (100) parts sociales de classe D et cent (100) parts sociales de classe E, toutes sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune, à douze mille huit cents euros (EUR 12.800) par le rachat et l'annulation de (i) cent (100) parts
sociales de classe B, représentant l'intégralité des parts sociales de classe B et (ii) cent (100) parts sociales de classe D,
représentant l'intégralité des parts sociales de classe D et remboursement à l'actionnaire.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura dé-
sormais le libellé suivant:
" 5.1. Le capital social est fixé à douze mille huit cents euros (EUR 12.800), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts
Sociales Ordinaires), 100 (cent) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A), 100 (cent) parts sociales de classe C sous forme nominative ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe C) et 100 (cent) parts sociales de classe E sous
100287
L
U X E M B O U R G
forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe E, et ensemble avec
les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales).
La Société peut également créer et émettre des autres classes de parts sociales qu'il faudra désigner différemment
comme une classe qui tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront. Les Parts Sociales
Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe E forment des
classes séparées de parts sociales dans la Société, mais ont les mêmes droits et obligations à tous égards sauf disposition
particulière ci-après.
Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement indirect de la
Société via Erdec Finance S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 92.739 (Erdec Finance) dans le capital social de Foncierdec S.A.S., une société par
actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 438 458 911 (Foncierdec), et tous prêts ou
avances consentis par Erdec Finance à Foncierdec (l'Investissement de Classe A).
Les Parts Sociales de Classe C tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement indirect de la
Société via Erdec Finance dans le capital social de Nimes Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
français, ayant son siège social au 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 450 931 845 (NH), et tous prêts ou avances consentis par Erdec Finance à
NH (l'Investissement de Classe C).
Les Parts Sociales de Classe E tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement indirect de la
Société via Erdec Finance dans le capital social de Erdec S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français de droit
français, ayant son siège social au 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 150 931 845 (Erdec France), et tous prêts ou avances consentis par Erdec
Finance à Erdec France (l'Investissement de Classe E)."
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 16.2. des Statuts, qui aura
désormais le libellé suivant:
" 15.2. Après l'affectation de tous bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions
obligatoires légales, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:
(a) les détenteurs des parts sociales de chaque classe, au prorata du capital investi par chacun d'entre eux pour leurs
parts sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), auront droit à un dividende égal à (i) tous produits et
revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des
ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les produits de la
souscription pour les parts sociales de cette classe, moins (ii) tous frais directement liés à cet investissement, les points
(i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil;
(b) en tout état de cause:
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement indirect dans l'Inves-
tissement de Classe A (le Revenu Net d'Investissement de Classe A) moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe C au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe C pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement indirect dans l'Inves-
tissement de Classe C (le Revenu Net d'Investissement de Classe C) moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe C, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe E au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe E pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement indirect dans l'Inves-
tissement de Classe E (le Revenu Net d'Investissement de Classe E) moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe E, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil;
(c) l'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus (le cas échéant) des bénéfices
qui ne sont pas dérivés par la Société d'un investissement spécifique dont la performance et le rendement sont tracés
100288
L
U X E M B O U R G
par une classe de parts sociales spécifique. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le
transférer à la réserve ou le reporter. En cas de déclaration de paiement par l'assemblée générale des associés de la
totalité ou d'une partie du surplus des bénéfices sous forme de dividendes, ces dividendes seront versés aux détenteurs
des Parts Sociales Ordinaires sur une base proportionnelle au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et
à tout associé ou employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de
la Société à l'annulation des parts sociales de classe B et des parts sociales de classe D dans le registre des associés de la
Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même partie
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé, ensemble avec le
notaire, le présent acte original.
Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juin 2013. Relation: LAC/2013/27393. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Référence de publication: 2013096817/294.
(130118229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Perseus Immobilien Gesellschaft 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 127.221.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2013i>
Sitzverlegung
Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 55-57, avenue Pasteur L-2311
Luxembourg nach 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg zu verlegen.
<i>Geschäftsführeri>
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt als Kategorie B Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung von GS Lux
Management Services S.à r.l., W2007 Parallel Bear S.à r.l. und Whitehall Bear S.à r.l., an.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Daniel AEGERTER, geboren in Gurzelen
(Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft Rigistraße 7 CH-8126 Zuminkon (Schweiz), als Kategorie A Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Martin RECHSTEINER, geboren in Lachen,
(Schweiz) am 19. Juli 1977, wohnhaft Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht, Zurich, (Schweiz) als Kategorie A Geschäftsführer
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Nico HANSEN, geboren in Differdange, am
31. März 1969, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf unbes-
timmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbruck
am 25. August 1972, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
100289
L
U X E M B O U R G
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (Frankreich)
am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Geschäftsführer sind:
Name
Fonktion
Herr Daniel Aegerter
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Simon König
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Martin Rechsteiner
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Nico Hansen
Kategorie B Geschäftsführer
Herr Alain Bartholme
Kategorie B Geschäftsführer
Frau Sophie Batardy
Kategorie B Geschäftsführer
<i>Gesellschafteri>
Die Gesellschafter Perseus Real Estate Investment S.à r.l. hat Ihr Gesellschaftssitz nach 681, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg verlegt.
Référence de publication: 2013096317/41.
(130116480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
GPO Advisory (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 122.706.
In the year two thousand and thirteen, on the twelfth of June;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
The limited company incorporated and existing under the laws of the Hon Kong "Goodman Logistics (HK) Limited",
established and having its registered office in Hong Kong, 1, Queen's Road East, Three Pacific Place (People's Republic of
China), registered with the Companies Registry of Hong Kong number 1700359,
here represented by Monsieur Alvin SICRE, employee, residing professionally in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company "GPO Advisory (Lux) S.à r.l.", (the "Company"), established and having its
registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered with the Trade and Companies' Registry
of Luxembourg, section B, under the number 122706, has been originally incorporated under the name of "MGPO Ad-
visory S.à r.l.", by deed of M
e
Jacques DELVAUX, notary then residing in Luxembourg, on November 27, 2006, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 176 of February 14, 2007,
and that the articles of association have been amended pursuant to a deed of M
e
Jean-Joseph WAGNER, notary
residing in Sanem, on June 28, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2073 of
September 24, 2007, containing notably the adoption by the Company of its current denomination;
- That the appearing party is the sole actual partner (the "Sole Partner") of the Company and that it has taken, through
its proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner decides to change the financial year of the Company, so that it shall henceforth run from July 1st of
each year to June 30 of the following year and to subsequently amend point 1 of article 11 of the by-laws in order to give
it the following wordings:
" 11.1. Fiscal Year. The Company's financial year starts on the July 1
st
of each year and ends on the June 30 of the
following year."
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner states that the current financial year will be exceptionally shortened, so that the same financial year,
started on January 1
st
, 2013, will end on June 30, 2013.
100290
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
For the case where the number of shareholders exceeds twenty-five, the Sole Partner decide to change the date of
the annual general meeting in order to be forthwith held on the 1
st
Monday of the month of November at 03:00 p.m.
and to consequently amend point 1 of article 9 of the by-laws as follows:
" 9.1. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held,
in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 1
st
Monday of the month of November at 03:00 p.m.."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred and thirty-five
Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le douze juin;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société anonyme constituée et existant sous les lois de Hong Kong "Goodman Logistics (HK) Limited", établie et
ayant son siège social à Hong Kong, 1, Queen's Road East, Three Pacific Place (République Populaire de Chine), inscrite
au Companies Registry of Hong Kong sous le numéro 1700359,
ici représentée par Monsieur Alvin SICRE, employé, demeurant professionnellement à L-1160 Luxembourg, 28, bou-
levard d'Avranches, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée
ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec
lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée "GPO Advisory (Lux) S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social
à L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 122706, a été originairement constituée sous le nom de "MGPO Advisory S.à r.l.", suivant acte
reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 27 novembre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 176 du 14 février 2007,
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,
le 28 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2073 du 24 septembre 2007, contenant
notamment l'adoption par la Société de sa dénomination actuelle;
- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa
mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de changer l'année sociale de la Société, de sorte qu'elle courra désormais du 1
er
juillet de
chaque année au 30 juin de l'année suivante et de modifier subséquemment le point 1 de l'article 11 des statuts afin de
lui donner la teneur suivante:
" 11.1. Exercice Social. L'année sociale commence le 1
er
juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année
suivante."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée unique déclare en outre que l'année sociale en cours sera exceptionnellement raccourcie, de sorte que
cette même année sociale, ayant débuté le 1
er
janvier 2013, se terminera le 30 juin 2013.
100291
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
Pour le cas où le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, l'Associée Unique décide de changer la date de
l'assemblée générale annuelle, de sorte qu'elle se tiendra dans l'avenir le 1
er
lundi du mois de novembre à 15.00 heures
et de modifier conséquemment le point 1 de l'article 9 des statuts comme suit:
" 9.1. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue,
conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé
dans la convocation de l'assemblée, le 1
er
premier lundi du mois de novembre à 15.00 heures."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent trente-
cinq euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. SICRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juin 2013. LAC/2013/26961. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013096940/109.
(130117591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Perseus Immobilien Gesellschaft 10, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 132.808.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2013i>
Sitzverlegung
Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 55-57, avenue Pasteur L-2311
Luxembourg nach 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg zu verlegen.
<i>Geschäftsführeri>
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt als Kategorie B Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung von GS Lux
Management Services S.à r.l., W2007 Parallel Bear S.à r.l. und Whitehall Bear S.à r.l., an.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Daniel AEGERTER, geboren in Gurzelen
(Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft Rigistraße 7 CH-8126 Zuminkon (Schweiz), als Kategorie A Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Martin RECHSTEINER, geboren in Lachen,
(Schweiz) am 19. Juli 1977, wohnhaft Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht, Zurich, (Schweiz) als Kategorie A Geschäftsführer
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Nico HANSEN, geboren in Differdange, am
31. März 1969, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf unbes-
timmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbruck
am 25. August 1972, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (Frankreich)
am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
100292
L
U X E M B O U R G
Die Geschäftsführer sind:
Name
Fonktion
Herr Daniel Aegerter
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Simon König
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Martin Rechsteiner
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Nico Hansen
Kategorie B Geschäftsführer
Herr Alain Bartholmé
Kategorie B Geschäftsführer
Frau Sophie Batardy
Kategorie B Geschäftsführer
<i>Gesellschafteri>
Die Gesellschafter Perseus Real Estate Investment S.à r.l. hat Ihr Gesellschaftssitz nach 681, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg verlegt.
Référence de publication: 2013096318/41.
(130116841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Perseus Immobilien Gesellschaft 11, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 132.800.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2013i>
Sitzverlegung
Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 55-57, avenue Pasteur L-2311
Luxembourg nach 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg zu verlegen.
<i>Geschäftsführeri>
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt als Kategorie B Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung von GS Lux
Management Services S.à r.l., W2007 Parallel Bear S.à r.l. und Whitehall Bear S.à r.l., an.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Daniel AEGERTER, geboren in Gurzelen
(Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft Rigistraße 7 CH-8126 Zuminkon (Schweiz), als Kategorie A Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Martin RECHSTEINER, geboren in Lachen,
(Schweiz) am 19. Juli 1977, wohnhaft Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht, Zurich, (Schweiz) als Kategorie A Geschäftsführer
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Nico HANSEN, geboren in Differdange, am
31. März 1969, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf unbes-
timmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbruck
am 25. August 1972, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (Frankreich)
am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Geschäftsführer sind:
Name
Fonktion
Herr Daniel Aegerter
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Simon König
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Martin Rechsteiner
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Nico Hansen
Kategorie B Geschäftsführer
Herr Alain Bartholmé
Kategorie B Geschäftsführer
Frau Sophie Batardy
Kategorie B Geschäftsführer
<i>Gesellschafteri>
Die Gesellschafter Perseus Real Estate Investment S.à r.l. hat Ihr Gesellschaftssitz nach 681, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg verlegt.
Référence de publication: 2013096319/41.
(130116753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
100293
L
U X E M B O U R G
H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 126.452.
In the year two thousand and thirteen, on the second day of the month of July;
before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "H-Hohestr./ Kaiserstr. S.à r.l." (the
"Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 126.452 incorporated
on 27 March 2007 by deed of Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Remich, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1113 of 9 June 2007.
The meeting was presided by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mrs Flora Gibert, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed
by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all one hundred (100) shares in issue in the Company were represented at
the general meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that
the meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
- Amendment of first paragraph of article 10 of the articles of association of the Company so as to provide for the
possibility to revoke managers with or without cause, so as to read as follows:
Art. 10. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. They are appointed and removed from
office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term
of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be
re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
After deliberation the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolved to amend first paragraph of article 10 of the articles as set forth in the agenda.
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at eight hundred euros (EUR 800.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed has been executed in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le deuxième jour du mois de juillet,
par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés Assemblée») de «H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund
S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 126.452, constituée le
27 mars 2007 suivant un acte reçu du notaire Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1113 du 9 juin 2007.
L'assemblée a été présidée par Madame Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.
A été nommé secrétaire et scrutateur Madame Flora Gibert, employée privée, résidant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
100294
L
U X E M B O U R G
1. Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée
par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent
acte afin d'être soumise aux formalités de l'enregistrement.
Il appert de ladite liste de présence que la totalité des cent (100) parts sociales émises de la Société était représentée
à l'assemblée générale et les associés de la Société ont déclaré avoir pris connaissance de l'ordre du jour au préalable, de
sorte que l'assemblée était valablement constituée et pouvait valablement prendre des décisions sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Modification du premier paragraphe de l'article dix des statuts de la Société comme suit:
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale
des associés statuant à la majorité simple, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est
indiquée, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles, mais leur nomination est
également révocable avec ou sans motif (ad nutum) et ce, à tout moment.
Après délibération, l'assemblée a pris la décision suivante à l'unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article dix des statuts tels qu'il figure à l'ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société sont estimés
à huit cents euros (EUR 800,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties aux pré-
sentes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes
parties comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, les membres du Bureau et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 5 juillet 2013. Relation: LAC/2013/31293. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2013096949/85.
(130117147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Perseus Immobilien Gesellschaft 4, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 132.803.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2013i>
Sitzverlegung
Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 55-57, avenue Pasteur L-2311
Luxembourg nach 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg zu verlegen.
<i>Geschäftsführeri>
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt als Kategorie B Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung von GS Lux
Management Services S.à r.l., W2007 Parallel Bear S.à r.l. und Whitehall Bear S.à r.l., an.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Daniel AEGERTER, geboren in Gurzelen
(Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft Rigistraße 7 CH-8126 Zuminkon (Schweiz), als Kategorie A Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Martin RECHSTEINER, geboren in Lachen,
(Schweiz) am 19. Juli 1977, wohnhaft Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht, Zurich, (Schweiz) als Kategorie A Geschäftsführer
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Nico HANSEN, geboren in Differdange, am
31. März 1969, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf unbes-
timmte Zeit zu ernennen.
100295
L
U X E M B O U R G
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbruck
am 25. August 1972, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (Frankreich)
am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Geschäftsführer sind:
Name
Fonktion
Herr Daniel Aegerter
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Simon König
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Martin Rechsteiner
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Nico Hansen
Kategorie B Geschäftsführer
Herr Alain Bartholme
Kategorie B Geschäftsführer
Frau Sophie Batardy
Kategorie B Geschäftsführer
<i>Gesellschafteri>
Die Gesellschafter Perseus Real Estate Investment S.à r.l. hat Ihr Gesellschaftssitz nach 681, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg verlegt.
Référence de publication: 2013096320/41.
(130116635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Perseus Immobilien Gesellschaft 5, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 132.802.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2013i>
Sitzverlegung
Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 55-57, avenue Pasteur L-2311
Luxembourg nach 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg zu verlegen.
<i>Geschäftsführeri>
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt als Kategorie B Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung von GS Lux
Management Services S.à r.l., W2007 Parallel Bear S.à r.l. und Whitehall Bear S.à r.l., an.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Daniel AEGERTER, geboren in Gurzelen
(Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft Rigistraße 7 CH-8126 Zuminkon (Schweiz), als Kategorie A Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Martin RECHSTEINER, geboren in Lachen,
(Schweiz) am 19. Juli 1977, wohnhaft Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht, Zurich, (Schweiz) als Kategorie A Geschäftsführer
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Nico HANSEN, geboren in Differdange, am
31. März 1969, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf unbes-
timmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbruck
am 25. August 1972, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (Frankreich)
am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Geschäftsführer sind:
Name
Fonktion
Herr Daniel Aegerter
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Simon König
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Martin Rechsteiner
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Nico Hansen
Kategorie B Geschäftsführer
Herr Alain Bartholme
Kategorie B Geschäftsführer
Frau Sophie Batardy
Kategorie B Geschäftsführer
100296
L
U X E M B O U R G
<i>Gesellschafteri>
Die Gesellschafter Perseus Real Estate Investment S.à r.l. hat Ihr Gesellschaftssitz nach 681, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg verlegt.
Référence de publication: 2013096321/41.
(130116675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 178.570.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the first day of July.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
HayFin Jade LuxCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS),
here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of
a power of attorney given in Luxembourg, on 1
st
July 2013,
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit, loans, receivables and other debt instruments and, more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of
patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
100297
L
U X E M B O U R G
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty
five (125) shares in registered form, having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders
6.8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders
will not terminate the Company.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
100298
L
U X E M B O U R G
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, provided that
if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken
by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one
or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B
manager votes in favour of the resolution. Such quorum cannot exist if there is a preponderance of managers physically
present in one country unless that country is the Grand Duchy of Luxembourg.
(vi) Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting, which must be physically
present in the Grand Duchy of Luxembourg, or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The signature of the sole manager shall bind the Company. If several managers are appointed, the joint signature of
any two managers, or, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B
managers, the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager, shall bind the Company.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
100299
L
U X E M B O U R G
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year. The Company’s first financial year begins on the date of its incorporation and ends on the thirty-
first (31) of December 2014. Thereafter, each financial year shall begin on the first (1) of January and ends on the thirty-
first (31) of December of each year.
Art. 14. Financial Statements.
14.1. Each year, with reference to the end of the financial year, the Company’s accounts shall be established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
14.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
100300
L
U X E M B O U R G
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2014.
<i>Subscription and Paymenti>
HayFin Jade LuxCo 1 S.à r.l., represented as stated above, subscribes to one hundred twenty five (125) shares in
registered form, having a nominal value of one hundred euros (EUR 100,.-) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company as was
evidenced to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
(i) Mrs Carmen lonescu, born on 26 March 1974 in Bucharest (Romania), with professional address at 124, boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, as class A manager;
(ii) Mr Tej Gujadhur, born on 21 October 1971 in Curepipe (Mauritius), with professional address at 9th Floor Orange
Tower, Ebene, Cybercity (Mauritius), as class A manager;
(iii) Mrs Heike Kubica, born on 23 July 1974 in Lutherstadt Eisleben (Germany), with professional address at 2, Bou-
levard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, as class B manager; and
(iv) Mr Rolf Caspers, born on 12 March 1968 in Trier (Germany), with professional address at 2, Boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, as class B manager.
2. The registered office of the Company is located at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille treize, le premier jour de juillet
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
HayFin Jade LuxCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, dont l’enregistrement auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) est en cours,
représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Luxembourg, le 1
er
juillet 2013.
100301
L
U X E M B O U R G
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l." (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt, prêts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mo-
bilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
100302
L
U X E M B O U R G
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu’elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés.
6.8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin
à la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil seront valablement prises
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de
classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur
de la décision. Un tel quorum ne peut être atteint s'il existe une majorité de gérants physiquement présents dans un pays
autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
(vi) Les décisions du Conseil, sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion, qui doit
être physiquement présent au Grand-Duché de Luxembourg, ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables
et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
100303
L
U X E M B O U R G
8.3. Représentation
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. Si plusieurs gérants sont nommés, la Société sera engagée
par les signatures conjointes de deux gérants ou, si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social. Le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et finit le
trente-et-un (31) décembre 2014. Chaque exercice social suivant commencera le premier (1) janvier et se terminera le
trente-et-un (31) décembre de chaque année.
100304
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Approbation des comptes annuels.
14.1. Par référence à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis chaque année et le gérant, ou en
cas de pluralité de gérants, le Conseil, prépare un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
14.2. Chaque actionnaire peut prendre inspection de l’inventaire susmentionné et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Commissaires / Réviseurs d’entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
15.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
16.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
17.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
18.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
18.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
100305
L
U X E M B O U R G
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente-et-un (31) décembre
2014.
<i>Souscription et Libérationi>
HayFin Jade LuxCo 1 S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-cinq (125) parts
sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l’intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée illimitée:
(i) Mme Carmen lonescu, née le 26 mars 1974 à Bucarest (Roumanie), avec adresse personnelle est au 124, boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, en tant que gérant de classe A;
(ii) M. Tej Gujadhur, né le 21 octobre 1971 à Curepipe (Ile Maurice), avec adresse professionnelle au 9
th
Floor Orange
Tower, Ebene, Cybercity (Ile Maurice), en tant que gérant de classe A;
(iii) Mme Heike Kubica, née le 23 juillet 1974 à Lutherstadt Eisleben (Allemagne), avec adresse professionnelle au 2,
Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en tant que gérant de classe B; et
(iv) M. Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trier (Allemagne), avec adresse professionnelle au 2, Boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.
2. Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 3 juillet 2013. Relation: LAC/2013/30832. Reçu soixante quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Référence de publication: 2013096955/519.
(130117124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
HayFin DLF (GBP Parallel) LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 178.572.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the first day of July
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
HayFin Direct Lending Fund Cayco (GBP Parallel) Limited, a limited company organized and existing under the laws
of the Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Cayman Islands Registrar under number WK-278741,
here represented by Ms Sara Lecomte, private employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of
a power of attorney given in Grand Cayman, Cayman Islands, on June 25, 2013,
100306
L
U X E M B O U R G
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "HayFin DLF (GBP Parallel) LuxCo 1 S.à r.l." (the Company). The Company
is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit, loans, receivables and other debt instruments and, more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of
patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-), represented by one
hundred twenty five (125) shares in registered form, having a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100.-)
each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
100307
L
U X E M B O U R G
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders
6.8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders
will not terminate the Company.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, provided that
if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken
by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one
or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B
manager votes in favour of the resolution. Such quorum cannot exist if there is a preponderance of managers physically
present in one country unless that country is the Grand Duchy of Luxembourg.
(vi) Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting, which must be physically
present in the Grand Duchy of Luxembourg, or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The signature of the sole manager shall bind the Company. If several managers are appointed, the joint signature of
any two managers, or, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B
managers, the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager, shall bind the Company.
100308
L
U X E M B O U R G
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general
meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year. The Company's first financial year begins on the date of its incorporation and ends on the thirty-
first (31) of December 2014. Thereafter, each financial year shall begin on the first (1) of January and ends on the thirty-
first (31) of December of each year.
Art. 14. Financial Statements.
14.1. Each year, with reference to the end of the financial year, the Company's accounts shall be established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.
14.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
100309
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
15.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
16.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2014.
<i>Subscription and Paymenti>
HayFin Direct Lending Fund Cayco (GBP Parallel) Limited, represented as stated above, subscribes to one hundred
twenty five (125) shares in registered form, having a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100.-) each, and
100310
L
U X E M B O U R G
agrees to pay them in full by a contribution in cash of twenty-five thousand pounds sterling (GBP 25,000.-), The aggregate
amount of the contribution is to be allocated as follows:
- twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) to the nominal share capital account of the Company;
and
- twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) to the share premium account of the Company.
The amount of twenty-five thousand pounds sterling (GBP 25,000.-) is at the free disposal of the Company as was
evidenced to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an unlimited duration:
(i) Mr John Molloy, born on 9 March 1962 in Gaillimh/Galway (Ireland), with personal address at 6, rue du Château,
L-6961 Senningen (Grand Duchy of Luxembourg), as class A manager;
(ii) Mr Tej Gujadhur, born on 21 October 1971 in Curepipe (Mauritius), with professional address is 9th Floor Orange
Tower, Ebene, Cybercity (Mauritius), as class A manager;
(iii) Mrs Heike Kubica, born on 23 July 1974 in Lutherstadt Eisleben (Germany), with professional address at 2, Bou-
levard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, as class B manager; and
(iv) Mr Rolf Caspers, born on 12 March 1968 in Trier (Germany), with professional address at 2, Boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, as class B manager.
2. The registered office of the Company is located at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le premier jour du mois de juillet
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
HayFin Direct Lending Fund Cayco (GBP Parallel) Limited, une société régie et existant sous le droit des Iles Caïmans,
ayant son siège social à 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, enregistrée auprès
du registre des Iles Caïmans sous le numéro WK-278741,
représentée par Madame Sara Lecomte, employee privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Grand Cayman, Cayman Islands, le 25 juin 2013.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est " HayFin DLF (GBP Parallel) LuxCo 1 S.à r.l." (la Société). La Société
est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
100311
L
U X E M B O U R G
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt, prêts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mo-
bilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent livres sterling (GBP 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés.
6.8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin
à la Société.
100312
L
U X E M B O U R G
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil seront valablement prises
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition qu'un ou les associés ont nommé un ou plusieurs
gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent
en faveur de la décision. Un tel quorum ne peut être atteint s'il existe une majorité de gérants physiquement présents
dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
(vi) Les décisions du Conseil, sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion, qui doit
être physiquement présent au Grand-Duché de Luxembourg, ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre
moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables
et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. Si plusieurs gérants sont nommés, la Société sera engagée
par les signatures conjointes de deux gérants ou, à la si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
100313
L
U X E M B O U R G
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social. Le premier exercice social de la Société commence à la date de sa constitution et finit le
trente-et-un (31) décembre 2014. Chaque exercice social suivant commencera le premier (1) janvier et se terminera le
trente-et-un (31) décembre de chaque année.
Art. 14. Approbation des comptes annuels.
14.1. Par référence à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis chaque année et le gérant, ou en
cas de pluralité de gérants, le Conseil, prépare un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
14.2. Chaque actionnaire peut prendre inspection de l'inventaire susmentionné et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
15.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
100314
L
U X E M B O U R G
16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions Générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente-et-un (31) décembre
2014.
<i>Souscription et Libérationi>
HayFin Direct Lending Fund Cayco (GBP Parallel) Limited, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à
cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-)
chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq mille livres sterling (GBP
25.000,-). Le montant intégral de l'apport est alloué comme suit:
- douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) au capital social nominal de la Société; et
- douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) au compte de primes d'émission de la Société.
Le montant de vingt-cinq mille livres sterling (GBP 25.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé
au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
100315
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée illimitée:
(i) M. John Molloy, né le 9 mars 1962 à Gaillimh/Galway (Irlande), avec adresse personnelle au 6 rue du Château, L-6961
Senningen (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de catégorie A;
(ii) M. Tej Gujadhur, né le 21 octobre 1971 à Curepipe (Ile Maurice), avec adresse professionnelle au 9
th
Floor Orange
Tower, Ebene, Cybercity (Ile Maurice), en tant que gérant de catégorie A;
(iii) Mme Heike Kubica, née le 23 juillet 1974 à Lutherstadt Eisleben (Allemagne), avec adresse professionnelle au 2,
Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B; et
(iv) M. Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trier (Allemagne), avec adresse professionnelle au 2, Boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.
2. Le siège social de la Société est établi au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg AC, le 3 juillet 2013. Relation: LAC/2013/30834. Reçu soixante quinze euros (75,- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la Société sur sa demande
Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Référence de publication: 2013096952/527.
(130117163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Fondation Lëtzeburger Kannerduerf, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-7534 Mersch, 10, rue H. Gmeiner.
R.C.S. Luxembourg G 5.
Etablissement d'utilité publique
Village d'Enfants SOS de Luxembourg
Constituée par acte du Notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, le 29 mars 1973, Approuvée par Arrêté
Grand-Ducal du 26 avril 1973.
Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C, N°116 du 9 juillet 1973.
Statuts modifiés par résolution du conseil d'administration du 8 juin 2000,
modification publiée au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C, N°893 du 15 décembre 2000
N° R.C.S Luxembourg G5
<i>Exercice 2012i>
Toutes les indications sont en €
<i>Bilan au 31.12.2012i>
ACTIF
Actif immobilisé
IMMOBILISATIONS CORPORELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.932.055,46
ACOMPTES VERSES ET IMMOB.CORP. EN COURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
644.815,99
Actif circulant
CREANCES - AUTRES CREANCES DONT LA DUREE RESIDUELLE EST INFERIEURE OU
EGALE A UN AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.165.394,25
AVOIRS EN BANQUES, VALEURS MOBILIERES, AVOIRS EN COMPTES CHEQUES POSTAUX,
CHEQUES ET CAISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.383.009,85
COMPTE DE RÉGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.989,59
28.152.265,14
100316
L
U X E M B O U R G
PASSIF
Fonds Propres AVOIR SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE PRECEDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.847.264,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.951.084,87
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - ÉTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.978.978,62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - AUTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
764.596,23
Dettes
DETTES SUR ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES DONT LA DUREE RESIDUELLE EST
INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.591,44
DETTES FISCALES ET DETTES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE DONT LA DUREE
RESIDUELLE ET INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193.313,50
AUTRES DETTES DONT LA DUREE RESIDUELLE EST INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . .
279.436,00
28.152.265,14
** Immobilisations nettes
<i>Compte de Résultat au 31.12.2012i>
Libellés en €
DÉBIT
€
FRAIS DE PERSONNEL
Traitements, Salaires bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.113.493,75
Charges Sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
832.974,07
FRAIS DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.675.804,30
DOTATIONS AUX FONDS DÉDIÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.009,59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490.677,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.951.084,87
11.088.043,65
CRÉDIT
€
SUBVENTIONS RECUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.790.301,68
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.793,47
INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140.963,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.062.984,91
11.088.043,65
<i>Budget 2013i>
RECETTES
MRC - PAIEMENT ELTEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.000,00 €
ACV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,00 €
LOCATIONS DIVERSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.000,00 €
DONS/ DONATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850.000,00 €
RECETTES SUMMERFEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000,00 €
LEGS SANS DROIT DE REPRISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000,00 €
SUBVENTION MIFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.650.000,00 €
CONVENTION KD
FORFAITS JOURNALIERS
FORFAITS HORAIRES
CISP
MRC
FRAIS SPECIFIQUES-SUIVI
FRAIS SPECIFIQUES-MEDICAUX
FRAIS SPECIFIQUES-LOYERS/CONTRAT D'ENTRETIEN
FRAIS DE FORMATION
FAMILLES D'ACCUEIL
SUPERVISION FAMILLES D'ACCUEIL
AUTRES SUBSIDES
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,00 €
PRODUITS FINANCIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000,00 €
100317
L
U X E M B O U R G
AUTRES PROD.EXCEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,00 €
PART. DE L'ASBL AUX FRAIS ADMINISTRATIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,00 €
QUOTE PART DES SUB.D'INV.VIREE AU RESULTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220.000,00 €
Total des recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.451.000,00 €
DEPENSES
Budget 2013
FRAIS DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.726.078,43 €
FRAIS DE PERSONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000,00 €
DCV SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000,00 €
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR FONDS DÉDIÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,00 €
Total des dépenses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.731.078,43 €
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
719.921,57 €
Signatures
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2013096866/97.
(130117796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
ISIWIS Research S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.500.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.711.
En date du 14 juin 2013, et avec effet au 1
er
janvier 2013, les cessions de parts sociales suivantes ont eu lieu:
- l'associée Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé l'inté-
gralité des 27 531 parts sociales qu'elle détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., avec siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert;
- l'associé Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé
l'intégralité des 1 065 462 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l.,
précitée, qui les acquiert;
- l'associé René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé l'inté-
gralité des 748 719 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée, qui
les acquiert;
- l'associée Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé l'inté-
gralité des 8 544 parts sociales qu'elle détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée, qui
les acquiert;
- l'associé Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé l'in-
tégralité des 63 466 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée,
qui les acquiert;
- l'associé Javed Rahman, avec adresse professionnelle au 88, De Veoux Rd, Princeton TWR, 33B, West Hong Kong,
Hong Kong, a cédé l'intégralité des 10 191 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations
S.à r.l., précitée, qui les acquiert;
- l'associé Jean-Marc Goossens, avec adresse au 10, Allée du Bois de Bercuit, 1390 Grez-Doiceau, Belgique, a cédé
l'intégralité des 12 500 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée,
qui les acquiert;
- l'associé James Brasher, avec adresse à Petit Hiboux, Mont Isaac, JE3 1GB St Lawrence, Jersey, a cédé l'intégralité
des 26 812 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée, qui les
acquiert;
- l'associé Maflolu Investments Limited, avec siège social au 11, Limassol Avenue, Galatariotis Building, 2112 Nicosia,
Chypre, a cédé l'intégralité des 18 987 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations
S.à r.l., précitée, qui les acquiert;
- l'associé Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé
l'intégralité des 26 582 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée,
qui les acquiert;
- l'associé Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé l'in-
tégralité des 29 317 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée,
qui les acquiert;
100318
L
U X E M B O U R G
- l'associé Adriaan Kolff, avec adresse au 131, Ardsley Road, NY10583 Scarsdale, Etats-Unis a cédé l'intégralité des 23
734 parts sociales qu'il détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée, qui les acquiert;
- l'associée Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé l'inté-
gralité des 18 987 parts sociales qu' elle détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée,
qui les acquiert;
- l'associée Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé
l'intégralité des 142 405 parts sociales qu'elle détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l.,
précitée, qui les acquiert;
En date du 28 juin 2013, et avec effet au 1
er
janvier 2013, l'associé Vilmeid Investments Limited, avec siège social au
11, Limassol Avenue, Galatariotis Building, 2112 Nicosia, Chypre, a cédé l'intégralité des 276 763 parts sociales qu'il
détient dans la Société à la société Alter Domus Participations S.à r.l., précitée, qui les acquiert.
Suite à ces cessions de parts sociales, Alter Domus Participations S.à r.l., précitée, est l'associé unique de la Société
en détenant l'intégralité des 2.500.000 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Référence de publication: 2013097011/57.
(130117518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2013.
Global Ventures S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.986,69.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 69.727.
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS
B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146
Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et
ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882
Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B
99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
Luxembourg, le 15 avril 2013.
<i>Pour GLOBAL VENTURES S.A.i>
Référence de publication: 2013093309/24.
(130114454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Perseus Immobilien Gesellschaft 9, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 132.806.
<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2013i>
Sitzverlegung
Die Hauptversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Gesellschaftssitz von 55-57, avenue Pasteur L-2311
Luxembourg nach 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg zu verlegen.
<i>Geschäftsführeri>
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt als Kategorie B Geschäftsführer, mit sofortiger Wirkung von GS Lux
Management Services S.à r.l., W2007 Parallel Bear S.à r.l. und Whitehall Bear S.à r.l., an.
100319
L
U X E M B O U R G
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Daniel AEGERTER, geboren in Gurzelen
(Schweiz) am 20. Juli 1969, wohnhaft Rigistraße 7 CH-8126 Zuminkon (Schweiz), als Kategorie A Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Martin RECHSTEINER, geboren in Lachen,
(Schweiz) am 19. Juli 1977, wohnhaft Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht, Zurich, (Schweiz) als Kategorie A Geschäftsführer
auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Nico HANSEN, geboren in Differdange, am
31. März 1969, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf unbes-
timmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Herrn Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbruck
am 25. August 1972, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung, Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (Frankreich)
am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg als Kategorie B Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit zu ernennen.
Die Geschäftsführer sind:
Name
Fonktion
Herr Daniel Aegerter
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Simon König
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Martin Rechsteiner
Kategorie A Geschäftsführer
Herr Nico Hansen
Kategorie B Geschäftsführer
Herr Alain Bartholmé
Kategorie B Geschäftsführer
Frau Sophie Batardy
Kategorie B Geschäftsführer
<i>Gesellschafteri>
Die Gesellschafter Perseus Real Estate Investment S.à r.l. hat Ihr Gesellschaftssitz nach 681, rue de Neudorf L-2220
Luxembourg verlegt.
Référence de publication: 2013096323/41.
(130116808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.
Golden Lions S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 300.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 42.649.
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS
B 99746 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146
Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et
ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882
Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,
L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B
99739 et ayant son siège social suite à son transfert de siège intervenu le 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach,
L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement de Madame Rika Mamdy.
Luxembourg, le 15 avril 2013.
<i>Pour GOLDEN LIONS S.A.i>
Référence de publication: 2013093310/24.
(130114453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
100320
Bora
C.A.T. Holding S.A.
Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.
C-Rights S.à r.l.
C.RO Ports S.A.
Danir B S.A.
DB PEP V
Double Green S.A.
Draconis S.A.
DSTI Luxembourg S.à r.l.
Eaglemax S.A.
ECH S.A.
Edelweiss Property Holding S.à.r.l.
Edinem S.A.
Electro Viaduc S.à r.l.
Energiae Consult S.à.r.l.
Energie Investissements Holding S.A.
Enim S.A.
EPISO Treptowers Berlin S.à r.l.
Erdec Holding S.à r.l.
ERGO Insurance, agissant aussi sous la dénomination de "ERGO"
Erima Sàrl
ESFIL - Espirito Santo Financière S.A.
Etablissements CAR
Eurolux Créations S.à r.l.
Europack S.A.
Europe Aciers S.à.r.l.
European Carbon Fund
European Emerging Economies S.à r.l.
European Investment & Asset Management S.A.
European Real Estate Opportunities Fund
Eventsmania S.A.
Ex-Aequo S.à r.l.
ExxonMobil Netherlands Holdings
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A.
FDD, Financière de développement S.A.
FD immobilier
Fego S.A.
Fenjefflux S.à r.l.
Fidco S.A.
Fidesco S.A.
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A.
Findi S. à r.l.
FirstService International Holdings S.à r.l.
Fitema Participations S.A.
Fondation Lëtzeburger Kannerduerf
Fonds Rusnano Capital SA
Foodservice & Intellectual Property S.à r.l.
Fragrance Resources Investments S.à r.l.
FRL Participations S.à r.l.
Global Ventures S.A.
Golden Lions S.A.
GPO Advisory (Lux) S.à r.l.
HayFin DLF (GBP Parallel) LuxCo 1 S.à r.l.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l.
H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l.
ISIWIS Research S.à r.l.
Lux-Composition S.A.
Perseus Immobilien Gesellschaft 1
Perseus Immobilien Gesellschaft 10
Perseus Immobilien Gesellschaft 11
Perseus Immobilien Gesellschaft 4
Perseus Immobilien Gesellschaft 5
Perseus Immobilien Gesellschaft 9