This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2059
24 août 2013
SOMMAIRE
Abilen Eurasia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98831
AdB, Almanach de Bruxelles . . . . . . . . . . . .
98825
AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier
de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98824
Bepaumat Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98826
Cavenagh Luxembourg Management . . . .
98810
Dentsply Holding Company Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98793
Dentsply International Inc. Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98786
Dentsply International Inc. Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98793
ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98794
Ernst August Carree S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
98832
European Institute for Applied Sciences SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98828
Exakt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98797
First Data International Luxembourg VIII
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98794
Fitflop International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
98794
Fondation Bridderlech Deelen . . . . . . . . . . .
98804
Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98798
Hotel & Co II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98797
Independence Trans Europe Lines Navy
2001 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98797
Industry Credit Asia B.V. . . . . . . . . . . . . . . .
98797
Isystelec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98803
JER Adriana S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98803
JER Audrey S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98798
JER Baywatch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98798
Jubelade Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
98799
KanAm Grund Omegalux S.A. . . . . . . . . . .
98803
Kersting Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
98798
Kilcullen Tesla Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
98800
KJcompTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98799
KJcompTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98799
Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98803
Koma Services Corporation . . . . . . . . . . . . .
98800
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l. . . . . .
98798
Lab Datavault PSF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98800
Lainière Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
98799
Lainière Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
98802
Lainière Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
98802
Lala Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98801
Langley Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98800
LCP Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
98801
Leofin Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
98802
Les Jardins d'Alysea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
98801
Leverlake Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
98800
Librairie-Papeterie KUTTEN S.à r.l. . . . . .
98801
LIP second S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98832
Little Sister S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98802
LRP III Luxembourg Holdings S.àr.l. . . . . .
98803
LSL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98801
Luik Investment 2008 S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
98799
Luthor S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98832
Mäi Coiffer Julie Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98802
Mediobanca International Immobilière S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98804
Pitney Bowes Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
98796
Progeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98796
Prostar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98796
Ramako S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98795
RBS European Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .
98794
Reflexes Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98795
Rigatte SA, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98796
Right Choice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98795
Rue des Tulipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98795
SHS Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98796
Société d'Investissement et de Développe-
ment Economique Familial S.A., SPF . . .
98812
98785
L
U X E M B O U R G
Dentsply International Inc. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 163.225.
Amended and Restated By-Laws
of
Dentsply International Inc.
(formerly Gendex Corporation)
Art. 1. Stockholders' Meetings.
Section 1. Annual Meetings. The annual meeting of the stockholders, for the purpose of electing directors and for the
transaction of such other business as may properly come before the meeting, shall be held on such date and at such time
as shall be designated from time to time by the Board of Directors.
Section 2. Special Meetings. Except as otherwise required by law and subject to the rights of the holders of any class
or series of capital stock having a preference over the common stock as to dividends or upon liquidation, special meetings
of stockholders of the corporation may be called only by the Chairman of the Board, the Chief Executive Officer or the
President pursuant to a resolution adopted by the Board of Directors.
Section 3. Place of Meeting. The Board of Directors may designate any place, either within or without the State of
Delaware, as the place of meeting for any annual meeting, or for any special meeting called pursuant to Article I, Section
2, above. A waiver of notice signed by all stockholders entitled to vote at a meeting may designate any place, either within
or without the State of Delaware, as the place for the holding of such meeting. If no designation is made, or if a special
meeting shall be otherwise called, the place of meeting shall be the principal office of the corporation.
Section 4. Notice of Meeting. Written notice stating the place, date and hour of the meeting and, in the case of a special
meeting, the purpose or purposes for which the meeting is called, shall be delivered not less than ten (10) nor more than
sixty (60) days before the date of the meeting either personally or by mail, by or at the discretion of the Chief Executive
Officer, the President or the officer or persons calling the meeting. If mailed, such notice shall be deemed to be delivered
when deposited in the United States mail, addressed to the stockholder at his address as it appears on the stock record
books of the corporation, with postage thereon prepaid.
Section 5. Fixing of Record Date.
(a) For the purpose of determining stockholders entitled to notice of or to vote at any meeting of stockholders or
any adjournment thereof, the Board of Directors of the corporation may fix, in advance, a date as the record date for
any such determination of stockholders, such date in any case to be not more than sixty (60) nor less than ten (10) days
prior to the date of any proposed meeting of stockholders. In no event shall the stock transfer books be closed. When
a determination of stockholders entitled to vote at any meeting of stockholders has been made as provided in this Section,
such determination shall be applied to any adjournment thereof.
(b) For the purpose of determining stockholders entitled to receive payment of any dividend or other distribution or
allotment of any rights, or in order to make a determination of stockholders for any other lawful purpose, the Board of
Directors of the corporation may fix a date as the record date for any such determination of stockholders, which record
date shall not precede the date upon which the resolution fixing the record date is adopted, and which record date shall
be not more than sixty (60) days prior to such action. In no event shall the stock transfer books be closed.
Section 6. Quorum. A majority of the outstanding shares of the corporation entitled to vote, represented in person
or by proxy, shall constitute a quorum at a meeting of stockholders. Provided that a meeting has been duly convened in
accordance herewith, any meeting of the stockholders may be adjourned from time to time without further notice. At
any adjourned meeting at which a quorum shall be present or represented, any business may be transacted which might
have been transacted at the meeting as originally notified. Any meeting (a) at which all of the outstanding shares are
present in person or represented by proxy and at which none of such shares attend for the purpose of objecting, at the
beginning of the meeting, to the transaction of any business thereat because the meeting was not lawfully called or
convened, or (b) at which all of the outstanding stock has waived notice, or (c) for which notice shall have been duly given
as provided herein, shall be deemed a properly constituted meeting of the stockholders.
Section 7. Proxies. At all meetings of stockholders, a stockholder entitled to vote may vote by proxy appointed in
writing by the stockholder or by his duly authorized attorney in fact. Such proxy shall be filed with the Secretary of the
corporation before or at the time of the meeting. An instrument appointing a proxy shall, unless the contrary is stated
thereon, be valid only at the meeting for which it has been given or any adjournment thereof.
Section 8. Voting of Shares. At each meeting of stockholders, every stockholder entitled to vote thereat shall be entitled
to vote in person or by a duly authorized proxy, which proxy may be appointed by an instrument in writing executed by
such stockholder or his duly authorized attorney or through electronic means, if applicable, such as the internet. Subject
to the provisions of applicable law and the corporation's Certificate of Incorporation, each holder of common stock shall
be entitled to one (1) vote for each share of stock standing registered in his name at the close of business on the day
fixed by the Board of Directors as the record date for the determination of the stockholders entitled to notice of and
vote at such meeting. Shares standing in the name of another corporation may be voted by any officer of such corporation
98786
L
U X E M B O U R G
or any proxy appointed by any officer of such corporation in the absence of express notice of such corporation given in
writing to the Secretary of this corporation in connection with the particular meeting, that such officer has no authority
to vote such shares.
Section 9. List of Stockholders. A complete list of the stockholders entitled to vote at the ensuing meeting, arranged
in alphabetical order and showing the address of each stockholder and the number of shares registered in the name of
each stockholder, shall be prepared by the Secretary, or other officer of the corporation having charge of said stock
ledger. Such list shall be open to the examination of any stockholder during ordinary business hours, for a period of at
least ten (10) days prior to the meeting, either at a place within the city where the meeting is to be held, which place
shall be specified in the notice of the meeting, or, if not so specified, at the place where said meeting is to be held, and
the list shall be produced and kept at the time and place of the meeting during the whole time thereof, and shall be subject
to the inspection of any stockholder who may be present.
Section 10. Waiver of Notice by Stockholders. Whenever any notice whatever is required to be given to any stock-
holder of the corporation under the provisions of these By-Laws or under the provisions of the Certificate of
Incorporation or under the provisions of any statute, a waiver thereof in writing, signed at any time, whether before or
after the time of meeting, by the stockholder entitled to such notice, shall be deemed equivalent to the giving of such
notice.
Section 11. Advance Notice of Stockholder-Proposed Business at Annual Meetings. No business may be transacted at
an annual meeting of stockholders, other than business that is either (a) specified in the notice of meeting (or any sup-
plement thereto) given by or at the direction of the Board of Directors (or any duly authorized committee thereof), (b)
otherwise properly brought before the annual meeting by or at the direction of the Board of Directors (or any duly
authorized committee thereof), or (c) otherwise properly brought before the annual meeting by any stockholder of the
corporation (i) who is a stockholder of record on the date of the giving of the notice provided for in this Section 11 and
on the record date for the determination of stockholders entitled to notice of and to vote at such annual meeting and
(ii) who complies with the notice procedures set forth in this Section 11.
In addition to any other applicable requirements, for business to be properly brought before an annual meeting by a
stockholder, such stockholder must have given timely notice thereof in proper written form to the Secretary of the
corporation.
To be timely, a stockholder's notice to the Secretary must be delivered to or mailed and received at the principal
executive offices of the corporation not less than ninety (90) days nor more than one hundred twenty (120) days prior
to the anniversary date of the immediately preceding annual meeting of stockholders; provided, however, that in the
event that the annual meeting is called for a date that is not within twenty-five (25) days before or after such anniversary
date, notice by the stockholder in order to be timely must be so received not later than the close of business on the
tenth (10
th
) day following the day on which such notice of the date of the annual meeting was mailed or such public
disclosure of the date of the annual meeting was made, whichever first occurs.
To be in proper written form, a stockholder's notice to the Secretary must set forth as to each matter such stockholder
proposes to bring before the annual meeting (i) a brief description of the business desired to be brought before the annual
meeting, the reasons for conducting such business at the annual meeting and any material interest in such business of
such stockholder and any Stockholder Associated Person (as defined below), individually or in the aggregate, including
any anticipated benefit to the stockholder or the Stockholder Associated Person therefrom, (ii) the name and record
address of such stockholder, (iii) as to the stockholder giving the notice and any Stockholder Associated Person, (A) the
class, series and number of all shares of stock of the corporation which are owned by such stockholder and by such
Stockholder Associated Person, if any (B) the nominee holder for, and number of, shares owned beneficially but not of
record by such stockholder and by any such Stockholder Associated Person, and (C) any derivative positions held or
beneficially held by the stockholder and by any such Stockholder Associated Person and whether and the extent to which
any hedging or other transaction or series of transactions has been entered into by or on behalf of, or any other agreement,
arrangement or understanding (including any short position or any borrowing or lending of shares) has been made, the
effect or intent of which is to mitigate loss to or manage risk or benefit of share price changes for, or to increase or
decrease the voting power of, such stockholder or any such Stockholder Associated Person with respect to any share
of stock of the corporation; (iv) as to the stockholder giving the notice and any Stockholder Associated Person covered
by clause (iii) of this paragraph, the name and address of such stockholder, as they appear on the corporation's stock
ledger, and current name and address, if different, and of such Stockholder Associated Person; (v) a description of all
proxy, contract, arrangement, understanding, or relationship between such stockholder and any other person or persons
(including their names) in connection with the proposal of such business by such stockholder; and (vi) a representation
that such stockholder intends to appear in person or by proxy at the annual meeting to bring such business before the
meeting.
Notwithstanding anything in these By-Laws to the contrary, no business shall be conducted at the annual meeting
except business brought before the annual meeting in accordance with the procedures set forth in this Section 11;
provided, however, that, once business has been properly brought before the annual meeting in accordance with such
procedures, nothing in this Section 11 shall be deemed to preclude discussion by any stockholder of any such business.
If the chairman of an annual meeting determines that business was not properly brought before the annual meeting in
98787
L
U X E M B O U R G
accordance with the foregoing procedures, the chairman shall declare to the meeting that the business was not properly
brought before the meeting and such business shall not be transacted.
For purposes of this Section 11 and Section 12 of this Article I, “Stockholder Associated Person” of any stockholder
shall mean (i) any person controlling, directly or indirectly, or acting in concert with, such stockholder, (ii) any beneficial
owner of shares of stock of the corporation owned of record or beneficially by such stockholder and (iii) any person
controlling, controlled by or under common control with such Stockholder Associated Person.
Section 12. Procedure for Nomination of Directors. Only persons who are nominated in accordance with the following
procedures shall be eligible for election as directors of the corporation, except as may be otherwise provided in the
Certificate of Incorporation with respect to the right of holders of preferred stock of the corporation to nominate and
elect a specified number of directors in certain circumstances. Nominations of persons for election to the Board of
Directors may be made at any annual meeting of stockholders, or at any special meeting of stockholders called for the
purpose of electing directors, (a) by or at the direction of the Board of Directors (or any duly authorized committee
thereof), or (b) by any stockholder of the corporation (i) who is a stockholder of record on the date of the giving of the
notice provided for in this Section 12 and on the record date for the determination of stockholders entitled to notice of
and to vote at such meeting and (ii) who complies with the notice procedures set forth in this Section 12.
In addition to any other applicable requirements, for a nomination to be made by a stockholder, such stockholder
must have given timely notice thereof in proper written form to the Secretary of the corporation.
To be timely, a stockholder's notice to the Secretary must be delivered to or mailed and received at the principal
executive offices of the corporation (a) in the case of an annual meeting, not less than ninety (90) days nor more than
one hundred twenty (120) days prior to the anniversary date of the immediately preceding annual meeting of stockholders;
provided, however, that in the event that the annual meeting is called for a date that is not within twenty-five (25) days
before or after such anniversary date, notice by the stockholder in order to be timely must be so received not later than
the close of business on the tenth (10
th
) day following the day on which such notice of the date of the annual meeting
was mailed or such public disclosure of the date of the annual meeting was made, whichever first occurs; and (b) in the
case of a special meeting of stockholders called for the purpose of electing directors, not later than the close of business
on the tenth (10
th
) day following the day on which notice of the date of the special meeting was mailed or public disclosure
of the date of the special meeting was made, whichever first occurs.
To be in proper written form, a stockholder's notice to the Secretary must set forth (a) as to each person whom the
stockholder proposes to nominate for election as a director (i) the name, age, business address and residence address
of the person, (ii) the principal occupation or employment of the person, (iii) the class or series and number of shares of
capital stock of the corporation which are owned beneficially or of record by the person, and (iv) any other information
relating to the person that would be required to be disclosed in a proxy statement or other filings required to be made
in connection with solicitations of proxies for election of directors pursuant to Section 14 of the Exchange Act of 1934,
as amended (the “Exchange Act”), and the rules and regulations promulgated thereunder; and (b) as to the stockholder
giving the notice and any Stockholder Associated Person, (i) the name and record address of such stockholder, (ii) the
class, series and number of all shares of stock of the corporation which are owned by such stockholder and by such
Stockholder Associated Person, if any, (iii) the nominee holder for, and number of, shares owned beneficially but not of
record by such stockholder and by any such Stockholder Associated Person, (iv) any derivative positions held or bene-
ficially held by the stockholder and by any such Stockholder Associated Person and whether and the extent to which any
hedging or other transaction or series of transactions has been entered into by or on behalf of, or any other agreement,
arrangement or understanding (including any short position or any borrowing or lending of shares) has been made, the
effect or intent of which is to mitigate loss to or manage risk or benefit of share price changes for, or to increase or
decrease the voting power of, such stockholder or any such Stockholder Associated Person with respect to any share
of stock of the corporation, (v) a description of all arrangements or understandings between such stockholder or any
such Stockholder Associated Person and each proposed nominee and any other person or persons (including their names)
pursuant to which the nomination(s) are to be made by such stockholder, (vi) as to the stockholder giving the notice, a
representation that such stockholder intends to appear in person or by proxy at the meeting to nominate the persons
named in its notice and (vii) any other information relating to the stockholder giving the notice that would be required
to be disclosed in a proxy statement or other filings required to be made in connection with solicitations of proxies for
election of directors pursuant to Section 14 of the Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder.
Such notice must be accompanied by a written consent of each proposed nominee to being named as a nominee and to
serve as a director if elected.
No person shall be eligible for election as a director of the corporation unless nominated in accordance with the
procedures set forth in this Section 12. If the Chairman of the meeting determines that a nomination was not made in
accordance with the foregoing procedures, the Chairman shall declare to the meeting that the nomination was defective
and such defective nomination shall be disregarded.
Section 13. Election of Directors. Except as provided in Section 8 of Article II of these bylaws, a nominee for director
shall be elected to the Board of Directors if the votes cast for such nominee's election exceed the votes cast against such
nominee's election; provided, however, that directors shall be elected by a plurality of the votes cast at any meeting of
stockholders for which (i) the Secretary of the Corporation receives a notice that a stockholder has nominated a person
98788
L
U X E M B O U R G
for election to the Board of Directors in compliance with the advance notice requirements for stockholder nominees
for director set forth in Article I, Section 12 of these bylaws and (ii) such nomination has not been withdrawn by such
stockholder on or prior to the fourteenth day before the date the Corporation first mails to the stockholders its notice
of such meeting. If directors are to be elected by a plurality of the votes cast, stockholders shall not be permitted to vote
against a nominee, but only to withhold their vote.
Art. 2. Board of Directors.
Section 1. General Powers. The business and affairs of the corporation shall be managed by its Board of Directors.
The Board of Directors may adopt, amend or repeal by-laws adopted by the Board or by the stockholders.
Section 2. Number of Directors, Tenure and Qualifications. The number of members of the Board of Directors shall
be not less than three (3) nor more than thirteen (13) as determined from time to time by the Board of Directors. The
directors need not be stockholders of the corporation. Effective immediately upon the filing of the Certificate of Amend-
ment to the Restated Certificate of Incorporation of the corporation, the term of office for the class of directors elected
in 2011 shall expire at the annual meeting of stockholders to be held in 2014, the term of office for the class of directors
elected in 2012 shall expire at the annual meeting of stockholders to be held in 2015, and the term of office for the class
of directors elected in 2013 shall expire at the annual meeting of stockholders to be held in 2016, with the members of
each class to hold office until their successors are elected and qualified. Commencing at the annual meeting of stockholders
to be held in 2014, directors succeeding those whose terms are then expired shall be elected to hold office for a term
expiring at the annual meeting of stockholders held in the year following the year of their election and until their successors
are elected and qualified. Commencing with the annual meeting of stockholders to be held in 2016, the classification of
the board of directors shall terminate and all directors shall be of one class. Any additional director elected to fill a vacancy
resulting from an increase in the number of directors shall hold office until the next annual meeting of stockholders, but
in no case will a decrease in the number of directors shorten the term of any incumbent director. A director shall hold
office until the annual meeting for the year in which his or her term expires and until his or her successor shall be elected
and shall qualify, subject, however, to prior death, resignation, incapacitation or removal from office, and except as
otherwise required by law. In the event such election is not held at the annual meeting of stockholders, it shall be held
at any adjournment thereof or a special meeting. Except as otherwise required by law, any vacancy on the board of
directors that results from an increase in the number of directors shall be filled only by a majority of the board of directors
then in office, provided that a quorum is present, and any other vacancy occurring in the board of directors shall be filled
by a majority of the directors then in office, even if less than a quorum, or by a sole remaining director. Any director
elected to fill a vacancy not resulting from an increase in the number of directors shall have the same remaining term as
that of his or her predecessor. A director may be removed only for cause by the stockholders.
Section 3. Regular Meetings. Regular meetings of the Board of Directors shall be held without any other notice than
this By-Law immediately after, and at the same place as, the annual meeting of stockholders, and each adjourned session
thereof. The Board of Directors may designate the time and place, either within or without the State of Delaware, for
the holding of additional regular meetings without other notice than such designation.
Section 4. Special Meetings. Special meetings of the Board of Directors may be called by or at the request of the
Chairman of the Board, the Chief Executive Officer, the President or by members of the Board of Directors constituting
no less than three-fourths (3/4) of the total number of directors then in office. The person or persons authorized to call
special meetings of the Board of Directors may fix any place either within or without the State of Delaware, as the place
for holding any special meeting of the Board of Directors called by them.
Section 5. Notice. Notice of any special meeting shall be given at least five (5) days previously thereto by written notice
delivered or mailed to each director at his last known address, or at least forty-eight (48) hours previously thereto by
personal delivery or by facsimile to a telephone number provided to the corporation. If mailed, such notice shall be
deemed to be delivered when deposited in the United States mail so addressed, with postage thereon prepaid. If notice
is given by facsimile, such notice shall be deemed to be delivered when transmitted with receipt confirmed. Whenever
any notice whatever is required to be given to any director of the corporation under the provisions of these By-Laws or
under the provisions of the Certificate of Incorporation or under the provisions of any statute, a waiver thereof in writing,
signed at any time, whether before or after the time of meeting, by the director entitled to such notice, shall be deemed
equivalent to the giving of such notice. The attendance of a director at a meeting shall constitute a waiver of notice of
such meeting except where a director attends a meeting and objects thereat to the transaction of any business because
the meeting is not lawfully called or convened. Neither the business to be transacted at, nor the purpose of, any regular
or special meeting of the Board of Directors need be specified in the notice or waiver of notice of such meeting.
Section 6. Quorum. Two-thirds (2/3) of the directors shall constitute a quorum for the transaction of business at any
meeting of the Board of Directors.
Section 7. Manner of Acting. The act of the majority of the directors then in office shall be the act of the Board of
Directors, unless the act of a greater number is required by these By-Laws or By-Law.
Section 8. Vacancies. Except as otherwise required by law, any vacancy on the Board of Directors that results from
an increase in the number of directors shall be filled only by a majority of the Board of Directors then in office, provided
that a quorum is present, and any other vacancy occurring on the Board of Directors shall be filled by a majority of the
directors then in office, even if less than a quorum, or by a sole remaining director. Any director elected to fill a vacancy
98789
L
U X E M B O U R G
not resulting from an increase in the number of directors shall have the same remaining term as that of his or her
predecessor. The resignation of a director shall be effective upon receipt by the corporation, unless some subsequent
time is fixed in the resignation, and then from that time. Acceptance of such resignation by the corporation shall not be
required.
Section 9. Compensation. The Board of Directors, by affirmative vote of a majority of the directors, and irrespective
of any personal interest of any of its members, may establish reasonable compensation of all directors for services to the
corporation as directors, officers or otherwise, or may delegate such authority to an appropriate committee.
Section 10. Presumption of Assent. A director of the corporation who is present at a meeting of the Board of Directors
or a committee thereof at which action on any corporate matter is taken shall be presumed to have assented to the
action taken unless his dissent shall be entered in the minutes of the meeting or unless he shall file his written dissent to
such action with the person acting as the secretary of the meeting before the adjournment thereof. Such right to dissent
shall not apply to a director who voted in favor of such action.
Section 11. Committees. The Board of Directors by resolution may designate one (1) or more committees, each
committee to consist of one (1) or more directors elected by the Board of Directors, which to the extent provided in
such resolution, as initially adopted, and as thereafter supplemented or amended by further resolution adopted by a like
vote, shall have and may exercise, when the Board of Directors is not in session, the powers of the Board of Directors
in the management of the business and affairs of the corporation, except action with respect to amendment of the
Certificate of Incorporation or By-Laws, adoption of an agreement of merger or consolidation (other than the adoption
of a Certificate of Ownership and Merger in accordance with Section 253 of the General Corporation Law of the State
of Delaware, as such law may be amended or supplemented), recommendation to the stockholders of the sale, lease or
exchange of all or substantially all of the corporation's property or assets, recommendation to the stockholders of the
dissolution or the revocation of a dissolution of the corporation, election of officers or the filling of vacancies on the
Board of Directors or on committees created pursuant to this Section or declaration of dividends. The Board of Directors
may elect one (1) or more of its members as alternate members of any such committee who may take the place of any
absent or disqualified member or members at any meeting of such committee, upon request by the Chairman of the
Board, the Chief Executive Officer or the President or upon request by the chairman of such meeting. Each such com-
mittee may fix its own rules governing the conduct of its activities and shall make such reports to the Board of Directors
of its activities as the Board of Directors may request.
Section 12. Removal of Directors. Exclusive of directors, if any, elected by the holders of one (1) or more classes of
preferred stock, no director of the corporation may be removed from office, except for cause and by the affirmative vote
of two-thirds (2/3) of the outstanding shares of capital stock of the corporation entitled to vote at a meeting of the
stockholders duly called for such purpose. As used in this Article II, the meaning of “cause” shall be limited to malfeasance
arising from the performance of a director's duty which has a materially adverse effect on the business of the corporation.
Section 13. Action of the Board by Written Consent. Any action required or permitted to be taken at any meeting of
the Board of Directors or any committee thereof may be taken without a meeting of the Board of Directors or any
committee thereof if prior to such action a written consent thereto is signed by all members of the Board or of the
committee, as the case may be, and such written consent is filed with the minutes of the proceedings of the Board or the
committee.
Section 14. Conferences. Members of the Board of Directors or any committee designated by the Board may parti-
cipate in a meeting of such Board or committee by means of conference telephone or similar communications equipment
by means of which all persons participating in the meeting can hear each other, and participation in a meeting pursuant
to this Section 14 shall constitute presence in person at such meeting.
Art. 3. Officers.
Section 1. Number. The officers of the corporation shall consist of a Chairman of the Board and a Chief Executive
Officer. The Board of Directors may appoint as officers a Vice Chairman of the Board, President, such number of Senior
Vice Presidents and Vice Presidents, a Secretary, a Treasurer, one (1) or more Assistant Treasurers, one (1) or more
Assistant Secretaries, and such other officers as are created by the Board from time to time. The same person may hold
two (2) or more of such offices.
Section 2. Election and Term of Office. The Chairman of the Board and the Vice Chairman of the Board shall be elected
by the directors from among their own number; other officers need not be directors. In addition to the powers conferred
upon them by these By-Laws, all officers elected or appointed by the Board of Directors shall have such authority and
shall perform such duties as from time to time may be prescribed by the Board of Directors by resolution.
Section 3. Removal. Any officer or agent elected or appointed by the Board of Directors may be removed by the Board
of Directors, whenever in its judgment the best interests of the corporation will be served thereby, but such removal
shall be without prejudice to the contract rights, if any, of the person so removed. Election or appointment shall not of
itself create contract rights.
Section 4. Chairman of the Board. The Chairman of the Board shall preside at all meetings of the Board of Directors
and meetings of the stockholders. He shall also perform such other duties as from time to time may be assigned to him
by the Board of Directors.
98790
L
U X E M B O U R G
Section 5. Vice Chairman of the Board. In the absence of the Chairman of the Board because of death or physical
disability which prevents the Chairman of the Board from performing his duties, or in the event of his inability or refusal
to act, the Vice Chairman of the Board shall perform the duties of the Chairman of the Board and, when so acting, have
the powers of and be subject to all of the restrictions upon the Chairman of the Board.
Section 6. Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer shall be the principal executive officer of the corporation
and shall have the general charge of and control over the business, affairs, and personnel of the corporation, subject to
the authority of the Board of Directors. The Chief Executive Officer may, together with the Secretary, sign all certificates
for shares of the capital stock of the corporation and shall perform such other duties as shall be delegated to him by the
Board of Directors. Except as may be specified by the Board of Directors, the Chief Executive Officer shall have the
power to enter into contracts and make commitments on behalf of the corporation and shall have the right to execute
deeds, mortgages, bonds, contracts and other instruments necessary or proper to be executed in connection with the
corporation's regular business and may authorize the President, and any other officer of the corporation, to sign, execute
and acknowledge such documents and instruments in his place and stead.
Section 7. President. The President shall be the chief operating officer of the corporation, and shall report to the Chief
Executive Officer. The President may, together with the Secretary, sign all certificates for shares of the capital stock of
the corporation and may, together with the Secretary, execute on behalf of the corporation any contract, except in cases
where the signing and execution thereof shall be expressly delegated by the Board of Directors or the Chief Executive
Officer to some other officer or agent, and shall perform such duties as are assigned to him by the Board of Directors
or the Chief Executive Officer.
Section 8. Senior Vice President and Vice Presidents. Each Senior Vice President or Vice President shall perform such
duties and have such authority as from time to time may be assigned to him by the Board of Directors, the Chief Executive
Officer or the President.
Section 9. Secretary and Assistant Secretaries. The Secretary shall have custody of the seal of the corporation and of
all books, records and papers of the corporation, except such as shall be in the charge of the Treasurer or some other
person authorized to have custody and be in possession thereof by resolution of the Board of Directors. The Secretary
shall record the proceedings of the meetings of the stockholders and of the Board of Directors in books kept by him for
that purpose and may, at the direction of the Board of Directors, give any notice required by statute or by these By-Laws
of all such meetings. The Secretary shall, together with the Chief Executive Officer or the President, sign certificates for
shares of the capital stock of the corporation. Any Assistant Secretaries elected by the Board of Directors, in order of
their seniority, shall, in the absence or disability of the Secretary, perform the duties and exercise the powers of the
Secretary as aforesaid. The Secretary or any Assistant Secretary may, together with the Chief Executive Officer, the
President or any other authorized officer, execute on behalf of the corporation any contract which has been approved
by the Board of Directors, and shall perform such other duties as the Board of Directors, the Chief Executive Officer or
the President shall prescribe.
Section 10. Treasurer and Assistant Treasurer. The Treasurer shall keep accounts of all moneys of the corporation
received and disbursed, and shall deposit all monies and valuables of the corporation in its name and to its credit in such
banks and depositories as the Board of Directors shall designate. Any Assistant Treasurers elected by the Board of
Directors, in order of their seniority, shall, in the absence or disability of the Treasurer, perform the duties and exercise
the powers of the Treasurer, and shall perform such other duties as the Board of Directors, the Chief Executive Officer
or the President shall prescribe.
Section 11. Salaries. The salaries of the officers shall be fixed from time to time by the Board of Directors and no
officer shall be prevented from receiving such salary by reason of the fact that he is also a director of the corporation.
Section 12. Representation in Other Companies. Unless otherwise ordered by the Board of Directors, the Chief
Executive Officer, the President or a Vice President designated by the President shall have full power and authority on
behalf of the corporation to attend and to act and to vote at any meetings of security holders of corporations in which
the corporation may hold securities, and at such meetings shall possess and may exercise any and all rights and powers
incident to the ownership of such securities, and which as the owner thereof the corporation might have possessed and
exercised, if present. The Board of Directors by resolution from time to time may confer like powers upon any other
person or persons.
Art. 4. Stock and transfer of stock.
Section 1. Shares of Stock. The shares of capital stock of the corporation shall be represented by a certificate, unless
and until the Board of Directors of the corporation adopts a resolution permitting shares to be uncertificated. Not-
withstanding the adoption of any such resolution providing for uncertificated shares, every holder of capital stock of the
corporation theretofore represented by certificates and, upon request, every holder of uncertificated shares, shall be
entitled to have a certificate for shares of capital stock of the corporation signed by the Chief Executive Officer or the
President and by the Secretary. To the extent that shares are represented by certificates, the certificates shall be in such
form as shall be determined by the Board of Directors and shall be consecutively numbered or otherwise identified. The
name and address of the person to whom the shares represented thereby are issued, with the number of shares and date
of issue, shall be entered on the stock transfer books of the corporation. With respect to certificated shares of stock, all
certificates surrendered to the corporation for transfer shall be canceled and no new certificate or uncertificated shares
98791
L
U X E M B O U R G
shall be issued until the former certificate for a like number of shares shall have been surrendered and canceled, except
that in case of a lost, destroyed or mutilated certificate, a new certificate or uncertificated shares may be issued therefor
upon such terms and indemnity to the corporation as the Board of Directors may prescribe.
Section 2. Transfer of Shares. Stock of the corporation shall be transferable in the manner prescribed by applicable
law and in these By-Laws. Transfers of stock shall be made on the books of the corporation, and in the case of certificated
shares of stock, only by the person named in the certificate or by such person's attorney lawfully constituted in writing
and upon the surrender of the certificate therefor, properly endorsed for transfer and payment of all necessary transfer
taxes; or, in the case of uncertificated shares of stock, upon receipt of proper transfer instructions from the registered
holder of the shares or by such person's attorney lawfully constituted in writing, and upon payment of all necessary
transfer taxes and compliance with appropriate procedures for transferring shares in uncertificated form; provided, ho-
wever, that such surrender and endorsement, compliance or payment of taxes shall not be required in any case in which
the officers of the corporation shall determine to waive such requirement. Prior to due presentment for registration of
transfer of a certificate representing shares of capital stock of the corporation or of proper transfer instructions with
respect to uncertificated shares, the corporation may treat the registered owner of such shares as the person exclusively
entitled to vote, to receive notifications and otherwise to exercise all the rights and powers of an owner.
Where a certificate for shares is presented to the corporation with a request to register for transfer, the corporation
shall not be liable to the owner or any other person suffering loss as a result of such registration of transfer if (a) there
were on or with the certificate the necessary endorsements, and (b) the corporation had no duty to inquire into adverse
claims or has discharged any such duty. The corporation may require reasonable assurance that said endorsements are
genuine and effective and in compliance with such other regulations as may be prescribed under the authority of the
Board of Directors.
Art. 5. Indemnification of Directors, Officers, Employees and Agents.
Section 1. Indemnification Generally. The corporation shall indemnify any person who was or is a party or is threatened
to be made a party to any threatened, pending or completed action, suit or proceeding, whether civil, criminal, adminis-
trative or investigative (other than an action by or in the right of the corporation), by reason of the fact that he or she
is or was a director, officer, employee or agent of the corporation, or is or was serving at the request of the corporation
as a director, officer, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise, or
is alleged to have violated the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, against expenses (including
attorneys' fees), judgments, fines, penalties, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by him or
her in connection with such action, suit or proceeding if he or she acted in good faith and in a manner he or she reasonably
believed to be in or not opposed to the best interests of the corporation, and, with respect to any criminal action or
proceeding, had no reasonable cause to believe his or her conduct was unlawful. The termination of any action, suit or
proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or upon plea of nolo contendere or its equivalent shall not, of
itself, create a presumption that the person did not act in good faith and in a manner which he or she reasonably believed
to be in or not opposed to the best interests of the corporation, and, with respect to any criminal action or proceeding,
had reasonable cause to believe that his or her conduct was unlawful.
Section 2. Indemnification in Actions By or In the Right Of the Corporation. The corporation shall indemnify any person
who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action or suit by or
in the right of the corporation to procure a judgment in its favor by reason of the fact that he or she is or was a director,
officer, employee or agent of the corporation, or is or was serving at the request of the corporation as a director, officer,
employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise against expenses (including
attorneys' fees) actually and reasonably incurred by him or her in connection with the defense and settlement of such
action or suit if he or she acted in good faith and in a manner he or she reasonably believed to be in or not opposed to
the best interests of the corporation and except that no indemnification shall be made in respect of any claim, issue or
matter as to which such person shall have been adjudged to be liable to the corporation unless and only to the extent
that the Delaware Court of Chancery or the court in which such action or suit was brought shall determine upon
application that, despite the adjudication of liability but in view of all the circumstances of the case, such person is fairly
and reasonably entitled to indemnity for such expenses which the Delaware Court of Chancery or such other court shall
deem proper.
Section 3. Success on the Merits; Indemnification Against Expenses. To the extent that a director, officer, employee
or agent of the corporation has been successful on the merits or otherwise in defense of any action, suit or proceeding
referred to in Section 1 or Section 2 of this Article V, or in defense of any claim, issue or matter therein, he or she shall
be indemnified against expenses (including attorneys' fees) actually and reasonably incurred by him or her in connection
therewith.
Section 4. Determination that Indemnification is Proper. Any indemnification under Section 1 or Section 2 of this
Article V, unless ordered by a court, shall be made by the corporation only as authorized in the specific case upon a
determination that indemnification of the director, officer, employee or agent is proper in the circumstances under the
standard of conduct set forth in such Section 1 or Section 2 of this Article V, as the case may be. Such determination
shall be made:
98792
L
U X E M B O U R G
(a) By the Board of Directors by a majority vote of a quorum consisting of directors who were not parties to such
action, suit or proceeding;
(b) If such a quorum is not obtainable, or, even if obtainable if a quorum of disinterested directors so directs, by
independent legal counsel in a written opinion; or
(c) By the stockholders.
Section 5. Insurance; Indemnification Agreements. The corporation may, but shall not be required to, supplement the
right of indemnification under this Article V by any lawful means, including, without limitation by reason of enumeration,
(i) the purchase and maintenance of insurance on behalf of any one or more of such indemnitees, whether or not the
corporation would be obligated to indemnify such person under this Article V or otherwise, and (ii) individual or group
indemnification agreements with any one or more of such indemnities.
Section 6. Advancement of Expenses. Expenses (including attorneys' fees) incurred by an indemnitee in defending any
civil, criminal, administrative or investigative action, suit or proceeding shall be paid by the corporation in advance of the
final disposition of such action, suit or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the indemnitee to
repay such amount if it shall ultimately be determined that he or she is not entitled to be indemnified by the corporation
as to such amounts.
Section 7. Rights Not Exclusive. The indemnification and advancement of expenses provided by this Article V shall be
not deemed exclusive of any other right to which an indemnified person may be entitled under Section 145 of the General
Corporation Law of the State of Delaware (or any successor provision) or otherwise under applicable law, or under any
agreement, vote of stockholders or disinterested directors or otherwise, both as to action in his or her official capacity
and as to action in another capacity while holding such office and shall continue as to a person who has ceased to be a
director, officer, employee or agent and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a
person.
Section 8. Severability. To the extent that any court of competent jurisdiction shall determine that the indemnification
provided under this Article V shall be invalid as applied to a particular claim, issue or matter, the provisions hereof shall
be deemed amended to allow indemnification to the maximum extent permitted by law.
Section 9. Modification. This Article V shall be deemed to be a contract between the corporation and each previous,
current or future director, officer, employee or agent. The provisions of this Article V shall be applicable to all actions,
claims, suits or proceedings, commenced after the adoption hereof, whether arising from any action taken or failure to
act before or after such adoption. No amendment, modification or repeal of this Article V shall diminish the rights provided
hereby or diminish the right to indemnification with respect to any claim, issue or matter in any then pending or subsequent
proceeding which is based in any material respect from any alleged action or failure to act prior to such amendment,
modification or repeal.
Référence de publication: 2013106767/452.
(130130395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
Dentsply International Inc. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger,
(anc. Dentsply Holding Company Luxembourg Branch).
Adresse de la succursale: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 163.225.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée généralei>
<i>des actionnaires de la société-mère avec effet au 3 janvier 2013i>
Suite à la fusion de la société DENTSPLY Holding Company (société absorbée) avec la société Dentsply International
Inc., (société absorbante) avec effet au 3 janvier 2013:
- la société-mère est désormais la société Dentsply International Inc., une «corporation», ayant son siège social à USA-
PA 17404 York (Etats-Unis d'Amérique), 221, W. Philadelphia Street, enregistrée auprès du Registre de l'Etat du Delaware
«Division of Corporations» sous le numéro 2002951;
- la dénomination de la succursale est désormais la suivante: Dentsply International Inc. Luxembourg Branch;
Luxembourg, le 19 juillet 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Dentsply International Inc. Luxembourg Branch
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013106766/20.
(130130395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.
98793
L
U X E M B O U R G
ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B, Société en Commandite simple sous la forme
d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 157.654.
Suite à une assemblée du conseil de gérance du 19 juin 2013, il a été annoncé que l'associé «VPV Invest Verwaltungs-
gesellschaft S. à r.l.» (RCSL B157103) est remplacé par «Union Investment Luxembourg S.A.» (RCSL B28679), dont le
siège se situe à 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, avec effet 1
er
juillet 2013.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013091461/12.
(130112371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
First Data International Luxembourg VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 151.024.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 Juillet 2013.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013091497/13.
(130111616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Fitflop International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 157.353.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2013.
FitFlop International S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manageri>
Référence de publication: 2013091499/14.
(130111820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
RBS European Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.275.
<i>Rectificatif des comptes annuels se terminant au 15 décembre 2011, enregistrés à Luxembourg - Sociétés, le 5 avril 2013 référencei>
<i>L-130054505i>
Les comptes annuels au 15 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
RBS European Finance S.A.
Richard Lawrence / Steven L. Lizars
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013091855/15.
(130111748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98794
L
U X E M B O U R G
Reflexes Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 101.570.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 28 juin 2013i>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet au 06 juin 2013 de Monsieur Christophe BLONDEAU de sa
fonction d'administrateur au sein de la Société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat
jusqu'à la date de sa démission.
L'Assemblée Générale décide, de nommer, avec effet au 06 juin 2013, Monsieur Adrien COULOMBEL, demeurant
professionnellement au 163, rue du Kiem à L-8030 Strassen, à la fonction d'administrateur de la Société et ce, jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091843/16.
(130112399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Right Choice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R.C.S. Luxembourg B 118.731.
Le Bilan et l’affectation aux résultats au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RIGHT CHOICE SAi>
Référence de publication: 2013091848/11.
(130112284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Ramako S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 163.601.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 19 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2754 du 11 novembre 2011.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RAMAKO S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013091852/14.
(130112557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Rue des Tulipes, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg E 4.737.
Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les
informations inscrites auprès de celui-ci:
- que le siège social de l'administrateur NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. société inscrite au numéro RCS B 99746
est situé, suite à son transfert de siège du 16 décembre 2012 au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 avril 2013.
<i>Pour Rue des Tulipes Société civilei>
Référence de publication: 2013091849/13.
(130112059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98795
L
U X E M B O U R G
Progeny, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 169.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091836/9.
(130112010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Pitney Bowes Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 94.736.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66740 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091827/9.
(130112243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Prostar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 60.649.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091837/9.
(130112556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Rigatte SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.851.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RIGATTE SA, SPF
Société Anonyme - Société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2013091866/11.
(130112609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
SHS Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 87.067.
Messieurs Georges DIEDERICH, Jean-Marc HEITZ, Robert REGGIORI et Evaristo RICCI démissionnent de leur poste
d'administrateurs.
Monsieur Louis VEGAS-PIERONI démissionne de son poste de commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 04 juillet 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SHS EUROPE S.A.
i>MANACO S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013091940/16.
(130111518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98796
L
U X E M B O U R G
Hotel & Co II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 96.676.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en 31/12/2012 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2013091575/11.
(130112287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Industry Credit Asia B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 95.080.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2013
Industry Credit Asia B.V.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013091595/14.
(130111873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Independence Trans Europe Lines Navy 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.668.
Le bilan et le compte de pertes et profits abrégés au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire COFIGEST S.A. R.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2013091628/13.
(130112797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Exakt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 61.562.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2013i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de Siège social
Après présentation et acceptation de l'ordre du jour tel que proposé, l'assemblée générale extraordinaire prend la
résolution unique suivante à l'unanimité:
<i>Résolution unique:i>
Le siège social de la société est transféré au 64, Grand-rue, L-6630 Wasserbillig.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013091489/16.
(130112522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98797
L
U X E M B O U R G
Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 132.679.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013091534/12.
(130111737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
JER Audrey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 125.408.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013091642/10.
(130112523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
JER Baywatch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013091643/10.
(130112532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Kersting Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 49.651.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091663/9.
(130112251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.942.
Veuillez prendre note que la dénomination exacte de l'associée unique est Kulczyk Holding S.A. et non Kulczyk holding
Spolka Akcyjna.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013091659/13.
(130111794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98798
L
U X E M B O U R G
Jubelade Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.765.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091639/9.
(130112321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
KJcompTA, Société Anonyme.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 92.061.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2004i>
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2004 que le mandat du commissaire aux comptes
Madame Virginie VEXLARD est renouvelé pour une durée d'un an. Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KJCOMPTA S.A.
Katia JUNG
Référence de publication: 2013091668/14.
(130111445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
KJcompTA, Société Anonyme.
Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 92.061.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 02 janvier 2013i>
Il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 02 janvier 2013 que:
«Le siège social est transféré à partir du 02 janvier 2013 au 15, rue Robert Schuman à L-5751 Frisange.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KJCOMPTA S.A.
Katia JUNG
Référence de publication: 2013091673/13.
(130112424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Luik Investment 2008 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 135.760.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091694/9.
(130112658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Lainière Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 45.650.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091700/9.
(130111691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98799
L
U X E M B O U R G
Lab Datavault PSF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Münsbach, 9, rue Henri Tudor.
R.C.S. Luxembourg B 50.922.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LAB DATAVAULT PSF S.A.
Référence de publication: 2013091697/10.
(130112504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Leverlake Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 143.740.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leverlake Investments S.àr.l.
Référence de publication: 2013091686/10.
(130111861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Kilcullen Tesla Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 130.350.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la socétéi>
Référence de publication: 2013091667/10.
(130112239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Koma Services Corporation, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 86.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2013.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013091675/13.
(130112733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Langley Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.676.
Les statuts coordonnés au 19 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013091680/11.
(130112334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98800
L
U X E M B O U R G
Les Jardins d'Alysea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 159.468.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 juillet 2013.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2013091683/11.
(130111639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Librairie-Papeterie KUTTEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1267 Luxembourg, 15, rue Robert Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 26.368.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Librairie-Papeterie KUTTEN S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013091688/11.
(130111885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Lala Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 135.534.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013091702/10.
(130112215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
LCP Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 137.452.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LCP MANAGEMENT S.A.
i>Bernard & Associés, société civile
Référence de publication: 2013091703/11.
(130112629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
LSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 114.341.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013091717/11.
(130112576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98801
L
U X E M B O U R G
Lainière Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 45.650.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091701/9.
(130111692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Lainière Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 45.650.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2013i>
Est nommé administrateur de catégorie A, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2014:
Monsieur Gabriele BINI, demeurant professionnellement au Via Trasemino, 24, I-59013 MONTEMURLO (Prato).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2013.
Référence de publication: 2013091699/13.
(130111690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Leofin Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 103.614.
Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue par voie circulaire en date
du 4 juillet 2013 que les coordonnées de Me Alain RUKAVINA, administrateur, ont été modifiées comme suit:
Me Alain RUKAVINA, né le 2 juillet 1956 à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 9, rue Pierre
d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013091706/13.
(130112349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Mäi Coiffer Julie Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 37, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 42.716.
Les comptes annuels au 31décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013091729/9.
(130111791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Little Sister S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 118.540.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013091713/10.
(130112443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98802
L
U X E M B O U R G
Isystelec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 80.933.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2013091636/10.
(130111886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
JER Adriana S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.613.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013091641/10.
(130112519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
KanAm Grund Omegalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 39.608.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2013.
Référence de publication: 2013091653/10.
(130112552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 145.704.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013091656/10.
(130112357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
LRP III Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.574.700,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 106.147.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2013.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013091716/12.
(130112805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
98803
L
U X E M B O U R G
Mediobanca International Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 81.141.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la société le 28 juin 2013i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- la démission de Monsieur Luca MACCARI en tant que gérant unique de la Société a été acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Stefano BIONDI, avec adresse professionnelle au 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été nommé
en tant que gérant unique de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013091748/17.
(130112086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Fondation Bridderlech Deelen, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Génistre.
R.C.S. Luxembourg G 189.
Comptes annuels au 31 décembre 2012 et Rapport du réviseur d'entreprises agréé
RAPPORT DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉE
Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-
joints de Fondation Bridderlech Deelen, comprenant le bilan au 31 décembre 2012 ainsi que le compte de résultat pour
l'exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.
<i>Responsabilité du Conseil d'Administration pour les comptes annuelsi>
Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,
conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg ainsi que d'un contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
<i>Responsabilité du réviseur d'entreprises agrééi>
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et
de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises
agréé, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d'entreprises agréé prend
en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et à la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité.
Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que l'appréciation de la présen-
tation d'ensemble des comptes annuels.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
<i>Opinioni>
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de Fondation
Bridderlech Deelen au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au
Luxembourg.
98804
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 3 juin 2013.
BDO Audit
<i>Cabinet de révision agréé
i>Représenté par Joseph Hobscheid
<i>Bilan au 31 décembre 2012i>
<i>exprimé en EURi>
Note(s)
2012
2011
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 887,02
2 069,54
3 887,02
2 069,54
Actif circulant
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Autres créances
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .
305 690,13
171 198,19
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et
encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
860 404,87
960 116,19
1 166 095,00 1 131 314,38
Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
19 657,20
0,00
TOTAL DE L'ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 189 639,22 1 133 383,92
PASSIF
Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Fonds social initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000,00
250 000,00
Autres apports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
638 892,65
638 892,65
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 460,02
40 923,81
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(101 058,09)
36 536,21
865 294,58
966 352,67
Dettes non subordonnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Dettes sur achats et prestations de services
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an Autres dettes . . . . .
11 835,03
17 604,02
- dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . .
261 252,96
138 576,93
273 087,99
156 180,95
Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
51 256,65
10 850,30
TOTAL DU PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 189 639,22 1 133 383,92
<i>Compte de Profits et Pertes se clôturant le 31 décembre 2012i>
<i>exprimé en EURi>
Note(s)
2012
2011
CHARGES
Charges en relation avec les projets de coopération au développement . . . . .
10
2 920 687,12 2 366 907,92
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
52 995,61
51 203,31
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
218 178,22
174 153,90
Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 955,93
24 015,81
248 134,15
198 169,71
Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations
corporelles et incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1 747,52
2 195,02
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 711,99
114,50
Intérêts et autres charges financières
- autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336,90
326,30
Profit de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
36 536,21
TOTAL DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 228 613,29 2 655 452,97
98805
L
U X E M B O U R G
PRODUITS
Produits en relation avec les projets de coopération au développement . . . . .
9
2 918 657,88 2 480 404,63
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
200 601,29
169 177,68
Autres intérêts et autres produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
8 296,03
5 870,66
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 058,09
0,00
TOTAL DES PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 228 613,29 2 655 452,97
Les notes figurent en annexe et font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe aux comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2012
Note 1. Généralités. «Fondation Bridderlech Deelen» (la Fondation), est une fondation constituée le 29 octobre 2007
pour une durée illimitée.
La Fondation a pour objet de promouvoir et de soutenir des projets de coopération au développement visant à
améliorer les conditions de vie de la population, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, notamment au
niveau de l'éducation, de la formation, de la nutrition, de la santé, de l'habitat et de l'intégration dans le monde du travail.
La Fondation exerce ses activités en étroite coopération avec des partenaires locaux spécialisés dans les domaines res-
pectifs.
La Fondation peut acquérir les biens mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa
mission, conformément aux exigences des articles 35 et 40 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondation
sans but lucratif telle que modifiée.
Le siège social de la Fondation est fixé à Luxembourg.
La Fondation collabore étroitement avec le Ministère des Affaires Etrangères et dispose de l'agrément prévu à l'article
7 de la loi du 6 janvier 1996 de la part du Ministère de la Coopération et de l'Action humanitaire.
En date du 1 janvier 2010, suite à la dissolution de l'Association Œuvre diocésaine Bridderlech Deelen A.s.b.l., l'entièreté
des activités de l'Association a été transférée à la Fondation.
La Fondation a conclu les accords cadres suivants avec les autorités publiques:
- accord cadre de coopération signé avec les autorités publiques portant sur la période allant du 1 janvier 2012 au 31
décembre 2016;
- accord cadre de coopération signé avec les autorités publiques et la Fondation Caritas Luxembourg, portant sur la
période allant du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2014 (Consortium Caritas).
L'exercice social coïncide avec l'année civile.
Note 2. Principes, Règles et Méthodes comptables. Principes généraux
La Fondation présente les comptes annuels suivant les méthodes de la comptabilité commerciale.
Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en euros; le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.
A la date de clôture du bilan:
- les postes de l'actif, autre que les immobilisations corporelles, exprimés en monnaies étrangères sont valorisés
individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base des cours
de change en vigueur à la date de clôture du bilan.
Pour les immobilisations corporelles, elles sont enregistrées au cours de change historique.
- les postes du passif sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de
leur valeur déterminée sur base des cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan.
Les produits et les charges en devises autres que l'euro sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la
date des opérations.
Ainsi sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et les pertes de change réalisés et les pertes
de change non réalisées.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont valorisées à leur prix d'acquisition, déduction faite des corrections de valeur.
Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur 5 ans, à l'exception du matériel informatique qui est
amorti sur une période de 3 ans.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de corrections de valeur lorsque leur recouvre-
ment est compromis. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur constitution
ont cessé d'exister.
Dettes non subordonnées
Les dettes non subordonnées sont enregistrées à leur valeur de remboursement.
98806
L
U X E M B O U R G
Note 3. Evolution des immobilisations corporelles.
Valeurs d'acquisition
Valeur
d'acquisition
01/01/12
Cessions
de
l'exercice
Acquisitions
de l'exercice
Valeur
d'acquisition
31/12/12
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier
Matériel informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 468,04
0,00
0,00
8 468,04
Installations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 802,58
0,00
3 565,00
9 367,58
Mobiliers de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 925,29
0,00
0,00
1 925,29
16 195,91
0,00
3 565,00
19 760,91
Corrections de valeur
Cumuls des
corrections
de valeurs au
01/01/12
Reprise
de
l'exercice
Dotations
de
l'exercice
Cumuls des
corrections
de valeurs au
31/12/12
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier
Matériel informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6 398,50)
0,00 (1 034,52)
(7 433,02)
Installations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5 802,58)
0,00
(713,00)
(6 515,58)
Mobiliers de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1 925,29)
0,00
0,00
(1 925,29)
(14 126,37)
0,00 (1 747,52)
(15 873,89)
Valeurs nettes
Valeur
nette au
31/12/12
Valeur
nette au
31/12/11
Immobilisations corporelles
Autres installations, outillage et mobilier
Matériel informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 035,02 2 069,54
Installations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 852,00
0,00
Mobiliers de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
3 887,02 2 069,54
Note 4. Créances. Au 31 décembre 2012, la Fondation a comptabilisé les frais administratifs à rembourser par le
Ministère des Affaires Etrangères au titre de l'exercice 2012 (EUR 154 397,89) en produits à recevoir (2011: EUR 131
406,90).
Les autres créances sont également composées d'une créance de EUR 122 641,91 envers la Fondation Caritas Lu-
xembourg (2011: EUR 35 691,84), ainsi que d'une créance de EUR 28 650,33 envers la Fondation du Luxembourg
concernant un projet au Brésil.
Note 5. Capitaux propres. Selon les statuts de la Fondation, le fonds social initial affecté lors de la constitution s'élève
à EUR 250 000,00.
Suite à la dissolution de l'association Œuvre diocésaine Bridderlech Deelen A.s.b.l., l'entièreté des activités et des
résultats au 1
er
janvier 2010 de l'Association ont été transférés à la Fondation.
Le montant des réserves disponibles apportées à la Fondation s'élèvent à EUR 638 892,65.
Note 6. Dettes non subordonnées. Les dettes sur achats et prestations de services au 31 décembre 2012 correspon-
dent à des provisions de charges courantes relatives à l'exercice en cours pour un montant de EUR 11 835,03 (2011:
EUR 17 604,02).
Les autres dettes se composent principalement d'un compte courant auprès de l'Archevêché destiné à centraliser les
fonds recueillis des quêtes et à régler les salaires et traitements du personnel détaché de l'archevêché à la Fondation. Le
solde au 31 décembre 2012 est de EUR 175 271,64 (2011: EUR 116 838,71). Des dettes envers les partenaires s'élèvent
au 31 décembre 2012 à EUR 85 277,00 EUR.
Note 7. Comptes de régularisation. Dans le cadre de la convention établie entre la Fondation du Grand Duc et de la
Grande Duchesse et la Fondation Bridderlech Deelen en 2011, la Fondation a comptabilisé un produit constaté d'avance
de EUR 47 768,49 (2011: EUR 10 850,30).
Note 8. Impôts. La Fondation est exempte de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'Etat et des
communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
98807
L
U X E M B O U R G
Note 9. Produits en relation avec les projets de coopération au développement.
Produits en relation avec les projets de coopération au développement
2012
EUR
2011
EUR
Cofinancements par le Ministère des Affaires étrangères (Accord cadre) . . . . . . . . . . 1 600 000,00 1 400 000,00
Cofinancements par le Ministère des Affaires étrangères (Accord cadre
Consortium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345 286,07
357 600,00
Remboursement relatif à un cofinancement du MAE pour un projet de 1996 . . . . . . .
(5 155,47)
0,00
Subsides SNJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 683,66
7 893,10
Subsides autres ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299 847,12
132 851,56
Subsides provenant d'une administration communale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
9 495,00
Collectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105 150,38
117 603,73
Dons individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
564 258,62
373 549,31
Autres dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
53 313,39
Dons provenant de l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 587,50
23 850,00
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
4 248,54
2 918 657,88 2 480 404,63
Note 10. Charges en relation avec les projets de coopération au développement.
2012
EUR
2011
EUR
Charges en relation avec les projets de coopération au développement
Subventions pour projets non cofinancés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346 453,87
49 422,27
Subventions pour projets accord cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000,00 1 750 641,10
Subventions pour projets consortium avec la Fondation Caritas . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 442,46
447 554,98
Subvention à l'éducation au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 154,32
659,63
Subvention service volontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 183,66
5 629,94
Subvention projets autres ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 452,81
113 000,00
2 920 687,12 2 366 907,92
Note 11. Autres produits d'exploitation. Les autres produits d'exploitation se composent de remboursements de frais
administratifs par le Ministère des Affaires Etrangères, direction de la Coopération au Développement.
Note 12. Autres charges externes.
2012
EUR
2011
EUR
Services extérieurs
Locations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 840,00 12 840,00
Charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 100,00
3 958,98
Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493,29
421,40
Brochures et catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 905,39
2 397,32
Combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510,44
448,46
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386,34
376,47
Divers
Documentation technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299,61
261,00
Fournitures de bureau et petit équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 647,07
2 851,69
Cotisations et frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 773,61
4 161,21
Entretien de rénovations machines et mobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
645,90
Autres services extérieurs
Honoraires, Formations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 260,50 15 538,85
Déplacements et réceptions
Voyages et déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 217,00
2 027,36
Frais postaux et frais de télécommunication
Frais postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
925,38
1 560,57
Affranchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 636,98
3 714,10
52 995,61 51 203,31
Note 13. Personnel. L'effectif moyen en 2012 de la Fondation s'élève à 4 personnes (2011: 4).
98808
L
U X E M B O U R G
Note 14. Autres intérêts et Autres produits financiers. Cette rubrique d'un solde de EUR 8 296,03 (2011: EUR 5
870,66) comprend des intérêts perçus sur les comptes à termes d'établissements bancaires.
Note 15. Conseil d'administration. Il n'y a pas eu de rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration
pour l'exercice 2012.
Note 16. Evènements post-clôture. Il n'y a pas eu d'événement postérieur à la clôture qui a un impact sur la situation
de la société telle que présentée dans ces comptes annuels.
<i>Budget pour l'exercice 2013i>
CHARGES
Budget 2013
A. Charges
2 a)
Charges en relation avec les projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 783 500,00
2.1.1.
Subvention projets non cofinancé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216 000,00
2.1.2.
Subvention projets accord cadre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000,00
2.1.3.
Subvention projets consortium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 000,00
2.1.4.
Subvention projets éducation au développ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 500,00
2.1.5.
Subvention service volontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000,00
2.1.6.
Subvention projets autres ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 000,00
2 b)
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 060,00
2.2.
Services extérieurs
2.2.1.
Locations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 840,00
2.2.2.
Charges locatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 100,00
2.2.3.
Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
2.2.4.
Combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
520,00
2.2.5.
Ordures et déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
2.2.6.
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,00
2.2.7.
Brochures et catalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000,00
2.3.
Divers
2.3.1.
Documentation technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,00
2.3.2.
Fournitures de bureau et petit équip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 700,00
2.3.3.
Cotisations et frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 000,00
2.3.4.
Entretien et réparation machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600,00
2.4.
Autres services extérieurs
2.4.1.
Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 500,00
2.4.2.
Travaux de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 300,00
2.4.3.
Voyages et déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 000,00
2.4.4.
Frais postaux et téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 300,00
2.4.5.
Formation professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 000,00
3
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000,00
3a)
Traitements et salaires
3.1.1.
Traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220 000,00
3b)
Charges sociales
3.2.1.
Charges sociales employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 000,00
4
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 750,00
4.1.
Amortissements sur immob. corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 750,00
5
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,00
5.1.
Droit d'enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,00
7
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350,00
7.1.
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350,00
10
Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
TOTAL CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 105 780,00
PRODUITS
B. PRODUITS
1
Produits en relation avec les projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 884 480,00
1.1.
Subventions de fonctionnement
1.1.1.
Confinancements par le MAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950 000,00
98809
L
U X E M B O U R G
1.1.2.
Remboursement au MAE
1.1.3.
Subsides provenant d'Admin. Commun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 000,00
1.1.4.
Subsides SNJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000,00
1.1.5.
Subsides autres ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327 732,00
1.2.
Produits divers
1.2.1.
Collectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 000,00
1.2.2.
Dons individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467 000,00
1.2.3.
Subsides divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
1.2.4.
Dons provenant de l'étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000,00
1.2.5.
Autres dons (successions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 748,00
1.2.6.
Cession d'éléments de l'actif corporel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
4
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213 300,00
4.1.
Remboursement des frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208 000,00
4.2.
Prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 300,00
7
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 000,00
7.1.
7.1. Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 000,00
10
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 105 780,00
Référence de publication: 2013091501/326.
(130112084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Cavenagh Luxembourg Management, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 153.765.
In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of May,
Before Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Cavenagh Capital B.V., a private limited company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Gustav Mahlerplein 3 - 115, 1082 MS Amsterdam, registered with the trade register of the chamber of commerce
under number 34391304 (the "Sole Shareholder"), represented by Me Anne-Sophie Lliteras, professionally residing in
Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 May 2013 (a copy of which shall remain attached to the present deed to be
registered with it), being the Sole Shareholder of Cavenagh Luxembourg Management, (the "Company"), a société á
responsabilité limitée having its registered office in 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, registered with the Register
of Trade and Companies of Luxembourg under number B 153.765, incorporated by deed of Me Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 10 June 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations ("Memorial") under number 1340 of 30 June 2010.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The Sole Shareholder holds all one hundred twenty-five thousand (125,000) shares in issue, so that decisions can
validly be taken on all items of the agenda.
2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
<i>Agendai>
1) Decision on the dissolution and liquidation of the Company;
2) Appointment of Mr Alain Guérard as liquidator of the Company and determination of the powers of the liquidator
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder then resolved to appoint Mr Alain Guérard, residing at L-1219 Luxembourg 24, rue Beaumont
as liquidator.
The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August, 1915 on commercial
companies (as amended), are granted to the liquidator by the Sole Shareholder. The Sole Shareholder resolved to au-
thorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law
without any special authorisation from the Sole Shareholder if such authorisation is required by law.
98810
L
U X E M B O U R G
The Sole Shareholder resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and it may refer to the books
of the Company. The liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies
with respect to specific acts or deeds. The liquidator may bind the Company under its sole signature.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing person, whom is known to the notary, by his respective name, first
name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trente et unième jour du mois de mai,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Cavenagh Capital B.V., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Pays-Bas ayant son siège social
à Gustav Mahlerplein 3 - 115, 1082 MS Amsterdam, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro 34391304 ("l'Associé Unique"), représentée par Me Anne-Sophie Lliteras, résidant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 mai 2013 (dont une copie restera annexée au présent acte pour
être soumise à la formalité de l'enregistrement), étant l'Associé Unique de Cavenagh Luxembourg Management (la "So-
ciété"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153.765, constituée suivant acte de Me Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 10 juin 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1340 du 30 juin 2010.
Lequel mandataire a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. L'Associé Unique détient la totalité des cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales émises, de sorte que les
décisions puissent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. Les points devant faire l'objet d'une résolution sont les suivants:
<i>Ordre du jouri>
1) Décision sur la dissolution et la liquidation de la Société;
2) Désignation de M. Alain Guérard comme liquidateur de la Société et détermination de ses pouvoirs en tant que
liquidateur
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de dissoudre la Société et de la placer en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Par suite, l'Associé Unique a décidé de désigner Monsieur Alain Guérard, demeurant à L-1219 Luxembourg 24, rue
Beaumont, comme liquidateur.
Les pleins pouvoirs, et en particulier ceux énoncés aux articles 144 et suivants de la loi du 10 juin 1915 sur les sociétés
commerciales (tels qu'amendés) sont octroyés au liquidateur par l'Associé Unique. Par avance, l'Associé unique décide
d'autoriser le liquidateur à accomplir les actes et à passer les actes prévus à l'article 145 de la loi précitée, sans autorisation
spéciale de l'Associé Unique dans le cas où la loi exigerait une telle autorisation.
L'Associé Unique a décidé de dispenser le liquidateur de procéder à un inventaire et il pourra se référer aux livres de
la Société. Le liquidateur sera autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires, en conformité avec la loi ou les actes. Le liquidateur est susceptible de lier la Société par sa seule signature.
Dont acte, le présent acte notarié a été passé à Luxembourg en date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une
traduction française; à la requête du comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais
fera foi.
Le présent acte ayant été lu au comparant qui est connu du notaire, par son nom, prénom usuel, état civil et demeure,
le comparant a signé l'original de cet acte notarié avec nous, le notaire.
Signé: A.-S. LLITERAS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2013. Relation: LAC/2013/26034. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
98811
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Référence de publication: 2013092274/89.
(130112978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.
Société d'Investissement et de Développement Economique Familial S.A., SPF, Société Anonyme - So-
ciété de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 178.462.
STATUTES
The year two thousand and thirteen on the twenty eighth day of June
Before MaTtre Joseph ELVINGER, notary with residence in Luxembourg, undersigned.
Meets an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Namade Int. Corp.", a limited company, incorporated
under the Panama law, having its registered office at the Law Firm RIERA, DIAZ & ASOCIADOS, with domicile P.O. Box
0823-01111, in Panama City, Republic of Panama, incorporated on November 19
th
, 2009 registered with the Public
Register of Panama, under number microfilm 682280.
The Meeting is presided by Mrs Flora Gibert, notary's clerk residing in Luxembourg.
The President appoints as secretary and the Meeting chooses as scrutineer Mrs Kalliopi Fournari with professional
address in Luxembourg.
The President requests the notary to bear witness:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares which they hold are noted on an attendance
sheet, which will be signed, annexed hereto together with the powers-of-attorney, all registered with the deed.
II.- That it is demonstrated by the attendance sheet that the entirety of the share capital is represented at the present
Extraordinary General Meeting, so that the Meeting may validly deliberate regarding all items placed on the order of
business.
All the shareholders present and their proxies declare that they waive all formalities concerning the convocation of
General Meeting and declare having had full and complete knowledge of the order of business of the General Meeting of
Shareholders as well as of the text of the new Articles of Incorporation following the transfer of the registered office of
the Company to Luxembourg, including in particular the exact text of the purpose of the Company after the said transfer
of the registered office.
III.- The General Meeting of Shareholders bears witness that the following documents have been submitted to the
General Meeting:
- a certificate dated April 23 2013 issued by the Register of Panama
- the decision of the board of directors containing the transfer of the registered office of the Company to Luxembourg,
made on April 24, 2013
The said documents, signed ne varietur, shall remain attached to the present deed.
IV.- The President declares that the order of business is as follows:
1. Ratification of the resolutions taken by the board of directors of the company NAMADE INT.CORP. dated on April
24, 2013 deciding to transfer without discontinuity of the Company from Panama to the Grand Duchy of Luxembourg,
as well as registering the Company with the Trade and Companies Register of Luxembourg;
2. Increase of the Company's share capital without creation of new shares by incorporation of a part of the shareholders
loan to raise it from its present amount up to two hundred sixty thousand US dollars (USD 260,000.-) represented by
ten (ten) shares without nominal value;
3. Change of the name of the company as follows "SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECO-
NOMIQUE FAMILIAL S.A., SPF" and adoption of the Luxembourg nationality and conversion of the company into a public
limited liability company (société anonyme) and adoption of the object of a "société de gestion de patrimoine familial -
SPF" in accordance with the law dated May 11, 2007;
4. Amendment to the articles of incorporation as far as it could be necessary in order to adapt them to the Luxembourg
legislation;
5. Decision to set the registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
6. Acceptance of the resignation of the directors of the Company;
7. Appointment of news directors of the Company;
8. Appointment of FIN Contrôle S.A, a public limited company ("société anonyme") existing under Luxembourg law,
with registered office at L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register, under the number B 42.230, as statutory auditor ("commissaire") of the Company;
9. Determination of transitory measures concerning the accounting year;
98812
L
U X E M B O U R G
10. Determination of the accounting statement reference of the Company and confirmation of the carrying out of the
transfer from Panama to Luxembourg in accordance with a necessary and perfect property and juridical continuity;
11. Miscellaneous.
V.- The President declares:
That the Company decides to establish its registered office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The General Meeting has already decided, unanimously, to transfer the registered office of the Company to Luxem-
bourg, the present General Meeting being called upon to vote and approve for a second time the transfer of the registered
office from Bahamas to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and to authenticate the said resolutions in accordance
with the requirements of Luxembourg law.
Charge was also given to the present Shareholders' General Meeting to effect the amendments mentioned below and
those required in order to bring the Articles of Incorporation into accordance with the requirements of Luxembourg
law, as well as to proceed to the election of a Board of Directors and the appointment of a financial commissioner.
Upon which, the Shareholders' General Meeting proceeds to the order of business and after deliberation, the following
resolutions are passed, unanimously:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to confirm and to ratify the resolutions of the Board of Directors of the company dated on April
24
th
, 2013 deciding to transfer the registered office of the Company from Panama to the Grand Duchy of Luxembourg,
with effect as per today, in accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules concerning juridical-person
status, the Company being maintained without break in continuity and without the creation of a new legal entity.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of two hundred fifty thousand US dollars (USD
250,000.-) so as to raise it from its present amount of ten thousand US dollars (USD 10,000.-) to two hundred sixty
thousand US dollars (USD 260,000.-) without creation of new shares.
<i>Subscription - Paying ini>
The increase of the share capital is subscribe by the existing shareholders in proportion of their current shareholding
and is paid in by contribution by the shareholders of a total amount of two hundred fifty thousand US dollars (USD
250,000.-) from the shareholders account.
The proof of the existing shareholders account has been reported to the undersigned notary by a balance sheet showing
such amounts, their contribution up to a global amount of two hundred fifty thousand US dollars (USD 250,000.-) in the
share capital having been duly approved by the shareholders.
In accordance with articles 33-1, 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution has been
supervised by Everard &Klein réviseurs d'entreprises, having its registered office at 83, rue de la Libération, L-5969, Itzig
independent auditor (Réviseur d'Entreprises), and its report concludes as follows:
<i>Conclusion:i>
"Sur base des vérifications effectuées, nous sommes d'avis que l'apport des actifs et passifs transférés sur base de leurs
valeurs au 24 avril 2013 correspond au moins à la valeur du capital social de USD 260.000,00 représenté par 10 actions
sans valeur nominale"
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides that the Company adopts the Luxembourgish nationality and to give to the company in Luxem-
bourg the name of "SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FAMILIAL S.A., SPF" and
to adopt as Company purpose of a "société de gestion de patrimoine familial - SPF" in accordance with the law dated May
11, 2007.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides that the Company shall be as of today and henceforth exclusively governed by Luxembourg law.
Therefore the Meeting decides to proceed to a complete recast of the Articles of Incorporation, in accordance with
Luxembourg law, to read as follows:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be
governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 11 May 2007 introducing the family wealth management
company (société de gestion de patrimoine familial) (the Law on SPF) and by the law dated August 10, 1915, on commercial
companies, as amended (the Law on Companies), as well as by the present articles of association (the Articles).
1.2 The Company will exist under the name of "SOCIETE D' INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE FAMILIAL S.A., SPF".
98813
L
U X E M B O U R G
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted
in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate objects.
4.1 The sole object of the Company, to the exclusion of any commercial activity, is the acquisition, holding, management
and disposal of, on the one hand, financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee
contracts, and, on the other hand, of cash and assets of any kind held in a bank account.
A financial instrument within the meaning of the law of 5 August 2005 on financial guarantee contracts it is to be
understood (a) all securities and other instruments, including, but not limited to, shares in companies and other instru-
ments comparable to shares in companies, participations in companies and units in collective investment undertakings,
bonds and other forms of debt instruments, certificates of deposit, loan notes and payment instruments; (b) securities
which give the right to acquire shares, bonds or other instruments by subscription, purchase or exchange; (c) term financial
instruments and instruments giving rise to a cash settlement (excluding instruments of payment), including money market
instruments; (d) all other instruments evidencing ownership rights, claim rights or securities; (e) all other instruments
related to financial underlyings, indices, commodities, precious metals, produce, metals or merchandise, other goods or
risks; (f) claims related to the items described in sub-paragraph a) to e) above or any rights pertaining to these items,
whether these financial instruments are in physical form, dematerialised, transferable by book entry or delivery, bearer
or registered, endorseable or not and regardless of their governing law.
4.2 Generally speaking, the Company may implement any measure of surveillance or control and carry out any ope-
ration or transaction which it deems necessary or useful for the accomplishment and the development of its corporate
object in the broadest manner possible, provided that the Company does not interfere in the management of the com-
panies in which it holds participations.
Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at two hundred sixty thousand US dollars (USD 260,000.-) consisting of ten (10)
ordinary shares without nominal value.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Shares may only be held by qualified investors as defined in article 3 of the Law on SPF.
6.2 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,
at the opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject
to the restrictions foreseen by Law on Companies.
6.3 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title
of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
6.4 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law on Companies.
98814
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company
(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the third Monday of the month of May, at 10.00 a.m.. If such day is not a
business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by Law on Companies shall govern the notice for, and the conduct
of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.
8.2 Each share is entitled to one vote.
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves
as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors
composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).
9.2 The Director(s) shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders.
The director(s) shall be eligible for reappointment.
9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person
delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
98815
L
U X E M B O U R G
10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law on
Companies or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 12. Delegation of powers.
12.1 The Board of Directors may appoint one delegate to the day to day management of the Company, who need not
to be neither a shareholder neither a Directors, who will have the full power to act in the name of the Company concerning
the day to day management.
12.2 The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two
members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to
whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.
14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or,
where requested by the Law on Companies, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory
auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
terminate on the 31
st
of December of the same year.
98816
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.3 above.
17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law on Companies.
Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law on Companies.
Art. 20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law on SPF and the Law on Companies for all
matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitional provisionsi>
1) The first financial year in the Grand Duchy of Luxembourg shall begin today to end on 31 December 2013.
2) The first Ordinary General Meeting in the Grand Duchy of Luxembourg shall be held at 10.00 a.m. on the third
Monday of the month of May 2014.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting confirms and decides that the registered office of the Company is established at the following address:
412 F route d'Esch, L-2086 Luxembourg
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting accepts the resignation of the directors.
The Meeting decides to set the number of directors at three.
<i>Are appointed directors:i>
- Mr. Jean-Hugues Doubet born on 7 May 1974 in Strasbourg and residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg;
- Mr. Renaud LEONARD, born on 8 November 1979 in Bastogne (Belgium) and residing professionally at 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mrs. Regine BARBIER, born on 25 October 1964 in Saint-Mard (Belgium) and residing professionally at 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Their mandate shall end during the Ordinary General Meeting of 2019.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting decides to set the number of statutory auditor at one.
Is appointed statutory auditor:
FIN Contrôle S.A, a public limited company (société anonyme) existing under Luxembourg law, with registered office
at L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under
the number B 42.230 The mandate shall end with the General Meeting of 2019.
<i>Costsi>
The costs, expenditures, remunerations and charges in whatsoever form, incumbent on the Company or chargeable
to it by reason of these presents, are estimated, without any prejudice, at approximately the sum of one thousand five
hundred Euro.
No item remaining on the order of business, the meeting is concluded.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
IN WITNESS WHEREOF, drawn up in Luxembourg, the day, month and year as in the heading of these presents.
And after reading given to those appearing, all did sign with Us, Notary, the present minutes.
98817
L
U X E M B O U R G
Follows the french translation
L'an deux mille treize le vingt huit juin,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit de Panama "Namade
Int. Corp.", ayant son siege social auprès de RIERA, DIAZ & ASOCIADOS, P.O. Box 0823-01111, Panama City, République
de Panama, incorporée le 19 novembre 2009 et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Panama, sous
le numéro microfilm 682280.
L'assemblée est présidée par Mme Flora Gibert, clerc de notaire demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mme Kalliopi Fournari, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation
des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l'objet de la Société après ledit transfert du siège social.
III.- L'Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l'Assemblée
Générale:
- un certificat daté du 23 avril 2013, émis par le registre du Panama
- la décision du Conseil d'administration contenant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg prise en
date du 24 avril 2013
Les dits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV.- Le Président déclare que l'ordre du jour est le suivant:
1. Ratification de la décision du conseil d'administration adoptées en date du 24 avril 2013 ayant décidé le transfert
sans disparition de la personnalité juridique de la Société de Panama au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l'imma-
triculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg;
2. Augmentation du capital social par incorporation d'une partie du compte courant des actionnaires afin de le porter
à deux cent soixante mille Dollars US (USD 260.000,-) sans émission d'actions nouvelles représenté par dix (10) actions
sans désignation de valeur nominale;
3. Changement de la dénomination sociale de la société en "SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE FAMILIAL S.A., SPF" et adoption de la nationalité luxembourgeoise et transformation de la société en
une société anonyme et adoption de l'objet d'une société de gestion de patrimoine familial conformément à la loi du 11
mai 2007;
4. Modification des statuts afin de les adapter à la législation luxembourgeoise.
5. Décision de fixer le siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
6. Acceptation de la démission des administrateurs;
7. Nomination de nouveaux administrateurs;
8. Nomination de FIN Contrôle S.A, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1882 Lu-
xembourg, 12 rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg B 42.230, en tant que commissaire aux comptes ("commissaire")
de la société;
9. Détermination des dispositions transitoires concernant le premier exercice social;
10. Détermination de l'état comptable de référence de la Société et confirmation de la réalisation du transfert en
provenance des Bahamas au Luxembourg, dans une continuité juridique parfaite.
11. Divers.
V.- Le Président déclare:
Que la Société décide d'établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'assemblée générale des actionnaires a déjà décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société à Luxem-
bourg, la présente assemblée générale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège
social des Bahamas à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et à authentifier lesdites résolutions conformément
aux exigences de la loi luxembourgeoise.
Le soin a également été confié à la présente assemblée générale des actionnaires d'effectuer les modifications men-
tionnées ci-dessus et celles exigées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises
légales, de même que l'élection du Conseil d'Administration et la nomination du commissaire aux comptes.
98818
L
U X E M B O U R G
Sur ce, l'assemblée générale des actionnaires aborde l'ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes
sont prises à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en
date du 24 avril 2013 décidant de transférer le siège social de la société de Panama au Grand-Duché de Luxembourg,
avec effet à la date de ce jour, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le
statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture et sans création d'un être moral
nouveau.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille Dollars US (USD 250.000-)
pour le porter de son montant actuel de dix mille Dollars US (USD 10.000,-) à deux cent soixante mille Dollars US (USD
260.000,-) sans émission d'actions nouvelles représenté par dix (10) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Souscription - Libérationi>
L'augmentation de capital est souscrite par les actionnaires existants proportionnellement à leur participation actuelle
dans la société et sera libérée par prélèvement à due concurrence sur le compte des actionnaires pour un montant total
de deux cent cinquante mille Dollars US (USD 250.000,-).
La preuve de l'existence du compte des actionnaires a été faite au Notaire instrumentant par remise d'une situation
comptable reprenant au moins la valeur de l'apport pour un montant global de deux cent cinquante mille Dollars US
(USD 250.000,-) au capital social de la société. L'apport en capital a été dûment approuvé par les actionnaires.
Conformément aux articles 33-1, 32-1 et 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, ce transfert de siège a fait
l'objet d'une vérification par Everard & Klein, Réviseur d'Entreprises indépendant, ayant son siège social au 83, rue de la
Libération, L-5969, Itzig, et son rapport conclut comme suit:
<i>Conclusion:i>
"Sur base des vérifications effectuées, nous sommes d'avis que l'apport des actifs et passifs transférés sur base de leurs
valeurs au 24 avril 2013 correspond au moins à la valeur du capital social de USD 260.000,00 représenté par 10 actions
sans valeur nominale ".
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide que la société existera sous la forme d'une société anonyme. L'assemblée décide de donner comme
dénomination de la société à Luxembourg "SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
FAMILIAL S.A., SPF" et d'adopter comme objet de la société les dispositions concernant une société de gestion de
patrimoine familial conformément à la loi du 11 mai 2007.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion
de tout autre.
Par conséquent, l'assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et
de leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination.
1.1 II est formé une société anonyme (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («Loi sur les SPF») et par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts
(les Statuts).
1.2 La Société existe sous la dénomination de «SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE FAMILIAL S.A., SPF».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra
pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.
Art. 2 Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-
tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.
2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
98819
L
U X E M B O U R G
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)
de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion
et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. Par instrument financier au sens
de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et
autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et
d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse
et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de
souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en
espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous les autres
titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à des
sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou
marchandises, à d'autres biens ou risques, (f)les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les
droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et
quelque soit le droit qui leur est applicable.
4.2 D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute
opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF.
Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à deux cent soixante mille Dollars US (USD 260.000) représenté par dix (10)
actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.
5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1 Les parts sociales ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi
sur les SPF.
6.2 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de
l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi sur les Sociétés.
6.3 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
6.4 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi sur les Sociétés, racheter ses propres actions.
Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.
Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.
7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-
blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
98820
L
U X E M B O U R G
7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de
la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de
mai, à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sur les Sociétés sont applicables aux avis de convocation et
à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts, les décisions de
l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et
votants.
8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment
convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration
composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).
9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée
Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).
9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-
nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et
peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au
lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un
autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont
présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.
98821
L
U X E M B O U R G
10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.
Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.
10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence
téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.
10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Ad-
ministration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du
Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.
12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution
de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux
administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.
Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé
d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.
14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire
de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.
Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi
sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant
pas six ans et il est rééligible.
15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,
leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.
Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
la même année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
98822
L
U X E M B O U R G
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.
17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer
des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.
17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et
doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.
Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation.
L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.
Art. 20. Droit applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi sur les SPF et la Loi sur les Sociétés.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg débutera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2013.
2) La première Assemblée Ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra le deuxième mardi du mois de juin
2014.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: 412F, route d'Esch,
L-2086 Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée prend acte de la révocation des administrateurs
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs:
- Mr. Jean-Hugues Doubet né le 7 mai 1974 à Strasbourg (France) et résident professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mr. Renaud LEONARD, né on 8 novembre 1979 à Bastogne (Belgique) et résident professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mrs. Regine BARBIER, née le 25 octobre 1964 à Saint-Mard (Belgique) et résident professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L'assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommé comme commissaire: FIN Contrôle S.A, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social
à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg B 42.230.
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F.GIBERT, K.FOURNARI, J.ELVINGER.
98823
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1
er
juillet 2013. Relation: LAC/2013/30207. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2013092837/660.
(130113337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.
AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 28.850.
L'an deux mille treize, le quatre juillet.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AGEFI Luxembourg -Le
Journal Financier de Luxembourg", établie et ayant son siège social à L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 8 septembre 1988, publié au
Mémorial C numéro 317 du 1
er
décembre 1988, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous
le numéro numéro B 28850.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Joëlle BADEN,
notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 novembre 2008, publié au Mémorial C numéro 1834 du 10 août 2011.
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Adelin REMY, demeurant professionnellement
à L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme SCHMIT, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Adelin REMY, demeurant professionnellement à L-8287 Kehlen, 41,
Zone Industrielle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon, à L-8287 Kehlen, 41, Zone Indus-
trielle et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que sur les NEUF MILLE TRENTE-QUATRE (9.034) actions sans désignation
de valeur nominale, HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF actions sont représentées, à la présente assemblée, de
sorte que celle-ci peut valablement délibérer; cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires repré-
sentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau, resteront annexées au présent procès-verbal
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Que la majorité du capital social étant représentée à la présente assemblée, et les actionnaires représentés se
reconnaissant dûment convoqués par lettres recommandées datées du 19 juin 2013, et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, l'Assemblée est valablement constituée et en
mesure de prendre valablement des décisions sur l'ensemble des points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon, à
L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 1
er
des statuts qui
aura la teneur suivante:
"Le siège social de la société est établi dans la commune de Kehlen".
Les autres alinéas de l'article 1
er
restent inchangés.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: REMY, SCHMIT, MOUTRIER
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05/07/2013. Relation: EAC/2013/8753. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
98824
L
U X E M B O U R G
Esch-sur-Alzette, le 09 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093009/53.
(130114534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
AdB, Almanach de Bruxelles, Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 120.115.
L'an deux mille treize, le quatre juillet.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AdB, ALMANACH DE BRU-
XELLES", établie et ayant son siège social à L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 28 septembre 2006, publié au Mémorial C numéro
2176 du 21 novembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro numéro B
120.115
Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 537 du 4 mars 2008.
La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Adelin REMY, demeurant professionnellement
à L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme SCHMIT, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Adelin REMY, demeurant professionnellement à L-8287 Kehlen, 41,
Zone Industrielle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon, à L-8287 Kehlen, 41, Zone Indus-
trielle et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
2.- Divers.
II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX
EUROS (€ 310.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont
dûment présentes ou représentées à la présente assemblée; cette liste de présence ainsi que la procuration de l'actionnaire
représenté, après avoir été signées par les membres du bureau, resteront annexées au présent procès-verbal pour être
soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, et les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués par lettres recommandées datées du juin 2013, et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, l'Assemblée est valablement
constituée et en mesure de prendre valablement des décisions sur l'ensemble des points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon, à
L-8287 Kehlen, 41, Zone Industrielle et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura
la teneur suivante:
"Le siège social de la société est établi dans la commune de Kehlen".
Les autres alinéas de l'article 2 restent inchangés.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: REMY, SCHMIT, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05/07/2013. Relation: EAC/2013/8755. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
98825
L
U X E M B O U R G
Esch-sur-Alzette, le 09 juillet 2013.
Référence de publication: 2013092988/53.
(130114688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Bepaumat Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.486.
STATUTS
L'an deux mil treize, le vingt et un juin.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
- Monsieur Peter Jan BEYERS, indépendant, né à Mortsel (Belgique), le 5 septembre 1967, demeurant à B-6810 Jamoigne
(Belgique), 10, rue de Grigny.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite, et dont il a arrêté les statuts
comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «BEPAUMAT Sàrl».
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Windhof.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par décision du ou des associés pris
aux conditions requises pour la modification des statuts.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet les activités et services commerciaux, en particulier dans le domaine du software.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-€), divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq euros (125.-€) chacune.
Toutes les parts ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par l'associé unique, Monsieur Peter Jan
BEYERS, indépendant, demeurant à B-6810 Jamoigne, 10, rue de Grigny, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant moyennant certificat bancaire.
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. L'associé unique est libre de céder ses parts.
En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.
En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément, donné
en assemblée générale des autres associés représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'associé unique ou d'un des associés ne mettent pas fin à
la société.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
98826
L
U X E M B O U R G
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés, qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Les décisions de l'associé unique
prises dans ce domaine sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès verbal
ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui
lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Année sociale - Bilan
Art. 14. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-
mément aux dispositions légales en vigueur.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-
pation au capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 950,- EUR.
<i>Décisions de l'Associé Uniquei>
Les statuts de la société ainsi été arrêtés, le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1.- L'adresse du siège social est fixée à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Peter Jan BEYERS, préqualifié.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Beyers, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 juin 2013. Relation: LAC/2013/29126.
98827
L
U X E M B O U R G
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPÉDITION CONFORME, Délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 9 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093075/103.
(130114627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
EIFAS SA, European Institute for Applied Sciences SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 46, boulevard de la Fraternité.
R.C.S. Luxembourg B 178.477.
STATUTEN
Im Jahre zweitausenddreizehn, den vierundzwanzigsten Juni.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg).
Ist erschienen:
- Die Gesellschaft "Letta S.ä r.l", mit Sitz zu L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange, eingetragen im Handelsregister
unter der Nummer B 171.200,
hier vertreten durch seinen Geschäftsführer Prof. Dr. Nicolaus WENZEL, Wirtschaftsingenieur, wohnhaft zu L-1541
Luxembourg, 46, boulevard de la Fraternité.
Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft
luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "European Institute for Applied Sciences SA", abgekürzt: "EIFAS SA" ge-
gründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-
gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität
der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
(1) Die Förderung von angewandter Wissenschaft und Forschung und der damit in Zusammenhang stehenden Tech-
nologien.
(2) Forschung für eigene Zwecke und Auftragsforschung und Auftragsentwicklung.
(3) Prüfung für eigene Zwecke und Auftragsprüfung.
(4) Erstellung von Programmen und Software im Bereich von angewandter Wissenschaft und Forschung und der damit
in Zusammenhang stehenden Techniken.
(5) Erarbeitung von Konzepten im Bereich Industrial Engineering. Auditieren von industriellen Prozessen. Handeln als
Institut für Industrial Engineering, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen.
(6) Produktion und Handel mit Produkten als Ergebnis der angewandten Wissenschaft und Forschung und der damit
in Zusammenhang stehenden Technologien.
(7) Vermittlung von Wissenschaftlern und Fachkräften im Bereich der angewandten Wissenschaft und Forschung und
der damit in Zusammenhang stehenden Technologien.
(8) Das Erstellen und Vermitteln von Gutachten in allen technischen Bereichen, der An- und Verkauf von Know-How
in allen technischen Bereichen, die Beratung bezüglich technischer Lösung bzw. von entsprechendem Know-how Transfer
sowie die Beratung und Lehrgänge für den Bereich Know-How und entsprechender Gutachten im Bereich der ange-
wandten Wissenschaft und Forschung und der damit in Zusammenhang stehenden Technologien.
(9) Anmeldung, Kauf oder anderweitiger Erwerb sowie Besitz und Nutzung intellektuellen Rechten jeder Art, Über-
tragung von Rechten zur Nutzung oder Veröffentlichung von Geheimnissen oder sonstigen Kenntnissen sowie Nutzung,
Ausübung, Entwicklung und Vergabe von Lizenzen zu auf diese Art und Weise erworbenem Eigentum, Rechten und
Kenntnissen.
(10) Tätigkeit als Holding für Unternehmensbeteiligung und Immobilien und materielle und immaterielle Wirtschafts-
güter, sowie Kauf oder sonstiger Erwerb und Übernahme von jeglichen Geschäften oder Unternehmen, die zweckdienlich
erscheinen, oder Beteiligung an und Durchführung oder Veräußerung, Aufgabe oder Beendigung dieser Geschäftstätig-
98828
L
U X E M B O U R G
keiten bzw. sonstiger Umgang mit derartigen Geschäften oder Unternehmungen, wie dies als wünschenswert erachtet
wird.
(11) Geschäftstätigkeit einer allgemeinen Handelsgesellschaft, sowie ausführen jeglicher anderer Art von Handel oder
Geschäft mit Hardware und Software.
(12) Jegliche sonstige Geschäftstätigkeit, die nach Auffassung der Direktoren von der Gesellschaft in vorteilhafter Art
und Weise durchgeführt werden kann.
(13) Erwerb, Besitz oder Beteiligung von bzw. an Grundstücken, Gebäuden, Dienstbarkeiten, Rechten, Vorrechten,
Konzessionen, Lizenzen, Geheimverfahren, Maschinen, Anlagen, Beständen und jeglichem beweglichen und unbeweglichen
Eigentum aller Art, das/die für den Zweck der Gesellschaft oder in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
notwendig bzw. geeignet ist/sind, durch Kauf, Pacht, Tausch, Miete oder anderweitig.
(14) Errichtung, Umbau oder Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen und Maschinen, die für die Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft notwendig bzw. geeignet sind und Mitwirkung oder finanzielle Unterstützung bei Errichtung, Bau oder Ins-
tandhaltung der Obengenannten.
(15) Gründung anderer Gesellschaften oder Mitwirkung bei der Gründung anderer Gesellschaften zum Zwecke des
Erwerbs oder der Übernahme des gesamten oder eines Teils des Vermögens, der Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten
der Gesellschaft oder zum Zwecke der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Gegenstands oder der Interessen
der Gesellschaft sowie Erwerb, Besitz oder Veräußerung von einer solchen anderen Gesellschaft herausgegebenen An-
teilen bzw. Aktien, Anleihen oder Wertpapieren oder sonstigen Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten einer solchen
Gesellschaft.
(16) Anlage von und Geschäftstätigkeit mit Geldern der Gesellschaft, die nicht unmittelbar für die Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft benötigt werden; die Anlagen und deren Form werden von der Gesellschaft genehmigt.
(17) Eingehen von Vereinbarungen über Gemeinschaftsarbeit, Zusammenschluss, Partnerschaften, Gewinnbeteiligung,
Interessengemeinschaften, gegenseitige Zugeständnisse oder Zusammenarbeit mit Gesellschaften, Firmen oder Personen,
die eine Tätigkeit durchführen oder durchzuführen beabsichtigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung
steht und dieser unmittelbar oder mittelbar von Nutzen sein könnte.
(18) Kauf oder anderweitiger Erwerb und Übernahme des gesamten Unternehmens, Eigentums, der gesamten Ver-
bindlichkeiten und Geschäfte von Personen, Firmen oder Gesellschaften, die eine Geschäftstätigkeit durchführen, die der
Gesellschaft oder deren Interessen dienlich sein könnte oder Eigenschaften besitzen, die dem Zweck der Gesellschaft
dienlich sein könnten, oder von Teilen davon.
(19) Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobilen und
immobilen Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Errei-
chung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxembourg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt VIERZIGTAUSEND EURO (40.000.- €), eingeteilt in VIERZIGTAUSEND
(40.000) Aktien mit einem Nominalwert von je EINEM EURO (1.- €), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in
den Generalversammlungen.
Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien
bestehen.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-
versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher
aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen
kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die
Generalversammlung ernannt werden.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und
gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.
98829
L
U X E M B O U R G
Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die
Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder duch
die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.
Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage
vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.
Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-
sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-
tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2013.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2014.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet. Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe
eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von VIERZIGTAUSEND EURO (40.000.- €) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger
Gründung erwachsen, auf ungefähr NEUNHUNDERT EURO (900.- €).
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zum einzigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
- Prof. Dr. Nicolaus WENZEL, Wirtschaftsingenieur, wohnhaft zu L-1541 Luxembourg, 46, boulevard de la Fraternité.
<i>Zweiter Beschlußi>
Zum Kommissar wird ernannt:
- Annette WENZEL, Diplom-Ökonomin, wohnhaft zu L-1541 Luxembourg, 46, boulevard de la Fraternité.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Mandate des einzigen Verwaltungsratsmitglieds und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung
welche über das Geschäftsjahr 2018 befindet.
98830
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlußi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-1541 Luxembourg, 46, boulevard de la Fraternité.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der
statutarische Gesellschaftssitz befindet.
<i>Fünfter Beschlußi>
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen
Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: WENZEL, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 juin 2013. Relation: LAC / 2013 / 30025.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Référence de publication: 2013093225/174.
(130114255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.
Abilen Eurasia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 176.051.
<i>Written resolutions of the sole shareholder of the Company dated 21 i>
<i>sti>
<i> May 2013i>
The undersigned,
Valentina BABINETS, residing professionally at 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
being the holder of all the shares of the Company hereby:
Noted article 200-2 of the Luxembourg law of 10
th
August 1915 on commercial companies as amended and the
articles of incorporation of the Company.
Noted that Geleyn Wim Mark P has resigned from his mandate as Class B Manager of the Company, with effect as of
16
th
May 2013.
Resolved to appoint, with effect as of 16
th
May 2013, Maksim RASATSKI, born on 18 December 1990 in Minsk, Belarus,
residing at 207, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, as Class B Manager of the Company for an undetermined period of
time.
As result of the above, the board of managers of the Company is composed as follows:
- Valentina BABINETS, Class A Manager; and
- Maksim RASATSKI, Class B Manager.
In witness thereof the sole shareholder of the Company signed the present shareholder resolution dated the date
hereaforementioned.
Valentina BABINETS.
<i>Résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société en date du 21 mai 2013i>
Par la présente, la soussignée
Valentina BABINETS demeurant professionnellement à 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
en sa qualité de détenteur de toutes les parts de la Société,
en se référant à l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et
à l'Acte constitutif de la Société,
a pris acte de la démission de Geleyn Wim Mark P de son mandat de gérant de Classe B de la Société, avec effet au
16 mai 2013;
98831
L
U X E M B O U R G
a pris la décision de nommer, avec effet au 16 mai 2013, Maksim RASATSKI né le 18 décembre 1990 à Minsk, Bélarus,
demeurant à 207, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, en qualité de gérant de Classe B de la Société pour une période
indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil de gérance de la Société se compose comme suit.
- Valentina BABINETS, gérant de Classe A et
- Maksim RASATSKI, gérant de Classe B:
En foi de quoi l'actionnaire unique de la Société a signé la présente résolution de l'actionnaire, date qu'en tête des
présents.
Valentina BABINETS.
18.06.13.
Près les Tribunaux Luxembourgeois
Valéry BARANOV
<i>Traducteur Assermentéi>
Référence de publication: 2013091164/46.
(130110880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2013.
Ernst August Carree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.636.400,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 130.430.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par le gérant unique en date du 26 juin 2013 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 26-28, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet au 1
er
juillet 2013.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2013.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013091451/15.
(130112202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Luthor S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.252.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/6/2013.
Signature.
Référence de publication: 2013091721/10.
(130112460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
LIP second S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 16, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 139.169.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG CONSULT S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2013091712/13.
(130112000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
98832
Abilen Eurasia S.à r.l.
AdB, Almanach de Bruxelles
AGEFI Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg
Bepaumat Sàrl
Cavenagh Luxembourg Management
Dentsply Holding Company Luxembourg Branch
Dentsply International Inc. Luxembourg Branch
Dentsply International Inc. Luxembourg Branch
ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B
Ernst August Carree S.à r.l.
European Institute for Applied Sciences SA
Exakt S.A.
First Data International Luxembourg VIII S.à r.l.
Fitflop International S.à r.l.
Fondation Bridderlech Deelen
Goodman Marble Logistics (Lux) S.à r.l.
Hotel & Co II S.à r.l.
Independence Trans Europe Lines Navy 2001 S.A.
Industry Credit Asia B.V.
Isystelec S.à r.l.
JER Adriana S. à r.l.
JER Audrey S.à r.l.
JER Baywatch S.à r.l.
Jubelade Management S.à r.l.
KanAm Grund Omegalux S.A.
Kersting Luxembourg Sàrl
Kilcullen Tesla Holding S.A.
KJcompTA
KJcompTA
Koch Nitrogen Finance Luxembourg S.àr.l.
Koma Services Corporation
Kulczyk Real Estate Holding S. à r.l.
Lab Datavault PSF S.A.
Lainière Luxembourg S.A.
Lainière Luxembourg S.A.
Lainière Luxembourg S.A.
Lala Private Equity S.A.
Langley Luxco 2 S.à r.l.
LCP Management S.A.
Leofin Investissements S.A.
Les Jardins d'Alysea S.A.
Leverlake Investments S.àr.l.
Librairie-Papeterie KUTTEN S.à r.l.
LIP second S.à r.l.
Little Sister S.A.
LRP III Luxembourg Holdings S.àr.l.
LSL S.à r.l.
Luik Investment 2008 S. à r.l.
Luthor S.à.r.l.
Mäi Coiffer Julie Sàrl
Mediobanca International Immobilière S.à r.l.
Pitney Bowes Luxembourg
Progeny
Prostar S.A.
Ramako S.à r.l.
RBS European Finance S.A.
Reflexes Finance S.A.
Rigatte SA, SPF
Right Choice S.A.
Rue des Tulipes
SHS Europe S.A.
Société d'Investissement et de Développement Economique Familial S.A., SPF