logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2014

20 août 2013

SOMMAIRE

Cheverny 2 International S.à r.l.  . . . . . . . . .

96661

Ecofi (Lux) Premium SICAV  . . . . . . . . . . . .

96641

GHE Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96669

Investissements Minéraux et Financiers

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96666

Italian Food Participations S.A. . . . . . . . . . .

96664

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.)  . . .

96665

Jemco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96666

JOFAD Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96667

Jubrifin S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96667

Jupiter Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

96663

Kahasun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96665

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.  . . . . .

96668

Kalmo Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

96668

Kirchberg Securities Finance Fund, SI-

CAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96668

KPI Retail Property 35 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

96665

La Royale Ressource Vive Distribution  . . .

96662

LogAxes Investment Properties S.à r.l.  . .

96662

Longbow UK Real Estate Debt Invest-

ments II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96666

Lux Fund Consult S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

96667

Minotaur S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96661

Oneley S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96627

OREF Real Estate G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . .

96626

Origami Realty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96631

Orlando Italy Management S.A.  . . . . . . . . .

96631

Ostria Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

96669

OXEA FINANCE & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . .

96632

Parker Hannifin Partnership S.C.S.  . . . . . .

96631

Partners Group Direct Investments 2009

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96632

Partners Group Global Mezzanine 2007

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96660

Partners Group Global Mezzanine 2007

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96660

Partners Group Global Value 2008 S.C.A.,

SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96632

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96656

Paser Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

96655

Philips Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

96660

PHM Holdco 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96660

PIE Group II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96636

PIE Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96657

Pimas-Umbrella SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . .

96627

Pimco Luxembourg IV S.A.  . . . . . . . . . . . . .

96659

Pimco Luxembourg IV S.A.  . . . . . . . . . . . . .

96659

Pradier Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

96626

Praesidium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96636

Precision Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96661

Protection International S.à r.l. . . . . . . . . . .

96661

Prowell Consult Luxco GmbH . . . . . . . . . . .

96642

Resolution Bremen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

96626

RF Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96656

Russian Asset MBS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

96626

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96656

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96656

Sime Darby Investments (Europe) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96662

Steen Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96663

96625

L

U X E M B O U R G

Resolution Bremen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 139.651.

EXTRAIT

Il est porté à connaissance à qui de droit que le siège social de l'associé unique de la Société, à savoir «Resolution III

Holdings S.à r.l.», a été transféré du 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 15 - 17 Avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg, avec effet au 3 mai 2013

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Valérie Ingelbrecht
<i>Gérante

Référence de publication: 2013088021/14.
(130108085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Russian Asset MBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.377.

<i>Extrait des minutes du conseil d'administration tenu au siège social de la société le 20 juin 2013

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400,

Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, enregistré sous le numéro B65477 au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société concernant l'audit des comptes annuels se clôturant le 31 dé-
cembre 2012.

A Luxembourg, le 24 juin 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013088024/16.
(130107972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

OREF Real Estate G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013088876/10.
(130109978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Pradier Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.152.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PRADIER PARTICIPATIONS S.A.
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013088934/14.
(130109370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

96626

L

U X E M B O U R G

Pimas-Umbrella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 143.368.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-

<i>Golf, Großherzogtum Luxemburg, am 18. März 2013 um 10.00 Uhr abgehalten wurde.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, mit Wirkung zum 18. März 2013, die Ernennung des Herrn Magister Erhard

Tschmelitsch,  geboren  am  23.  September  1961  in  Lustenau,  Österreich,  geschäftsansässig  in  Walserstrasse  61,  6991
Riezlern, Österreich, als Mitglied des Verwaltungsrates Gesellschaft.

Die Dauer des Verwaltungsratsmandats endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im August 2013

stattfinden wird.

Référence de publication: 2013088894/15.
(130109767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Oneley S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 178.339.

STATUTS

L'an deux mille treize,
le vingt et un juin.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxem-

bourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de
Luxembourg, la présente minute restant en la garde et détention du notaire Jean-Joseph WAGNER,

a comparu:

«CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, R.C.S. Luxembourg, section B sous le numéro
97 199,

ici représentée par:
Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 juin 2013.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

Lequel mandataire, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société de

gestion de patrimoine familial (SPF) sous forme d'une société anonyme que la partie comparante déclare constituer et
dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par l'actionnaire unique une société anonyme de gestion de patrimoine familial (la "Société")

régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée et telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial («SPF») et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «ONELEY S.A., SPF».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

96627

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

La société ne peut avoir aucune activité commerciale.
Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

La société est soumise au respect de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine

familial «SPF».

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3'500'000.- EUR) représenté

par trois mille cinq cents (3'500) actions ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.-EUR) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

96628

L

U X E M B O U R G

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le quinze mars de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

96629

L

U X E M B O U R G

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions Générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, la société «CRITERIA S.à r.l.», prénommée,

représentée comme mentionné ci-avant, déclare souscrire, en sa qualité de seul et unique actionnaire, les trois mille cinq
cents (3'500) actions ordinaires.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TROIS MILLIONS CINQ

CENT MILLE EUROS (3'500'000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille cent euros.

<i>Résolutions de l’actionnaire unique

La partie comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique

de la société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. Est nommé administrateur unique:
Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, demeurant professionnellement au 10B, rue

des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société «MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise aux lois luxembour-

geoises, établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 145 419).

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statutaire de l'année 2019.

Toutefois, le mandat de l'administrateur unique expirera à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de

l'existence de plus d'un actionnaire.

5. Le siège social de la société est fixé au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: B. D. KLAPP, M. SCHAEFFER.

96630

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 juin 2013. Relation: EAC/2013/8266. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013088873/201.
(130109741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Orlando Italy Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.648.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Assemblée tenue le 20 juin 2013.

<i>Résolution:

Étant donné que les mandats des membres du conseil d'administration se terminent à la présente assemblée, l'assem-

blée générale décide de renouveler les mandats de:

- M. Gustave Stoffel, Consultant, demeurant professionnellement à 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg

- M. Georg Madersbacher, Managing Director, demeurant professionnellement à Fischerweg 2, D - 86938 Schondorf
- M. Mauro Ercolani, Chief Financial Officer, demeurant professionnellement à 31, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg

En outre, M. Gustave Stoffel est nommé Président du Conseil d'Administration.
Les mandats des membres du conseil d'administration expireront lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra

en 2018.

Étant donné que le mandat du Commissaire aux comptes se termine à la présente assemblée, l'assemblée générale

décide de renouveler le mandat de Picigiemme S.à r.l., ayant son siège social à 38, Haerebierg, L-6868 Wecker, jusqu'à
l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra à 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

Référence de publication: 2013088880/25.
(130109736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Origami Realty, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 152.780.

EXTRAIT

Il est noté le du changement d'adresse professionnelle des administrateurs:
- Maître Michaël Dandois,
- Maître Antoine Meynial,
- Monsieur Stéphane Warnier,
désormais au 23 rue Jean Jaurès L-1836 Luxembourg.
L'adresse du commissaire aux comptes Chester &amp; Jones Sàrl a également été transférée, au 14 rue Bernard Haal,

L-1711 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2013088877/17.
(130109315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Parker Hannifin Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.172.

EXTRAIT

- Il résulte d'une décision de la Société que le siège social est transféré du 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg au 20, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

96631

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088886/12.
(130109460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Partners Group Global Value 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.053.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 28. Juni 2013

Am 28. Juni 2013 kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers Société coopérative (vormals PricewaterhouseCoopers

S.à r.l.) wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre verlängert.

Luxemburg, den 02 Juli 2013.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2013088890/17.
(130109424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Partners Group Direct Investments 2009 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 142.451.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 28. Juni 2013

Am 28. Juni 2013 kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers Société coopérative (vormals PricewaterhouseCoopers

S.à r.l.) wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre verlängert.

Luxemburg, den 02 Juli 2013.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2013088887/17.
(130109426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.693.

In the year two thousand and thirteen, on the fourteenth day of June.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement  of  Maître  Jean-Joseph  WAGNER,  notary  residing  in  Sanem,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  who  will  remain
depositary of the present original deed.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of OXEA FINANCE &amp; CY S.C.A., a société en commandite

par actions, having its registered office at 47, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.693 and incorporated by a notarial
deed dated 3 June 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 23
July  2010  (number  1515,  page  72675),  whose  articles  of  association  have  not  been  amended  until  today's  date  (the
"Company").

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Christèle PIERRE-ALEXANDRE, lawyer, residing in Howald, who is also elected as

scrutineer by the general meeting.

96632

L

U X E M B O U R G

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of nineteen thousand Euros (EUR 19,000.00) so as to raise

it from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.00) up to fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), by
the issue of nineteen thousand (19,000) new ordinary shares, each having a par value of EUR 1.-, having the rights and
obligations as set out in the Company's articles of incorporationas amended by the below resolutions (the "New Shares"),
to be paid up by a contribution in kind amounting to one million nine hundred and sixty-nine thousand Euros (EUR
1,969,000.00) consisting in an unquestioned claim due for immediate payment held by "OXEA Corporation", a corporation
formed under the laws of the State of Delaware, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, and with its principal offices at 1505 West LBJ Freeway, Dallas, Texas 75234, registered under
number 4261033 against the Company (the "Contribution").

The New Shares shall be fully subscribed by OXEA Corporation, prenamed and the Contribution of one million nine

hundred and sixty-nine thousand Euros (EUR 1,969,000.00) shall be allocated to the Company's share capital for an amount
of nineteen thousand Euros (EUR 19,000.00) and to the Company's share premium account for an amount of one million
nine hundred and fifty thousand Euros (EUR 1,950,000.00).

2. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of nineteen thousand Euros (EUR

19,000.00) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.00) up to fifty thousand
Euros (EUR 50,000.00), by the issue of nineteen thousand (19,000) new ordinary shares, each having a par value of EUR
1.-, having the rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below
resolutions (the "New Shares"), paid up by means of a contribution in kind amounting to one million nine hundred and
sixty-nine thousand Euros (EUR 1,969,000.00) consisting in an unquestioned claim due for immediate payment held by
"OXEA Corporation", a corporation formed under the laws of the State of Delaware, with registered office at Corpo-
ration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, and with its principal offices at 1505 West LBJ Freeway,
Dallas, Texas 75234, registered under number 4261033 against the Company (the "Contribution").

The Contribution of one million nine hundred and sixty-nine thousand Euros (EUR 1,969,000.00) is allocated (i) to the

Company's share capital for an amount of nineteen thousand Euros (EUR 19,000.00) and (ii) to the Company's share
premium account for an amount of one million nine hundred and fifty thousand Euros(EUR 1,950,000.00).

<i>Subscription

"OXEA Corporation", prenamed, here represented by Mrs Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy

given on 13 June 2013, hereto annexed, has declared to subscribe for the New Shares and to pay them a total price of
one million nine hundred and sixty-nine thousand Euros (EUR 1,969,000.00), by means of a contribution in kind consisting
in an uncontested, current and immediately exercisable claim it holds against the Company.

A report dated 14 June 2013, has been drawn up by Interaudit S.à r.l., a réviseurd'entreprises agréé, having its registered

office at 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, pursuant to the requirements set out under article 26-1, 32-1
(5)  and  103  of  the  law  dated  10  August  1915  on  commercial  companies,  as  amended,  which  contains  the  following
conclusion:

"Based  on  the  verifications  carried  out  as  described  above,  we  express  no  observation  on  the  total  value  of  the

contribution, which corresponds at least to the number and par value of the shares to be issued as consideration together
with a share premium."

The aforesaid report issued by Interaudit S.à r.l., prenamed, will remain annexed to the present deed to be filed at the

same time with the registration authorities

96633

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of

incorporation of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:

5.1. The Company has a share capital of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) divided into forty-nine thousand nine

hundred and ninety-nine (49,999) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one (1) management share (the "Manage-
ment  Share")  with  a  par  value  of  one  euro  (EUR  1.00)  each  (all  shares  together  referred  to  as  the  "Shares").  The
Management Share shall be held by OXEA Finance S.à r.l., prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandité)."

<i>Valuation - Costs

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to four thousand euro.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le quatorze juin.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «OXEA

FINANCE &amp; CY S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.693, ayant son siège social au
47, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 3 juin
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 23 juillet 2010, numéro 1515,
page 72625. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés à ce jour.

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Howald,
qui désigne comme secrétaire Madame Christèle ALEXANDRE, maître en droit, demeurant à Howald, qui est aussi

choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,00), de façon à

l'accroître de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) à cinquante mille euros (EUR 50.000,00),
par l'émission de dix-neuf mille (19.000) nouvelles actions ordinaires (les «Nouvelles Actions Ordinaires») chacune ayant
une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'indiqués dans les statuts de la
Société, qui seront payées au moyen d'un apport en nature consistant en une créance certaine liquide et exigible détenue
contre la Société par «OXEA Corporation», une société régie par les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social
au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware et immatriculée sous le numéro 4261033, et
ce pour un montant total d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,00) (l'«Apport»).

Les Nouvelles Actions Ordinaires seront intégralement souscrites par OXEA Corporation, prénommée, et l'Apport

d' un montant total d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,00) sera alloué au capital social pour
un montant de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,00) et au compte de prime d'émission de la Société pour un montant
d'un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1,950,000.00).

2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

96634

L

U X E M B O U R G

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de dix-neuf mille euros (EUR

19.000,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) à cinquante mille
euros (EUR 50.000,00), par l'émission de dix-neuf mille (19.000) nouvelles actions ordinaires (les «Nouvelles Actions
Ordinaires») chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu'in-
diqués dans les statuts de la Société, payées au moyen d'un apport en nature consistant en une créance certaine liquide
et exigible détenue contre la Société par «OXEA Corporation», une société régie par les lois de l'Etat de Delaware, ayant
son siège social au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware et immatriculée sous le numéro
4261033, et ce pour un montant total d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,00) (l'«Apport»).

L'Apport d'un montant total d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,00) est alloué au capital

social pour un montant de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,00) et au compte de prime d'émission de la Société pour un
montant d'un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1,950,000.00).

<i>Souscription

OXEA Corporation prénommée et représentée par Maître Linda Harroch, prénommée, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé en date du 13 juin 2013, a déclaré souscrire l'ensemble des Nouvelles Actions Ordinaires et de
payer pour un montant total d'un million neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.969.000,00) par un apport en capital
d'une créance certaine, liquide et exigible.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par «Interaudit S.à r.l.», réviseur d'entreprises,

ayant son siège social au 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en date du 14 juin 2013 conformément à
l'article 26-1, 32-1(5) et 103 de la loi concernant les sociétés commerciales datée du 10 août 1915 contenant la conclusion
suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur globale de l'apport, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contre-
partie avec une prime d'émission.»

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les déci-

sions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est de cinquante mille Euros (EUR 50,000.-), représenté par quarante-neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix neuf (49,999) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") et une (1) action de commandité
(l'"Action de Commandité") ayant chacune une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.00) chacune (toutes ensembles les
«Actions»). L'Action de Commandité est détenue par OXEA Finance S.à r.l., précité, actionnaire commandité de la Société.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à quatre mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, C. PIERRE-ALEXANDRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juin 2013. Relation: EAC/2013/7990. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013088881/182.
(130110244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

96635

L

U X E M B O U R G

Praesidium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 152.177.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schwebsange, den 02.07.2013.

Référence de publication: 2013088897/10.
(130109683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

PIE Group II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.099.644,89.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 140.754.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,
ON THE TWENTY-SIXTH DAY OF THE MONTH OF JUNE,
before Us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

CVC European Equity Partners V (A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK22056, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, ("CVC European Equity Partners V (A) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

25, 2013;

CVC European Equity Partners V (B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK24527, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, ("CVC European Equity Partners V (B) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

25, 2013;

CVC European Equity Partners V (C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK24524, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, ("CVC European Equity Partners V (C) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

25, 2013;

CVC European Equity Partners V (D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK25044, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, ("CVC European Equity Partners V (D) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

25, 2013;

CVC European Equity Partners V (E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its

registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered
with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK25043, represented by its general
partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission
under number 99031, ("CVC European Equity Partners V (E) L.P."),

96636

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

25, 2013;

CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK18598, re-
presented by its general partner, CVC European Equity Tandem GP Limited, a limited company governed by the laws of
Jersey and having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands,
registered with the Jersey Financial Services Commission under number 94504, ("CVC European Equity Partners Tandem
Fund (A) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

26, 2013;

CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands,

having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK18596, represented
by its general partner, CVC European Equity Tandem GP Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and
having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands, registered with
the Jersey Financial Services Commission under number 94504, ("CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

26, 2013;

CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman

Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK18734, re-
presented by its general partner, CVC European Equity Tandem GP Limited, a limited company governed by the laws of
Jersey and having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands,
registered with the Jersey Financial Services Commission under number 94504, ("CVC European Equity Partners Tandem
Fund (C) L.P."),

hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

26, 2013;

Knud Borge Pedersen, K0bmandsgarden 48, 4130 Viby Sjaelland, Denmark ("KBP"),
hereby represented by Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June

25, 2013;

(CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity Partners

V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P., CVC European Equity
Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., CVC European Equity Partners
Tandem Fund (C) L.P., and KBP together referred to as the "Shareholders").

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are all the shareholders of

PIE Group II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one
million six hundred forty-nine thousand four hundred sixty-seven euro and thirty-three cent (EUR 1,649,467.33), with
registered office at 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated following a
deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 18 July 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2090 of 28 August 2008 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140754 (the "Company"). The articles of as-
sociation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary of 11 June
2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To reduce the corporate capital of the Company by an amount of five hundred forty-nine thousand eight hundred

twenty-two euro and forty-four cent (EUR 549,822.44) so as to reduce it from its current amount of one million six
hundred forty-nine thousand four hundred sixty-seven euro and thirty-three cent (EUR 1,649,467.33) to one million
ninety-nine thousand six hundred forty-four euro and eighty-nine cent (EUR 1,099,644.89) for the purpose and by can-
cellation of the fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) class C ordinary
shares, which have been repurchased by the Company.

2. To amend articles 6, 12 and 13 of the articles of association of the Company, in order to reflect the capital reduction.
have requested the undersigned notary to record the following resolution:

<i>First resolution

The Shareholders unanimously resolved to reduce, with immediate effect, the corporate capital of the Company by

an amount of five hundred forty-nine thousand eight hundred twenty-two euro and forty-four cent (EUR 549,822.44) so

96637

L

U X E M B O U R G

as to reduce it from its current amount of one million six hundred forty-nine thousand four hundred sixty-seven euro
and thirty-three cent (EUR 1,649,467.33) to one million ninety-nine thousand six hundred forty-four euro and eighty-
nine  cent  (EUR  1,099,644.89)  for  the  purpose  and  by  cancellation  of  the  fifty-four  million  nine  hundred  eighty-two
thousand two hundred forty-four (54,982,244) class C ordinary shares, which have been repurchased by the Company.

<i>Second resolution

The Shareholders unanimously resolved to amend paragraph 1 of article 6, paragraph 3 of article 12, and paragraph 4

to article 13 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions.

Paragraph 1 of article 6 will from now on read as follows:
"The Company's corporate capital is fixed at one million ninety-nine thousand six hundred forty-four euro and eighty-

nine cent (EUR 1,099,644.89) represented by

- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class A ordinary shares,
- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class B ordinary shares,
- one (1) Class B preference share,
having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up.".
Paragraph 3 of article 12 will from now on reads as follows:

12.3. The shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the

annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without ever exceeding the
amounts proposed by the board of directors.

In any year in which the shareholders resolve to make any distribution of dividends, the holders of the Class B prefe-

rence shares shall, first in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
not less that zero point seventy-five per cent (0.75%) of the nominal capital with respect to such shares of the Company,
the holders of the Class A ordinary shares shall, second priority, be entitled to receive dividend distributions with respect
to such year in an amount not less that zero point sixty-five per cent (0.65%) of the nominal capital with respect to such
shares of the Company, the holders of the Class B ordinary shares shall, third priority, be entitled to receive the remainder
of all dividend distributions without prejudice to the profit entitlements of the holders of the Class B preference shares
as agreed from time to time by the shareholders. Should the Class B ordinary shares have all been cancelled following
their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the Class A ordinary shares shall be entitled
to receive the remainder of all dividend distributions without prejudice to the profit entitlements of the holders of the
Class B preference shares as agreed from time to time by the shareholders."

Paragraph 4 of article 13 will from now on reads as follows:

13.4. In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, to creditors other than shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provision

for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities to the shareholders;

(ii) second, to the shareholders in satisfaction, up to the nominal value of the shares; and
(iii) third, to the payment of liquidation allocations to holders of Class B preference shares, Class A ordinary shares

and Class B ordinary shares, to the extent and in consideration of such classes of shares which are still in issue at the
time of the liquidation, according to the priority and proportions set in article 12 for the appropriation of profits.".

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at EUR 1.600.-.

There being no other business on the Agenda, the meeting was adjourned at 5.30 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREUPON, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at

the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE VINGT-SIXIEME JOUR DU MOIS DE JUIN.
Par devant Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

96638

L

U X E M B O U R G

CVC European Equity Partners V (A) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège

social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK22056, représenté par son General Partner CVC Eu-
ropean Equity V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St.
Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC
European Equity Partners V (A) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

25 juin 2013;

CVC European Equity Partners V (B) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social

au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK24527, représenté par son General Partner CVC European Equity
V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG,
Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC European Equity
Partners V (B) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

25 juin 2013;

CVC European Equity Partners V (C) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège

social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Iles Cayman, inscrit au Register of
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK24524, représenté par son General Partner CVC Eu-
ropean Equity V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St.
Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC
European Equity Partners V (C) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

25 juin 2013;

CVC European Equity Partners V (D) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège

social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Iles Cayman, inscrit au Register of
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK25044, représenté par son General Partner CVC Eu-
ropean Equity V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St.
Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC
European Equity Partners V (D) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

25 juin 2013;

CVC European Equity Partners V (E) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social

au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Iles Cayman, inscrit au Register of Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK25043, représenté par son General Partner CVC European Equity
V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG,
Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC European Equity
Partners V (E) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

25 juin 2013;

CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant

son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Iles Cayman, inscrit au
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK18598, représenté par son General Partner
CVC European Equity Tandem GP Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au Lime
Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 94504 («CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

26 juin 2013;

CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant

son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Iles Cayman, inscrit au
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK18596, représenté par son General Partner
CVC European Equity Tandem GP Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au Lime
Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 94504 («CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

26 juin 2013;

CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant

son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK18734, représenté par son General Partner

96639

L

U X E M B O U R G

CVC European Equity Tandem GP Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au Lime
Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 94504 («CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P.»),

ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

26 juin 2013;

Knud Borge Pedersen, K0bmandsgarden 48, 4130 Viby Sjaelland, Danmark («KBP»),
ci-après représenté par Caroline RONFORT, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date du

25 juin 2013;

(CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity Partners

V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P., CVC European Equity
Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., CVC European Equity Partners
Tandem Fund (C) L.P. et KBP, collectivement les «Associés»).

Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter que les Associés sont les seuls et uniques associés de PIE Group

II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de un million six
cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et trente-trois cents (EUR 1.649.467,33), ayant son siège social
au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Jacques
Delvaux, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 juillet 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2090 le 28 août 2008 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140754 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 11 juin 2013, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Les  Associés,  représentés  comme  indiqués  ci-dessus  reconnaissent  avoir  été  dûment  et  pleinement  informés  des

décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence de cinq cent quarante-neuf mille huit cent vingt-deux euros

et quarante-quatre cents (EUR 549.822,44) afin de le réduire de son montant actuel de un million six cent quarante-neuf
mille quatre cent soixante-sept euros et trente-trois cents (EUR 1.649.467,33) à un montant de un million quatre-vingt-
dix-neuf mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 1.099.644,89) en vue de et par annulation
de cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales de
catégorie C, ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et qui ont été rachetées par la Société.

2. De modifier les articles 6, 12 et 13 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital.
ont requis le notaire soussigné d'enregistrer les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé à l'unanimité de réduire, avec effet immédiat, le capital social de la Société à concurrence de

cinq cent quarante-neuf mille huit cent vingt-deux euros et quarante-quatre cents (EUR 549.822,44) afin de le réduire de
son montant actuel de un million six cent quarante-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et trente-trois cents (EUR
1.649.467,33) à un montant de un million quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-neuf
cents (EUR 1.099.644,89) en vue de et par annulation de cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux
cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales de catégorie C, ayant une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune,
et qui ont été rachetées par la Société.

<i>Seconde résolution

Les Associés approuvent à l'unanimité la modification du paragraphe 1 de l'article 6, du paragraphe 3 de l'article 12 et

du paragraphe 4 de l'article 13 des Statuts afin de refléter les résolutions précédentes.

Le paragraphe 1 de l'article 6 sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à un million quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-quatre euros et quatre-

vingt-neuf cents (EUR 1.099.644,89) représenté par

- cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales

ordinaires de Catégorie A,

- cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales

ordinaires de Catégorie B, et,

- une (1) part sociale préférentielle de Catégorie B,
toutes d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune et toutes entièrement souscrites et libérées.».
Le paragraphe 3 de l'article 12 sera dorénavant rédigé comme suit:

« 12.3. Les associés, sur recommandation du conseil de gérance, décideront de l'affectation du solde du bénéfice annuel

net et pourront déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par le
conseil de gérance.

96640

L

U X E M B O U R G

Chaque année où les associés décident de procéder à une distribution de dividendes, les propriétaires des parts sociales

préférentielles de Catégorie B auront le droit, en premier rang de priorité, de recevoir des distributions de dividendes
pour cette année, d'un montant qui ne pourra pas être inférieur à zéro virgule soixante-quinze pour cent (0,75 %) de la
valeur nominale de ces parts sociales de la Société, les propriétaires des parts sociales ordinaires de Catégorie A auront
le droit, en second rang de priorité, de recevoir des distributions de dividendes pour cette année, d'un montant qui ne
pourra pas être intérieur à zéro virgule soixante-cinq pour cent (0,65 %) de la valeur nominale de ces parts sociales de
la Société, les propriétaires des parts sociales ordinaires de Catégorie B auront le droit, en troisième rang de priorité,
au solde de toute distribution de dividendes sans préjudice à la participation aux bénéfices de(s) propriétaires des parts
sociales préférentielles de Catégorie B tel que décidé par les associés de temps à autre. Dans la mesure où toutes les
parts sociales ordinaires de Catégorie B auront été annulées suite à leur rachat, achat ou autre au moment de la distri-
bution, les parts sociales ordinaires de Catégorie A auront le droit au solde de toute distribution de dividendes sans
préjudice à la participation aux bénéfices de(s) propriétaires des parts sociales préférentielles de Catégorie B tel que
décidé par les associés de temps à autre.»

Le paragraphe 4 de l'article 13 sera dorénavant rédigé comme suit:

« 13.4. En cas de liquidation, tout les actifs et avoirs de la Société seront répartis selon l'ordre de priorité suivant:
(i) premièrement, aux créanciers autres que les associés par règlement (soit par paiement, soit par constitution d'une

provision pour ce paiement) de toutes les dettes et charges de la Société aux associés;

(ii) deuxièmement, aux associés par règlement jusqu'au montant de la valeur nominale des parts sociales; et
(iii) troisièmement, au paiement du boni de liquidation aux propriétaires de parts sociales préférentielles de Catégorie

B, parts sociales ordinaires de catégorie A, et catégorie B au vu et en considération des catégories d'actions encore en
émission au moment de la liquidation, conformément aux règles de priorité et de proportionnalité stipulées à l'article 12
pour l'affectation des bénéfices.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation

de capital sont estimés à EUR 1.600.-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 30.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: C. RONFORT, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 juin 2013. Relation: RED/2013/1056. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 03 juillet 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013088923/314.
(130109708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Ecofi (Lux) Premium SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.222.

Les comptes annuels de 2012 ont été clôturés au 31 décembre 2012 et approuvés lors de l’assemblée ordinaire des

actionnaires le 28 juin 2013 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juillet 2013.

Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2013088899/13.
(130110022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

96641

L

U X E M B O U R G

Prowell Consult Luxco GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 178.344.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den neunundzwanzigsten April.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Ist erschienen:

Herr Christian Cyrus Wiesner, geboren am 5. März 1967 in Berlin, Deutschland, wohnhaft Leipziger Platz 9, 10117

Berlin, Deutschland,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Christine Kröger, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, kraft einer am 26. April 2013 in Berlin, Deutschland, erteilten Vollmacht.

Nachdem die Vollmacht durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet worden

ist, soll diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

aufzunehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma
"Prowell Consult Luxco GmbH" (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Gesellschaftszweck ist weiterhin (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in sonstiger Weise, und die Über-

tragung im Rahmen des Verkaufs, Tauschs oder in sonstiger Weise, von jeglichen Rechten an geistigem oder gewerblichem
Eigentum jedweder Art (beispielsweise Patente, Marken oder Urheberrechte), (ii) die Gewährung und der Erwerb von
Lizenzen an derartigen Rechten an geistigem oder gewerblichem Eigentum, und (iii) das Halten, die Verwaltung und die
Entwicklung derartiger Rechte an geistigem oder gewerblichem Eigentum.

3.3. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.4.  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Transaktionen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  ihrem  Zweck  dienen.

Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

96642

L

U X E M B O U R G

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-

sendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden

Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäft-
santeile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

96643

L

U X E M B O U R G

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des

Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  "alleiniger  Gesellschafter"  nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zei-
traums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe

96644

L

U X E M B O U R G

11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse  bei der ersten  Abstimmung wirksam  gefasst,  wenn sie von Gesellschaftern angenommen  werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.

11.6. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Bes-

chlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat"
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

96645

L

U X E M B O U R G

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einvers-
tändnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunika-
tionsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch
ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden
sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht
erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schrift-
lichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

in der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Im Falle mehrerer Klassen von Geschäftsführern kann der Geschäftsführerrat
nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn wenigstens ein (1) Geschäftsführer jeder Klasse in der Sitzung anwesend
oder vertreten ist.

18.3. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben. Im Falle mehrerer Klassen von
Geschäftsführern werden Beschlüsse nur mit der Zustimmung wenigstens eines (1) Geschäftsführers jeder Klasse gefasst.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vi-

deokonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betref-
fenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inter-
essenskonflikt  im  Protokoll  über  die  betreffende  Transaktion  aufgenommen  werden.  Dieser  Artikel  18.7  ist  nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

96646

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame

Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die ge-
meinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unters-
chriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Im Falle mehrere
Klassen von Geschäftsführern wird die Gesellschaft unter allen Umständen ausschließlich durch die gemeinsame Unters-
chrift eines (1) Geschäftsführers jeder Klasse gebunden. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen
einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten
gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich über-
tragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr.  Das  Geschäftsjahr  der  Gesellschaft  beginnt  am  ersten  Januar  jedes  Jahres  und  endet  am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

96647

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-

raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2013.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die auszugebenden Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
Herr Christian Cyrus Wiesner, geboren am 5. März 1967 in Berlin, Deutschland, wohnhaft Leipziger Platz 9, 10117

Berlin, Deutschland, zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gegen Zeichnung von zwölftausendfünfhundert
(12.500) Geschäftsanteilen.

Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.
Alle Geschäftsanteile sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200.-) geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sodann folgende

Beschlüsse gefasst.

1) Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf zwei (2) festgesetzt.
2) Die folgenden Personen werden, mit Wirkung des Datums dieses Beschlusses und für unbestimmte Zeit, als Mit-

glieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:

a) Herr Christian Cyrus Wiesner, geboren am 5. März 1967 in Berlin, Deutschland, wohnhaft Leipziger Platz 9, 10117

Berlin, Deutschland, wird als Geschäftsführer der Klasse A ernannt; und

b) Frau Catherine Koch, geboren am 12. Februar 1965 in Sarreguemines, Frankreich, mit beruflicher Adresse in 19,

rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wird als Geschäftsführerin der Klasse B ernannt.

3) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen  Partei  auf  Deutsch  geschrieben  ist,  gefolgt  von  einer  englischen  Übersetzung.  Auf  Anfrage  derselben
erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text soll die deutsche
Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten

Tag aufgenommen.

96648

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-

tigte diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Follows the English translation of the preceding text:

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Christian Cyrus Wiesner, born on 5 March 1967 in Berlin, Germany, residing at Leipziger Platz 9, 10117 Berlin,

Germany,

duly  represented  by  Ms.  Christine  Kröger,  having  her  professional  address  in  Luxembourg-City,  Grand  Duchy  of

Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 April 2013 in Luxembourg.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a Gesellschaft mit beschränkter Haftung under the name of "Prowell Consult
Luxco GmbH" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company's purpose is further (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights of any kind (such as patents,
trademarks, copyrights), (ii) the granting and obtaining of licenses on such intellectual and industrial property rights, and
(iii) the holding, the management and the development of such intellectual and industrial property rights.

3.3. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.4. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

96649

L

U X E M B O U R G

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve

thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of

plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6. The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-

ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

96650

L

U X E M B O U R G

C. General Meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in

the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them

to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

96651

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting

alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and Removal of managers and Term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for

successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of managers. In case the Company has several classes of managers, the board of managers can
deliberate or act validly only if at least one (1) manager of each class is present or represented at the meeting.

18.3. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote. In case the Company has several classes of managers,

96652

L

U X E M B O U R G

resolutions of the board of managers are adopted validly only if such majority contains the affirmative vote by one (1)
manager of each class.

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
email or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of any two managers or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature
of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager.
In case the Company has several classes of managers, the Company shall be validly bound only by the joint signature of
one (1) manager of each class of managers.

The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to

the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such
delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

96653

L

U X E M B O U R G

21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal

reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 

st

December 2013.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The shares to be issued have been subscribed as follows:
Mr. Christian Cyrus Wiesner, born on 5 March 1967 in Berlin, Germany, residing at Leipziger Platz 9, 10117 Berlin,

Germany, aforementioned,

paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand two hundred euro (EUR
1,200).

96654

L

U X E M B O U R G

<i>General Meeting of shareholders

The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital, then adopted the following resolu-

tions.

1. The number of members of the board of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company with effect as of the

date of the present resolution and for an unlimited period of time:

a) Mr. Christian Cyrus Wiesner, born on 05 March 1967 in Berlin, Germany, residing at Leipziger Platz 9, 10117 Berlin,

Germany, aforementioned, is appointed as class A manager of the Company; and

b) Mrs. Catherine Koch, born on 12 February 1965 in Sarreguemines, France, with professional address 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as class B manager.

3. The address of the Company's registered office is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that, on request of the appearing person,

this deed is worded in German followed by an English translation. On the request of the same appearing person and in
case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Signé: C. Kröger et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 mai 2013. LAC/2013/21216. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088903/743.
(130109940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Paser Participations S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 44.287.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 10 novembre 2012, lors de l'Assemblée Générale de la Société Paser Participations

<i>S.A.

L'Assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Eric Debled, né le 14/01/1964,

et, résidant professionnellement à L-1630 Luxembourg, au 56, Rue Glesener, en tant qu'administrateur de la Société Paser
Participations S.A.

L'Assemblée décide également de nommer Monsieur Nicolas Delattre, né le 26 octobre 1984 à Liège (Belgique), et,

résidant professionnellement à L-1630 Luxembourg au 56, Rue Glesener, en tant qu'Administrateur de la Société Paser
Participations S.A. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2018.

Dès lors, le conseil d'administration de la société se composera désormais de:
- Mr. Benoît Dabertrand
- Mr. Cédric de Caritat
- Mr. Nicolas Delattre
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PASER PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Référence de publication: 2013088913/22.
(130110141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

96655

L

U X E M B O U R G

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 134.995.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 28. Juni 2013

Am 28. Juni 2013 kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers Société coopérative (vormals PricewaterhouseCoopers

S.à r.l.) wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre verlängert.

Luxemburg, den 02 Juli 2013.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2013088911/17.
(130109425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

RF Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 138.034.

EXTRAIT

La soussignée SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A., en tant que domiciliatane de la société RF Holdings S.à.r.l.,

inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138034, ayant son siège social au 64,
rue Principale, L-5367 Schuttrange, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 20 juin 2013.

SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2013088959/15.
(130109973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg, Société Anonyme.

Siège social: L-2549 Luxembourg, 39, rue Jacques Stas.

R.C.S. Luxembourg B 6.183.

<i>Assemblée générale Ordinaire du 18 juin 2013 - Point 4 de l'ordre du jour

Le mandat d'administrateur de
Mademoiselle FEYEREISEN Suzanne 3, rue Théodore de Wacquant L-3899 FOETZ est reconduit pour une période

de six ans à partir du 18 juin 2013.

Pour extrait conforme du folio 33 des Procès-verbaux des Assemblées Générales.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

André Castagna / Henri René Feyereisen
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Directeur

Référence de publication: 2013088969/15.
(130110224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg, Société Anonyme.

Siège social: L-2549 Luxembourg, 39, rue Jacques Stas.

R.C.S. Luxembourg B 6.183.

<i>Assemblée générale Ordinaire du 18 juin 2013 - Point 5 de l'ordre du jour

Nomination de BDO Audit S.A. 2, Avenue Charles de Gaulle L-2013 Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises

pour une période de trois ans à partir de l'année 2013.

96656

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme du folio 34 des Procès-verbaux des Assemblées Générales.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

André Castagna / Henri René Feyereisen
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur-Directeur

Référence de publication: 2013088970/14.
(130110224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

PIE Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.812.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,
ON THE TWENTY-SIXTH DAY OF THE MONTH OF JUNE,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PIE Group S.A., a société anonyme governed by the

laws of Luxembourg, with registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of 7 October 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1335 of 6 December 2005 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-111812 (the "Company"). The articles of incorpo-
ration of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 11 June 2013,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was declared open at 5.30 p.m. by Caroline RONFORT, employee, with professional address in Luxem-

bourg, in the chair, who appointed as secretary Thomas MORANA, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Thomas MORANA, employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1. To reduce the corporate capital of the Company by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) so

as to reduce it from its current amount of three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) to two hundred thousand euro
(EUR 200,000.-) for the purpose and by cancellation of the eighty thousand (80,000) class C shares having a par value of
one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each, which have been repurchased by the Company on 26 June 2013 following
the resolutions of the board of director as per the authorisations and instructions provided by the general meeting of
shareholders and the share repurchase agreements dated 26 June 2013;

2. To amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital reduction.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented

declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to reduce, with immediate effect, the corporate capital of the Company by an amount

of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) so as to reduce it from its current amount of three hundred thousand
euro (EUR 300,000.-) to two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) for the purpose and by cancellation of the eighty
thousand (80,000) class C shares having a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each, which have been
repurchased by the Company on 26 June 2013 following the resolutions of the board of director as per the authorisations
and instructions provided by the general meeting of shareholders and the share repurchase agreements dated 26 June
2013.

96657

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The general meeting resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect

the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

5.1. Capital. The subscribed capital of the Corporation is set at two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) divided

into eighty thousand (80,000) class A shares and eighty thousand (80,000) class B shares, all with a par value of one euro
twenty-five cent (EUR 1.25) per share.".

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at EUR 1.300.-.

There being no other business on the Agenda, the meeting was adjourned at 5.45 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their surnames, first

names, civil status and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE VINGT-SIXIEME JOUR DU MOIS DE JUIN
par devant Nous Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PIE Group S.A., une société anonyme régie par

le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1335 du 6 décembre 2005 et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-111812 (la «Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 juin 2013, pas
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de Caroline RONFORT, employée, domiciliée

professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Thomas MORANA, employé, domicilié profession-
nellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Thomas MORANA, employé, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(vii) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) afin de le porter de son

montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) en vue de et par
annulation de quatre-vingts mille (80.000) actions de catégorie C ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents
(EUR 1,25) chacune, qui ont été rachetées par la Société le 26 juin 2013 à la suite des résolutions du conseil d'adminis-
tration prises en vertu des autorisations et instructions données par l'assemblée générale des actionnaires et les contrats
de rachat d'actions en date du 26 juin 2013.

2 Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital.
(viii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(ix) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du

bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(x) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés

ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.

(xi) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

(xii) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

96658

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé, avec effet immédiat, de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent mille

euros (EUR 100.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) à deux cent mille
euros (EUR 200.000,-) en vue de et par annulation de quatre-vingt mille (80.000) actions de catégorie C ayant une valeur
nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, qui ont été rachetées par la Société le 26 juin 2013 à la suite
des résolutions du conseil d'administration prises en vertu des autorisations et instructions fournies par l'assemblée
générale des actionnaires et les contrats de rachat d'actions en date du 26 juin 2013.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les

résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5.1. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) divisé en quatre-

vingt mille (80.000) actions de catégorie A et quatre-vingt mille (80.000) actions de catégorie B toutes ayant une valeur
nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25)."

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 1.300.-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 45.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant

nommés, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signés avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: C. RONFORT, T. MORANA, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 juin 2013. Relation: RED/2013/1055. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 03 juillet 2013.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013088924/133.
(130109667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Pimco Luxembourg IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.871.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2013, l'associé unique de la société PIMCO Luxembourg IV S.A. a pris

les résolutions suivantes:

- Réélection des membres du conseil d'administration de la société. Désormais, le conseil d'administration de la société

est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2014:

* Craig Allen Dawson
* Joseph Vincent McDevitt
* Jeffrey Michael Sargent
- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en leur fonction de réviseur d'entreprises agréé de

la société pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088926/17.
(130110080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Pimco Luxembourg IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.871.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

96659

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088925/10.
(130110079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

PHM Holdco 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 150.685.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088922/10.
(130109829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.458.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 28. Juni 2013

Am 28. Juni 2013 kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers Société coopérative (vormals PricewaterhouseCoopers

S.à r.l.) wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre verlängert.

Luxemburg, den 02 Juli 2013.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2013088909/17.
(130109422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 122.458.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013088910/11.
(130109430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Philips Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 27.882.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juillet 2013.

PHILIPS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2013088921/12.
(130109830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

96660

L

U X E M B O U R G

Protection International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cheverny 2 International S.à r.l.).

Capital social: EUR 1.612.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 177.197.

En date du 1 

er

 juillet 2013, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

1. l'associé IK VII N°1 Limited Partnership, avec adresse au 30-32, New Street, JE - JE2 3RA St. Helier, a cédé:
- 37 parts sociales à IK VII N°2 Limited Partnership,, avec adresse au 30-32, New Street, JE - JE2 3RA St. Helier,
- 64 parts sociales à IK VII N°3 Limited Partnership, avec adresse au 30-32, New Street, JE - JE2 3RA St. Helier.
2. l'associé IK VII N°4 Limited Partnership, avec adresse au 30-32, New Street, JE - JE2 3RA St. Helier, Jersey, a cédé

21 parts sociales à IK VII N°3 Limited Partnership, avec adresse au 30-32, New Street, JE - JE2 3RA St. Helier.

En conséquence:
Les associés détiennent les parts sociales suivantes:
IK VII N°1 Limited Partnership:
- 2,955 parts sociales
IK VII N°2 Limited Partnership:
- 2,730 parts sociales
IK VII N°3 Limited Partnership:
- 3,441 parts sociales
IK VII N°4 Limited Partnership:
- 3,374 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088902/26.
(130109393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Precision Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 121.640.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2013088935/12.
(130110279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Minotaur S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 20.276,84.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.864.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013096189/9.
(130116459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

96661

L

U X E M B O U R G

Sime Darby Investments (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 815.250,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.946.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 30 juin 2012 de sa société mère,
Sime Darby Berhad ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2013.

Référence de publication: 2013095450/12.
(130114962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

La Royale Ressource Vive Distribution, Société Anonyme.

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Mess, 5, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 63.504.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Actionnaire unique le 24 juin 2013 que:
- le mandat d'administrateur de Monsieur Charles HAZARD, Monsieur Michel HAZARD et de Monsieur Paul HA-

ZARD est renouvelé pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2019.

- le mandat de Commissaire de LUX-AUDIT S.A. est renouvelé pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de

l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 24 juin 2013 que:
- Monsieur Charles HAZARD est nommé en tant qu'Administrateur-délégué de la Société pour toute la durée de son

mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué.
- Monsieur Charles HAZARD est nommé en tant que Président du Conseil d'administration de la Société pour toute

la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

Il est en outre porté à la connaissance des tiers que l'adresse actuelle des Administrateurs M. Michel HAZARD et M.

Paul HAZARD est désormais L-4976 Bettange-sur-Mess, 5, rue du château d'eau.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettange-sur-Mess, le 24 juin 2013.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2013095227/26.
(130114748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

LogAxes Investment Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 249.900,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 126.265.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 8 juillet 2013, que:
- Mme Marine Le Lan, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, a été nommée en tant que gérante de la Société avec effet au 8 juillet 2013.

Le conseil de gérance se compose donc comme suit au 8 juillet 2013:
- Alix VAN ORMELINGEN, Gérante
- Mark PHILLIPS, Gérant
- Marine LE LAN, Gérante

96662

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 09 Juillet 2013.

Référence de publication: 2013095221/18.
(130115193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Steen Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Jupiter Investment S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 172.930.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of the month of June.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 164.012 (the "Sole Shareholder"),

represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 18 June 2013

which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the under-
signed notary,

being the Sole Shareholder of Jupiter Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited company),

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 172.930 (the
"Company"), incorporated on 22 November 2012 pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 3105 of 29 December 2012.

The articles of association of the Company have never been amended.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital is

represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.

2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
Amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so that Article 1 of the articles of association

of the Company reads as follows:

"A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Steen Holdco S.à r.l." (the "Company")

is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be
governed by these articles of association and the relevant legislation.".

Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to amend Article 1 of the articles of incorporation of the Company so that Article 1

of the articles of association of the Company reads as set out in the above agenda.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and German version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunzehnten Tage des Monats Juni.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) unter luxembur-

gischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingetragen im Registre de Commerce et
des Sociétés (Gesellschafts- und Handelsregister) zu Luxemburg, unter der Nummer B 164.012 (der «Alleinige Gesell-
schafter»),

96663

L

U X E M B O U R G

Hier vertreten durch Herrn Joe Zeaiter, juriste, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt

am 18. Juni 2013, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den Vollmachtnehmer
und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde.

Der Alleinige Gesellschafter der Jupiter Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung), mit Gesellschaftssitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg,
mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-). eingetragen im Registre de Commerce
et des Sociétés (Gesellschafts- und Handelsregister) zu Luxemburg, unter der Nummer B 172.930 (die «Gesellschaft»),
gegründet am 22 November 2012 gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxem-
burg,  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  (das  «Mémorial»),  Nummer  3105  vom  29.
Dezember 2012.

Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nie abgeändert.
Der Erschienene gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft besitzt alle fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile welche von der

Gesellschaft ausgegeben wurden, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der
Tagesordnung entschieden werden konnte.

2. Der Punkt für welche einen Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
Abänderung  von  Artikel  1  der  Satzung  der  Gesellschaft  so  dass  Artikel  1  der  Satzung  der  Gesellschaft  folgenden

Wortlaut hat:

"Eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée)  mit  dem  Namen  "Steen  Holdco  S.à

r.l." (die „Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als
Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende lu-
xemburgische Gesetzgebung geregelt.".

Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:

<i>Alleiniger Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der

Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese

Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juin 2013. Relation: LAC/2013/28673. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 10. Juli 2013.

Référence de publication: 2013095182/90.
(130115730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Italian Food Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 156.301.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2013

L'Assemblée Générale décide avec effet immédiat de transférer le siège social de la société du 55-57, avenue Pasteur

à L-2311 Luxembourg au 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

L'Assemblée Générale constate le changement d'adresse professionnelle des administrateurs:
- Monsieur Nico HANSEN demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
- Monsieur Alain BARTHOLME demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
- Madame Sophie BATARDY demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
L'Assemblée Générale constate également le changement d'adresse du commissaire aux comptes:
- MGI FISOGEST S.àr.l., sise 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
L'Assemblée Générale constate aussi le changement d'adresse professionnelle de l'administrateur délégué:

96664

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Nico HANSEN demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
Référence de publication: 2013095179/18.
(130115362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

KPI Retail Property 35 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.085.

Il résulte d'un constat de fusion du 15 novembre 2012 que la société RAULE PROPERTIES S.à r.l., associée de la Société,

a été absorbée par la société OYSTER I HOLDCO S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35,
Avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121.843, cette dernière étant
dès lors devenue l'associée de la Société.

Partant, les 250 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont réparties comme suit:

OYSTER I HOLDCO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
BGP Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2013095209/18.
(130115476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Kahasun, Société Civile.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg E 4.884.

<i>Résolutions de l'associé unique prises en date du 24 juin 2013

Siège social
L'Assemblée générale décide de transférer, avec effet au 28 juin 2013, le siège social de la société du 55-57, avenue

Pasteur à L-2311 Luxembourg au 681, rue de Neudorf à l-2220 Luxembourg.

<i>Gérant

L'Assemblée générale constate le changement d'adresse professionnelle de son gérant:
Monsieur Nico Hansen demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

<i>Associés

L'Assemblée générale constate le changement d'adresse de deux de ses associés:
Monsieur Nico Hansen demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.
Madame Sandra Weidenhaupt demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.
Référence de publication: 2013095201/18.
(130115422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 96.686.

<i>Dépôt rectificatif du 02/07/2013 no L130108720

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2013

L'assemblée générale procède à la nomination du nouveau conseil d'administration, qui se compose dès lors comme

suit:

1. Monsieur Nicolas Comes, administrateur et administrateur délégué, demeurant à L-8129 Bridel, 1, Feitekneppchen
2. Monsieur Harold Linke, administrateur, demeurant à D-54294 Trier, Gneisenaustrasse 13.
3. Monsieur Yves Elsen, administrateur, demeurant à L-8266 Mamer, 8, rue des Thermes Romains.
Pouvoir de signature: la société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit

par la signature collective de deux administrateurs.

96665

L

U X E M B O U R G

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

L'assemblée nomme commissaire aux comptes Monsieur Gerhard Wais, demeurant à D-85049 Ingolstadt, Anato-

miestrasse 31.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

Pour extrait conforme
IT-MANAGED SERVICES S.A. (ITMS S.A.)

Référence de publication: 2013095177/24.
(130115186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Investissements Minéraux et Financiers, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 22.181.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 mai 2013, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Jean-Louis Colette, avec adresse au 16, Avenue des Créneaux, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique,
- Gérard BECQUER, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les

comptes annuels dont l'exercice se clôture au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014;

2. renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de H.R.T. Revision S.A., avec siège social au 163, rue du

Kiem, L-8030 Strassen, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui
statuera sur les comptes annuels dont l'exercice se clôture au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Référence de publication: 2013095176/19.
(130115134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Jemco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 101.825.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013095186/11.
(130115625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 155.001.

Il est à noter que suite à un contrat de transfert de Parts Sociales daté au 14 juin 2013, Nortrust Nominees Limited

représentant Nominee of Allied Domecq First Pension Trust Limited, associé de la «Société», a cédé l'entièreté ses parts
sociales de classe A comme suit:

1. 325 parts sociales A à Nortrust Nominees Limited A/C ADPF17, ayant son siège social au 50, Bank Street, Canary

Wharf, E145NT London et immatriculée sous le numéro 00955951 au Registre de commerce de l'Angleterre et du Pays
de Galles.

Il est à noter que suite à un contrat de transfert de Parts Sociales daté au 28 juin 2013, LONGBOW REAL ESTATE

Capital LLP, associé de la «Société», a cédé l'entièreté ses parts sociales de classe A et B comme suit:

96666

L

U X E M B O U R G

1. 175 755 parts sociales A à INTERMEDIATE Capital MANAGERS LIMITED, ayant son siège social au 100 St Paul's

Churchyard, London EC4M 8BU et immatriculée sous le numéro 2327504 au Registre de commerce de l'Angleterre et
du Pays de Galles.

2. 2 parts sociales B à INTERMEDIATE Capital MANAGERS LIMITED, ayant son siège social au 100 St Paul's Chur-

chyard, London EC4M 8BU et immatriculée sous le numéro 2327504 au Registre de commerce de l'Angleterre et du
Pays de Galles.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 10/07/2013.

Référence de publication: 2013095222/24.
(130115791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Lux Fund Consult S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 156.768.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013095223/14.
(130115646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

JOFAD Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 56.714.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générales de l'actionnaire en date du 30 juin 2013

1. Madame Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Donovan ANDRE, administrateur de sociétés, né à Virton (Belgique), le 21 janvier 1986, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour JOFAD Holding S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013095189/16.
(130114844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Jubrifin S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 154.181.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2013

L'Assemblée Générale décide avec effet immédiat de transférer le siège social de la société du 55-57, avenue Pasteur

à L-2311 Luxembourg au 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg.

L'Assemblée Générale constate le changement d'adresse professionnelle des administrateurs:
- Monsieur Nico HANSEN demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
- Monsieur Alain BARTHOLME demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
- Madame Sophie BATARDY demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
L'Assemblée Générale constate également le changement d'adresse du commissaire aux comptes:
- MGI FISOGEST S.àr.l., sise 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
L'Assemblée Générale constate aussi le changement d'adresse professionnelle de l'administrateur délégué:

96667

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Nico HANSEN demeure professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg
Référence de publication: 2013095193/18.
(130115361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 95.474.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 4 juin 2013, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Hugues Judong, avec adresse au 69, rue Adolphe Dumont, B-4051 Vaux-Sous-Chèvremont, Belgique,
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Dirk de Kat, avec adresse au 20, Duinendreef, B-2950 Kapellen, Belgique,
- Jacqueline de Ponton d'Amecourt, avec adresse au 9, rue Sébastien Bottin, F- 75007 Paris, France
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les

comptes annuels dont l'exercice se clôture au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014;

2. acceptation, avec effet au 4 avril 2013, de la démission de son mandat d'administrateur de Wojciech Malinowski,

avec adresse au 22, ul. Herwina Piatka, PL - 30-809 Krakow, Pologne;

3. renouvellement du mandat de Réviseur d'entreprises agréé de H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 163, rue du

Kiem, L-8030 Strassen, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui
statuera sur les comptes annuels dont l'exercice se clôture au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Référence de publication: 2013095194/24.
(130115177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Kirchberg Securities Finance Fund, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 154.276.

Le bilan au 31 octobre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Georges Beckené

Référence de publication: 2013095198/12.
(130115808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Kalmo Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.935.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 mai 2013

- Il est pris acte de la démission de Madame Corinne BITTERLICH de son mandat d'Administrateur et de ses fonctions

de Présidente du Conseil d'Administration avec effet à ce jour.

- Madame Cynthia BODY, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Corinne BITTERLICH, démissionnaire, avec
effet à ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

96668

L

U X E M B O U R G

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2013.

Certifié sincère et conforme
KALMO FINANCE S.A., SPF
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013095202/19.
(130115166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

GHE Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

R.C.S. Luxembourg B 76.799.

La Convention de Domiciliation conclue entre la Société Anonyme GHE HOLDING S.A., précédemment avec Siège

social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la Société Anonyme Société Européenne de Banque,
Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n°
B 13.859, a été résiliée avec effet au 1 

er

 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2013095994/14.
(130116990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Ostria Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 96.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 169.361.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Ostria Investments S.à r.l., a société à respon-

sabilité  limitée  governed  by  the  laws  of  Luxembourg,  with  registered  office  at  15,  Rue  Edward  Steichen,  L-2540
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 169.361, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, the Grand
Duchy of Luxembourg, on June 06 

th

 , 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number

1715 of July 07 

th

 , 2012 (the "Company"). The articles of incorporation have not been amended since.

The sole shareholder, being:
CDC Engineering Cyprus Limited a company organised under the laws of Cyprus, having its registered office at 21,

Aglantzias Ave., Complex 21 B, 2 

nd

 Floor, Flat/Office 1, 2108 Aglantzia Nicosia, Cyprus and registered with the Cyprus

register of commerce and companies under number HE 294471, hereinafter referred to as the "Sole Shareholder".

The Sole Shareholder is duly represented by Mrs Eva MERTES, private employee, with professional address at 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (the "Proxyholder") by virtue of a proxy given under
private seal on April 26 

th

 , 2013.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing party acting in her here

above stated capacity and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. That the agenda of the meeting is as follows:
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital by an amount of eighty-three thousand five hundred Euros (EUR 83,500.00) so as to

raise it from its current amount of Euros twelve thousand five hundred (EUR 12,500,00) to ninety-six thousand Euros
(EUR 96,000.00) by the issuance of eighty-three thousand five hundred (83,500) new shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each, the whole to be fully paid up through a contribution in cash of the eighty-three thousand five
hundred Euros (EUR 83,500.00).

3. Subscription and payment of the new shares;
4. New shareholding of the Company;

96669

L

U X E M B O U R G

5. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company relating to the share capital in

order to reflect the new share capital of the Company amounting to ninety- six thousand Euros (EUR 96,000.00) pursuant
to the above resolutions;

6. Miscellaneous.
II. That the meeting was regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
III. That the general meeting of the Shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives it right to the prior notice of the current meeting. The Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
carefully examine each document.

<i>Second resolution

The general meeting of the Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of

eighty-three thousand five hundred Euros (EUR 83,500.00) so as to raise it from its current amount of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.00) to ninety-six thousand Euros (EUR 96,000.00).

<i>Third resolution

The general meeting of the Sole Shareholder resolved to issue eighty-three thousand five hundred (83,500) new shares

with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and
entitling to dividends as from the day of this resolutions resolving on the proposed capital increase.

<i>Fourth resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment of the new shares through the contribution in cash described

below.

<i>Subscription - Payment

The above mentioned Sole Shareholder declared to subscribe for the eighty-three thousand five hundred (83,500) new

shares, with a nominal value of one Euro (Euro 1.00) per share and to fully pay in cash these shares by an amount of
eighty-three thousand five hundred Euros (EUR 83,500.00).

The amount of eighty-three thousand five hundred Euros (EUR 83,500.00) was thus as from that moment at the disposal

of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The general meeting of the Sole Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the eighty-

three thousand five hundred (83,500) new shares to the above mentioned Contributor.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolutions, the above contribution being fully carried out, the

shareholding of the Company is now composed of:

- CDC Engineering Cyprus Limited, holder of nighty-six thousand (96,000) shares.

<i>Sixth resolution

The  general  meeting  of  the  Sole  Shareholder  resolved  to  amend  article  5  of  the  articles  of  incorporation  of  the

Company in order to reflect the above resolutions. Said article will from now on read as follows:

« Art. 6. Share capital. The issued share capital of the Company is set at ninety-six thousand Euros (EUR 96,000.00)

divided into ninety-six thousand (96,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders as provided for in Article 7 of the present
articles of association.

Any share premium shall be freely distributable by decision of shareholders."

<i>Seventh resolution

The general meeting of the sole shareholder resolved to amend the books and registers of the Company, in order to

reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Vistra
(Luxembourg) S.à r.l, to proceed individually, on behalf of the Company with the registration of the above changes in the
relevant registers of the Company.

<i>Estimate - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred
euro (EUR 1.600.-).

96670

L

U X E M B O U R G

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-sept juin.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
A été tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de Ostria Investments S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 169.361, constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, le 06 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1715 du 07 juillet 2012
(la «Société»). Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'Associée Unique, étant,
CDC Engineering Cyprus Limited, une société de droit chypriote ayant son siège social au 21, Aglantzias Ave., Complex

21B, 2 

nd

 Floor, 2108 Aglantzia Nicosia, Chypre, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Chypre sous le

numéro HE 294471, ici appelée l'«Associé Unique».

L'Associé Unique est ici dûment représentée par Madame Eva MERTES, employée privé, demeurant professionnelle-

ment à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (le «Mandataire») en vertu d'une
procuration établie sous seing privé le 26 avril 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de l'Associée Unique et

par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités
compétentes.

La partie comparante, es-qualité qu'elle agit, a requis le notaire d'instrumentant d'acter comme suit:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux convocations préalables;
2.  Augmentation  du  capital  social  de  la  Société  d'un  montant  de  quatre-vingt-trois  mille  cinq  cents  euros  (EUR

83,500.00) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12,500.00 ) à un montant de quatre-vingt-seize mille euros (EUR 96,000.00 ) par l'émission de quatre-vingt-trois mille
cinq cents (83,500) parts sociale d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.00 EUR) chacune, par une contribution en
espèce de la somme quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 83,500.00);

3. Souscription et paiement des nouvelles parts sociales;
4. Nouvelle détention des parts sociales de l'Associée Unique de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société suite à l'augmentation de capital de manière à refléter

le montant du nouveau capital social s'élevant à la somme de quatre-vingt-seize mille euros (EUR 96.000,00) suite à
l'adoption des résolutions précédentes;

6. Divers.
II. L'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III. L'assemblée générale de l'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associée Unique renonce aux for-

malités  de  convocation,  l'Associée  Unique  représentée  à  l'Assemblée  se  considérant  comme  dûment  convoquée  et
déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été rendu accessible avant l'Assemblée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale de l'Associée Unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de

quatre-vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 83,500.00) afin de porter le capital social de la Société de son montant
actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.00) à un montant de quatre-vingt-seize mille euros (EUR 96,000.00).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale de l'Associée Unique décide d'émettre quatre-vingt-trois mille cinq cents (83,500) nouvelles parts

sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.00) par part sociale, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes donnant droit aux dividendes à partir du jour de l'adoption des présentes résolutions ayant décidées
l'augmentation de capital.

96671

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription et le paiement des nouvelles parts sociales par un apport en

espèce tel que décrit ci-dessous:

<i>Souscription - Libération

L'Associée Unique, prénommée, déclare souscrire les quatre-vingt-trois mille cinq cents (83,500) nouvelles parts so-

ciales, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.00) par part sociale et de les payer par un apport en espèces de la somme
quatre-vingt-trois mille cinq cents euro (83,500.00 EUR).

La somme de quatre-vingt-trois mille cinq cents (EUR 83,500,00), est désormais à la disposition de la Société tel qu'il

a été dûment prouvé au notaire par un certificat.

L'assemblée générale de l'Associé Unique accepte ladite souscription et le paiement de manière à attribuer les quatre-

vingt-trois mille cinq cents (83,500) nouvelles parts sociales au souscripteur ci-dessus mentionnée.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions précédentes et la contribution ayant été apportée, l'Associé Unique de la Société détient les

parts sociales suivantes:

- CDC Engineering Cyprus Limited, détentrice de quatre-vingt-seize mille (96,000) parts sociales.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale de l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts en vue de refléter les précédentes

résolutions, de sorte qu'il aura la teneur suivante:

« Art. 6. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt-seize mille euros (EUR 96,000.00)

divisé en quatre-vingt-seize mille (96,000) part sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.00) chacune. Le capital
de la Société peut être augmenté ou réduite par une résolution des associés tel que prévu à l'article 7 des présents statuts.

Toute prime d'émission est librement distribuable par une décision des associés.»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale de l'Associé Unique décide+ de modifier les livres et registres de la Société, afin de refléter les

changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à n'importe quel gérant de la Société et/ou à n'importe quel
employé de chez Vistra (Luxembourg) S.à r.l., afin de procéder individuellement et pour le compte de la Société aux
enregistrements des changements ci-dessus dans les registres de la Société correspondants.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ mille six cents euros (EUR 1.600.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Mertes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juin 2013. LAC/2013/29189. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Référence de publication: 2013093542/183.

(130114410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

96672


Document Outline

Cheverny 2 International S.à r.l.

Ecofi (Lux) Premium SICAV

GHE Holding S.A.

Investissements Minéraux et Financiers

Italian Food Participations S.A.

IT-Managed Services S.A. (ITMS S.A.)

Jemco S.A.

JOFAD Holding S.A.

Jubrifin S.A. SPF

Jupiter Investment S.à r.l.

Kahasun

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.

Kalmo Finance S.A., SPF

Kirchberg Securities Finance Fund, SICAV-SIF

KPI Retail Property 35 S.à.r.l.

La Royale Ressource Vive Distribution

LogAxes Investment Properties S.à r.l.

Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l.

Lux Fund Consult S.àr.l.

Minotaur S.à r.l.

Oneley S.A., SPF

OREF Real Estate G.m.b.H.

Origami Realty

Orlando Italy Management S.A.

Ostria Investments S.à r.l.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A.

Parker Hannifin Partnership S.C.S.

Partners Group Direct Investments 2009 S.C.A., SICAR

Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR

Partners Group Global Mezzanine 2007 S.C.A., SICAR

Partners Group Global Value 2008 S.C.A., SICAR

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR

Paser Participations S.A.

Philips Luxembourg S.A.

PHM Holdco 12 S.à r.l.

PIE Group II S.à r.l.

PIE Group S.A.

Pimas-Umbrella SICAV

Pimco Luxembourg IV S.A.

Pimco Luxembourg IV S.A.

Pradier Participations S.A.

Praesidium S.A.

Precision Capital S.A.

Protection International S.à r.l.

Prowell Consult Luxco GmbH

Resolution Bremen S.à r.l.

RF Holdings S.à r.l.

Russian Asset MBS S.A.

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg

Sime Darby Investments (Europe) S.à r.l.

Steen Holdco S.à r.l.