logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2006

20 août 2013

SOMMAIRE

Astralis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96254

Build Group Co. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96245

Cloisinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96244

Dexia Prime Advanced  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96243

Endurance Asset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

96279

Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96242

GREP Vier S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96279

Gwenael SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96279

Igorance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96278

IMI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96278

Indian Orchid S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96278

Infigen Energy Finance (Lux) S.à r.l.  . . . . .

96280

Infra-Invest 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96280

ING (L) Patrimonial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96280

Intellicast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96245

International Century Corporation S.A.,

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96281

Intersaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96244

INVESCO European Hotel Real Estate S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96281

IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96281

Iris Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96282

Isolda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96282

Isolda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96282

ista Holdco 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96257

Istanbul Bond Company S.A.  . . . . . . . . . . . .

96279

IVG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

96250

IW Alternativ SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96283

J3L International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96283

Jaccar Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96282

Jesmond Benelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96284

Jod S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96284

JPMorgan Specialist Investment Funds  . . .

96284

JrJ S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96283

JR Partnership GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

96280

KanAm Grund Espace Pétrusse S.A.  . . . . .

96284

Kauri Cab Arminius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96285

Kilbroney Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96285

Kilcullen Tesla Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

96284

KJK Fund II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96286

Kredietcorp S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96280

Kulczyk Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

96285

Labmex International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

96286

Lander S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96281

LaSalle UK Ventures Property 9 . . . . . . . . .

96287

Liberty Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

96285

LuxcoSITQ 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96283

LuxcoSITQ 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96286

LuxcoSITQ 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96287

LuxcoSITQ 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96287

LuxcoSITQ 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96288

NSS Latin America Holdings  . . . . . . . . . . . .

96251

Pioneer Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96245

Red & Black Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

96262

Royale Neuve VII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

96246

SADMI (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . .

96242

SES Astra Services Europe S.A.  . . . . . . . . .

96254

SES Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96251

Smalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96249

SOLKARST INTERNATIONAL Spf S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96242

Swiss-German High Yield Bond Fund  . . . .

96243

Threadneedle Strategic Property Fund IV

Luxembourg SA SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .

96288

96241

L

U X E M B O U R G

SOLKARST INTERNATIONAL Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.621.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra extraordinairement le <i>10.09.2013 à 10.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.03.2013;
- Affectation du résultat au 31.03.2013;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l'Assemblée au Siège Social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013118532/18.

SADMI (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 30.744.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>09.09.2013 à 16.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2012;
- Affectation du résultat au 31.12.2012;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Continuation de l'activité de la société
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l'Assemblée au Siège Social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013118571/19.

Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 106.770.

All holders of Notes issued by Estates S.A. (the "Noteholders" and the "Company" respectively) in relation to the

Compartment 2007/06/3 of the Issuer are invited to attend a

GENERAL MEETING

of Noteholders to be held at the registered office of the Company on <i>September 6, 2013 at 9.00 a.m., in order to

consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report from the board on the most important actions and decisions made or taken or contemplated to be made

or taken by the Issuer or the Target Company in relation to the Real Properties, and in particular regarding offers
for the sale of the lease rights of one of the Securitized Assets.

2. Approval of the actions and decisions referred to in the Report from the Board.
3. Miscellaneous.
This meeting is convened at the initiative of the Company.

96242

L

U X E M B O U R G

In the event this general meeting is not able to deliberate validly for lack of quorum, a second meeting of Noteholders

holding Notes issued in relation to that Compartment shall be held at 9.00 a.m. on September 13, 2013 at the registered
office of the Company, with the same agenda and such second meeting shall have the right to pass resolutions on the
items on the agenda irrespective of the quorum.

To be admitted to the meeting, the Noteholders shall be required at the beginning of the meeting to present the Notes

in respect of which they intend to vote, or an attestation issued by a bank in Luxembourg attesting that the Notes are
held by such bank on behalf of the Noteholders and shall be blocked until September 30, 2013.

The Report from the board of directors referred to in the agenda and the resolutions which will be proposed will be

available for consultation at the registered office of the Company at least 8 days prior to the meeting upon presentation
of one Note issued in relation to the Compartment concerned or upon presentation of the above mentioned attestation.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2013117746/29.

Dexia Prime Advanced, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.505.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l'Assemblée») de DEXIA PRIME ADVANCED aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch,

L-1470 Luxembourg le <i>28 août 2013 à 11 heures 30

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 mars

2013

2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars

2013

3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 mars 2013
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les

décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de

s'inscrire avant le 26 août 2013 auprès de DEXIA PRIME ADVANCED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention
de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L - 1470 Luxem-
bourg.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social

de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.

<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2013113719/755/29.

Swiss-German High Yield Bond Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 172.248.

Die Aktionäre der Swiss-German High Yield Bond Fund werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>29. August 2013 , 10.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung der Gesetzesgrundlage: Die Investmentgesellschaft wird von einer Luxemburger Investmentgesellschaft

gemäß Teil II in eine Luxemburger Gesellschaft gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) umgewandelt. Vor diesem Hinter-
grund erfolgt eine umfangreiche Anpassung des Verkaufsprospektes und der Satzung der Investmentgesellschaft an
die Vorgaben gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

96243

L

U X E M B O U R G

2. Der Name der Investmentgesellschaft wird von Swiss-German High Yield Bond Fund in I|A|F|A Global Bond SICAV

geändert.

3. Verlegung des Gesellschaftssitzes der SICAV von 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen zum Sitz der

neuen Verwaltungsgesellschaft 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die Änderungen treten zum 1. September 2013 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-

heitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird,
wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxem-
burgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser
Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren
lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung
nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich bis spätestens 24. August 2013 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Swiss-German High Yield Bond Fund (DZ

PRIVATBANK  S.A.)  unter  Telefon:  00352/44  903-4025,  Fax:  00352/44903-4506  oder  E-Mail:  directors-office@dz-
privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im August 2013.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013115219/755/38.

Intersaco S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 9.531.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>29 août 2013 à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013114355/534/15.

Cloisinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 74.233.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 août 2013 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2012.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Démission de M. Jonathan LEPAGE de son mandat d'administrateur et décharge.
7. Démission de Mme Audrey THONUS de son mandat d'administrateur et décharge.

96244

L

U X E M B O U R G

8. Nomination de Mme Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeu-

rant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

9. Nomination de Mme Laurence BIVER, administrateur de sociétés, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), le 6 janvier 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2013115216/29/25.

Build Group Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 122.985.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>29 août 2013 à 09.00 au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013115215/755/18.

Pioneer Funds, Fonds Commun de Placement.

The amended management regulations with respect to the fund PIONEER FUNDS have been filed with the Luxembourg

Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement PIONEER FUNDS a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pioneer Asset Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2013103512/12.
(130125979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Intellicast, Société Anonyme.

Siège social: L-2153 Luxembourg, 41, rue Antoine Meyer.

R.C.S. Luxembourg B 68.502.

Aux termes d'une convention en date du 7 janvier 2013, les sociétés:
INTELLICAST, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 32 000 euros dont le siège social est à 41 rue

Antoine MEYER L-2153 Luxembourg (Luxembourg) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg ville sous le numéro B 68502 (Société Apporteuse),

Et
INTELLICAST, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, dont le siège social est à Vanves (92 170) 108

rue Victor Hugo (France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 752 540
864 (Société Bénéficiaire)

ont établi un projet d'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions, aux termes duquel la société

apporteuse fait apport à la société bénéficiaire de sa branche d'activité de conception, commercialisation, installation,
mise en oeuvre, exploitation et maintenance de tous types de services de communication et d'information par tous
supports et tous médias, exploitée à ce jour au 11 rue Charles Schmidt à Saint Ouen (93400), d'une valeur nette de 750
000 euros.

96245

L

U X E M B O U R G

Cette convention d'apport partiel d'actif a été approuvée par décisions de l'associé unique de la société bénéficiaire

en date du 29 juin 2013 et par l'associé unique de la société apporteuse en date du 29 juin 2013.

En rémunération de cet apport, l'associé unique de la société bénéficiaire a procédé à une augmentation de capital de

750 000 euros pour le porter de 100 euros à 750 100 euros, par création de 7 500 actions nouvelles de 100 euros de
nominal, entièrement libérées, attribuées en totalité à la société apporteuse.

Il n'a été créé aucune prime d'apport.
En conséquence, aux termes de sa délibération du 29 juin 2013 l'associé unique de la société bénéficiaire a modifié les

articles 6 et 7 de ses statuts, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes:

Art. 6. Apports. Ancienne mention
«Lors de la constitution, l'associé unique fait apport d'une somme en numéraire de cent euros (100 euros), ainsi qu'il

résulte du certificat établi en date du15 juin 2012 par la banque HSBC- Agence de Levallois Perret - 92300, 29 rue Paul
Vaillant Couturier, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par
l'associé unique.»

Cette somme a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque

sous le numéro 30056 00913 09139653160 29.»

Nouvelle mention
Il est ajouté à l'alinéa précédent
«Par convention en date du 7 janvier 2013 approuvé par décision de l'associé unique du 29 juin 2013, il a été fait apport

par la société INTELLICAST société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 32 000 euros, dont le siège social
est à Luxembourg (LUXEMBOURG) L-2153, 41 rue Antoine Meyer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg ville sous le numéro 68502 (ci-après INTELLICAST Luxembourg), de sa branche complète et autonome
d'activité de conception, commercialisation, installation, mise en oeuvre, exploitation et maintenance de tous types de
services de communication et d'information par tous moyens supports (hertzien, satellite, câble, ect...) et pour tous
médias, pour une valeur nette de 750 000 euros, lequel apport a été rémunéré par la création de 7 500 actions de 100
euros attribuées à la société INTELLICAST Luxembourg, au titre d'une augmentation de capital de 750 000 euros de la
Société.»

Art. 7. Capital social. Ancienne Mention
«Le capital social est fixé à la somme de cents euros (100 euros).
Il est divisé en une (1) action ordinaire de CENTS EUROS (100 €), entièrement libérée comme il a été dit ci-dessus

et attribuée en totalité à l'associé unique.»

Nouvelle mention
«Le capital social est fixé à SEPT CENT CINQUANTE MILLE CENT EUROS (750 100) divisé en SEPT MILLE CINQ

CENT UNE (7 501) actions de même catégorie de CENT EUROS (100 €) chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Président

Référence de publication: 2013110235/55.
(130133181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2013.

Royale Neuve VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.089.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth of July,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

There appeared

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg, a société anonyme incorporated under the French laws, having its regis-

tered office in L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 23.968 (the "Sole Member"),

here represented by Mrs Delphine Guillou, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal in Luxembourg on 15 July 2013.

The proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be registered with it.

The appearing party is the sole member of the société à responsabilité limitée ROYALE NEUVE VII S.à r.l. (the "Com-

pany"), having its registered office in L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.-F. Kennedy, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 144.089, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 16 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 266 of 6

96246

L

U X E M B O U R G

February 2009. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed
of the undersigned notary dated 3 February 2012, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, number 756 of 22 March 2012.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, then deliberates upon the

following:

<i>Agenda

Approval of the merger plan between the companies ROYALE NEUVE VII S.à r.l. and SMALT S.A. by way of absorption

of the company SMALT S.A. pursuant to Articles 278 and following of the Law of 10 August 1915 on commercial com-
panies, as amended.

The  appearing  party,  represented  as  stated  above,  declares  that  the  provisions  of  the  law  of  10  August  1915  on

commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), relating to mergers have been respected, namely:

1. Publication of the merger plan of 19 June 2013 approved by the boards of managers respectively of directors of the

merging companies in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1525 of 27 June 2013, i.e. at least
one month before the date of the general meetings called to approve the merger plan.

2. Filing of the documents as required by Article 267 of the Law at the registered office of the merging companies at

least one month before the date of the general meetings for inspection by shareholders, subject to provisions of Article
278 of the Law.

A certificate signed by one Class A Manager and one Class B Manager confirming the filing of these documents will

remain attached to the present deed.

The Company being the sole member of the company SMALT, neither a written report of the board of managers

respectively of directors of the merging companies explaining and justifying the merger plan pursuant to Article 265 of
the Law, nor the examination of the merger plan and the establishment of a written report by an independent expert
pursuant to Article 266 of the Law, are required pursuant to Article 278 of the Law.

Then the Sole Member, represented as stated above, has required the undersigned notary to enact the following

resolution:

<i>Sole resolution:

The Sole Member resolves to approve the merger plan between the Company, as absorbing company, and the société

anonyme SMALT, with registered office at L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 29.273, as absorbed company, as this merger plan has been approved
and published by the board of managers of the Company and by the board of directors of SMALT pursuant to Article
278 and following of the Law.

Consequently, the Sole Member notes the universal transfer of all assets and liabilities of SMALT to the Company,

with accounting and fiscal effect from 1 

st

 January 2013 as described in the merger plan.

<i>Statement

The Sole Member notes that the sole shareholder of SMALT has approved the merger by general meeting dated today.
The undersigned notary, pursuant to Article 271, paragraph 2, of the Law, verified and hereby certify the existence

and legality of the acts and formalities required to the Company and of the merger plan.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearer and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente juillet,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La  société  anonyme  de  droit  français  BNP  PARIBAS,  Succursale  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  à  L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 23.968 (ci-après «l'Associé Unique»),

ici représentée par Madame Delphine Guillou, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2013.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

96247

L

U X E M B O U R G

La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée ROYALE NEUVE VII S.àr.l. (la «Société»),

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 144.089, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 16 décembre 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 266 du 6 février 2009. Les statuts de la Société ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné du 3 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 756 du 22 mars 2012.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Approbation du projet commun de fusion entre les sociétés ROYALE NEUVE VII S.à r.l. et SMALT S.A. par voie

d'absorption de la société SMALT S.A. conformément aux articles 278 et suivants de la Loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare que les dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée (ci-après la «Loi»), relatives aux fusions ont été respectées, savoir:

1. Publication du projet de fusion du 19 juin 2013 établi par les Conseils de Gérance respectivement d'Administration

des sociétés qui fusionnent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1525 du 27 juin 2013, soit un
mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la Loi au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion

des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires et associés, sous réserve des dispositions de
l'article 278 de la Loi.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par un gérant de classe A et un gérant de classe B de la

Société restera annexée aux présentes.

La Société étant associée unique de la société SMALT, ni l'établissement d'un rapport écrit par les Conseils de Gérance

respectivement d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion au sens
de l'article 265 de la Loi, ni l'examen du projet commun de fusion et l'établissement d'un rapport écrit par un expert
indépendant au sens de l'article 266 de la Loi ne sont requis conformément à l'article 278 de la Loi.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte de la résolution

suivante:

<i>Résolution unique:

L'Associé Unique approuve le projet de fusion entre la Société, en tant que société absorbante, et la société anonyme

SMALT, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.273, en tant que société absorbée, tel que ce projet de fusion a été approuvé
et publié par le Conseil de Gérance de la Société et le Conseil d'Administration de SMALT conformément aux articles
278 et suivants de la Loi.

En conséquence, l'Associé Unique constate la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de

SMALT à la Société, avec effet comptable et fiscal à partir du 1 

er

 janvier 2013 tel que décrit dans le projet de fusion.

<i>Constatation

L'Associé Unique constate que l'actionnaire unique de SMALT a approuvé la fusion par assemblée générale en date

d'aujourd'hui.

Le notaire soussigné, conformément à l'article 27l, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste

par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparant, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. GUILLOU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2013. LAC/2013 /35734. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 août 2013.

Référence de publication: 2013114224/127.
(130138541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2013.

96248

L

U X E M B O U R G

Smalt, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.273.

L'an deux mille treize, le trente juillet,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La société à responsabilité limitée ROYALE NEUVE VII S.àr.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.-

F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.089 (ci-après
«l'Actionnaire Unique»),

ici représentée par Madame Delphine Guillou, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2013.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme SMALT (la «Société»), avec siège social à L-1855 Lu-

xembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 29.273, constituée suivant acte notarié en date du 28 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 27 du 31 janvier 1989. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié
du 29 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1934 du 3 août 2012.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du dépôt de tous les documents requis au siège social de la Société conformément à l'article 267 de

la Loi sur les sociétés commerciales;

Approbation de la fusion entre la Société et ROYALE NEUVE VII S.à r.l. en tant que société absorbante en application

et conformément au projet de fusion conformément aux articles 278 et suivants de la Loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales;

2. Proposition que les actions de la Société détenues par ROYALE NEUVE VII S.à r.l. soient annulées.
3. Transfert par la Société de tous ses actifs et passifs à ROYALE NEUVE VII S.à r.l.;
4. Dissolution de la Société par absorption et sans liquidation;
5. Proposition de donner décharge aux administrateurs de la Société;
6. Divers.
L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-avant, déclare que les dispositions de la Loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi») relatives aux fusions ont été respectées, savoir:

1. Publication du projet de fusion du 19 juin 2013 établi par les Conseils de Gérance respectivement d'Administration

des sociétés qui fusionnent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1525 du 27 juin 2013, soit un
mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

2. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la Loi au siège social des sociétés un mois avant la date de la réunion

des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires et associés, sous réserve des dispositions de
l'article 278 de la Loi.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs de la Société restera annexée

aux présentes.

La société absorbante étant actionnaire unique de la Société, ni l'établissement d'un rapport écrit par les Conseils de

Gérance respectivement d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de
fusion au sens de l'article 265 de la Loi, ni l'examen du projet commun de fusion par un expert indépendant et l'établis-
sement d'un rapport d'expert au sens de l'article 266 de la Loi ne sont requis conformément à l'article 278 de la Loi.

L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L'Actionnaire Unique approuve le projet de fusion entre la Société, en tant que société absorbée, et la société à

responsabilité limitée ROYALE NEUVE VII S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.-F. Kennedy,
en tant que société absorbante, tel que ce projet de fusion a été approuvé et publié par le Conseil de Gérance de la
Société et par le Conseil d'Administration de la société à responsabilité limitée ROYALE NEUVE VII S.à r.l. conformément
à l'article 278 de la Loi.

96249

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'Actionnaire Unique constate que, sous réserve d'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale de la

société à responsabilité limitée ROYALE NEUVE VII S.à r.l., la fusion a les effets suivants:

a. l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société est transféré à ROYALE NEUVE VII S.à r.l. avec effet comptable

et fiscal au 1 

er

 janvier 2013 comme indiqué dans le projet de fusion;

b. la Société est dissoute sans liquidation et cesse d'exister;
c. les actions de la Société détenues par ROYALE NEUVE VII S.à r.l. sont annulées.

<i>Troisième résolution:

L'Actionnaire Unique donne décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour. Cette décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société sera confirmée pour le
compte de la société absorbante lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.

<i>Constatation:

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les

sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à
la Société et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. GUILLOU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2013. LAC/2013/35733. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 août 2013.

Référence de publication: 2013114258/81.
(130138263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2013.

IVG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 150.381.

Im Jahr zweitausenddreizehn, am zwölften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung seines verhinderten

Kollegen, Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz
und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,

ERSCHIENEN:

„IVG Luxembourg S.à r.l.“, eine luxemburgische société à responsabilité limitée mit Sitz in 24, avenue Emile Reuter,

L-2420 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 150.381, ge-
gründet gemäß Urkunde vom 15. Dezember 2009, aufgenommen durch Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz
in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Memorial“), Nummer 420 vom
4. Februar 2010 (die „Übernehmende Gesellschaft“). Die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft wurde letztmalig
geändert gemäß Urkunde vom 27. April 2012, aufgenommen durch Maître Francis KESSELER, Notar mit Amtssitz in Esch-
sur-Alzette, veröffentlicht im Memorial Nummer 1645 am 29. Juni 2012.

Die Übernehmende Gesellschaft wird vertreten durch Dr. Antje REIBOLD, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund der Vollmacht, die ihr durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft vom
27. Juni 2013 gegeben wurde.

Eine Abschrift des Protokolls über den vorbenannten Beschluss des Rates der Geschäftsführer bleibt der Urkunde,

nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte und den unterzeichnenden Notar, beigefügt, um mit dieser
bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, vorbenannt und vertreten wie erwähnt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgende

Erklärungen und Feststellungen aufzunehmen:

1. Die Übernehmende Gesellschaft und IVG Austria (Lux) Verwaltungsgesellschaft S.A, eine luxemburgische société

anonyme, mit Sitz in 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesell-
schaftsregister unter Nummer B 145.943, gegründet gemäß Urkunde vom 24. April 2009, aufgenommen durch Maître
Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Memorial Nummer 1034 vom 19. Mai 2009,

96250

L

U X E M B O U R G

deren Satzung letztmalig gemäß Urkunde vom 1. Juni 2012, aufgenommen von Maître Carlo WERSANDT, Notar mit
Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Memorial Nummer 1800 am 18. Juni 2012, geändert wurde (die „Übertragende
Gesellschaft“ und zusammen mit der Übernehmenden Gesellschaft, die „Verschmelzenden Gesellschaften") haben ent-
schieden, sich zu verschmelzen.

2. Der Verschmelzungsplan über die Verschmelzung zwischen (i) der Übernehmenden Gesellschaft, als übernehmende

Gesellschaft und (ii) der Übertragenden Gesellschaft, als übertragende Gesellschaft, wurde im Memorial vom 11. Juli 2013
unter Nummer 1656 veröffentlicht (der „Verschmelzungsplan“);

3. Gemäß Artikel 279 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung (das

„Gesetz“) waren der Verschmelzungsplan und die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre der Verschmelzenden Gesell-
schaften am jeweiligen Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften seit mindestens einem Monat für die Gesellschafter der
Übernehmenden Gesellschaft verfügbar;

4. Kein Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft hat gemäß Artikel 279 (1) c) des Gesetzes die Einberufung

einer Gesellschafterversammlung beantragt;

5. Gemäß Artikel 273 des Gesetzes wird die Verschmelzung am Tag der Veröffentlichung im Memorial einer notariellen

Bescheinigung darüber, dass die Bedingungen des Artikels 279 des Gesetzes erfüllt sind, wirksam;

6. Die Verschmelzung hat (i) die Gesamtrechtsnachfolge der Übernehmenden Gesellschaft nach der Übertragenden

Gesellschaft,  (ii)  die  Auflösung  ohne  Abwicklung  der  Übertragenden  Gesellschaft  (iii)  die  Einziehung  der  Aktien  der
Übertragenden Gesellschaft, sowie (iv) die Hinterlegung der Bücher der Übertragenden Gesellschaft am Sitz der Über-
nehmenden Gesellschaft zur Folge.

Die  erschienene  Partei,  vorbenannt  und  vertreten  wie  erwähnt,  hat  den  unterzeichnenden  Notar  gebeten  gemäß

Artikel 273 des Gesetzes die folgende Bescheinigung auszustellen:

<i>Bescheinigung

Gemäß Artikel 273 des Gesetzes bestätigt der unterzeichnende Notar hiermit, dass alle durch Artikel 279 des Gesetzes

vorgeschriebenen Bedingungen zum Wirksamwerden der Verschmelzung zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften
vorliegen und die Verschmelzung damit am Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Bestätigung gemäß Artikel 273 des
Gesetzes wirksam wird.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.

Gezeichnet: Antje REIBOLD, Martine SCHAEFFER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. August 2013. Relation: EAC/2013/10748. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2013116754/64.
(130141850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2013.

SES Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 101.799.

NSS Latin America Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 101.885.

L'an deux mille treize, le cinq août.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

Ont comparu

1) SES Participations, une société anonyme ayant son siège social à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.799, constituée suivant acte notarié en
date du 17 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 941 du 22 septembre 2004.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 14 décembre 2006, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194 du 16 février 2007.

2) NSS Latin America Holdings S.A., une société anonyme ayant son siège social à Betzdorf, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.885, constituée suivant acte notarié en date du 10 juin
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 959 du 27 septembre 2004.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 28 juillet 2006, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1925 du 12 octobre 2006.

96251

L

U X E M B O U R G

Toutes les deux ici représentées par Madame Anne Reuland, Senior Legal Counsel, demeurant à Strassen,
agissant comme représentante des Conseils d'Administration des deux sociétés en question suivant les pouvoirs con-

férés par les résolutions écrites du Conseil d'Administration desdites sociétés en date du 1 

er

 Juillet 2013.

Des copies des résolutions des Conseils de d'Administration, après avoir été paraphées "ne varietur" par le repré-

sentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à
la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet

de fusion ci-après:

PROJET DE FUSION:

1) Les sociétés participant à la fusion:
SES Participations, une société anonyme ayant son siège social à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.799, constituée suivant acte notarié en
date du 17 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 941 du 22 septembre 2004,

comme société absorbante (ci-après "SES Participations"),
et
NSS  Latin  America  Holdings  S.A.,  une  société  anonyme  ayant  son  siège  social  à  Betzdorf,  inscrite  au  Registre  de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.885, constituée suivant acte notarié en date du 10 juin
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 959 du 27 septembre 2004,

comme société absorbée (ci-après "NSS").
2) SES Participations détient quarante-neuf millions cinq cent sept mille cinquante-et-un (49.507.051) actions, sans

désignation de valeur nominale, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de NSS qui s'élève à quatre cent
quatre-vingt-quinze millions soixante-dix mille cinq cent dix euros (495,070,510 EUR) et conférant tous les droits de vote
dans NSS. Le capital social de NSS est libéré à hauteur de cent pourcent (100%). Aucun autre titre donnant droit de vote
n'a été émis par NSS.

3) SES Participations entend absorber NSS par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LSC").

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de

titres autres que des actions.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de SES Participations tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la

fusion entre SES Participations et NSS est considérée du point de vue juridique comme accomplie entre parties est fixée
à un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de NSS sont considérées du point de vue comptable comme accomplies

pour compte de SES Participations a été fixée au 1 Janvier 2013.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes

les obligations de NSS vis-à-vis de tiers seront pris en charge par SES Participations.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires respectivement réviseurs des

sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de SES Participations ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de SES Participations,
des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) LSC et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans
frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de SES Participations, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit

de SES Participations, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation
d'une assemblée générale de SES Participations appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de SES Participations tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de

SES Participations et NSS deviendra définitive entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble

du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b) la société absorbée cesse d'exister;
c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.
12) Décharge sera accordée aux administrateurs de la société absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice

en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.

13) Les documents sociaux de NSS seront conservés pendant le délai légal au siège social de SES Participations.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article

271 (2) LSC.

96252

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la représentante des comparantes,

le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise et qu'en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu à la représentante des comparantes, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et

demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and thirteen, on the fifth of August.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg:

there appeared

1) SES Participations, a limited company (une société anonyme), having its registered office at Betzdorf, recorded with

the Luxembourg trade and companies' register under the number B 101.799, and which was incorporated pursuant to a
notarial deed dated 17 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 941 dated
22 September 2004.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 14 December 2006,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 194 dated 16 February 2007.

2) NSS Latin America Holdings S.A., a limited company (une société anonyme), having its registered office at Betzdorf,

recorded with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 101.885, and which was incorporated
pursuant to a notarial deed dated 10 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
959 dated 27 September 2004.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial dated 28 July 2006, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1925 dated 12 October 2006.

Both here represented by Mrs Anne Reuland, Senior Legal Counsel, residing in Strassen,
acting in her capacity as special representative for and on behalf of the Boards of Directors of the two companies

appointed pursuant to powers conferred on her by the Boards of Directors of the said companies dated 1 July 2013.

Copies of the resolutions of the said Boards of Directors will remain attached to the present deed to be formally

registered therewith, after having been signed "ne varietur" by the parties' representative and the undersigned notary.

The appearing parties, represented as stated above, require the undersigned notary to authenticate the following

merger proposal:

MERGER PROPOSAL:

1) The companies participating in the merger:
SES Participations, a limited company (une société anonyme), having its registered office at Betzdorf, recorded with

the Luxembourg trade and companies' register under the number B 101.799, and which was incorporated pursuant to a
notarial deed dated 6 Julyl 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1484 dated
2 August 2006,

as the absorbing company (hereinafter "SES Participations"),
and
NSS Latin America Holdings S.A., a limited company (une société anonyme), having its registered office at Betzdorf,

recorded with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 101.885, and which was incorporated
pursuant to a notarial deed dated 10 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
959 dated 27 September 2004,

as the absorbed company (hereinafter "NSS").
2) SES Participations owns forty-nine million five hundred seven thousand and fifty one (49,507,051) shares, with no

par value indicated, representing the entirety (i.e. 100%) of the share capital of the company NSS, which amounts to four
hundred ninety-five million and seventy thousand five hundred and ten euros (EUR 495,070,510) and which carries all the
voting rights in NSS. The share capital of NSS has been fully paid up (100%). No other securities carrying voting rights
have been issued by NSS.

3) SES Participations intends to absorb NSS by way of a merger in accordance with Articles 278 and following of the

Law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "LSC").

4) Neither the absorbed company nor the absorbing company have shareholders with special rights, nor does any

person own securities in those companies other than the shares.

5) Subject to the rights of the shareholders of SES Participations as described in 10) hereafter, the date on which the

merger between SES Participations and NSS will be considered complete between the parties from a legal point of view
will be one month after the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) The date on which the operations of NSS will be considered as being carried out on behalf of SES Participations

from an accounting point of view will be 1 January 2013.

96253

L

U X E M B O U R G

7) With effect from the effective date of the merger from a legal point of view, as stated in 5) above, all the rights and

obligations of NSS with regard to third parties will be assumed by SES Participations.

8) No special benefits have been conferred to the Directors or to the statutory auditor respectively the independent

auditor of the merging companies.

9) The shareholders of SES Participations have the right, for a period of one month following the publication of the

proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to peruse the documents indicated in Article
267, (1) a), b) and c) LSC at the registered office of SES Participations, and to obtain complete copies of the said documents
on request, free of charge.

10) One or more shareholders of SES Participations, holding at least five per cent (5%) of the subscribed capital of

that company, have the right to ask for the convening of a general meeting of SES Participations within the period men-
tioned in 9) above, to decide whether to approve the merger.

11) Notwithstanding the rights of the shareholders of SES Participations described in 10) above, the merger of SES

Participations and NSS will become final between the parties one month after the publication of the proposed merger in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and will ipso jure have the effects provided for by Article 274 LSC,
i.e.:

a) the universal transfer of all the assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company, as well as

between those companies and with regard to third parties;

b) the absorbed company ceasing to exist;
c) the cancellation of the shares of the absorbed company owned by the absorbing company.
12) At the next annual general meeting of the absorbing company, the Directors of the absorbed company will be

given a discharge in respect of their conduct of the company's affairs during the current financial year.

13) The corporate documents of NSS will be retained at the registered office of SES Participations for the legal limitation

period.

The undersigned notary certifies the accuracy of this merger proposal in accordance with the provisions of Article

271(2) LSC.

In witness whereof, this deed has been executed in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date

set at the beginning of this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the representative of

the appearing parties, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

This deed having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with

the notary the present deed.

Signé: A. REULAND et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2013. LAC/2013 /36822. Reçu douze euros € 12,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013117610/172.
(130142571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2013.

SES Astra Services Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 117.813.

Astralis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 116.578.

L'an deux mille treize, le cinq août.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg:

Ont comparu

1) SES Astra Services Europe S.A., une société anonyme ayant son siège social à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.813, constituée suivant acte
notarié en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1484 du 2 août
2006.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 30 avril 2010, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1454 du 15 juillet 2010.

96254

L

U X E M B O U R G

2) Astralis S.A., une société anonyme ayant son siège social à Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.578, constituée suivant acte notarié en date du 19 mai 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1427 du 25 juillet 2006.

Toutes les deux ici représentées par Madame Anne Reuland, Senior Legal Counsel, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administration des deux sociétés

en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseil d'Administration desdites sociétés en date du 13 mai 2013.

Des copies des résolutions des Conseil d'Administration, après avoir été paraphées ne varietur par le représentant

des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la for-
malité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet

de fusion ci-après:

PROJET DE FUSION:

1) Les sociétés participant à la fusion:
SES Astra Services Europe S.A., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Château de Betzdorf,

L-6815 Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.813, constituée
suivant acte notarié en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1484
du 2 août 2006,

comme société absorbante (ci-après "Astra Services"),
et
Astralis S.A., une société anonyme ayant son siège social à Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 116.578, constituée suivant acte notarié en date du 19 mai 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1427 du 25 juillet 2006,

comme société absorbée (ci-après "Astralis").
2) Astra Services détient quinze mille cinq cent (15.500) actions avec une valeur nominale désignée de deux euros (2

EUR) représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de Astralis qui s'élève à trente et un mille d'euros (31.000 EUR)
et conférant tous les droits de vote dans Astralis. Le capital social de Astralis est libéré à hauteur de cent pourcent (100%).
Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par Astralis.

3) Astra Services entend absorber Astralis par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LSC").

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de

titres autres que des actions.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de Astra Services tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la fusion

entre Astra Services et Astralis est considérée du point de vue juridique comme accomplie entre parties est fixée à un
mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de Astralis sont considérées du point de vue comptable comme accomplies

pour compte de Astra Services a été fixée au 1 Janvier 2013.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes

les obligations de Astralis vis-à-vis de tiers seront pris en charge par Astra Services.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux gérants ou aux commissaires aux comptes respectivement réviseurs

des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de Astra Services ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de Astra Services, des
documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) LSC et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de Astra Services, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de

Astra Services, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation
d'une assemblée générale de Astra Services appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de Astra Services tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de Astra

Services et Astralis deviendra définitive entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble

du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b) la société absorbée cesse d'exister;
c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.
12) Décharge sera accordée aux gérants de la société absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en

cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société absorbante.

13) Les documents sociaux de Astralis seront conservés pendant le délai légal au siège social de Astra Services.

96255

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article

271 (2) LSC.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la représentante des comparantes,

le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise et qu'en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu à la représentante des comparantes, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et

demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and thirteen, on the fifth of August.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg:

there appeared

1) SES Astra Services Europe S.A.., a public limited liability company (une société anonyme), having its registered office

at Betzdorf, recorded with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 117.813, and which was
incorporated pursuant to a notarial deed dated 6 July 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 1484 dated 2 August 2006.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30

April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1454 dated 15 July 2010.

2) Astralis S.A., a public limited liability company (une société anonyme), having its registered office at Betzdorf, re-

corded with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 116.578, and which was incorporated
pursuant to a notarial deed dated 7 September 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1427 dated 25 July 2006.

Both here represented by Mrs Anne Reuland, Senior Legal Counsel, residing in Strassen,
acting in her capacity as special representative for and on behalf of the Boards of Directors of the two companies

appointed pursuant to powers conferred on her by the Boards of Directors of the said companies dated 13 May 2013.

Copies of the resolutions of the said Boards of Directors will remain attached to the present deed to be formally

registered therewith, after having been signed ne varietur by the parties' representative and the undersigned notary.

The appearing parties, represented as stated above, require the undersigned notary to authenticate the following

merger proposal:

MERGER PROPOSAL:

1) The companies participating in the merger:
SES Astra Services Europe S.A., a limited liability company (une société à responsabilité limitée), having its registered

office at Betzdorf, recorded with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 117.813, and which
was incorporated pursuant to a notarial deed dated 6 July 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1484 dated 2 August 2006,

as the absorbing company (hereinafter "Astra Services"),
and
Astralis S.A., a public limited liability company (une société anonyme), having its registered office at Betzdorf, recorded

with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 116.578, and which was incorporated pursuant
to a notarial deed dated 19 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1427
dated 25 July 2006,

as the absorbed company (hereinafter "Astralis").
2) Astra Services owns fifteen thousand five hundred (15.500) shares having a nominal value of two euros (EUR 2)

representing the entirety (i.e. 100%) of the share capital of the company Astralis, thirty-one thousand euros (EUR 31.000)
and which carries all the voting rights in Astralis. The share capital of Astralis has been fully paid up (100%). No other
securities carrying voting rights have been issued by Astralis.

3) Astra Services intends to absorb Astralis by way of a merger in accordance with Articles 278 and following of the

Law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "LSC").

4) Neither the absorbed company nor the absorbing company have shareholders with special rights, nor does any

person own securities in those companies other than the shares.

5) Subject to the rights of the shareholders of Astra Services as described in 10) hereafter, the date on which the

merger between Astra Services and Astralis will be considered complete between the parties from a legal point of view
will be one month after the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) The date on which the operations of Astralis will be considered as being carried out on behalf of Astra Services

from an accounting point of view will be 1 January 2013.

96256

L

U X E M B O U R G

7) With effect from the effective date of the merger from a legal point of view, as stated in 5) above, all the rights and

obligations of Astralis with regard to third parties will be assumed by Astra Services.

8) No special benefits have been conferred to the Directors or to the statutory auditor respectively the independent

auditor of the merging companies.

9) The shareholders of Astra Services have the right, for a period of one month following the publication of the

proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to peruse the documents indicated in Article
267, (1) a), b) and c) LSC at the registered office of Astra Services, and to obtain complete copies of the said documents
on request, free of charge.

10) One or more shareholders of Astra Services, holding at least five per cent (5%) of the subscribed capital of that

company, have the right to ask for the convening of a general meeting of Astra Services within the period mentioned in
9) above, to decide whether to approve the merger.

11) Notwithstanding the rights of the shareholders of Astra Services described in 10) above, the merger of Astra

Services and Astralis will become final between the parties one month after the publication of the proposed merger in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and will ipso jure have the effects provided for by Article 274 LSC,
i.e.:

a) the universal transfer of all the assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company, as well as

between those companies and with regard to third parties;

b) the absorbed company ceasing to exist;
c) the cancellation of the shares of the absorbed company owned by the absorbing company.
12) At the next annual general meeting of the absorbing company, the Directors of the absorbed company will be

given a discharge in respect of their conduct of the company's affairs during the current financial year.

13) The corporate documents of Astralis will be retained at the registered office of Astra Services for the legal limitation

period.

The undersigned notary certifies the accuracy of this merger proposal in accordance with the provisions of Article

271(2) LSC. In witness whereof,

This deed has been executed in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date set at the beginning

of this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the representative of

the appearing parties, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

This deed having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with

the notary the present deed.

Signé: A. REULAND et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2013. LAC/2013/36823. Reçu douze euros € 12,-

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 août 2013.

Référence de publication: 2013117609/167.
(130142546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2013.

ista Holdco 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 125.799.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of August,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of ista Holdco 1 S.A., a public limited liability

company (société anonyme), having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 125.799 (the Company). The Company has
been incorporated pursuant to a notarial deed dated 15 March 2007 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1045 of 2 June 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 21 June 2013 and in the process of being
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is opened at 10.15 a.m. and chaired by Bertrand Geradin, Attorney-at-law, professionally residing in

Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Adrien Pastorelli, Attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, as secretary (the

Secretary).

96257

L

U X E M B O U R G

The Meeting appoints Marine Baillet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer (the Scrutineer) (the

Chairman, the Secretary and the Scrutineer are together referred to hereafter as the Bureau).

All shareholders of the Company are present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are

indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by their
representative and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders of the Company, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting

in the name and on behalf of the shareholders and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed
to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I. all of the 26,700,000 (twenty-six million seven hundred thousand) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro)

each, representing the entire subscribed share capital of the Company, are present or duly represented at the Meeting,
which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda reproduced hereinafter;

II. the agenda of the Meeting is as follows:
(1) Waiver of the convening notices;
(2) Waiver of the provisions of article 7 of the Articles dealing with the modalities of a share redemption, including

but not limited, to (i) the redemption in alphabetical order of classes of shares as further described in article 7.1, (ii) the
requirement to have the redemption on a pro rata basis as further described in article 7.1 and (iii) the calculation method
for the redemption price as further described in article 7.7, and approval of the redemption of 83,615 (eighty-three
thousand six hundred and fifteen) class F shares; 83,613 (eighty-three thousand six hundred and thirteen) class G shares;
83,614 (eighty-three thousand six hundred and fourteen) class H shares; 83,612 (eighty-three thousand six hundred and
twelve) class I shares, and 83,612 (eighty-three thousand six hundred and twelve) class J shares (the Redeemed Shares),
having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, all held by Trius Holdings S.C.A., a Luxembourg partnership limited by
shares (société en commandite par action), having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 176699, against payment of an
amount of EUR 29,436,027.06, to be paid in kind, to Trius Holdings S.C.A.;

(3) Reduction of the nominal share capital of the Company by an amount of EUR 418,066 (four hundred and eighteen

thousand and sixty-six Euros), corresponding to the aggregate nominal value of the Redeemed Shares, by way of cancel-
lation of the Redeemed Shares;

(4) Creation of a reserve in accordance with article 69-2 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10

August 1915, as amended in an amount of EUR 418,066 (four hundred and eighteen thousand and sixty-six Euros);

(5) Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the share capital reduction specified under item (3) above;

(6) Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any director of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed, under his sole
signature, on behalf of the Company to the registration of the redemption of the Redeemed Shares and the share can-
cellation specified under item (3) above in the share register of the Company; and

(7) Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being present or represented at the Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the shareholders of the Company represented at the Meeting considering themselves as duly convened
and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting acknowledges the provisions of article 7 of the Articles dealing with the redemption of shares in the

Company and resolves to waive any rights resulting from these provisions so as to allow Trius Holdings S.C.A. to solely
benefit from the planned share redemption. Each shareholder other than Trius Holdings S.C.A. has expressly waived such
right in the respective proxy attached to this deed.

The Meeting further resolves to approve the redemption of 83,615 (eighty¬three thousand six hundred and fifteen)

class F shares, 83,613 (eighty-three thousand six hundred and thirteen) class G shares, 83,614 (eighty-three thousand six
hundred and fourteen) class H shares, 83,612 (eighty-three thousand six hundred and twelve) class I shares and 83,612
(eighty-three thousand six hundred and twelve) class J shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, held by
Trius Holdings S.C.A. against payment of a consideration to Trius Holdings S.C.A. in the amount of EUR 29,436,027.06,
being the fair market value of the Redeemed Shares (the Redemption Price).

The Meeting finally acknowledges and, to the extent required, approves that the Redemption Price will be paid by the

Company in kind through the transfer and assignment by the Company to Trius Holdings S.C.A. of a certain receivable
in the amount of EUR 29,436,027.06.

96258

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Meeting resolves to hereby cancel the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed nominal share capital of

the Company is reduced by an amount of EUR 418,066 (four hundred and eighteen thousand and sixty-six Euros), cor-
responding to the aggregate nominal value of the Redeemed Shares, and is brought from its present amount of EUR
26,700,000 (twenty-six million seven hundred thousand euros) to EUR 26,281,934 (twenty-six million two hundred and
eight-one thousand nine hundred and thirty-four euros), represented by 4,340,000 (four million three hundred and forty
thousand) Class A Shares; 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class B Shares; 4,340,000 (four
million three hundred and forty thousand) Class C Shares; 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand)
Class D Shares; 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class E Shares; 916,385 (nine hundred and
sixteen thousand three hundred and eighty-five) Class F Shares; 916,387 (nine hundred and sixteen thousand three hun-
dred and eighty-seven) Class G Shares; 916,386 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-six) Class
H Shares; 916,388 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-eight) Class I Shares; and 916,388 (nine
hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-eight) Class J Shares, all having a nominal value of EUR 1 (one
euro).

<i>Fourth resolution

To comply with the terms of article 69-2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the

Meeting resolves to create a reserve in an amount of EUR 418,066 (four hundred and eighteen thousand and sixty-six
Euros), which can only be distributed to the shareholders via the procedure of the reduction of the subscribed capital,
by the conversion of the corresponding amount of free reserves of the Company, a letter from the management of the
Company dated 8 August 2013 confirming that the amount of free reserves is sufficient to that effect on the date hereof.

<i>Fifth resolution

As a result of the share capital reduction resolved upon by the Meeting in the third resolution above, article 5.1 of the

Articles shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 26,281,934 (twenty-six million two hundred and eight-

one thousand nine hundred and thirty-four Euros) divided into:

(a) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class A Shares;
(b) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class B Shares;
(c) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class C Shares;
(d) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class D Shares;
(e) 4,340,000 (four million three hundred and forty thousand) Class E Shares;
(f) 916,385 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-five) Class F Shares;
(g) 916,387 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-seven) Class G Shares;
(h) 916,386 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-six) Class H Shares;
(i) 916,388 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-eight) Class I Shares; and
(j) 916,388 (nine hundred and sixteen thousand three hundred and eighty-eight) Class J Shares.
..."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby

empowers and authorizes any director of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg to
proceed on behalf of the Company, under his/her sole signature, to the registration of the share redemption and the
share cancellation referred to in the above third resolution in the share register of the Company and to see to any
formalities in connection therewith.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,500 (two thousand five hundred euros).

The meeting is closed at 10.30 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing
parties, in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing parties, the of the parties appearing signed together with us, the

notary, the present original deed.

96259

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le neuvième jour du mois d'août,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, au Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de ista Holdco 1 S.A., une société ano-

nyme  ayant  son  siège  social  au  174,  route  de  Longwy,  L-1940  Luxembourg,  et  immatriculée  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.799 (la Société). La Société a été constituée en vertu
d'un acte notarié en date du 15 mars 2007 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1045
du 2 juin 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu
d'un acte du notaire soussigné en date du 21 juin 2013 et en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

L'Assemblée est ouverte à 10.15 heures et présidée par Bertrand Géradin, avocat à la Cour, résidant professionnel-

lement à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne Adrien Pastorelli, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire de

l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée élit Marine Baillet, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur de l'As-

semblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau.

Tous les actionnaires de la Société sont présent ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le
mandataire des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des

actionnaires, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire de prendre acte de ce qui suit:
I. que l'ensemble des 26.700.000 (vingt-six millions sept cent mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un

euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, sont présentes ou représentées à la
présente Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et apte à délibérer des points de l'ordre du jour
reproduit ci-dessous;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Renonciation aux provisions de l'article 7 des Statuts portant sur les modalities de rachat d'actions, incluant sans

limitation, (i) le rachat par ordre alphabétique des classes d'actions tel que décrit plus avant dans l'article 7.1, (ii) l'obligation
de baser le rachat sur une base proratisée telle que décrit plus avant dans l'article 7.1 et (iii) la méthode de calcul pour
le prix de rachat telle que décrit plus avant dans l'article 7.7 et approbation du rachat de 83.615 (quatre-vingt-trois mille
six cent quinze) actions de classe F, de 83.613 (quatre-vingt-trois mille six cent treize) actions de classe G, de 83.614
(quatre-vingt-trois mille six cent quatorze) actions de classe H, de 83.612 (quatre-vingt-trois mille six cent douze) actions
de classe I, et de 83.612 (quatre-vingt-trois mille six cent douze) actions de classe J (les Actions Rachetées) ayant une
valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, toutes détenues par Trius Holdings S.C.A., une société en commandite par
actions luxembourgeoise ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.699 pour un montant de EUR 418.066
(quatre cent dix-huit mille soixante-six euros) contre le versement d'un montant de 29.436.027,06 EUR devant être payé
en nature à Trius Holdings SCA.;

(3) Réduction du capital social nominal de la Société d'un montant de EUR 418.066 (quatre cent dix-huit mille soixante-

six  euros)  correspondant  à  la  valeur  nominale  totale  des  Actions  Rachetées,  au  moyen  de  l'annulation  des  Actions
Rachetées;

(4) Création d'une réserve conformément à l'article 69-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, d'un montant de EUR 418.066 (quatre cent dix-huit mille soixante-six euros);

(5) Modification consécutive de l'article 5.1 des Statuts de façon à y refléter la réduction de capital social mentionnée

au point (3) ci-dessus;

(6) Modification du registre d'actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et

autorisation à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy Luxembourg afin de
procéder, sous sa seule signature, pour le compte de la Société, à l'inscription dans le registre d'actionnaires de la Société
du rachat des Actions Rachetées et de l'annulation d'actions mentionnée au point (3) ci-dessus dans le registre d'action-
naires de la Société; et

(7) Divers.
III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

96260

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant présents ou représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce

aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment
convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend actes des termes de l'article 7 des Statuts traitant du rachat d'actions de la Société et décide de

renoncer à tout droit en découlant de façon à permettre à Trius Holdings S.C.A. de bénéficier à titre exclusif du rachat
d'actions envisagé. Chaque actionnaire autre que Trius Holdings S.C.A. a expressément renoncé à tout droit dans chacune
des procurations qui restera annexée au présent acte.

L'Assemblée décide de plus d'approuver le rachat de 83.615 (quatre-vingt-trois mille six cent quinze) actions de classe

F, de 83.613 (quatre-vingt-trois mille six cent treize) actions de classe G, de 83.614 (quatre-vingt-trois mille six cent
quatorze) actions de classe H, de 83.612 (quatre-vingt-trois mille six cent douze) actions de classe I, et de 83.612 (quatre-
vingt-trois mille six cent douze) actions de classe J ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) détenues par Trius
Holdings S.C.A. contre le versement d'un montant de 29.436.027,06 EUR à Trius Holdings S.C.A représentant la valeur
de marché des Actions Rachetées (le Prix de Rachat).

Enfin, l'Assemblée reconnaît en outre, et dans la mesure du nécessaire approuve le fait que le Prix de Rachat soit payé

par la Société au moyen d'un apport en nature par le transfert et la cession par la Société à Trius Holdings S.C.A. d'une
créance d'un montant de 29.436.027,06 EUR.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide par les présentes d'annuler les Actions Rachetées. Par conséquent, le capital social nominal souscrit

de la Société est diminué d'un montant de EUR 418.066 (quatre cent dix-huit mille soixante-six euros), correspondant
en la valeur nominale totale des Actions Rachetées, et est porté de son montant actuel de EUR 26.700.000 (vingt-six
millions sept cent mille euros) à un montant de EUR 26.281.934 (vingt-six millions deux cent quatre-vingt-un mille neuf
cent trente-quatre euros), représenté par 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe A,
4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe B, 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante
mille) Actions de Classe C, 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe D, 4.340.000 (quatre
millions trois cent quarante mille) Actions de Classe E, 916.385 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-cinq) Actions
de Classe F, 916.387 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-sept) Actions de Classe G, 916.386 (neuf cent seize
mille trois cent quatre-vingt-six) Actions de Classe H, 916.388 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-huit) Actions
de Classe I, et 916.388 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-huit) Actions de Classe J, ayant une valeur nominale
de EUR 1 (un euro) chacune.

<i>Quatrième résolution

Pour se conformer aux dispositions de l'article 69-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, l'Assemblée décide de constituer une réserve d'un montant de 418.066 EUR (quatre cent dix-huit mille soixante-
six euros), qui ne peut être distribuée aux actionnaires qu'au moyen de la réduction du capital souscrit, de la conversion
du montant de réserves disponibles correspondant de la Société, une lettre émise par les administrateurs de la Société
en date du 8 août 2013 confirmant que le montant de réserves disponibles est suffisant à cet effet à la date des présentes.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la réduction de capital social décidée par l'Assemblée dans la troisième résolution ci-dessus, l'article

5.1 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est établi à EUR 26.281.934 (vingt-six millions deux cent quatre-vingt-un

mille neuf cent trente-quatre euros) divisés en:

(a) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe A;
(b) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe B;
(c) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe C;
(d) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe D;
(e) 4.340.000 (quatre millions trois cent quarante mille) Actions de Classe E;
(f) 916.385 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-cinq) Actions de Classe F;
(g) 916.387 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-sept) Actions de Classe G;
(h) 916.386 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-six) Actions de Classe H;
(i) 916.388 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-huit) Actions de Classe I; et
(j) 916.388 (neuf cent seize mille trois cent quatre-vingt-huit) Actions de Classe J.
..."

96261

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre d'actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, et

accorde pouvoir et autorisation à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy
Luxembourg afin de procéder, pour le compte de la Société et sous leur seule signature, à l'inscription du rachat et de
l'annulation d'actions mentionnés dans la troisième résolution ci-dessus dans le registre d'actionnaires de la Société, et
afin de procéder à toutes les formalités y relatives nécessaires.

<i>Déclaration - Frais

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.500 (deux mille cinq cents euros).

L'assemblée est clôturée à 10.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête de la présente.
Et après lecture faite aux parties comparantes, ces dernières ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent

acte.

Signé: B. Geradin, A. Pastorelli, M. Baillet, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 13 août 2013. REM/2013/1469. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 14 août 2013.

Référence de publication: 2013117106/259.
(130142891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2013.

Red &amp; Black Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.105.125,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 127.992.

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am vierten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Sind erschienen:

1. Red &amp; Black Lux S.à r.l. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Felipe Diaz Toro, Rechtsanwalt, geschäftsmäßig anssässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
2. Red &amp; Black Holding GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit satzungsmäßigem

Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Oberursel (Taunus), Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Thomas Duong, Jurist, geschäftsmäßig anssässig in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Besagte Vollmachten, nachdem sie ne varietur durch den Erschienenen und den amtierenden Notar unterschrieben

wurden, bleiben vorliegender Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Erschienenen baten sodann um Beurkundung des Folgenden:

VERSCHMELZUNGSPLAN

zwischen
1. der Red &amp; Black Holding GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit satzungsmäßigem

Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Oberursel (Taunus), Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Bad Homburg unter HRB 11721, als übertragendem Rechtsträger

- nachfolgend „R&amp;B GmbH"-
und
2. der Red &amp; Black Lux S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à res-

ponsabilité limitée) mit satzungsmäßigem Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Geschäftsregister Luxemburg, (Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer
B 127992, als übernehmendem Rechtsträger

96262

L

U X E M B O U R G

- nachfolgend „ R&amp;B Lux" -
R&amp;B GmbH und R&amp;B Lux werden im Folgenden einzeln auch als „Partei" und gemeinsam als „Parteien" bezeichnet.

<i>Vorbemerkung

(A) Die R&amp;B GmbH, übertragende Gesellschaft, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit

Sitz in Oberursel (Taunus), Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg unter HRB
11721. Ihre Geschäftsadresse lautet Alberusstraße 4, 61440 Oberursel (Taunus), Deutschland. Das Stammkapital der R&amp;B
GmbH beträgt EUR 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) und ist vollständig eingezahlt. Alleinige Gesell-
schafterin der R&amp;B GmbH ist die R&amp;B Lux.

(B) Die R&amp;B Lux, übernehmende Gesellschaft, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts

mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Geschäftsregister Luxemburg (Registre
de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer B 127992. Ihre Geschäftsadresse lautet 282, Route de Longwy, L-1940
Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Das ausgegebene Stammkapital der R&amp;B Lux beträgt bei Aufstellung dieses
Verschmelzungsplans EUR 1.105.125, welches in gleicher Höhe eingezahlt ist.

(C) Alleinige Gesellschafterin der R&amp;B Lux ist die Red &amp; Black Topco S.à r.l. („R&amp;B Topco"), eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit satzungsmäßigem Sitz und Ort der
Geschäftsleitung in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Geschäftsregister Luxemburg
(Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer B 129047. Ihre Geschäftsadresse lautet 282, Route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Das ausgegebene Stammkapital der R&amp;B Topco beträgt bei
Aufstellung dieses Verschmelzungsplans EUR 1.390.997.

(D) Sowohl die R&amp;B GmbH als auch die R&amp;B Lux sind arbeitnehmerlos.
(E)  Die  Geschäftsführung  der  R&amp;B  Lux  und  die  Geschäftsführung  der  R&amp;B  GmbH  beabsichtigen,  die  R&amp;B  GmbH

grenzüberschreitend auf ihre Alleingesellschafterin, die R&amp;B Lux, zu verschmelzen. Ziel der Verschmelzung ist insbeson-
dere die Vereinfachung der Beteiligungsstruktur der Red &amp; Black Gruppe.

(F) Die Verschmelzung wird auf der Grundlage der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten (die „EU-
Verschmelzungsrichtlinie") durchgeführt. Auf die Verschmelzung finden - soweit deutsches Recht anwendbar ist - die §§
122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (im Folgenden: „UmwG"), die die EU- Verschmelzungsrichtlinie in deutsches
Recht umgesetzt haben, und - soweit luxemburgisches Recht anwendbar ist - die Artikel 257 ff. des luxemburgischen
Gesetzes betreffend Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils gültigen Fassung (Loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales) (im Folgenden „LSG"), die die EU- Verschmelzungsrichtlinie in luxemburgisches
Recht umgesetzt haben, Anwendung.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt:

§ 1. Vermögensübertragung.
1.1 Die R&amp;B GmbH als übertragende Gesellschaft wird gemäß § 122a Abs. 2 i.V.m. § 2 Nr. 1 UmwG und gemäß den

Artikeln 278 ff. sowie den einschlägigen Vorschriften des Abschnitts XIV, Unterabschnitt I des LSC unter Auflösung ohne
Abwicklung durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die R&amp;B Lux als übernehmende Gesellschaft verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).

1.2 Da sämtliche Geschäftsanteile an der R&amp;B GmbH von der R&amp;B Lux gehalten werden, wird das Stammkapital der

R&amp;B Lux zur Durchführung der Verschmelzung gemäß Artikel 278 i.V.m. Artikel 274 LSC und § 122a Abs. 2 i.V.m. § 54
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG nicht erhöht. Daher werden im Rahmen der Verschmelzung keine Geschäftsanteile der R&amp;B
Lux geschaffen, ausgegeben oder gewährt. Ferner entfallen gemäß den anwendbaren deutschen Vorschriften die Angaben
über  den  Umtausch  von  Anteilen,  insbesondere  (i)  die  Angaben  zum  Umtauschverhältnis  der  Anteile  und  zur  Höhe
etwaiger barer Zuzahlungen (§ 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG), (ii) die Angaben hinsichtlich der Übertragung oder Ausgabe
von neuen Geschäftsanteilen an der R&amp;B Lux (§ 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG) und (iii) die Angabe des Zeitpunkts, von dem
an neu geschaffene Geschäftsanteile das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren (§ 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG) sowie
eine Verschmelzungsprüfung (§ 122f Satz 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 UmwG). Nach Artikel 278 LSC entfallen insbesondere (i) die
Angaben über ein Umtauschverhältnis und zur Höhe etwaiger barer Zuzahlungen, (ii) die Angaben hinsichtlich der Über-
tragung oder Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen an der R&amp;B Lux inkl. der Verfahrensweise diesbezüglich und (iii) die
Angabe des Zeitpunkts, von dem an neu geschaffene Geschäftsanteile das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren
inkl. etwaiger Verfahrensweisen diesbezüglich.

1.3 Die Verschmelzung wird rechtlich an demjenigen Tag wirksam, an dem der notariell beurkundete Gesellschafter-

beschluss der R&amp;B Lux im Amtsblatt Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) bekanntgemacht
wird (Artikel 273ter Abs. 1 LSC). Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung geht das Vermögen der R&amp;B GmbH von
Gesetzes wegen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge als Ganzes auf die R&amp;B Lux über. Gleichzeitig erlischt die R&amp;B
GmbH.

§ 2. Gegenleistung. Eine Gegenleistung wird gemäß §§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 Nr. 3, Satz 1, 2. Halbsatz, 1. Fall UmwG

und auch nach Artikel 278 i.V.m. Artikel 274 LSC nicht gewährt. Die Verschmelzung findet gemäß §§ 122a Abs. 2, 54 Abs.

96263

L

U X E M B O U R G

1 Satz 1 Nr. 1 UmwG und Artikel 278 und 274 LSC ohne Kapital erhöhung bei der R&amp;B Lux und ohne anderweitige
Ausgabe von Anteilen statt (siehe oben unter § 1.2).

§ 3. Verschmelzungsstichtag, Bewertung des zu übertragenden Vermögens, Bilanzen.
3.1 Die Übernahme des Vermögens der R&amp;B GmbH durch die R&amp;B Lux erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Rech-

nungslegung im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1. Juli 2013, 0:00 Uhr („Verschmelzungsstichtag"). Die R&amp;B GmbH und
die R&amp;B Lux sind sich darin einig, dass unter Rechnungslegungsgesichtspunkten von diesem Zeitpunkt an sämtliche Hand-
lungen und Geschäfte der R&amp;B GmbH als für Rechnung der R&amp;B Lux vorgenommen gelten. Der 30. Juni 2013 ist gleichzeitig
der Übertragungsstichtag nach deutschem Steuerrecht. Der Verschmelzung wird die Zwischenbilanz der R&amp;B GmbH zum
30. Juni 2013 als Schlussbilanz i.S.v. § 122k Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 1 UmwG zugrundegelegt.

3.2 Die R&amp;B Lux wird die im Rahmen der Verschmelzung von der R&amp;B GmbH auf die R&amp;B Lux übergehenden Aktiva

und Passiva zu Buchwerten übernehmen und zu diesen Werten in ihrer handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegung
ansetzen (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG; Artikel 261 Abs. 2 lit. e) LSC).

3.3 Der Verschmelzung werden die Zwischenbilanzen der R&amp;B GmbH und der R&amp;B Lux jeweils zum 30. Juni 2013

zugrunde gelegt.

§ 4. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung. Weder die übertragende Gesellschaft

noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Daher hat die Verschmelzung der R&amp;B GmbH auf die
R&amp;B Lux keinerlei Folgen für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertretungen dieser Gesellschaften. Insoweit sind keine
Maßnahmen vorgesehen.

§ 5. Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmungsrechte. Weder die übertragende Gesellschaft noch die überneh-

mende  Gesellschaft  beschäftigt  Arbeitnehmer.  Ferner  ist  keine  der  zu  verschmelzenden  Gesellschaften  mitbestimmt.
Durch die Verschmelzung ändert sich der Umfang an Mitbestimmung gegenüber dem bestehenden Umfang daher nicht.
Ein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte im Sinne der Artikel L.
426-13 ff. des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuchs (Code du Travail) bzw. des Artikel 16 der EU-Verschmelzungsricht-
linie ist daher nicht durchzuführen. Da kein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer durchzuführen ist, entfallen auch
die diesbezüglichen Angaben im Verschmelzungsplan.

§ 6. Gewährung von Rechten an Gesellschafter, die mit Sonderrechten ausgestattet sind oder an Inhaber von anderen

Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen.

6.1 Bei der R&amp;B GmbH gibt es keine mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter oder Inhaber von anderen Wert-

papieren  als  Geschäftsanteilen,  insbesondere  keine  Inhaber  von  Wandelschuldverschreibungen,  Genussrechten  oder
ähnlichen Instrumenten. Daher ist keine Gewährung von Rechten an solche Personen und auch keine Durchführung von
anderen Maßnahmen für solche Personen i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Artikel 261 Abs. 2 lit. f) LSC erfolgt bzw.
vorgesehen.

6.2 Bei der R&amp;B Lux gibt es mit Ausnahme der Alleingesellschafterin R&amp;B Topco keine mit Sonderrechten ausgestattete

Gesellschafter oder Inhaber von anderen Wertpapieren als Geschäftsanteilen, insbesondere keine Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten oder ähnlichen Instrumenten. Eine Gewährung von Rechten an die R&amp;B Topco
oder Durchführung von anderen Maßnahmen für die R&amp;B Topco i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Artikel 261 Abs.
2 lit. f) LSC ist nicht erfolgt bzw. vorgesehen.

§ 7. Vorteile für unabhängige Sachverständige oder Organmitglieder. Weder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Lei-

tungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der R&amp;B GmbH und der R&amp;B Lux noch unabhängigen Sachverständigen wurden
besondere Vorteile im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Artikel 261 Abs. 2 lit. g) LSC gewährt. Diese werden
auch künftig im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht gewährt werden.

§ 8. Satzung der R&amp;B Lux. Die Satzung der R&amp;B Lux wurde mit notarieller Gründungsurkunde vom 15. Mai 2007 vor

dem  Notar  Martine  Schaeffer  mit  dem  damaligen  Amtssitz  in  Remich,  Großherzogtum  Luxemburg,  veröffentlicht  im
Amtsblatt Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) vom 5. Juli 2007, Nummer 1364 veröffentlicht.
Die Satzung ist zuletzt mit notarieller Urkunde vom 21. April 2008, veröffentlicht im Amtsblatt Luxemburg (Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations) am 13. Mai 2008, Nummer 1159, durch vorgenannten Notar geändert worden.

Die Satzung der R&amp;B Lux wird im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert und ist diesem Verschmel-

zungsplan in beglaubigter Übersetzung als Anlage 1 beigefügt.

§ 9. Weitere Regelungen im Zusammenhang mit der Verschmelzung.
9.1 Die Firma der R&amp;B Lux wird ohne Änderung fortgeführt.
9.2 Die Zusammensetzung der Geschäftsführung der R&amp;B Lux als übernehmendem Rechtsträger ändert sich nicht,

insbesondere wird kein Geschäftsführer der R&amp;B GmbH anlässlich der Verschmelzung zum Mitglied der Geschäftsführung
der R&amp;B Lux bestellt.

9.3  Die  Verschmelzung  bedarf  nach  §  122g  Abs.  2  UmwG  keines  Verschmelzungsbeschlusses  des  übertragenden

Rechtsträgers, da sich sämtliche Geschäftsanteile des übertragenden Rechtsträgers in der Hand des übernehmenden
Rechtsträgers befinden.

9.4 Die Anlage 1 zu diesem Verschmelzungsplan ist integrativer Bestandteil dieser Urkunde.

96264

L

U X E M B O U R G

§ 10. Kosten. Die R&amp;B GmbH und die R&amp;B Lux tragen die ihnen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durch-

führung der Verschmelzung sowie die im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan entstehenden Kosten selbst.
Die gemeinsam veranlassten Kosten werden von der R&amp;B Lux und die R&amp;B GmbH jeweils zur Hälfte getragen.

<i>Stellungnahme

Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit die Gesetzmäßigkeit des vorliegenden Verschmelzungsplans gemäß Ar-

tikel 261 ff. des Luxemburgischen Gesetzes.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, nimmt zur Kenntnis, dass auf Antrag der hier erschie-

nenen Parteien die vorliegende Urkunde in Deutsch gefolgt von einer englischen Übersetzung verfasst wurde, wobei im
Falle von Abweichungen zwischen der in Deutschen verfassten Urkunde und der englischen Übersetzung die deutsche
Version maßgebend ist.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nach Vorlesung der Urkunde hat die dem Notar beim Vor- und Familiennamen, Personenstand und Wohnort bekannt

erschienene Partei zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Follows the English translation

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of the month of July.
Before, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Red &amp; Black Lux S.à r.l. a company with limited liability under Luxembourg law (société à responsabilité limitée),

having its registered office and place of management in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mr. Felipe Diaz Toro, Lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
2. Red &amp; Black Holding GmbH. a company with limited liability under German law (Gesellschaft mit beschränkter

Haftung), having its registered office and place of management in Oberursel (Taunus), Germany

here represented by Mr. Thomas Duong, jurist, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The persons appearing then asked for the authentication of the following:

DRAFT TERMS OF MERGER

between
1. Red &amp; Black Holding GmbH, a company with limited liability under German law (Gesellschaft mit beschränkter

Haftung), having its registered office and place of management in Oberursel (Taunus), Germany, registered in the com-
mercial register of the Amtsgericht Local Court Bad Homburg under HRB 11721 as the company being acquired

- hereinafter referred to as "R&amp;B GmbH"-
and
2. Red &amp; Black Lux S.á r.l., a company with limited liability under Luxembourg law (société á responsabilité limitée),

having its registered office and place of management in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital
of EUR 1,105,125 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127992
as the acquiring company

- hereinafter referred to as "R&amp;B Lux" -
R&amp;B GmbH and R&amp;B Lux are hereinafter also referred to individually as a "Party" and jointly as the "Parties".
Recitals
(A) R&amp;B GmbH, the company being acquired, is a company with limited liability under German law having its seat in

Oberursel (Taunus), Germany, registered in the commercial register of the Amtsgericht [Local Court] Bad Homburg
under HRB 11721. Its business address is Alberusstraße 4, 61440 Oberursel (Taunus), Germany. The registered share
capital of R&amp;B GmbH amounts to EUR 25,000 (in words: twenty-five thousand euro) and has been fully paid up. Sole
shareholder of R&amp;B GmbH is R&amp;B Lux.

(B)  R&amp;B  Lux,  the  acquiring  company,  is  a  company  with  limited  liability  under  Luxembourg  law  having  its  seat  in

Luxembourg, registered in the commercial register of the Chamber of Commerce Luxembourg (Registre de Commerce
et des Sociétés), under no. B 127992. Its business address is 282, Route de Longwy, 1940 Luxembourg, Great Duchy of
Luxembourg. The issued registered share capital of R&amp;B Lux amounts to EUR 1.105.125 at the date when these draft
terms of merger are drawn up; it has been fully paid up. R&amp;B Lux is the sole shareholder of R&amp;B GmbH.

96265

L

U X E M B O U R G

(C) Sole shareholder of R&amp;B Lux is Red &amp; Black Topco S.à r.l. ("R&amp;B Topco"), a company with limited liability under

Luxembourg law having its seat in Luxembourg, Luxembourg, Great Duchy of Luxembourg, registered in the commercial
register of the Chamber of Commerce Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés), under no. B 129047. Its
business address is 282, Route de Longwy, 1940 Luxembourg, Great Duchy of Luxembourg. The issued registered share
capital of R&amp;B Topco amounts to EUR 1.390.997 at the date when these draft terms of merger are drawn up.

(D) Neither R&amp;B GmbH nor R&amp;B Lux have any employees.
(E) The management of R&amp;B Lux and the management of R&amp;B GmbH intend to effect a cross-border merger of R&amp;B

GmbH onto its sole shareholder, R&amp;B Lux. The objective of such merger is, in particular, to simplify the participation
structure of the Red &amp; Black group.

(F) The merger shall be carried out on the basis of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council

of 26 October 2005 on cross- border mergers of limited liability companies (the "EU Mergers Directive"). To the extent
German law is applicable, Sections 122a et seqq. of the German Umwandlungsgesetz (Transformation Act, hereinafter
referred to as the "UmwG"), which implemented the EU Mergers Directive into German law, and - to the extent Lux-
embourg law is applicable - Articles 257 et seqq. of the Luxembourg Law of 10 August 1915 concerning Commercial
Companies (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) (hereinafter referred to as the "LSC"), which
implemented the EU Mergers Directive into Luxembourg law, shall be applicable to the merger.

Now, therefore, the Parties agree as follows:

§ 1. Transfer of assets and Liabilities.
1.1 In accordance with Section 122a (2) in conjunction with Section 2 point 1 UmwG and in accordance with Articles

278 et seqq. and the applicable provisions of Sections XIV Sub-Section I of the LSC, R&amp;B GmbH as the company being
acquired shall be merged as a whole onto R&amp;B Lux as the acquiring company, being dissolved without going into liquidation
and transferring all its assets and liabilities (merger by acquisition).

1.2 As all shares in R&amp;B GmbH are held by R&amp;B Lux, the registered share capital of R&amp;B Lux will not be increased in

order to carry out the merger in accordance with Article 278 in conjunction with Article 274 LSC and Section 122a (2)
in conjunction with Section 54 (1) sentence 1 point 1 UmwG. Therefore, no shares in R&amp;B Lux will be created or issued
as part of the merger. Furthermore, according to the applicable German provisions, the information on the exchange of
shares, in particular (i) the indication of the exchange ratio of the shares and on the amount of additional cash payments,
if any (Section 122c (2) point 2 UmwG), (ii) the indication of the transfer or issue of new shares in R&amp;B Lux (Section 122c
(2) point 3 UmwG) and (iii) the indication of the date as from which newly created shares grant a right to profit partici-
pation (Section 122c (2) point 5 UmwG), as well as a merger audit (Section 122f sentence 1 in conjunction with Section
9 (2) UmwG) are dispensed. According to Article 278 LSC, in particular (i) the indication of a share exchange ratio and
the amount of additional cash payments, if any, (ii) the indication of the methods regarding the transfer or issuance of
new shares in R&amp;B Lux and (iii) the indication of the date as from which newly created shares grant a right to profit
participation(and any particular methods relating thereto) are dispensed.

1.3 The merger shall be legally effective on the day when the notarised shareholder resolution of R&amp;B Lux is published

in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (Article 273ter para. 1 LSC). Upon
the merger becoming effective, the assets and liabilities of R&amp;B GmbH shall by operation of law be transferred as a whole
to R&amp;B Lux by means of universal succession. At the same time, R&amp;B GmbH shall cease to exist.

§ 2. Consideration. No consideration shall be granted in accordance with Sections 122a (2), 20 (1) point 3, sentence

1, 2nd half sentence, 1st case UmwG and pursuant to Article 278 in conjunction with Article 274 LSC. In accordance
with Sections 122a (2), 54 (1) sentence 1 point 1 UmwG and Article 278 i.V.m. 274 LSC, the merger shall be carried out
without any increase of the capital of R&amp;B Lux nor any allotment of shares (see at Section 1.2 above).

§ 3. Effective Merger Date, Valuation of the assets to be transferred, Balance sheets.
3.1 As between the merging companies, for accounting purposes the transfer of R&amp;B GmbH's assets and liabilities to

R&amp;B Lux shall occur with effect as per 1 July 2013, 0:00 CET ("Effective Merger Date"). R&amp;B GmbH and R&amp;B Lux agree
that for accounting purposes all actions and transactions by R&amp;B GmbH as from that date shall be deemed undertaken
on behalf of R&amp;B Lux. At the same time, 30 June 2013 shall be the transfer date for the purposes of German tax law. The
merger shall be based on the interim balance sheet of R&amp;B GmbH as of 30 June 2013 as closing balance sheet in the sense
of Section 122k (1) sentence 2 conjunction with 17 (2) sentence 1 UmwG.

3.2 R&amp;B Lux will receive the assets and liabilities transferred due to the merger of R&amp;B GmbH to R&amp;B Lux at their

book value and report them at this value in the commercial law and tax accounting (Section 122c para. 2 no. 11 UmwG;
Article 261 Abs. 2 lit. e) LSC).

3.3  The  merger  shall  be  based  on  the  interim  balance  sheets  of  R&amp;B  GmbH  and  R&amp;B  Lux  as  per  30  June  2013,

respectively.

§ 4. Impact of the merger on employment. Neither the company being acquired nor the acquiring company have any

employees. Therefore, the merger of R&amp;B GmbH onto R&amp;B Lux will have no impact on employees or employee repre-
sentatives of these companies. Insofar, no relevant measures have been prepared.

96266

L

U X E M B O U R G

§ 5. Procedure to establish co-determination rights. Neither the company being acquired nor the acquiring company

have any employees. Furthermore, neither of the companies to be merged is subject to co-determination. Accordingly,
the scope of co-determination will not be different from its existing scope due to the merger. A procedure for the
involvement of employees in the definition of their rights to participation within the meaning of Article L. 426-13 et seqq.
of the Luxembourg Labour Code (Code du Travail) and of Article 16 of the EU Mergers Directive, respectively, therefore,
need not be carried out. As no procedure for the involvement of employees is to be carried out, the corresponding
indications in the draft terms of merger are dispensed.

§ 6. Grant of rights to shareholders provided with special rights or holders of securities other than shares.
6.1 R&amp;B GmbH does not have any shareholders provided with special rights or holders of securities other than shares,

in particular any holders of convertible bonds, profit-sharing rights, or similar instruments. Therefore, no grant of rights
to such persons or the implementation of other measures in favour of such persons within the meaning of Section 122c
(2) point 7 UmwG and Article 261 (2) lit. f) LSC has been made or provided.

6.2 R&amp;B Lux does not have - with the exception of its sole shareholder R&amp;B Topco - any shareholders provided with

special rights or holders of securities other than shares, in particular any holders of convertible bonds, profit-sharing
rights, or similar instruments. No grant of rights to R&amp;B Topco or the implementation of other measures in favour of
R&amp;B Topco within the meaning of Section 122c (2) point 7 UmwG and Article 261 (2) lit. f) LSC has been made or
provided.

§ 7. Benefits for independent experts or the management. Neither the members of administrative, managing, super-

visory or controlling bodies of R&amp;B GmbH or R&amp;B Lux nor any independent experts were granted special benefits as
defined in Section 122c (2) point 8 UmwG and Article 261 (2) lit. g) LSC. Neither will such benefits be granted in the
future in the context of the merger.

§ 8. Articles of Association of R&amp;B Lux. The Articles of Association of R&amp;B Lux were drawn up by deed of incorporation

executed on 15 May 2007 before Me Martine Schaeffer, then notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 5 July 2007 number 1364. The articles of asso-
ciation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by the prenamed notary on 21 April
2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 13 May 2008 number 1159.

The Articles of Association of R&amp;B Lux will not be amended in the context of the merger; a certified translation of

the Articles is attached to these draft terms of merger as Annex 1.

§ 9. Further provisions related to the merger.
9.1 The company name of R&amp;B Lux shall continue unchanged.
9.2 The composition of the managing board of R&amp;B Lux as the acquiring company will not change; in particular, no

managing director of R&amp;B GmbH will be appointed a member of the managing board of R&amp;B Lux on the occasion of the
merger.

9.3 According to Section 122g (2) UmwG, the merger does not require a merger resolution of the company being

acquired, as all shares of the company being acquired are held by the acquiring company.

9.4 Annex 1 to this merger plan is an integral part of this document.

§ 10. Costs. R&amp;B Lux and R&amp;B GmbH shall each bear their own costs incurred in connection with the preparation

and implementation of the merger as well as the costs that arise in connection with these draft terms of merger. The
costs incurred jointly shall be borne by R&amp;B Lux and R&amp;B GmbH in equal shares.

<i>Statement

In accordance with the provisions of article 261 and seq. of the Luxembourg Law the undersigned notary declares to

certify the lawfulness of the present merger proposal.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in German, followed by an English translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the German version and the English version, the German version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: F. DIAZ TORO, T. DUONG und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juillet 2013. Relation: LAC/2013/32309 Reçu douze euros (12.- EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

96267

L

U X E M B O U R G

Folgt die Satzung der übernehmenden Gesellschaft:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of RED &amp; BLACK LUX S.à r.l.

(hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any

form whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining

any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed
above.

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into

any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the
financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to

its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;

- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its

assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;

- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements,

underwriting  agreements,  marketing  agreements,  distribution  agreements,  management  agreements,  advisory  agree-
ments, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose;

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at one million one hundred five thousand one hundred twenty-five euro

(EUR 1,105,125) represented by one million one hundred five thousand one hundred twenty-five (1,105,125) shares with
a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or

in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable to

non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the same
case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of
shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by

approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-

lution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the partners, who

need not be partners of the Company. In case of one manager, he/it will be referred to as the «Sole Manager»'. In case
of plurality of managers, they will constitute a board of managers (hereafter the «Board of Managers»)

96268

L

U X E M B O U R G

The manager(s) shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration.
In case of plurality of managers, the total number of members of the Board of Managers of the Company shall be

determined by its direct partners, RED &amp; BLACK TOPCO 2 S.ar.l. and RED &amp; BLACK TOPCO S.ar.l. (the «Managers'
Number»). The total number of persons to be nominated for appointment as managers shall be determined by RED &amp;
BLACK TOPCO 2 S.ar.l. and RED &amp; BLACK TOPCO S.ar.l. (the «Applicants'Number»).

RED &amp; BLACK TOPCO 2 S.ar.l. and RED &amp; BLACK TOPCO S.ar.l. are entitled from time to time to nominate for

appointment a majority of the Applicants' Number, out of which the general meeting of partners of the Company shall
appoint a majority of the Managers' Number.

B Shareholders of RED &amp; BLACK TOPCO S.ar.l. are entitled from time to time to nominate for appointment less than

a majority of the Applicants' Number, out of which the general meeting of partners of the Company shall appoint, at least
two managers as long as the conditions set out in the articles of association of RED &amp; BLACK TOPCO S.ar.l. for such
entitlement to nominate for appointment are fulfilled.

A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or

the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager
shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions,
and such manager's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the
partners fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
remuneration.

96269

L

U X E M B O U R G

Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint or

single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of
managers.

Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge has

been granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties, the
Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be indemnified
out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses, which they
or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, concurred in, or
omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if any) as they shall
incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as provided for in article
59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act, receipts, neglects or
defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for any bankers or
other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe
custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of the Company may come,
or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency or deficiency or defect of
title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage
occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever
which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto, except the same shall happen by or
through their own willful neglect or default respectively.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 16. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII

of the law of August 10, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the

same year.

Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the

case may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

96270

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RED &amp; BLACK LUX S.à r.l. (ci-

après la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l'acquisition de tous titres, droits et actifs par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l'argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l'émission
d'obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d'autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l'objet décrit ci-dessus.

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n'entrera pas dans une

quelconque transaction qui l'engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:

- Accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant

d'emprunts, d'émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- Accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses

actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne.

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d'accords

d'association, d'accords de garantie, d'accords de marketing, d'accords de distribution, d'accords de gestion, d'accords
de conseil, d'accords d'administration et d'autres contrats de services, d'accords de vente, ou d'autre en rapport avec
son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles

à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement
liées aux activités décrites dans cet article.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe

qu'elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à
l'étranger.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à un million cent cinq mille cent vingt-cinq Euros (EUR 1.105.125) repré-

senté par un million cent cinq mille cent vingt-cinq (1.105.125) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1)
chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession

ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou si le cas se

réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la

Société.

96271

L

U X E M B O U R G

C. Gérance

Art. 10. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui n'ont pas besoin

d'être associés de la Société. Dans le cas d'un seul gérant, il y sera fait référence en tant que «Gérant Unique». En cas de
pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les gérants seront nommés par une décision des associés pour une durée indéterminée.
En cas de pluralité de gérants, le nombre total des membres du conseil de gérance de la Société sera déterminé par

ses associés directs, RED &amp; BLACK TOPCO 2 S.à r.l. et RED &amp; BLACK TOPCO S.à r.l. (le «Nombre de Gérants»). Le
nombre total de personnes à être désignées comme candidats à la nomination en tant que gérants sera déterminé par
RED &amp; BLACK TOPCO 2 S.à r.l. et RED &amp; BLACK TOPCO S.à r.l. (le «Nombre de Candidats»).

RED &amp; BLACK TOPCO 2 S.à r.l. et RED &amp; BLACK TOPCO S.à r.l. ont le droit, à tout moment, de désigner pour

nomination une majorité du Nombre de Candidats parmi lesquels l'assemblée générale des associés de la Société nommera
une majorité du Nombre de Gérants.

Les associés B de RED &amp; BLACK TOPCO S.à r.l. ont droit, à tout moment, de désigner pour nomination moins de la

majorité du Nombre de Candidats parmi lesquels l'assemblée générale des associés de la Société nommera au moins deux
Gérants du moment que les conditions fixées dans les statuts de RED &amp; BLACK TOPCO S.à r.l. pour ce droit de désigner
un candidat à la nomination sont remplies.

Un gérant peut être révoqué avec ou sans cause et remplacé à tout moment par une décision adoptée par les associés.
En cas de vacance à la place d'un gérant pour cause de mort, de retraite ou autre, les gérants restants peuvent élire,

par un vote à la majorité, un gérant pour pallier cette vacance jusqu'à la prochaine décision des associés ratifiant cette
élection.

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra alors

être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gérance et
des associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis

de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d'associés et tous les conseils de gérance, cependant en son

absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre

heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préala-
blement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu'un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu'au moyen d'une conférence téléphonique. La participation
par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un
facsimile, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la
résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président

pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.

96272

L

U X E M B O U R G

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou par deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour

la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute
personne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signatures

conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil
de gérance.

Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l'autorise et à condition que décharge ait été accordée par l'assemblée

générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions, les gérants, commissaires
aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l'actif de la Société contre toute action,
coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu'ils auront encouru pour cause de signature de contrats ou de tout
action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l'exercice de leurs fonctions, excepté s'ils les ont encouru
suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l'article 59 paragraphe
2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d'entre eux ne devra être responsable collectivement pour un
acte,  négligence  ou  défaut  commis  par  l'un  ou  l'autre  d'entre  eux,  ou  pour  avoir  agi  conjointement  dans  un  but  de
conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pourraient être
déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la Société ont été
remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l'achat de tout bien, pour l'absence ou l'invalidité de titres détenus
la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné par une erreur
de jugement ou d'inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte qui se produi-
raient dans l'exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s'ils sont causés par leur
propre malveillance, négligence ou défaut.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s'en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d'obligations convertibles ou d'autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d'une assemblée générale d'associés conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 17. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et provi-

sions représentent le bénéfice net de la société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l'associé unique ou l'assemblée

générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice,
après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

96273

L

U X E M B O U R G

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Folgt die beglaubigte auszugsweise Übersetzung aus der französischen in die deutsche Sprache:

A. Firma - Dauer - Zweck - Sitz

Art. 1.  Es  wird  eine  société  à  responsabilité  limitée  unter  der  Firma  „Red  &amp;  Black  Lux  S.à  r.l."  (nachstehend  die

„Gesellschaft"), die dem luxemburgischen Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils gelten-
den Fassung sowie dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteili-

gungen gleich welcher Art an anderen luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb jeglicher Wertpa-
piere, Rechte und Vermögenswerte durch Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, Festübernahme oder Kaufoption, Handel
und jede sonstige Art und Weise, der Erwerb von Patenten und Lizenzen, ihre Verwaltung und Verwertung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres vorstehend genannten Gesellschaftszwecks Mittel aufnehmen, unter anderem

Geld und Kredite in jeder Form aufnehmen und unter anderem über die Begebung von Anleihen, Schuldverschreibungen,
Schuldscheinen und anderen Schuldtiteln oder Eigenkapitalinstrumenten (ob mit oder ohne Wandlungsrecht) Mittel auf-
nehmen.

Die Gesellschaft kann ferner folgende Geschäfte abschließen, sofern sie kein Geschäft abschließt, durch das sie eine

Tätigkeit ausüben würde, die als regulierte Tätigkeit des Finanzsektors gilt:

- Gewährung von Krediten ohne Beschränkung an ihre Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder alle

sonstigen Unternehmen, unter anderem aus Mitteln, die sie über Anleihen, Schuldtitel oder Eigenkapitalinstrumente auf-
nimmt;

-  Gewährung  von  Garantien  und  Pfandrechten  sowie  Übertragung,  Verpfändung  und  Bestellung  und  Leistung  von

Sicherheiten an der Gesamtheit oder einem Teil ihres Vermögens und Gewährung von Garantien für ihre eigenen Verp-
flichtungen und Verbindlichkeiten und/oder die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten jedes anderen Unternehmens und
allgemeiner im eigenen Interesse oder im Interesse jedes anderen Unternehmens bzw. jeder anderen Person;

- Abschluss von Vereinbarungen, unter anderem jeglicher Art von Vereinbarungen über Kreditderivate, Vereinbarun-

gen über die Gründung einer Personenvereinigung, Garantievereinbarungen, Marketingvereinbarungen, Vertriebsverein-
barungen,  Managementvereinbarungen,  Beratungs¬vereinbarungen,  Verwaltungsvereinbarungen  und  sonstige
Dienstleistungs¬verträge, Verkaufsverträge oder sonstige Vereinbarungen mit Bezug auf ihren Gesellschaftszweck.

Die Gesellschaft kann außerdem alle geschäftlichen, technischen und finanziellen Maßnahmen, die zur Erreichung ihres

Gesellschaftszwecks wie in diesem Artikel beschrieben zweckmäßig erscheinen, sowie alle Maßnahmen, die mit den in
diesem Artikel beschriebenen Tätigkeiten direkt oder indirekt verbunden sind, treffen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss der

Geschäftsführung an einen beliebigen anderen Ort in der Stadt Luxemburg verlegt werden. Durch einfachen Beschluss
der Geschäftsführung können Zweigniederlassungen oder Geschäftsstellen im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile

Art.  5.  Das  Kapital  der  Gesellschaft  beträgt  eine  Million  einhundertfünftausend  einhundertfünfundzwanzig  Euro

(1.105.125 EUR), eingeteilt in eine Million einhundertfünftausend einhundertfünfundzwanzig (1.105.125)

Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (1 EUR).
Jeder Geschäftsanteil gewährt bei der Beschlussfassung der ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterver-

sammlungen eine Stimme.

Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Beteiligung am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft im Verhältnis zur Anzahl

der bestehenden Geschäftsanteile.

Art. 6. Die von einem alleinigen Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile sind sowohl unter Lebenden als auch im

Falle von Erbfolge oder Auflösung einer ehelichen Gütergemeinschaft frei übertragbar.

Falls es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Geschäftsanteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie sind im

selben Fall an Personen, die keine Gesellschafter sind, nur mit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter mit einer

96274

L

U X E M B O U R G

Mehrheit von drei Vierteln des Stammkapitals, übertragbar. Die Geschäftsanteile sind von Todes wegen auf Personen,
die  keine  Gesellschafter  sind,  nur  mit  der  Zustimmung  der  Gesellschafter  mit  einer  Mehrheit  von  drei  Vierteln  der
Geschäftsanteile, die von den überlebenden Gesellschaftern gehalten werden, übertragbar.

Art. 7. Das Stammkapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters bzw. (soweit dieser Fall eintritt)

der Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten, geändert werden.

Art. 8. Die Geschäftsanteile sind im Verhältnis zu der Gesellschaft, die je Geschäftsanteil nur einen einzigen Inhaber

anerkennt, unteilbar. Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, sind diese verpflichtet,
einen  gemeinsamen  Vertreter  zu  benennen,  der  ihre  Rechte  aus  dem  Gesellschaftsanteil  gegenüber  der  Gesellschaft
ausübt.

Art. 9. Der Tod, die Entmündigung, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters führen nicht zur

Auflösung der Gesellschaft.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt, die durch Bes-

chluss der Gesellschafter bestellt werden und keine Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Falls nur ein Geschäfts-
führer bestellt wird, wird dieser als „Einzelgeschäftsführer" bezeichnet. Falls mehrere Geschäftsführer bestellt sind, bilden
sie eine Geschäftsführung (die „Geschäftsführung").

Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafter auf unbestimmte Dauer bestellt.
Falls mehrere Geschäftsführer bestellt sind, wird die Gesamtzahl der Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft

von den unmittelbaren Gesellschaftern Red &amp; Black Topco 2 S.à r.l. und Red &amp; Black Topco S.à r.l. festgelegt (die „Anzahl
der Geschäftsführer"). Die Gesamtzahl der Personen, die als Kandidaten für die Bestellung als Geschäftsführer vorges-
chlagen  werden,  wird  von  Red  &amp;  Black  Topco  2  S.à  r.l.  und  Red  &amp;  Black  Topco  S.à  r.l.  festgelegt  (die  „Anzahl  der
Kandidaten").

Red &amp; Black Topco 2 S.à r.l. und Red &amp; Black Topco S.à r.l. sind berechtigt, jederzeit eine Mehrheit der Anzahl der

Kandidaten für die Bestellung vorzuschlagen, aus denen die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft eine Mehrheit
der Anzahl der Geschäftsführer bestellt.

Die B-Gesellschafter der Red &amp; Black Topco S.à r.l. sind berechtigt, jederzeit weniger als die Mehrheit der Anzahl der

Kandidaten für die Bestellung vorzuschlagen, aus denen die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mindestens zwei
Geschäftsführer bestellt, sofern die in der Satzung der Red &amp; Black Topco S.à r.l. festgelegten Bedingungen für das Recht,
einen Kandidaten für die Bestellung vorzuschlagen, erfüllt sind.

Ein Geschäftsführer kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafter mit oder ohne Grund abberufen und

ersetzt werden.

Falls das Amt eines Geschäftsführers aufgrund von Tod, Ruhestand oder anderen Gründen frei wird, können die übrigen

Geschäftsführer durch Mehrheitsbeschluss einen Geschäftsführer wählen, der das Amt bis zur nächsten Beschlussfassung
der Gesellschafter über die Genehmigung dieser Wahl besetzt.

Art. 11. Die Geschäftsführung kann aus ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden

bestellen. Sie kann außerdem einen Schriftführer, der nicht zugleich auch Mitglied der Geschäftsführung sein muss, bes-
tellen. Dieser ist für die Führung der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlun-
gen verantwortlich.

Die Sitzungen der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der

Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz auf allen Gesellschafterversammlungen und Sitzungen der Geschäftsführung. Im Falle

seiner Abwesenheit können die Gesellschafter oder Mitglieder der Geschäftsführung mit der Mehrheit der anwesenden
Stimmen einen vorübergehenden Vorsitzenden für die Versammlung bzw. Sitzung bestimmen.

Alle Geschäftsführer erhalten mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem für eine Sitzung der Geschäftsführung

vorgesehenen Termin eine schriftliche Bekanntmachung über diese Sitzung, außer in dringenden Fällen, in denen die Art
der Dringlichkeit in der Einberufungsbekanntmachung anzugeben ist. Auf die schriftliche Einberufung kann mit der Zus-
timmung jedes Geschäftsführers, die schriftlich (im Original, per Telefax oder per E-Mail) erteilt werden muss, verzichtet
werden.

Sitzungen der Geschäftsführung, bei denen alle Geschäftsführer anwesend sind oder vertreten werden und erklärt

haben, dass sie vorher von der Tagesordnung der Sitzung Kenntnis hatten, und Sitzungen der Geschäftsführung, die zu
einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die in einem von einem von der Geschäftsführung vorher ange-
nommenen Beschluss festgelegt wurden, bedürfen keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung vertreten lassen, indem er schriftlich - im

Original, per Telefax oder mittels eines anderen elektronischen Kommunikationsmittels, vorausgesetzt dessen Authen-
tizität ist anerkannt - einen anderen Geschäftsführer als seinen Vertreter bestellt.

96275

L

U X E M B O U R G

Die Geschäftsführung ist nur dann beschluss- und handlungsfähig, wenn bei einer Sitzung der Geschäftsführung mind-

estens die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist oder vertreten wird. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen
der auf einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Hat ein Geschäftsführer der Gesellschaft ein entgegenstehendes persönliches Interesse an einer Angelegenheit der

Gesellschaft (ausgenommen sind Interessen, die durch eine Funktion als Geschäftsführer, Beauftragter oder Mitarbeiter
einer anderen beteiligten Partei bedingt sind), muss dieser Geschäftsführer die Geschäftsführung über dieses entgegen-
stehende persönliche Interesse informieren und darf weder an den Beratungen noch an der Beschlussfassung über diese
Angelegenheit  teilnehmen.  Darüber  hinaus  muss  auf  der  nachfolgenden  Gesellschafterversammlung  über  dieses
entgegen¬stehende persönliche Interesse des betreffenden Geschäftsführers berichtet werden.

Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung der Geschäftsführung per Telefonkonferenz oder mithilfe jedes anderen

ähnlichen Kommunikationsmittels, mit dem sich alle an der Sitzung teilnehmenden Personen verständigen können, teil-
nehmen. Eine Sitzung kann daher auch nur mittels einer Telefonkonferenz abgehalten werden. Die Teilnahme an einer
Sitzung über ein solches Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme.

Die Geschäftsführung kann einstimmige Beschlüsse über ein oder mehrere Dokumente im Umlaufverfahren fassen.

Die Zustimmung der Mitglieder der Geschäftsführung muss in Form eines schriftlichen Originals, per Telefax, per E-Mail
oder mittels jedes anderen ähnlichen Kommunikationsmittels - erteilt werden. Alle Zustimmungen zusammen bilden das
Protokoll, das die Beschlussfassung nachweist.

Art. 12. Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung sind von dem Vorsitzenden und im Fall seiner Abwesenheit

von dem vorübergehenden Vorsitzenden, der den Vorsitz der betreffenden Sitzung übernommen hat, oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderswo vorgelegt werden sollen, werden

vom Vorsitzenden, vom Schriftführer oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 13. Die Geschäftsführung hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Der Geschäftsführung stehen alle Befugnisse zu, die nicht ausdrücklich gesetzlich
oder nach dieser Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind.

Die Geschäftsführung kann die Führung der laufenden Geschäfte der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft

für die Zwecke der laufenden Geschäftsführung einem oder mehreren Geschäftsführern übertragen, die ihrerseits Aus-
schüsse bilden können, die unter den von der Geschäftsführung festgelegten Bedingungen Beschlüsse fassen können. Die
Geschäftsführung kann außerdem jeglicher Person, unabhängig von deren Eigenschaft als Geschäftsführer, besondere
Befugnisse und Vollmachten verleihen, jegliche Führungskräfte und Mitarbeiter einstellen sowie entlassen und ihre Ver-
gütung festlegen.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift eines jeden Geschäftsführers der Gesellschaft oder durch

die  gemeinsamen  oder  einzelnen  Unterschriften  aller  anderen  Personen,  denen  die  Geschäftsführung  entsprechende
Zeichnungsvollmachten erteilt hat, verpflichtet.

Art. 15. Soweit nach luxemburgischem Recht zulässig und unter der Voraussetzung, dass die Gesellschafterversamm-

lung eine Entlastung von jeglicher Haftung, die diesen aus der Wahrnehmung ihrer Pflichten entstehen kann, erteilt hat,
werden die Geschäftsführer, Abschlussprüfer, Schriftführer, Mitarbeiter oder Vertreter der Gesellschaft aus dem Verm-
ögen der Gesellschaft von allen Klagen, Kosten, Belastungen, Verlusten, Schäden und Aufwendungen freigestellt, die ihnen
durch die Unterzeichnung von Verträgen oder jegliche Handlung oder Unterlassung, die direkt oder indirekt mit der
Wahrnehmung ihrer Pflichten zusammenhängt, entstehen, außer wenn diese aufgrund einer eigenen böswilligen oder
fahrlässigen Handlung oder Unterlassung von ihnen entstehen und außer gemäß Artikel 59 Abs. 2 des luxemburgischen
Gesetzes über die Handelsgesellschaften, und keiner von ihnen haftet gesamtschuldnerisch für eine Handlung, Fahrläs-
sigkeit oder Unterlassung eines anderen von ihnen oder für ein gemeinsames Handeln mit dem Ziel der Einheitlichkeit
oder für eine Bank oder jede andere Person, bei der Vermögenswerte der Gesellschaft verwahrt sein könnten, oder für
eine Bank, einen Wertpapiermakler oder jede andere Person, der Vermögenswerte der Gesellschaft anvertraut wurden,
oder für einen fehlenden Rechtstitel der Gesellschaft für den Kauf jeglicher Güter, für fehlende oder ungültige Rechtstitel
der Gesellschaft bei Anlage von Geldern der Gesellschaft, für jegliche Verluste oder Schäden, die durch eine falsche
Beurteilung oder Unachtsamkeit von ihnen verursacht wurden, für Verluste, Schäden oder Nachteile jeglicher Art, die
bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben oder im Zusammenhang mit ihren Aufgaben entstehen, außer wenn
diese aufgrund einer eigenen böswilligen oder fahrlässigen Handlung oder Unterlassung von ihnen entstehen.

D. Beschlüsse eines Alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter

Art. 16. Ein alleiniger Gesellschafter übt die der Gesellschafterversammlung durch die Bestimmungen von Abschnitt

XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung verliehenen Befugnisse
aus.

Daraus folgt, dass alle Beschlüsse, die über die den Geschäftsführern übertragenen Befugnisse hinausgehen, von dem

alleinigen Gesellschafter gefasst werden.

Falls es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Beschlüsse, die über die den Geschäftsführern übertragenen Befugnisse

hinausgehen, von der Gesellschafterversammlung gefasst.

96276

L

U X E M B O U R G

Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile an der Fassung der

gemeinsamen Beschlüsse teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat die Anzahl an Stimmen, die der Anzahl der Anteile, die von
ihm gehalten oder vertreten werden, entspricht.

Jede Ausgabe von Geschäftsanteilen infolge der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen oder anderen ähnlichen

Finanzinstrumenten erfordert die vorherige Einberufung einer Gesellschafterversammlung gemäß den Bestimmungen des
vorstehenden Artikels 7. Für die Zwecke der Wandlung wird jede Wandelschuldverschreibung bzw. jedes andere ähnliche
Finanzinstrument als Zeichnung von Geschäftsanteilen, die bei der Wandlung auszugeben sind, betrachtet.

E. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 18. Zum letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres wird der Jahresabschluss aufgestellt und der oder

die Geschäftsführer erstellen eine Aufstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Ein positiver Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug aller Aufwendungen, Abschreibungen, Belastungen

und Rückstellungen entspricht dem Nettogewinn der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns in die gesetzliche Rücklage eingestellt.
Diese Einstellung ist nicht mehr verpflichtend, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Stammkapitals erreicht

hat, wobei die Einstellung erneut vorzunehmen ist, bis der volle Umfang der gesetzlichen Rücklage wieder erreicht ist,
wenn diese - wann und aus welchem Grund auch immer -reduziert wurde.

Der verbleibende Überschuss wird einem alleinigen Gesellschafter zugewiesen oder unter den Gesellschaftern verteilt.

Der alleinige Gesellschafter bzw. die Gesellschafterversammlung können jedoch durch Mehrheitsbeschluss gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen beschließen, dass der Gewinn nach Abzug der Einstellung in die Rücklage vorge-
tragen oder in eine besondere Rücklage eingestellt wird.

F. Auflösung - Liquidation

Art. 19. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die keine

Gesellschafter sein müssen und von der Gesellschafterversammlung bestellt werden, die ihre Befugnisse und Vergütung
festlegt, durchgeführt. Der oder die Liquidatoren haben die weitestgehenden Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
genswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten.

Die Vermögenswerte nach Abzug der Verbindlichkeiten werden zwischen den Gesellschaftern im Verhältnis der von

ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile aufgeteilt.

Art. 20. In allen Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, nehmen die Gesellschafter Bezug auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 in der geltenden Fassung.

Ne varietur gezeichnet: F. D. T., T. D. und H. H.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juillet 2013. Relation: LAC/2013/32309. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Folgt die Anlage:
Bekanntmachung gemäß Art. 262 (2) des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesell-

schaften

Red &amp; Black Lux S.àr.l.
Gemäß Art. 268 Abs. 1 Satz 1 des luxemburgischen Gesetzes betreffend Handelsgesellschaften (Loi concernant les

sociétés commerciales) (im Folgenden „LSC") können Gläubiger der sich verschmelzenden Gesellschaften, deren For-
derungen vor der Veröffentlichung des Zustimmungsbeschlusses der Generalversammlung der Gesellschafter der Red &amp;
Black Lux S.àr.l. zur Verschmelzung im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations) begründet wurden, ungeachtet einer gegensätzlichen Vereinbarung innerhalb einer Frist von zwei Monaten
ab dem Tag dieser Veröffentlichung bei dem Vorsitzenden Richter der Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts
in Luxemburg (Tribunal d'Arrondissement)

in dessen Bezirk die Red &amp; Black Lux S.à r.l. ihren Sitz hat, die summarische Überprüfung der Stellung von Sicherheiten

für fällige und nicht fällige Forderungen beantragen, sofern sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Er-
füllung ihrer Forderung gefährdet wird und R&amp;B Black Lux S.à r.l. nicht genügend Sicherheiten bereitgestellt hat.

Der Vorsitzende der Kammer für Handelssachen des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) weist gemäß Art.

268 Abs. 1 Satz 2 LSC diesen Antrag zurück, wenn die Gläubiger über adäquate Sicherheiten verfügen oder wenn die
Stellung von Sicherheiten angesichts des Vermögens der Gesellschaft nach der Verschmelzung nicht notwendig ist.

Die Red &amp; Black Lux S.àr.l. kann sich nach Art. 268 Abs. 1 Satz 3 LSC dem Antrag widersetzen, indem sie den Gläubiger

auszahlt, selbst wenn es sich um eine noch nicht fällige Forderung handelt. Wenn die gegebenenfalls angeordneten Si-
cherheiten nicht innerhalb der festgelegten Frist gestellt werden, wird die Forderung unverzüglich fällig (Art. 268 Abs. 1
Satz 4 LSC).

96277

L

U X E M B O U R G

<i>Rechte der Minderheitsgesellschafter

Da weder an der Red &amp; Black Lux S.à r.l. noch an der Red &amp; Black Holding GmbH Minderheitsgesellschafter beteiligt

sind, finden die deutschen Schutzvorschriften des § 122h UmwG in Verbindung mit §§ 14, 15 UmwG (Verbesserung des
Umtauschverhältnisses) keine Anwendung. Dies gilt auch für die Regelung des § 122i UmwG i.V.m. § 29 UmwG (Abfin-
dungsangebot im Verschmelzungsplan).

Gleiches gilt auch für die luxemburgische Schutzvorschrift des Art. 271 Abs. 3 LSC, der im Falle vorhandener Mind-

erheitsgesellschafter die Barabfindung widersprechender Gesellschafter regeln würde.

Anschriften zur Einholung von Auskünften i.S.v. § 122d Satz 2 Nr. 4 UmwG und Art. 262(2) c) LSC:
Red &amp; Black Lux S.à r.l., 282 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, c/o Cédric Pedoni, Séverine Michel und Cornelia

Mettlen.

In Vertretung der Red &amp; Black Lux S.à r.l.
Gezeichnet: Thomas Duong
Ne varietur gezeichnet: F. D. T., T. D. und H. H.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juillet 2013. Relation: LAC/2013/32309. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 13. August 2013.

Référence de publication: 2013117559/875.
(130142285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2013.

Indian Orchid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 9, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 125.234.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2013087717/10.
(130108228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

IMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 152.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2013087711/10.
(130107995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Igorance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 82.162.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013087709/10.
(130108554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

96278

L

U X E M B O U R G

Endurance Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Capellen, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 110.782.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 8 juillet 2013

Le Conseil de Gérance a pris connaissance avec effet immédiat du changement des associés:
- Endurance Finance S.à r.l. enregistrée sous le numéro B113459 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

Luxembourg, personne morale ayant son siège social au 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.

- Endurance Real Estate Management Company S.A. enregistrée sous le numéro B105344 auprès du Registre de Com-

merce et des Sociétés Luxembourg, personne morale ayant son siège social au 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.

Pour
- SIDOTI A.S. enregistrée sous le numéro B12581 auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Prague, personne

morale ayant son siège social au Vaclavske namesti 1601/47110 00 Prague 1, République Tchèque.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013092388/19.
(130113501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

GREP Vier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 134.115.

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013087654/11.
(130108173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Gwenael SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 50.822.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GWENAEL S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2013087659/11.
(130108124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Istanbul Bond Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 114.703.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013087701/10.
(130108870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

96279

L

U X E M B O U R G

Kredietcorp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 14.223.

Le bilan au 31 décembre 2012 de la société KREDIETCORP S.A. a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2013087768/11.
(130108012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

JR Partnership GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 152.919.

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013087741/11.
(130108169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Infigen Energy Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 118.826.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Infigen Energy Finance (Lux) S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2013087718/11.
(130107640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Infra-Invest 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 150.941.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66689 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013087719/10.
(130108718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 24.401.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087720/10.
(130108769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

96280

L

U X E M B O U R G

Lander S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 175.908.

<i>Extrait suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 25 juin 2013 entre:

1. Monsieur Daniel Galhano, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant au 5, rue de Bonnevoie,

L-1260 Luxembourg,

Et
2. La société ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD, société de droit israélien, avec siège

social à 19, Ha'Barzel Street, Tel Aviv, IL-69710 Israel, avec numéro de registre 5-1317339-3.

Il en résulte ce qui suit:
Monsieur Daniel Galhano, demeurant au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-

Grande (Luxembourg), déclare céder à la société ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD,
avec siège social à 19, Ha'Barzel Street, Tel Aviv, IL-69710 Israel, avec numéro de registre 5-1317339-3,

12.500 parts sociales d'une valeur nominale de un euro chacune de la société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois LANDER S.à r.l. établie et ayant son siège social à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.908.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LANDER S.à r.l.

Référence de publication: 2013087804/23.
(130108935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

International Century Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 42.406.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087722/11.
(130108742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.686.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087724/10.
(130108382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 165.583.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087726/10.
(130108882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

96281

L

U X E M B O U R G

Iris Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 113.402.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013087727/10.

(130108943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Jaccar Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.405.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 juin 2013:

Le mandat de commissaire aux comptes et de réviseur d'entreprises d'Ernst &amp; Young, société anonyme, 7, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach, est renouvelé pour une durée d'un an, soit à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera
en 2014 sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 27 juin 2013.

Référence de publication: 2013087734/13.

(130107876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Isolda, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 89.484.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2013087728/11.

(130108490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Isolda, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 89.484.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2013087729/11.

(130108491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

96282

L

U X E M B O U R G

IW Alternativ SIF, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 167.457.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 20 juin 2013 et a renouvelé le mandat de Ernst

&amp; Young, en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2014.

Référence de publication: 2013087731/10.
(130108131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

LuxcoSITQ 1, Société Civile.

Capital social: EUR 130.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.966.

En date du 13 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Rita-Rose Gagné, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13

juin 2013.

- Nomination de Monsieur Tony Roy, né le 12 avril 1969 à Rivière du Loup, au Canada, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 1001, rue Square-Victoria, Montréal, H2Z 2B5, Québec, Canada, en qualité de nouveau gérant de la Société
avec effet au 13 juin 2013 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Gachet, né le 02 août 1956 à Strasbourg, en France, ayant pour adresse

professionnelle le 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de nouveau gérant de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087792/22.
(130108970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

JrJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3788 Tetange, 26, rue du Soleil.

R.C.S. Luxembourg B 50.449.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013087733/10.
(130108999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

J3L International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 99.638.

Le Bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013087743/10.
(130107825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

96283

L

U X E M B O U R G

JPMorgan Specialist Investment Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 158.266.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013087739/10.
(130108620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Jesmond Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 36.850.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013087736/12.
(130108990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Kilcullen Tesla Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.350.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 2 mai 2013

Le Conseil d'Administration décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Philip Denis GRANT, Administrateur,

demeurant au 76, Waterloo Road, IRL - Ballsbridge, Dublin 4, Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2013087763/12.
(130108763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Jod S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 87.418.

Les comptes annuels de l’exercice 2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 01/07/2013.

Mr Marinelli Johnny
<i>Le gérant

Référence de publication: 2013087738/13.
(130109053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

KanAm Grund Espace Pétrusse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.369.

<i>Auszug der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2013

Es wurde beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder um 6 Jahre zu verlängern, bis zur ordentlichen

Generalversammlung die in 2019 stattfinden wird.

96284

L

U X E M B O U R G

Das Mandat des Aufsichtskommissars PKF Abax Audit wurde nicht verlängert. Der neue Aufsichtskommissar ist De-

loitte Audit S. à r. l., eingetragen beim Handelsregister unter der Nummer B67895 mit Gesellschaftssitz in 560, rue de
Neudorf à L-2220 Luxembourg mit einem Mandat von 6 Jahren, bis zur ordentlichen Generalversammlung die in 2019
stattfinden wird.

Luxemburg, den 28. Juni 2013.

<i>Für KanAm Grund Espace Pétrusse S.A.
Irina RASPUTIN

Référence de publication: 2013087746/17.
(130108548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Kauri Cab Arminius, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013087756/10.
(130107937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Liberty Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.211.

La nouvelle adresse de Martinus C.J. Weijermans, gérant B de la Société, est la suivante: 6, Allée St Hubert, L-8138

Bridel, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Liberty Properties S.à r.l.
Exequtive Partners S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013087783/14.
(130108793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Kulczyk Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 126.198.

<i>Extrait de la décision prise par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 28 juin 2013 avec effet

<i>au 1 

<i>er

<i> juillet 2013

Le siège social a été transféré de L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kulczyk Investments S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013087751/15.
(130109089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Kilbroney Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 92.624.

Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

96285

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KILBRONEY FINANCE S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013087760/11.
(130109093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

KJK Fund II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 167.847.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 26 juin 2013

Le mandat de la société Ernst &amp; Young ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatri-

culée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47771 en tant que réviseur d'entreprises
est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme

Référence de publication: 2013087765/13.
(130108271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Labmex International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 112.131.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société adoptées en date du 19 Juin 2013:

- John Broadhurst Mills a démissionné de sa fonction de gérant de classe B avec effet au 19 Juin 2013.
- Laure Paklos, demeurant à 58 rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg a été nommée pour une durée indéterminée

en tant que gérant de classe B avec effet au 19 Juin 2013.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013087803/15.
(130108095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

LuxcoSITQ 2, Société Civile.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.967.

En date du 13 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Rita-Rose Gagné, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13

juin 2013.

- Nomination de Monsieur Tony Roy, né le 12 avril 1969 à Rivière du Loup, au Canada, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 1001, rue Square-Victoria, Montréal, H2Z 2B5, Québec, Canada, en qualité de nouveau gérant de la Société
avec effet au 13 juin 2013 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Gachet, né le 02 août 1956 à Strasbourg, en France, ayant pour adresse

professionnelle le 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de nouveau gérant de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

96286

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 juin 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087793/22.
(130108969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

LuxcoSITQ 3, Société Civile.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.968.

En date du 13 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Rita-Rose Gagné, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13

juin 2013.

- Nomination de Monsieur Tony Roy, né le 12 avril 1969 à Rivière du Loup, au Canada, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 1001, rue Square-Victoria, Montréal, H2Z 2B5, Québec, Canada, en qualité de nouveau gérant de la Société
avec effet au 13 juin 2013 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Gachet, né le 02 août 1956 à Strasbourg, en France, ayant pour adresse

professionnelle le 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de nouveau gérant de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087794/22.
(130108968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

LaSalle UK Ventures Property 9, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 131.872.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013087779/10.
(130107781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

LuxcoSITQ 4, Société Civile.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.969.

En date du 13 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Rita-Rose Gagné, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13

juin 2013.

- Nomination de Monsieur Tony Roy, né le 12 avril 1969 à Rivière du Loup, au Canada, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 1001, rue Square-Victoria, Montréal, H2Z 2B5, Québec, Canada, en qualité de nouveau gérant de la Société
avec effet au 13 juin 2013 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Gachet, né le 02 août 1956 à Strasbourg, en France, ayant pour adresse

professionnelle le 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de nouveau gérant de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

96287

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 juin 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087795/22.
(130108967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

LuxcoSITQ 5, Société Civile.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.970.

<i>Extrait rectificatif concernant la publication du 01/07/2013

Un extrait référencé sous le numéro L130107531 a été déposé le 1 

er

 juillet 2013 en vue de la publication au Mémorial

de l'élection du gérant Tony Roy.

Cet extrait est rectifié comme suit:
La localité concernant l'adresse de Monsieur Tony Roy est Montréal au lieu de Québec.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087796/17.
(130109112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Threadneedle Strategic Property Fund IV Luxembourg SA SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme

d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 146.228.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 04 juin 2013 a décidé:
a) de renouveler le mandat de:
Monsieur Richard PROSSER
13-14 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1 1BD, Channel Islands
Monsieur Arnold SPRUIT
15a, rue Langheck, L-5410 BEYREN
Monsieur Prosper VAN ZANTEN
Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas
Monsieur John WILLCOCK
Station Road, Swindon SN1 1HH, Royaume-Uni
en leur qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2014.

b) de renouveler le mandat de:
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l.
400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2014.

<i>Pour THREADNEEDLE STRATEGIC PROPERTY FUND IV LUXEMBOURG S.A. SICAV-SIF
Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2013088146/29.
(130109069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

96288


Document Outline

Astralis S.A.

Build Group Co. S.A.

Cloisinvest S.A.

Dexia Prime Advanced

Endurance Asset S.à r.l.

Estates S.A.

GREP Vier S.à r.l.

Gwenael SA

Igorance S.à r.l.

IMI S.A.

Indian Orchid S.à r.l.

Infigen Energy Finance (Lux) S.à r.l.

Infra-Invest 2

ING (L) Patrimonial

Intellicast

International Century Corporation S.A., SPF

Intersaco S.A.

INVESCO European Hotel Real Estate S.à r.l.

IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à r.l.

Iris Consulting S.A.

Isolda

Isolda

ista Holdco 1 S.A.

Istanbul Bond Company S.A.

IVG Luxembourg S.à r.l.

IW Alternativ SIF

J3L International S.A.

Jaccar Holdings

Jesmond Benelux S.A.

Jod S.à r.l.

JPMorgan Specialist Investment Funds

JrJ S.A.

JR Partnership GP S.à r.l.

KanAm Grund Espace Pétrusse S.A.

Kauri Cab Arminius

Kilbroney Finance S.A.

Kilcullen Tesla Holding S.A.

KJK Fund II

Kredietcorp S.A.

Kulczyk Investments S.A.

Labmex International S.à r.l.

Lander S.à r.l.

LaSalle UK Ventures Property 9

Liberty Properties S.à r.l.

LuxcoSITQ 1

LuxcoSITQ 2

LuxcoSITQ 3

LuxcoSITQ 4

LuxcoSITQ 5

NSS Latin America Holdings

Pioneer Funds

Red &amp; Black Lux S.àr.l.

Royale Neuve VII S.à r.l.

SADMI (Luxembourg) S.A.

SES Astra Services Europe S.A.

SES Participations

Smalt

SOLKARST INTERNATIONAL Spf S.A.

Swiss-German High Yield Bond Fund

Threadneedle Strategic Property Fund IV Luxembourg SA SICAV-SIF