logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1995

17 août 2013

SOMMAIRE

AA - Iberian Venture Capital Invest S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95751

ACM RE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95743

AC Nordic Management S.à r.l.  . . . . . . . . .

95752

Adeo Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

95755

Alfred  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95748

All Consulting Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

95753

Almacantar Shaftesbury S.à r.l. . . . . . . . . . .

95716

Anchorage Venture Lab S.A.  . . . . . . . . . . . .

95751

a-part s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95748

Argos Soditic Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . .

95752

Benetton International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

95756

BHR Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

95746

Bluegreen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95751

CEREP AIR 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95754

CEREP Ambroise S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

95754

CEREP Bac S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95759

CEREP Bellini 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95757

CEREP Bellini 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95757

CEREP Benelux Students S.à r.l. . . . . . . . . .

95758

Challenger Reassurance  . . . . . . . . . . . . . . . .

95759

Cilaos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95744

Cole Objekt Kistlerhofstrasse GmbH  . . . .

95750

COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95759

Compagnie Générale de Promotion S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95753

Crismagand, société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95758

Cyclone International Holdings Branch  . .

95752

Degato International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

95745

dfl Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95746

Digital Realty (St Denis) S.à r.l. . . . . . . . . . .

95750

Divine Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

95749

Dylux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95749

Glasswall Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

95744

M Group Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

95755

Natixis-Cape S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95756

Professional Care Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

95714

Professional Classic Ballet School . . . . . . . .

95747

Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF  . . .

95714

Regulus Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

95760

RN S.C.A. SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95714

S&B Minerals Participations S.A.  . . . . . . . .

95723

Schenkenberg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95716

Schleich Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

95760

SC Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95716

SC Luxembourg Investments S.à r.l.  . . . . .

95748

SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF  . . . . . . . . . .

95714

Tasselot S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95742

TCC Investments Luxembourg S.à r.l.  . . .

95744

The Bank of New York Mellon (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95750

Thomson Reuters Finance S.A.  . . . . . . . . . .

95743

Tierra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95715

Tiledrasi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95743

Timaru S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95745

Tornio Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

95741

Trilantic Events Management S.à r.l. . . . . .

95715

UBS Third Party Management Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95744

Unibeton Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

95746

Verone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95742

VH Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95745

VIII F Chateau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95747

Zwickau Arcaden Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . .

95747

95713

L

U X E M B O U R G

Professional Care Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 176.191.

EXTRAIT

Il résulte des contrats de transferts signés le 17 mai 2013 que l'associé unique, Professional Care Invest Sàrl, a transféré:
- 500,000 parts sociales de la Société, à Caphicon Management GmbH, société de droit allemand, avec siège sociale à

Mitterfeld 30, 82024 Taufkirchen, Allemagne;

- 200,000 parts sociales de la Société, à Paletoni Management GmbH i.G., société de droit allemand, avec siège sociale

à Schnablstr. 2, 81247 Munich, Allemagne.

Par conséquent, à compter du 17 mai 2013, les 10,000,000 parts sociales de la Société, sont détenues de la manière

suivante:

Professional Care Invest S.à r.l. - 9,300,000 parts sociales
Caphicon Management GmbH - 500,000 parts sociales
Paletoni Managment GmbH i.G. - 200,000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013086863/20.
(130107603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 138.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2013086895/12.
(130107456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

RN S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 153.952.

Société en Commandite par Actions constituée le 1 

er

 juin 2010 suivant publication au mémorial n° 1409 du 09 juillet

2010.

Les comptes annuels sociaux de RN S.C.A. SICAR, arrêtés au 31 décembre 2012 et dûment approuvés lors de l’As-

semblée Générale des Actionnaires en date du 25 juin 2013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

RN S.C.A. SICAR

Référence de publication: 2013086918/16.
(130107203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 164.951.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung 19. Juni 2013

Am 19. Juni 2013 um 11 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

95714

L

U X E M B O U R G

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Die Versammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. für die Prüfung des Ge-

schäftsjahres 2013 zu bestellen.

Luxemburg, den 27. Juni 2013.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2013087005/16.
(130106611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Tierra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 86.219.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire

Lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TIERRA

SA, ayant son siège social à L-1636, Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
section B, sous le numéro B86 219 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> résolution:

L'assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission de Maître Isabelle WELSCHEN, née le 21 août 1977 à Mont

Saint Martin (France) et demeurant professionnellement au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg de son poste
d'administrateur.

<i>2 

<i>ème

<i> résolution:

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en son remplacement Me Lex THIELEN, né le 21 juillet 1962 à Luxem-

bourg et demeurant au 15, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, administrateur de la société jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société

Référence de publication: 2013088177/21.
(130108594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Trilantic Events Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.642,80.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 138.170.

<i>Extrait des résolutions écrites prises en date du 1 

<i>er

<i> juillet 2013

Les associés ont décidé d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 janvier

2014 qui se tiendra en 2014, le conseil de gérance et le réviseur d'entreprises comme suit:

<i>Conseil de gérance

MM Laurent Forget, demeurant au 26 Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, gérant de catégorie B;
Joe Cohen, demeurant au 35 Portman Square, GB - W1H 6LR Londres, gérant de catégorie B;
Michaël Madar, au 35 Portman Square, GB - W1H 6LR Londres, gérant de catégorie B;
Eric Scussel, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, gérant de catégorie A;
Riccardo Zorzetto, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, gérant de catégorie A.

<i>Réviseur d'entreprises

Grant Thornton Lux Audit SA, 83, Pafebruch L-8308 Capellen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Trilantic Events Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2013088152/23.
(130108730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

95715

L

U X E M B O U R G

SC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.052.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088106/10.
(130108639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Schenkenberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 89.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013088107/10.
(130108674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Almacantar Shaftesbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 178.446.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of the month of June.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

ALMACANTAR, a Luxembourg public company limited by shares ("société anonyme") incorporated in Luxembourg,

registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B149157, with its registered office
at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,

here represented by M 

e

 Julie GORDET, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société á responsabilité limitée, the articles

of incorporation of which it has established as follows:

Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become

members in the future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as well
as by the present articles of incorporation (the "Company").

Art. 2. The object of the Company consists in the use of its funds to invest in real estate and immovable property as

well as in the establishment, management, development and disposal of its assets as they may be composed from time to
time.

The object of the Company is also to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and
development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of wha-

tever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the
Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guarantee.

The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims
or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached

95716

L

U X E M B O U R G

to these securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the
companies and/or enterprises in which it holds a participation or which are members of its group, in particular by granting
loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them
any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (iv) make deposits at banks or with
other depositaries and invest it in any other manner; and (v) in order to raise funds which it needs to carry out its activity
within the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in
which  it  holds  a  participation  or  which  is  part  of  its  group,  to  issue  debt  instruments  in  any  form  whatsoever.  The
enumeration above is enunciative and not restrictive.

The Company may issue any type of preferred equity certificates.
The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,

financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and deve-
lopment of its objects.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of "Almacantar Shaftesbury S.à r.l.".

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers (the "Board").

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the sole manager or of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary developments (such as political or military developments)

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. - Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twenty-five thousand British pounds (GBP 25,000.-), represented by twenty-

five thousand (25,000) shares of a par value of one British pound (GBP 1each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the member(s) adopted in the manner

required for amendment of these articles of incorporation.

The Company will recognise only one holder in respect of a share. In case of joint ownership, the Company may

suspend the exercise of any right related thereto until one person has been designated to represent the joint owners
towards the Company.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance

or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are

transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing three quarters of the capital.
In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of
the owners of shares representing three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of article 189 of the Luxembourg law dated 10 August 1915

on commercial companies, as amended (the "1915 Law") the value of a share is based on the last three balance sheets of
the Company and, in case the company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet
of the last year or of those of the last two years.

Title III. - Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member

or, as the case may be, the members. The managers constitute the Board.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate

instruments  in  writing  or  by  telegram,  telex,  electronic  mail  or  telefax  confirmed  in  writing  which  shall  all  together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a

proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

95717

L

U X E M B O U R G

Resolutions shall require a majority vote but in case of equality of votes, the chairman of the Board, if any, shall have

a casting vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a conference call, a video conference
or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The Board meeting
held by such means of communication is considered as having been held at the registered office of the Company.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the repre-

sentation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the signature of the sole manager or, in
case of several managers, by the joint signature of any two managers.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the 1915 Law.
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by

them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their
mandate.

Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the 1915 Law on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the

members.

Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar

means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. At least one member (or his
proxyholder) is physically present at the registered office of the Company. The meeting held by such means of commu-
nication is considered as having been held at the registered office of the Company.

Any amendments of the articles of incorporation shall be resolved by the sole member or by a general meeting of

members at the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.

Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. At the end of each financial year, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,

as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until
such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one.
However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Title VI. - Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

The dissolution of the Company shall be resolved by the sole member or by a general meeting of members at the

same majority requirements applying to an amendment of the articles of incorporation and the liquidation shall be carried
out by the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a
general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of
the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII. - General provisions

Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company.
For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, it shall be referred to the 1915 Law.

95718

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

The twenty-five thousand (25,000) shares representing the entire share capital of the Company have been subscribed

by Almacantar, prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twenty-five thousand British pounds (GBP 25,000.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2013.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred fifty euro.

The corporate capital is valued at EUR 29,470.40-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Pierre MARTINET, born on 2 December 1949 in Algiers, Algeria, with professional address at 3, rue de Saint-

Léger, CH-1205 Geneva, Switzerland;

- Mr. Mike HUSSEY, born on 4 October 1965 in Wanstead, London, United Kingdom, with professional address at 3,

Quebec Mews, GB-W1H 7NX London, United Kingdom;

- Mr. Jonathan PAUL, born on 21 July 1967 in Exeter, United Kingdom, with professional address at 3, Quebec Mews,

GB-W1H 7NX London, United Kingdom; and

- Mr. Aidan FOLEY, born on 8 December 1976 in Port Lairge (Waterford), Ireland, with professional address at L-1130

Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

2) The Company shall have its registered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer's proxyholder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour du mois de juin.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Almacantar, une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B.149157, ayant son siège social à 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg,

ici représentée par Maître Julie GORDET, Avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts (la «Société»).

Art. 2. L'objet de la Société consiste en l'utilisation de ses fonds en investissement immobilier et de propriété immo-

bilière, ainsi que l'établissement, la gestion, le développement et la cession de ses actifs suivant leur composition au fil du
temps. L'objet de la Société est aussi d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

95719

L

U X E M B O U R G

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets

de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société
détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.

La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous

titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance
et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant
des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé
quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers; (iii) accorder
toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle participe
ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de garanties
sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce
soit  comprenant  des  services  de  trésorerie  pour  le  groupe;  (iv)  faire  des  dépôts  auprès  de  banques  ou  tous  autres
dépositaires et les placer de toute autre manière; et (v) en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin
pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit,
accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe,
émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit. L'énumération précitée est énonciative et non limitative.

La Société peut procéder à l'émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplis-
sement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société prend la dénomination de «Almacantar Shaftesbury S.à r.l.».

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance (le «Conseil»).

II peut être créé par simple décision du gérant ou du Conseil, des succursales, filiales ou bureaux (autres que le siège

statutaire de la Société) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil estime que des évènements extraordinaires (tels que des évènements d'ordre politique ou militaire)

de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger
se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000)

parts sociales d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associé(s) adopté suivant la manière

requise pour modifier les statuts.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si la propriété de la part sociale est indivise, la Société

pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée
pour représenter les indivisaires à l'égard de la Société.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant les trois quarts du capital
social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l'article 189 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle que modifiée

95720

L

U X E M B O U R G

(la «Loi de 1915»). Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de
ceux des deux dernières années.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués, ad nutum, par l'associé unique

ou, selon le cas, les associés. Les gérants constitueront le Conseil.

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou

plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui consti-
tueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration,

qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix mais en cas d'égalité de voix, la voix du président du conseil,

le cas échéant, sera prépondérante. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à
plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera consi-
dérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Une réunion du Conseil tenue par ces moyens sera
considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la

Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, en
cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de

la Loi de 1915.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la Loi de 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par les

associés.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Un ou plusieurs associés peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la
réunion. Au moins un associé (ou son mandataire) devra être présent au siège de la Société. Une réunion tenue par ces
moyens sera considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

Toutes modifications des statuts seront décidées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la Loi de 1915.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. A la fin de chaque année sociale, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan

et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

95721

L

U X E M B O U R G

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique ou par l'assemblée des associés délibérant aux mêmes

conditions de majorité que celles exigées pour la modification des statuts et la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en
fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée
des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du
passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il y a lieu de s'en référer à la Loi de 1915.

<i>Souscription et Libération

Les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales représentant l'entièreté du capital social de la Société ont été souscrites

par Almacantar, prénommée.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000,-)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cent cinquante euros.

Le capital social est évalué à 29.470,40- EUR

<i>Résolutions de l'associé unique

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pierre MARTINET, né le 2 décembre 1949 à Algiers, Algérie, avec adresse professionnelle au 3, rue de

Saint-Léger, CH-1205 Genève, Suisse;

- Monsieur Mike HUSSEY, né le 4 octobre 1965 à Wanstead, Londres, Royaume Uni, avec adresse professionnelle au

3, Quebec Mews, GB-W1H 7NX Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Jonathan PAUL, né le 21 juillet 1967 à Exeter, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 3, Quebec

Mews, GB-W1H 7NX Londres, Royaume-Uni; et

- Monsieur Aidan FOLEY, né le 8 décembre 1976 à Port Lairge (Waterford), Irlande, avec adresse professionnelle à

L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la comparante le présent

acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: Julie GORDET, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 02 juillet 2013. Relation GRE/2013/2702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 5 juillet 2013.

Référence de publication: 2013091213/358.
(130112218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2013.

95722

L

U X E M B O U R G

S&amp;B Minerals Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 178.491.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of June.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri

Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

S&amp;B Minerals Finance S.C.A., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

duly represented by Mr. Jan Dobrzensky, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by

virtue of a proxy given on 26 June 2013 in Luxembourg.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain

attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société anonyme, which

it wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "S&amp;B Minerals Participations S.A." (the
"Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds,

by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

directors.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

95723

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1. Issued share capital
5.1.1. The Company's issued share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), consisting of two million

nine hundred forty-five thousand (2,945,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one hundred fifty-five thousand
(155,000) non-voting preferred shares (the "Preferred Shares"), all having a par value of one cent of a euro (EUR 0.01)
each.

5.1.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.1.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of

plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them  in  the  Company's  share  capital.  The  board  of  directors  shall  determine  the  period  of  time  during  which  such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject to the
terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an increase
of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorisation to be granted to the board of directors to increase
the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder
(s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.

5.1.4. Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into Ordinary Shares and Preferred Shares, each of them having the same

par value.

6.2. The Ordinary Shares and the Preferred Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall

rank pari passu in all respects save, as hereinafter specifically provided.

6.3. The Company may have one or several shareholders.
6.4. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares of such

class held by him/her/it in the Company's share capital.

6.5. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.6. The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.
6.7. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only

be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

6.8. The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by the Law of 10 August 1915

governing commercial companies, as amended (the "Law") and these articles of association, on the basis of amounts
available for distribution, repurchase or redeem its shares against payment in cash or in kind. However, the redemption
of Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the Preferred Shares.

6.9. The Ordinary Shares
6.9.1. All Ordinary Shares will be identical in all respects.
6.9.2. Dividends
All Ordinary Shares will share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way

of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Ordinary Shares in accordance with articles 25 and 26 of
these articles of association.

6.9.3. Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Ordinary Share entitles the holder thereof to liquidation proceeds attached

to the Ordinary Shares in accordance with article 27 of these articles of association.

6.9.4. Voting Rights
Each Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right

to vote.

6.10. The Preferred Shares
6.10.1. All Preferred Shares will be identical in all respects.
6.10.2. Dividends

95724

L

U X E M B O U R G

All Preferred Shares will share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way

of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Preferred Shares in accordance with articles 25 and 26 of
these articles of association.

6.10.3. Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Ordinary Share entitles the holder thereof to liquidation proceeds attached

to the Ordinary Shares in accordance with article 27 of these articles of association.

6.10.4. Voting Rights
The Preferred Shares are non-voting preferred shares in accordance with articles 44 to 47 of the Law. They will entitle

the holder thereof to one vote on all specific matters upon which holders of non-voting preferred shares have the right
to vote in accordance with article 46 of the Law and article 11.5.2 of these articles of association.

Art. 7. Register of shares.
7.1. A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by

any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or
registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on
the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares.

Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its
members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3. The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law.
8.4. Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording

of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their
representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant
to which any director may record such transfer in the register of shares.

8.5. The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General Meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2. For the avoidance of doubt, holders of Preferred Shares will only be authorized to vote, and the general meeting

of shareholders will then be composed of holders of Ordinary Shares and holders of Preferred Shares, in respect of the
resolutions contained in article 46 of the Law, as listed below under article 11.5.2 of these articles of association.

9.3. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

9.4. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or

by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice
of such meeting.The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory
auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors
or to the statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of
the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of
directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request
at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

95725

L

U X E M B O U R G

10.3. An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered

office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the third Thursday of May
at 2:00 pm. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following
business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general
meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.4. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.5. One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued

share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date
scheduled for the meeting.

10.6. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Law must be sent or notified to the holders

of Ordinary Shares shall likewise be sent or notified to the holders of Preferred Shares.

11.4. Quorum
No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise

required by law or by these articles of association. In case a holder of Preferred Shares is also a holder of Ordinary Shares,
it counts as one shareholder for the quorum requirements set forth by Law.

11.5. Vote
11.5.1. Each Ordinary Share entitles its holder to one (1) vote, subject to the provisions of the Law.
11.5.2. The Preferred Shares are non-voting preferred shares in accordance with articles 44 to 47 of the Law. Each

Preferred Share entitles its holder to one (1) vote, to the extent required pursuant to article 46 of the Law. In particular
Preferred Shares do not carry any voting rights, except, in accordance with article 46 of the Law, where the holders of
Preferred Shares are entitled to vote in any general meeting of shareholders called upon to deal with the following matters:

i. the issue of new shares carrying preferential rights;
ii. the determination of the preferential cumulative dividend attached to any class of Preferred Shares;
iii. the conversion of one or more Preferred Shares into Ordinary Shares;
iv. the reduction of the share capital of the Company;
v. any change to the Company's corporate object;
vi. the issue of convertible bonds;
vii. the dissolution of the Company before its term; and
viii. the transformation of the Company into a company of another legal form.
11.5.3. Holders of Preferred Shares shall recover the same voting rights as the holders of Ordinary Shares at all general

meetings of shareholders, in case, despite the existence of profits available for that purpose, the Preferred Shares Dividend
(as defined in Article 25.5 below) has not been paid in its entirety for any reason whatsoever for a period of two successive
financial years.

11.5.4. Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital
represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.6. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.7. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

95726

L

U X E M B O U R G

11.8. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.9. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them

to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-
thirds  of  the  votes  validly  cast  at  a  meeting  where  at  least  half  of  the  Company's  issued  share  capital  is  present  or
represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly
cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes
will not be taken into account.

Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the law, the board of

directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened
in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The board of directors must adjourn
any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in
the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general
meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.
14.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
14.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two
of its members or by the sole director, as the case may be.

D. Management

Art. 15. Powers of the board of directors.
15.1. The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company. The

Company may have several classes of directors.

15.2. If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may

be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that several
shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be
construed as a reference to the "sole director".

15.3. The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the

Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the
general meeting of shareholders.

15.4. In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation

in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to
any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be deter-
mined by a resolution of the board of directors.

15.5. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone

or jointly with others as agent of the Company.

Art. 16. Composition of the board of directors.
16.1. The board of directors is composed of at least three (3) members, without prejudice to article 15.2 of these

articles of association.

16.2. The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also

choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Art. 17. Election and Removal of directors and Term of the office.
17.1. Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

95727

L

U X E M B O U R G

17.2. If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent

representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

17.3. Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders.

17.4. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/

her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 18. Vacancy in the office of a director.
18.1. If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until
the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

18.2. If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three

(3) or below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled
without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board
members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

18.3. In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 19. Convening meetings of the board of directors.
19.1. The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

19.2. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of
the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in
writing pursuant to these articles of association.

Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors.
20.1. The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence,

the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

20.2. Quorum
20.3. The board of directors can act and deliberate validly only if (i) at least half of its members (ii) including one class

A director and one class B director, are present or represented at a meeting of the board of directors.

20.4. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the

board of directors, including at least one class a director and one class b director. The chairman shall not have a casting
vote.

20.5. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

20.6. Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office. Except in cases of emergency where directors
may participate in a meeting held by means of such communication regardless of the country from which they participate,
a meeting of the board of directors may only be held by such means of communication if less than half of the directors
who participate in such meeting are physically present in a single country (other than Luxembourg) at the time of the
meeting.

20.7. The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.Save as otherwise provided by law,

95728

L

U X E M B O U R G

any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board
of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest
and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take
part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported
to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has
a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between
the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be dis-
closed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 21. Minutes of meetings of the board of directors.
21.1. The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the

board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

21.2. The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
21.3. Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director,
as the case may be.

Art. 22. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of one (1) class A director and one (1) class B director or by the joint signatures or by the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors or by the sole director. Within
the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s)
to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or jointly in
accordance with the rules of such delegation.

E. Supervision

Art. 23. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
23.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not.
23.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory
auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

23.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

23.4. In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half,

the board of directors must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/
vacancies.

23.5. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

23.6. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

23.7. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

23.8. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, there shall be no requirement to appoint statutory auditor
(s).

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 25. Profits.
25.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal

reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

25.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

25.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

95729

L

U X E M B O U R G

25.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

25.5. Each financial year, out of the net profits after allocation to the legal reserve (the "Available Profits"), each holder

of Preferred Shares is entitled to a dividend per Preferred Share of 8% per annum of: (a) the par value of each Preferred
Shares plus (b) the amount of the Preferred Shares Premium Account, as defined under article 26.3 below, divided by the
number of Preferred Shares in issue (the "Preferred Shares Dividend").

25.6. The Preferred Shares Dividend is cumulative and recoverable, which means that the holders of Preferred Shares

shall, during posterior financial years, recover the Preferred Shares Dividend that they could not receive during the
foregoing financial years during which there was no realized nor distributed Available Profits. The recovery of the Pre-
ferred Shares Dividend is not limited in time. However, the Preferred Shares do not give right to an additional payment
of an ordinary dividend.

25.7. As applicable and should the Available Profits be sufficient to distribute the Preferred Shares Dividend, in whole

or in part, and the general meeting of shareholders takes no distribution resolution with respect to the Preferred Shares
Dividend, then the aggregate amount of the Preferred Shares Dividend that should have been distributed to the holders
of the Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Preferred Shares reserve
account (the "Preferred Shares Reserve Account").

25.8. After distribution or allocation of the Preferred Shares Dividend, as applicable, the remainder of the Available

Profits (that is, the Available Profits less the Preferred Shares Dividend) (the "Remaining Profits") may be distributed to
the holders of the Ordinary Shares. The Remaining Profits shall be allocated by the General Meeting, resolving to distribute
them proportionally to the holders of Ordinary Shares, to carry them forward, or to transfer them to a distributable
reserve. Each holder of Ordinary Share(s) is entitled to a fraction of the Remaining Profits distributed to all of the Ordinary
Shares in proportion to the total Ordinary Share(s) it holds in the Company.

Art. 26. Interim dividends - Share premium.
26.1. Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim

dividends.

26.2. The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of

the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and
in accordance with these articles of association.

26.3. Any share premium paid on the Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Shares premium account (the

"Ordinary Shares Premium Account"), and the Company shall book in such account, in the currency in which they are
effectively paid, the amount or value of any premium paid on the Ordinary Shares, any additional capital surplus contributed
by the holders of Ordinary Shares to the Company, and of any amount allocated to such Ordinary Shares Premium
Account in accordance with these articles of association.

26.4. Any share premium paid on Preferred Shares shall be booked in a Preferred Shares share premium account (the

"Preferred Shares Premium Account"), and the Company shall book in such account, in the currency in which they are
effectively paid, the amount or value of any premium paid on the Preferred Shares, any additional capital surplus contri-
buted by the holders of Preferred Shares to the Company, and of any amount allocated to such Preferred Shares Premium
Account in accordance with these articles of association.

26.5. The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of

the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and
in accordance with these articles of association.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation.
27.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution
which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

27.2 After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, each

holder of Preferred Shares will have a preferential right to payment.

27.3 If the Company cannot pay such amounts in full to all the holders of Preferred Shares, payment will be made on

a pro rata basis to each holder of Preferred Shares.

27.4 After payment of all debts and liabilities of the Company (including all shareholders' advances (if any)) and after

the payment of any amount due to the holders of Preferred Shares, under this article or deposit of any funds to that
effect, the surplus will be paid to the holders of Ordinary Shares in proportion to the number of Ordinary Shares held
by the relevant holders in the Company. The holders of Preferred Shares shall, in any case, be paid prior to the holders
of Ordinary Shares.

95730

L

U X E M B O U R G

H. Governing law

Art. 28. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
Law.

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31

December 2013.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2014.
3) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
S&amp;B Minerals Finance S.C.A., aforementioned,
paid  thirty-one  thousand  euro  (EUR  31,000)  in  subscription  for  two  million  nine  hundred  forty-five  thousand

(2,945,000) Ordinary Shares and one hundred fifty-five thousand (155,000) Preferred Shares. Total: thirty-one thousand
euro (EUR 31,000) paid for three million one hundred thousand (3,100,000) shares.

All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is as

of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in article 26,

26-3 ad 26-5 of the Law and expressly states that they have all been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the Company's entire issued share capital has passed the following re-

solutions by unanimous vote.

1) The number of members of the board of directors is fixed at four (4).
2) The following persons are appointed as members of the board of directors of the Company:
a) Mr. Kriton Leonidas Anavlavis, born on 30 July 1962 in Istanbul, Turkey, having his professional address at 15A

Andrea Metaxa Street, 14564 Kifisia, Athens, Greece, acting as class A director of the Company;

b) Mr. loannis Christodoulakis, born on 21 September 1954 in Karpathos, Greece, having his professional address at

15A Andrea Metaxa Street, 14564 Kifisia, Athens, Greece, acting as class A director of the Company;

c) Mr. Jacques de Patoul, born on 10 January 1980 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having his professional

address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as class B director of the
Company; and

d) Ms. Virginia Strelen, born on 30 May 1977 in Bergisch-Gladbach, Germany, with professional address at 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as class B director of the Company;

3) The following entity is appointed as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company:
Ernst &amp; Young S.A., RCS: B47771, 7 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach
4) The term of the office of the members of the board of directors and of the independent auditor shall end on the

date when the general meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, shall resolve upon the approval of
the Company's accounts of the financial year 2013 or at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/
sole shareholder, as the case may be, may determine.

5) The address of the Company's registered office is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

95731

L

U X E M B O U R G

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtundzwanzigsten Juni.
Vor der unterzeichneten Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung von Maître

Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

S&amp;B Minerals Finance S.C.A., eine gemäß dem Luxemburger Recht gegründete und existente Gesellschaft mit einge-

tragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, noch nicht im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register eingetragen,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Jan Dobrzensky, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, kraft einer am 26. Juni 2013 in Luxemburg erteilten Vollmacht.

Besagte Vollmacht, nachdem sie durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet

worden ist, wird dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société anonyme aufzunehmen, welche

sie gründen möchte und deren Satzung folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Aktien und/oder jeder anderen Person, die

künftig Aktionär sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société anonyme unter der Firma "S&amp;B Minerals Participations
S.A." (die "Gesellschaft").

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine
Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Verwaltungsratsmitglieds oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder
eines Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches
sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewäh-
ren; und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3.  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Transaktionen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  ihrem  Zweck  dienen.

Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats

verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in jede andere Gemeinde des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Verwaltungsrats errichtet werden.

95732

L

U X E M B O U R G

B. Aktienkapital - Aktien - Aktienverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Aktien

Art. 5. Aktienkapital.
5.1. Ausgegebenes Aktienkapital
5.1.1. Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) bestehend aus

zwei Millionen neunhundertfünfundvierzigtausend (2.945.000) Stammaktien (die „Stammaktien") und einhundertfünfund-
fünfzigtausend (155.000) stimmrechtslosen Vorzugsaktien (die „Vorzugsaktien"), alle mit einem Nominalwert von einem
Eurocent (EUR 0,01) pro Aktie.

5.1.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss

der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser
Satzung erforderlich ist.

5.1.3. Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden Aktionären/dem beste-

henden Aktionär zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden solche Aktien den Aktionären im
Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Aktienkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwal-
tungsrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Aktienbezugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser
Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Aktionäre/den Aktionär ge-
sendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen
kann jedoch die Hauptversammlung der Aktionäre, welche einberufen wurde, um (i) entweder über eine Erhöhung des
Aktienkapitals der Gesellschaft (ii) oder über die dem Verwaltungsrat zu erteilende Ermächtigung, das ausgegebene Ak-
tienkapital der Gesellschaft zu erhöhen, zu bestimmen, das bevorzugte Aktienbezugsrecht der bestehenden Aktionäre/
des bestehenden Aktionärs begrenzen oder aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun. Ein solcher
Beschluss muss in der Weise gefasst werden wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.1.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Aktienkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Haupt-

versammlung  herabgesetzt  werden,  welcher  in  der  Weise  gefasst  wird  wie  es  für  eine  Änderung  dieser  Satzung
erforderlich ist.

Art. 6. Aktien.
6.1. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist in Stamm- und Vorzugsaktien mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Stammaktien und die Vorzugsaktien bilden jeweils separate Aktienklassen in der Gesellschaft, sind aber in

jeder Hinsicht pari passu einzuordnen, sofern nachstehend nicht anders vorgesehen.

6.3. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4. Das Recht eines Aktionärs auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Aktienkapital der Gesellschaft gehaltenen Aktien einer solchen Klasse.

6.5. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Aktionär, falls anwendbar, oder jeden anderen Aktionär soll die Gesellschaft nicht aufgelöst werden.

6.6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.
6.7. Bruchteilsaktien sollen auf einer anteilsmäßigen Basis dieselben Rechte gewähren wie ganze Aktien, wobei aufgrund

von Aktien nur dann Stimmrechte ausgeübt werden können, wenn die Anzahl der Bruchteilsaktien in eine oder mehrere
Aktien zusammengefasst werden können. Falls Bruchteilsaktien bestehen, welche nicht zu einer Aktie zusammengefasst
werden können, können aufgrund solcher Bruchteilsaktien keine Stimmrechte ausgeübt werden.

6.8. Die Gesellschaft kann, im Rahmen von und gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, in der geänderten Fassung (das „Gesetz") und der vorliegenden Satzung, auf Basis der für eine
Ausschüttung verfügbaren Beträge, Aktien gegen Zahlung in bar oder in Natur zurückkaufen oder zurücknehmen. Die
Rücknahme von Stammaktien unterliegt jedoch einer vorherigen Rücknahme aller Vorzugsaktien.

6.9. Die Stammaktien
6.9.1. Alle Stammaktien sind in jeder Hinsicht identisch.
6.9.2. Dividenden
Alle Stammaktien sind im gleichen anteiligen Ausmaß an einer Dividendenausschüttung oder an jeglicher Ausschüttung

von Vermögen in einer anderen Form als durch Dividenden, welche insgesamt solchen Stammaktien in Übereinstimmung
mit den Artikeln 25 und 26 dieser Satzung zugeteilt werden, beteiligt.

6.9.3. Rechte im Fall einer Liquidation
Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt jede Stammaktie deren Inhaber zu dem den Stammaktien zuge-

hörigen Liquidationserlös gemäß Artikel 27 dieser Satzung.

6.9.4. Stimmrechte
Jede Stammaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme bei Abstimmungen über sämtliche den Aktieninhabern

vorbehaltenen Angelegenheiten. 6.10 Die Vorzugsaktien

6.10.1. Alle Vorzugsaktien sind in jeder Hinsicht identisch.
6.10.2. Dividenden

95733

L

U X E M B O U R G

Alle Vorzugsaktien sind im gleichen anteiligen Ausmaß an einer Dividendenausschüttung oder an jeglicher Ausschüttung

von Vermögen in einer anderen Form als durch Dividenden, welche insgesamt solchen Vorzugsaktien in Übereinstimmung
mit den Artikeln 25 und 26 dieser Satzung zugeteilt werden, beteiligt.

6.10.3. Rechte im Fall einer Liquidation
Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt jede Vorzugsaktie deren Inhaber zu dem den Vorzugsaktien

zugehörigen Liquidationserlös gemäß Artikel 27 dieser Satzung.

6.10.4. Stimmrechte
Die Vorzugsaktien sind stimmrechtlose Vorzugsaktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 bis 47 des Gesetzes.

Jede Vorzugsaktie berechtigt ihren Inhaber zu einer Stimme bei Abstimmungen über sämtliche den Vorzugsaktieninhabern
vorbehaltenen Angelegenheiten gemäß Artikel 46 des Gesetzes und Artikel 11.5.2. dieser vorliegenden Satzung.

Art. 7. Aktienverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Aktionär ein-

gesehen werden kann. Dieses Aktienverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder
eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Aktionär gehaltenen Aktien, die Angabe der auf diese Aktien
geleisteten Zahlungen, jede Übertragung von Aktien und deren Datum gemäß Artikel 8.4 dieser Satzung sowie jedes über
Aktien gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Aktionär wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen.

Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Aktionärs berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Aktien.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Aktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienverzeichnis erbracht

werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Aktionärs werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles
vom Präsidenten des Verwaltungsrats, von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Geschäfts-
führer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört, müssen

sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer der Aktie angesehen
werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einer im Eigentum mehrerer Personen stehenden
Aktie verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.

8.3. Die Aktien sind unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen frei übertragbar.
8.4. Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten entweder durch die Eintragung einer

vom Zedenten und vom Zessionar oder von deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung
ins Aktienverzeichnis oder durch Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung, gemäß derer jedes beliebige Verwaltungsratsmitglied die Übertragung in das Aktienverzeichnis eintragen
kann, wirksam.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jedes einzelne ihrer Verwaltungsratsmitglieder auch einer solchen Übertragung zu-

stimmen und diese ins Aktienverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1. Die Aktionäre üben ihre kollektiven Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2. Hiermit sei klargestellt, dass Vorzugsaktieninhaber nur hinsichtlich der in Artikel 46 des Gesetzes aufgezählten

Beschlüsse, wie sie in Artikel 11.5.2. der vorliegenden Gesellschaftssatzung aufgelistet sind, berechtigt sind abzustimmen,
und die Hauptversammlung der Aktionäre ist in diesem Fall aus Stammaktieninhabern und Vorzugsaktieninhabern zu-
sammengesetzt,.

9.3. Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre

aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich in dieser Satzung
erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die "Hauptversammlung der Aktionäre" als Verweis auf den
„alleinigen Aktionär" gelesen werden.

9.4. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen

Befugnisse.

Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsrat oder den/

die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird. Auf schriftliches, die Tagesordnung enthaltendes und an den Verwaltungsrat
oder den/die satzungsmäßigen Buchprüfer gerichtetes Ersuchen eines oder mehrerer Aktionäre, die zusammen zumindest
10 Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals repräsentieren, muss die Hauptversammlung der Aktionäre je nach
Lage des Falles vom Verwaltungsrat oder von dem/den satzungsmäßigen Buchprüfer(n), falls vorhanden, einberufen wer-

95734

L

U X E M B O U R G

den, um innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Monat ab Zugang des Ersuchens an dem Ort und zu der Zeit wie sie
sich aus der Ladung zur Versammlung ergeben abgehalten zu werden.

10.3. Eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Ge-

sellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt am dritten Donnerstag im Mai um 14:00
Uhr abgehalten werden. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am
darauf folgenden Werktag abzuhalten. Je nach Lage des Falles muss der Verwaltungsrat oder der/die satzungsmäßige(n)
Buchprüfer die Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss
der Gesellschaftskonten einberufen.

10.4. Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die

Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung
anberaumten Datum an jeden Aktionär abzusenden.

10.5. Einer oder mehrere Aktionäre, die insgesamt mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals

der Gesellschaft repräsentieren, können ersuchen, dass ein Punkt oder mehrere Punkte der Tagesordnung jeder belie-
bigen Hauptversammlung der Aktionäre zugefügt wird/werden. Dieses Ersuchen muss mindestens fünf (5) Tage vor dem
für die Versammlung anberaumten Datum per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

10.6. Wenn an einer Hauptversammlung der Aktionäre alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung der Aktionäre
ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Hauptversammlungen der Aktionäre.
11.1. In jeder Hauptversammlung der Aktionäre soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem

Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Hauptversammlung der Aktionäre
ernannt wird und welche weder Aktionäre noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen. Der Rat der Versammlung
soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den
Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

11.2. In jeder Hauptversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Jegliche Ladungen, Beriche und Dokumente, welche gemäß dem Gesetz jedem Stammaktieninhaber zuzustellen

oder mitzuteilen sind, werden gleichermaßen jedem Vorzugsaktieninhaber zugestellt odermitgeteilt.

11.4. Quorum
Für das wirksame Handeln und die wirksame Beschlussfassung der Hauptversammlung der Aktionäre ist kein Quorum

erforderlich, sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt. Sofern ein Stammaktienin-
haber auch Vorzugsaktieninhaber ist, zählt dieser als ein Aktionär für jedes gesetzlich vorgeschriebene Quorumerfor-
dernis.

11.5. Abstimmung
11.5.1. Jede Stammaktie gewährt ihrem Inhaber unbeschadet gesetzlicher Vorschriften eine (1) Stimme.
11.5.2. Die Vorzugsaktien sind stimmrechtlose Vorzugsaktien in Übereinstimmung mit den Artikeln 44 bis 47 des

Gesetzes. Jede Vorzugsaktie berechtigtt ihren Inhaber zu einer (1) Stimme in dem gemäß Artikel 46 des Gesetzes erfor-
derlichen Umfang. Insbesondere beinhalten Vorzugsaktien keinerlei Stimmrechte, außer in den Fällen gemäß Artikel 46
des Gesetzes, in denen Inhaber von Vorzugsaktien zur Abstimmung in Hauptversammlungen der Aktionäre berechtigt
sind, die über:

i. die Ausgabe weiterer Vorzugsaktien;
ii. die Festlegung der nachzuzahlenden Vorzugsdividende für die stimmrechtlosen Aktien;
iii. die Umwandlung stimmrechtloser Vorzugsaktien in Stammaktien;
iv. die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals;
v. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
vi. die Ausgabe von Wandelanleihen;
vii. die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft;
viii. die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft anderer Rechtsform beschließen.
11.5.3.  Sind  die  nachzuzahlenden  Vorzugsdividenden  aus  irgendeinem  Grund  trotz  hierfür  vorhandener  ausschüt-

tungsfähiger Gewinne in zwei (2) aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht vollständig zur Auszahlung gelangt, so steht
ihren Inhaber auf allen Versammlungen dasselbe Stimmrecht wie den Inhabern von Stammaktien zu, bis die Dividenden
vollständig nachgezahlt sind.

11.5.4. Sofern sich nicht aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer

ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen
gefasst unabhängig von dem vertretenen Anteil am Kapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksich-
tigt.

11.6. Ein Aktionär kann an jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person,

Aktionär oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch

95735

L

U X E M B O U R G

jedwedes  andere  Kommunikationsmittel  übermittelt  wird,  schriftlich  bevollmächtigt,  wobei  eine  Kopie  einer  solchen
Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

11.7. Es wird vermutet, dass ein Aktionär, der an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Aktionär
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.

11.8. Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Aktionäre können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorge-
schlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft
wird  nur  solche  Stimmformulare  berücksichtigen,  die  sie  vor  der  Hauptversammlung  der  Aktionäre,  auf  die  sie  sich
beziehen, erhalten hat.

11.9. Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen,

damit sie an Hauptversammlungen der Aktionäre teilnehmen können.

Art. 12. Änderung der Satzung. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann diese Satzung durch einen Beschluss der

Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, welcher bei der ersten Abstimmung mit einer Zweidrittelmehrheit
der gültig abgegebenen Stimmen in einer solchen Versammlung gefasst wird, an der zumindest die Hälfte des ausgegebenen
Aktienkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. Bei der zweiten Abstimmung wird der Beschluss ungeachtet
des an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Kapitalanteils mit einer Zweidrittelmehrheit der in der Ver-
sammlung gültig abgegebenen Stimmen gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Art. 13. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwal-

tungsrat  jede  bereits  begonnene  Hauptversammlung  der  Aktionäre  einschließlich  jeder  zu  einer  Satzungsänderung
einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre auf vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss eine bereits
begonnene Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder von mehreren Aktionären beantragt
wird, welche insgesamt mindestens zwanzig Prozent (20%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsen-
tieren. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in dieser
Versammlung bereits getroffene Beschluss wieder aufgehoben.

Art. 14. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
14.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Aktionär, der das ersucht, unterzeichnet wird.

14.2. Der alleinige Aktionär, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse

aufnehmen und unterzeichnen.

14.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Verwaltungsratspräsidenten, durch zwei beliebige Verwaltungsratsmitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates.
15.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, dessen Mitglieder nicht Aktionäre der Gesellschaft

sein müssen. Die Gesellschaft kann mehrere Klassen von Verwaltungsratsmitgliedern haben.

15.2. Wenn in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat,

kann die Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer verwaltet werden bis zu der Hauptversammlung der Akti-
onäre,  die  der  Erkenntnis  der  Gesellschaft  nachfolgt,  dass  es  mehrere  Aktionäre  gibt.  In  einem  solchen  Fall,  soweit
anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in
dieser  Satzung  genannter  Verweis  auf  den  "Verwaltungsrat"  als  Verweis  auf  den  „alleinigen  Geschäftsführer"  gelesen
werden.

15.3. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung

des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der
Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Handlungen.

15.4. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes können die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung

innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Personen,
ob sie Aktionäre sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre
Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss festgesetzt.

95736

L

U X E M B O U R G

15.5. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 16. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
16.1. Der Verwaltungsrat setzt sich unbeschadet des Artikels 15.2 dieser Satzung aus mindestens drei (3) Mitgliedern

zusammen.

16.2. Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Er kann auch einen Sekretär

ernennen, der weder Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Art. 17. Wahl und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern und Amtszeit.
17.1. Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre gewählt, welche deren Bezahlung

und Amtszeit festlegt.

17.2. Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied gewählt wird, muss diese eine natürliche Person als

dauernden Vertreter benennen, welche diese Rolle im Namen und für Rechnung der juristischen Person ausübt. Die
betreffende juristische Person kann nur dann ihren dauernden Vertreter abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen
Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann der dauernde Vertreter nur eines (1) Verwaltungsratsmitglieds sein und
kann nicht gleichzeitig auch das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds innehaben.

17.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Hauptversammlung der Aktio-

näre abberufen werden.

17.4. Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds kann nicht länger als sechs (6) Jahre betragen, und jedes Verwal-

tungsratsmitglied muss sein Amt weiter ausüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann
auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 18. Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds.
18.1. Wenn das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Ausscheidens oder

aus einem anderem Grund unbesetzt ist, kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorü-
bergehend besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, in welcher die Aktionäre, wenn
dies für geeignet erachtet wird, über eine dauerhafte Besetzung bestimmen.

18.2. Wenn im Falle von mehreren Aktionären die Gesamtanzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter drei (3) oder

unter eine sich eventuell aus dieser Satzung ergebende höhere Mindestzahl fällt, so muss diese freie Stelle unverzüglich
entweder durch die Hauptversammlung der Aktionäre oder vorübergehend durch die verbleibenden Verwaltungsrats-
mitglieder besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die dauerhafte
Besetzung bestimmt.

18.3. Wenn die Verhinderung im Amt des alleinigen Geschäftsführers entsteht, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 19. Ladung zu Verwaltungsratssitzungen.
19.1. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mit-

glieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

19.2. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-

raumten Datum zu jeder Verwaltungsratssitzung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikati-
onsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu
bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes
Verwaltungsratsmitglieds per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine
Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu
Verwaltungsratssitzungen  nicht  erforderlich,  welche  zu  einer  Zeit  und  an  einem  Ort  stattfinden  sollen  wie  in  einem
vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle
Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß dieser
Satzung.

Art. 20. Verlauf von Verwaltungsratssitzungen.
20.1. Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats geleitet. In seiner Abwesenheit

kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

20.2. Quorum
Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn (i) mindestens die Hälfte seiner Mitglieder

an der Sitzung (ii) einschließlich eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse
B anwesend oder vertreten ist.

20.3. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen

Mitglieder, einschließlich eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Klasse B,
gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

95737

L

U X E M B O U R G

20.4. Ein Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Verwal-

tungsratsmitglied schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmäch-
tigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einen
oder mehrere seiner Kollegen vertreten. Außer in Notfällen, in denen Mitglieder des Verwaltungsrats an einer durch
solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung unabhängig von dem Land, aus dem sie teilnehmen, teilnehmen können,
kann eine Sitzung des Verwaltungsrats nur dann durch solche Kommunikationsmittel abgehalten werden, wenn weniger
als die Hälfte der an einer solchen Sitzung teilnehmenden Mitglieder des Verwaltungsrats zur Zeit der Sitzung körperlich
in einem einzigen Land (außerhalb Luxemburgs) anwesend sind.

20.5. Es wird vermutet, dass ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz

oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden
kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung
teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine
durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

20.6. Der Verwaltungsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer

ordnungsgemäß  geladenen und  abgehaltenen  Sitzung  gefasste  Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind  gefasst,
wenn sie durch alle Verwaltungsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert
und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch
jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unter-
schriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das
Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

20.7. Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Transaktion,

die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches
mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und
seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsrats-
mitglied kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die
nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss vor Fassen jedweden Beschlusses betreffend einen Tagesordnungspunkt
über einen solchen Interessenskonflikt informiert werden. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und
dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein
vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interes-
senskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden.

Art. 21. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen.
21.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident soll ein Protokoll über jede Ver-

waltungsratssitzung aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

21.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
21.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Verwaltungsratspräsidenten,
von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 22. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame

Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse A und einem Verwaltungsratsmitglied der Klasse B, oder durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Un-
terschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. In den Grenzen
des Tagesgeschäfts wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/
denen diese Befugnis in Verbindung mit dem Tagesgeschäft der Gesellschaft gemäß den Regeln dieser Übertragung allein
oder gemeinschaftlich handelnd übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 23. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
23.1. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt,

welche Aktionäre sind oder nicht.

23.2. Die Hauptversammlung der Aktionäre soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen

und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen, welche nicht mehr als sechs (6) Jahre betragen darf. Ein ehemaliger oder
derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Hauptversammlung der Aktionäre wieder ernannt werden.

23.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Hauptversammlung der Akti-

onäre abberufen werden.

23.4. Im Falle einer Verringerung der Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer durch Versterben oder auf andere Weise

um mehr als die Hälfte muss der Verwaltungsrat die Hauptversammlung der Aktionäre unverzüglich einberufen, um die
freigewordene(n) Stelle(n) zu besetzen.

23.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

95738

L

U X E M B O U R G

23.6. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

23.7. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Aktionär noch sat-
zungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in dieser Satzung genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Verwaltungs-
ratssitzungen anwendbar sein.

23.8. Wenn die Aktionäre der Gesellschaft einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (reviseur(s) d'entre-

prises agree(s)) gemäß Artikel 69 des geänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und
die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen ernennen, so besteht keine Verpflichtung einen satzungsmä-
ßigen Buchprüfer zu bestellen.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 25. Gewinne.
25.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

25.2. Die durch einen Aktionär an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Aktionär dieser Zuführung zustimmt.

25.3. Im Falle einer Herabsetzung des Aktienkapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis

herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals nicht übersteigt.

25.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Verwaltungsrat wird die Hauptversammlung

der Aktionäre beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und dieser Satzung verwendet werden soll.

25.5. In jedem Geschäftsjahr hat jeder Vorzugsaktieninhaber auf Basis des Nettogewinns nach Zuweisung der gesetz-

lichen Reserve (die „Verfügbaren Gewinne") einen Anspruch auf eine Gewinnausschüttung von (8%) pro Vorzugsaktie
pro Jahr (a) des Nominalwerts jeder Vorzugsaktie zuzüglich (b) des Betrags des Vorzugsaktienagioreservekontos gemäß
der Definition unter Artikel 26.4 dieser Satzung, geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Vorzugsaktien (die „Vorzugs-
aktiendividende").

25.6. Die Vorzugsaktiendividende ist kumulativ und beitreibbar, was bedeutet, dass die Vorzugsaktieninhaber die Mög-

lichkeit haben, während der darauffolgenden Geschäftsjahre die Vorzugsaktiendividende einzutreiben, die sie während
der vorhergehenden Geschäftsjahre, während derer weder Verfügbare Gewinne erzielt wurden noch vorhanden waren,
nicht erhalten haben.

25.7. Sofern anwendbar und sofern die Verfügbaren Gewinne genügen sollten, um eine Vorzugsaktiendividende im

Ganzen oder teilweise auszuschütten, und sofern die Hauptversammlung der Aktionäre dennoch keinen Ausschüttungs-
beschluss hinsichtlich der Vorzugsaktiendividende fasst, wird der Gesamtbetrag der Vorzugsaktiendividende, der an die
Vorzugsaktieninhaber ausgeschüttet hätte werden sollen, automatisch einer ausschüttbaren Reserve zugeteilt, die in ei-
nem Vorzugsaktienreservekonto (das „Vorzugsaktienreservekonto") verbucht wird.

25.8. Nach Ausschüttung oder Zuteilung der Vorzugsaktiendividende wird der Restbetrag der Verfügbaren Gewinne

(also die Verfügbaren Gewinne abzüglich der Vorzugsaktiendividende (die „Restlichen Gewinne")) an die Stammaktien-
inhaber ausgeschüttet. Die Restlichen Gewinne werden durch Beschluss der Hauptversammlung zugeteilt. Die Haupt-
versammlung kann beschließen, entweder die Restlichen Gewinne anteilig an die Stammaktieninhaber auszuschütten, sie
vorzutragen oder sie in eine ausschüttbare Reserve zu übertragen. Jeder Stammaktieninhaber hat einen Anspruch auf
einen Bruchteil der Restlichen Gewinne, die an alle Stammaktieninhaber anteilig zu deren Anzahl an Stammaktien in der
Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Art. 26. Zwischendividenden - Agioreserve.
26.1. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden zahlen.
26.2. Die Agioreserve kann durch Aktionärsbeschluss oder Beschluss des Verwaltungsrats unter Beachtung der ge-

setzlichen  Bestimmungen  betreffend  die  Unantastbarkeit  des  Aktienkapitals  und  der  gesetzlichen  Rücklage  und  der
Bestimmungen dieser Satzung frei an den/die Aktionär(e) ausgeschüttet werden.

26.3. Jede Agioreserve die auf Stammaktien bezahlt wurde, wird auf dem Stammaktienagioreservekonto (das „Stamm-

aktienagioreservekonto")  verbucht.  Auf  diesem  Konto  wird  jeder  Betrag  und  jeder  Wert  einer  Agioreserve,  die  auf
Stammaktien gezahlt wurde, jeder von Stammaktieninhabern beigesteuerter zusätzlicher Kapitalüberschuss und jeder dem
Stammaktienagioreservekonto gemäß dieser Satzung zugewiesene Betrag in der Währung, in der diese tatsächlich gezahlt
wurden, verbucht.

95739

L

U X E M B O U R G

26.4. Jede Agioreserve, die auf Vorzugsaktien gezahlt wurde, wird auf dem Vorzugsaktienagioreservekonto (das „Vor-

zugsaktienagioreservekonto") verbucht. Auf diesem Konto wird jeder Betrag und jeder Wert einer Agioreserve, die auf
Vorzugsaktien gezahlt wurde, jeder von Vorzugsaktieninhabern beigesteuerter zusätzlicher Kapitalüberschuss und jeder
dem Vorzugsaktienagioreservekonto gemäß dieser Satzung zugewiesene Betrag in der Währung in der diese tatsächlich
gezahlt wurden, verbucht.

26.5. Die Agioreserve kann nach Beschluss der Aktionäre oder nach Beschluss der Vorstandsvorsitzenden unter Be-

achtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Aktienkapitals und der gesetzlichen Rücklage
und der Bestimmungen dieser Satzung frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation.
27.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche

oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

27.2. Nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten oder diesbezüglicher

Hinterlegung finanzieller Mittel, hat jeder Vorzugsaktieninhaber ein Vorzugsauszahlungsrecht.

27.3. Wenn die Gesellschaft diese Beträge nicht vollständig an jeden Vorzugsaktieninhaber auszahlen kann, wird jeder

Vorzugsaktieninhaber anteilig ausbezahlt.

27.4.  Nach  Zahlung  aller  Schulden  und  Verpflichtungen  der  Gesellschaft  (einschließlich  gegebenenfalls  jeder  Vor-

schusszahlung an die Aktionäre) und nach Auszahlung jeglicher den Vorzugsaktieninhabern zustehenden Beträge gemäß
diesem Artikel, oder der diesbezüglichen Hinterlegung finanzieller Mittel wird der Überschuss an die Stammaktieninhaber
anteilig zu deren Anzahl an Stammaktien in der Gesellschaft ausbezahlt. Die Vorzugsaktieninhaber werden in jedem Fall
vor den Stammaktieninhabern ausbezahlt.

H. Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Die Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle

in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz bestimmt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2013.

2) Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll in 2014 abgehalten werden.
3) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Der zeichnende Aktionär hat die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
S&amp;B Minerals Finance S.C.A, vorbenannt,
zahlte einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gegen Zeichnung von zwei Millionen neunhundertfünfundvierzigtau-

send (2.945.000) Stammaktien und einhundertfünfundfünfzigtausend (155.000) stimmrechtslosen Vorzugsaktien Aktien.

Gesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) gezahlt für drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) Aktien.
Alle Aktien sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) von

jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, dass er das Vorliegen der in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes ge-

nannten Voraussetzungen geprüft hat, und erklärt ausdrücklich, dass sie alle erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 1.200,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Aktionärs

Der Gründungsaktionär, welcher das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft repräsentiert hat folgende Beschlüsse

gefasst.

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) festgesetzt u.
2) Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt:
a) Herr Kriton Leonidas Anavlavis, geboren am 30. Juli 1962 in Istanbul, Türkei, mit beruflicher Adresse 15A Andrea

Metaxa Strasse, 14564 Kifisia, Athen, Griechenland, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse A der Gesellschaft;

95740

L

U X E M B O U R G

b) Herr Ioannis Christodoulakis, geboren am 21. September 1954 in Karpatos, Griechenland, mit beruflicher Adresse

15A Andrea Metaxa Strasse, 14564 Kifisia, Athen, Griechenland, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse A der Gesellschaft;

c) Herr Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse B der Gesellschaft; und

d) Frau Virginia Strelen, geboren am 30. Mai 1977 in Bergisch-Gladbach, mit beruflicher Adresse 15, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Klasse B der Gesellschaft.

3) Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft ernannt:

Ernst &amp; Young S.A., RCS: B47771, 7 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, RCS: B47771.

4) Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers soll an dem Zeitpunkt enden,

an dem die Hauptversammlung der Aktionäre/der alleinige Aktionär, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des
Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre/vom alleinigen Aktionär, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.

5) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen  Parteien  auf  Englisch  geschrieben  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Übersetzung.  Auf  Anfrage  derselben
erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische
Fassung vorrangig sein.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-

tigte diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DOBRZENSKY und M. SCHAEFFER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juillet 2013. Relation: LAC/2013/30339. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 8. Juli 2013.

Référence de publication: 2013095443/1031.

(130114940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2013.

Tornio Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 117.493.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 27 juin 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société anonyme
TORNIO INVESTMENTS S.A., dont le siège social à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a
été dénoncé en date du 14 septembre 2010.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Martine LEYTEM, premier juge au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Pierre-Yves MAGEROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxem-

bourg avant le 18 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Pierre-Yves MAGEROTTE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013087045/21.

(130106795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

95741

L

U X E M B O U R G

Verone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 176.455.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de VERONE S.A., tenue au siège social le 1 

<i>er

<i> juillet 2013 à 09

<i>heures

1. L'Assemblée approuve la radiation de l'Administrateur:
CENTURION S.A.L (OFF-SHORE)
enregistrée  auprès  du  registre  de  commerce  du  Liban  Lebanese  Republic  Commercial  register  sous  la  référence

1806463 ayant comme représentant permanent Monsieur Christian RANASINGHE ARACHCHIGE né le 12 octobre
1988 à Colombo (SRI LANKA) demeurant au 38, Georgers Magniez F-93120 La Courneuve (FRANCE)

2. L'Assemblée approuve la nomination des Administrateurs:
- Monsieur Mathieu FARANGUE HARIRI, Administrateur, né le 17 août 1988 à Aubervillers (FRANCE) demeurant

professionnellement au 13, rue de la Paix L-3871 Schifflange.

- Monsieur Thibaud SCHMEER, Administrateur, né le 1 

er

 septembre 1988 à Obernai (FRANCE) demeurant profes-

sionnellement au 13, rue de la Paix L-3871 Schifflange.

- Monsieur Christian RANASINGHE ARACHCHIGE, né le 12 octobre 1988 à Colombo (SRI LANKA) employé, de-

meurant professionnellement au 13, rue de la Paix L-3871 Schifflange.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018 statuant sur les comptes

annuels du 31 Décembre 2017.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 10 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Thibaud SCHMEER / Gérard LUSATTI / Mathieu FARANGUE HARIRI
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2013087077/28.

(130107426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Tasselot S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 78.664.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 juillet 2012, les actionnaires ont pris les décisions sui-

vantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Willem Adriaanse, avec adresse au 15, rue Jean-Pierre Sauvage, L-1024 Luxembourg;
- Carlo DAX, avec adresse au 16, rue de Kehlen, L-9394 Olm;
- Marcel Stephany, avec adresse au 23, Cité Aline Mayrisch, 7268 Bereldange;
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice

se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

2. Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué Carlo DAX, avec adresse au 16, rue de Kehlen, L-9394 Olm,

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

3. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de BDO Audit, avec siège social au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2013.

Référence de publication: 2013087024/23.

(130106586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

95742

L

U X E M B O U R G

Tiledrasi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 94.278.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2013

La démission de Monsieur Evangelos Raptis, liquidateur le 22 mars 2013 est accepté.
Monsieur George Mantzoros, né le 15 janvier 1962 à Athènes, ayant comme adresse professionnelle Nedmed Group,

Manis Street, Kantza Pallini of Attica, GR 153-51, Athènes Grèce est nommé liquidateur de la société avec effet le 22
mars 2013.

Luxembourg, le 27/6/2013.

Pour extrait conforme
Fiduciaire Nationale S.à r.l.
2, rue de l'Avenir
L-1147 Luxembourg
Signature
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2013087038/19.
(130107526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

ACM RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 169.255.

<i>Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 2 mai 2013

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 9, boulevard

du Prince Henri L-1724 Luxembourg, à compter du 1 

er

 juillet 2013.

<i>Pour la société ACM RE S.A.
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013087180/12.
(130108509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Thomson Reuters Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 45.994.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2013

L'assemblée générale décide de réélire tous les administrateurs en fonction pour un nouveau mandat qui se terminera

à l'issu de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

L'assemblée générale décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de six à sept et nomme Monsieur Chris Hart-

free, né le 24 juillet 1968 à Gateshead, Royaume-Uni, demeurant professionnellement 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg,  comme  nouvel  administrateur  de  la  Société  pour  une  période  qui  se  terminera  à  l'issu  de  l'assemblée
générale qui se tiendra en 2014.

Le conseil d'administration est composé comme suit:
1. Madame Camilla NUNN, administrateur, demeurant 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
2. Monsieur Tom LOESCH, administrateur et président, demeurant 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
3. Monsieur Alain STEICHEN, administrateur, demeurant 2, rue Peternelchen, bâtiment C étage 2, L-2370 Howald;
4. Monsieur Ken McCARTER, administrateur, demeurant Toronto Dominion Centre, bâtiment Aetna Tower, Suite

3000, CDN - M5K 1N2 Toronto, Ontario;

5. Madame Ruth CLAMP, administrateur, demeurant 153, route de Thonon, CH-1245 Collonge-Bellerive, Genève;
6. Madame Miranda HALL, administrateur, 33 Aldgate High Street, Aldgate House, EC3N 1DL, London; et
7. Monsieur Chris HARTFREE, administrateur, demeurant 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
L'assemblée générale décide de réélire PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, comme commissaire pour un

nouveau mandat qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

95743

L

U X E M B O U R G

<i>Pour THOMSON REUTERS FINANCE S.A.

Référence de publication: 2013087036/27.

(130106997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

TCC Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 135.531.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la société en date du 24 juin 2013

Le conseil de gérance décide de nommer ERNST &amp; YOUNG, société anonyme établie et ayant son siège social au 7,

rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg
sous le numéro B 47771, en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société, avec effet à la date de l'assemblée
générale annuelle des associés de la Société en relation avec l'approbation des comptes de l'exercice social clos au 31
décembre 2012 et pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle des associés de la Société en relation
avec l'approbation des comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013087025/16.

(130107173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Glasswall Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Cilaos S.à r.l.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 175.671.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66656 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013087333/11.
(130108564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

UBS Third Party Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 45.991.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2013

Sont réélus au Conseil d'Administration:
- M. Aloyse Hemmen, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale

annuelle de 2014, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

- M. Mark Porter, président du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle

de 2014, 21 Lombard Street, EC3V 9AH London, Royaume-Uni.

- M. Court Taylour, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle

de 2014, Talacker 30, CH-8001 Zurich, Suisse.

- M. David Lahr, membre du conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle

de 2014, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2013.

<i>Pour UBS THIRD PARTY Management COMPANY S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Sandra Ehlers
<i>Associate Director / Director

Référence de publication: 2013087056/23.

(130106378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

95744

L

U X E M B O U R G

Timaru S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 24.983.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013

L'assemblée accepte la démission de la société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ayant son siège social

au 824, Market Street, Suite 720, DE-19801 WILMINGTON -Etat du Delaware (U.S.A.) comme administrateur et nomme
en remplacement Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEM-
BOURG, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice
2016.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2013

Les membres du Conseil d'Administration décident de nommer comme Président du Conseil d'Administration Mon-

sieur Bernard EWEN, avec adresse privée au 17, rue Raoul Follereau, L-8027 STRASSEN, pour une période venant à
échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013087039/20.

(130107011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Degato International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 93.278.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2013087444/11.
(130108928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

VH Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 138.820.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 27 juin 2013

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2013:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;

- Monsieur Alexander STUDHALTER, conseiller fiscal, demeurant au 8, Matthofstrand, CH - 6000 Lucerne, Président.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 27 juin 2013.

Référence de publication: 2013087078/20.

(130107429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

95745

L

U X E M B O U R G

Unibeton Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 74.705.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 3 juin 2013 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises Agréé viennent à échéance à la présente Assemblée.
-  L'Assemblée  Générale  décide  à  l'unanimité  de  renouveler  les  mandats  d'administrateurs  de  Monsieur  Olivier

APRUZZESE, Président, de Monsieur Joël NEYHOUSER et de UNIBETON S.A.S, ainsi que le mandat du Réviseur d'en-
treprises Agréé de ERNST &amp; YOUNG (immatriculé au RCS B 47.771 dont le siège social est situé 7 Parc d'activité Syrdall
L-5365 Munsbach).

- Les mandats des administrateurs et du Réviseur d'entreprises Agréé viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2013.

Pour copie conforme
FIDUPAR
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013087060/19.

(130106264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

dfl Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.950.003,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.151.

Par résolutions circulaires prises en date du 12 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation, avec effet au 13 juin 2013, de la démission de son mandat de Gérant de Catégorie A de Pascal ROU-

MIGUIE, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

- nomination, avec effet au 13 juin 2013, au mandat de Gérant de Catégorie A de Gaël Sausy, avec adresse profes-

sionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087138/15.
(130108304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

BHR Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.830.762.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.929.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 11 juin 2013 a décidé
1) de renouveler le mandat des gérants en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en 2014, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Pit Reckinger, demeurant 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg
- Monsieur Joerg Schmittem, demeurant 48, Am Obstgarten, D-54317 Osburg
- Monsieur Robert J. Chitry, demeurant 2724, Lockerly Lane, USA-30097 Duluth GA
- Monsieur Paul Berge, demeurant 304 Zwanebloemlaan, NL-1087JT Amsterdam
2) de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young en tant que réviseurs d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

95746

L

U X E M B O U R G

<i>Pour BHR Luxembourg S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2013087127/21.
(130106318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2013.

Zwickau Arcaden Luxco, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.926.

En date du 13 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Rita-Rose Gagné, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13

juin 2013.

- Nomination de Monsieur Tony Roy, né le 12 avril 1969 à Rivière du Loup, au Canada, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 1001, rue Square-Victoria, Montréal, H2Z 2B5, Québec, Canada, en qualité de nouveau gérant de la Société
avec effet au 13 juin 2013 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Gachet, né le 02 août 1956 à Strasbourg, en France, ayant pour adresse

professionnelle le 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de nouveau gérant de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087099/22.
(130107278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Professional Classic Ballet School, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald, 185, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 81.483.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013087974/11.
(130107951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

VIII F Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.939.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin

2013, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2013, LAC/2013/28916, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que
la société "VIII F CHATEAU S.à r.l. (en liquidation)", R.C.S Luxembourg Numéro B 122.939, ayant son siège social à L-2163
Luxembourg au 33, avenue Monterey, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors
de résidence à Luxembourg, en date du 15 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 243 du 23 février 2007, sous la dénomination de «M CHATEAU VII S.à r.l.»;

la société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire en date du 30 mai 2013, non encore publié au

Mémorial C;

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans pendant 5 (cinq) ans à partir de la

date de la publication dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations,
Mémorial C, à l'adresse suivante: 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

95747

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087081/23.

(130108077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

SC Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 991.296.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.878.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 11 juin 2013 a décidé
1) de renouveler le mandat des gérants en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en 2014, de sorte, que jusqu'à cette date, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Robert J. Chitty, demeurant 2724, Lockerly Lane, USA-30097 Duluth GA
- Monsieur Joerg Schmittem, demeurant 48, Am Obstgarten, D-54317 Osburg
- Monsieur Paul Bergé, demeurant 304 Zwanebloemlaan, NL-1087JT Amsterdam
- Madame Martine Elvinger, demeurant 6, rue de Schoenfels, L-8151 Bridel.
2) renouveler le mandat de Ernst &amp; Young en tant que réviseurs d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale des ac-

tionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signatures

Référence de publication: 2013087134/21.
(130106320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2013.

Alfred, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 159.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013087209/10.
(130108096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

a-part s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2270 Luxembourg, 21, rue d'Orval.

R.C.S. Luxembourg B 103.049.

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales qu'avec effet au 30 juin 2013
- Monsieur Dan Neven, demeurant à L-9209 Diekirch, 98 Bamertal, a cédé 15 parts sociales dans la société A-Part S.à

r.l. à Monsieur Claude Jean Folschette, demeurant à L-3374 Leudelange, 12, Domaine Schaefert;

- Madame Isabelle Mersch, demeurant à L-6637 Wasserbillig, 47 Esplanade de la Moselle, a cédé 10 parts sociales dans

la société A-Part S.à r.l. à Monsieur Claude Jean Folschette, demeurant à L-3374 Leudelange, 12, Domaine Schaefert.

Après les cessions ci-avant décrites, le capital de la société se trouve réparti comme suit:

1.- Monsieur Dan Neven, demeurant à L-9209 Diekirch, 98 Bamertal, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Isabelle Mersch, demeurant à L-6637 Wasserbillig, 47 Esplanade de la Moselle, vingt-cinq
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3. -Monsieur Claude Jean Folschette, demeurant à L-3374 Leudelange, 12, Domaine Schaefert, vingt-cinq
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

95748

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Dan Neven
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087137/22.
(130108871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Divine Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 175.429.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 27 juin 2013 qu'il a été pris acte de la démission

de la personne suivante, avec effet au 6 mai 2013, de sa fonction d'administrateur de la Société:

- Monsieur Adel Ahmed M. Elsherbini, né le 18 août 1936 au Caire, Egypte, ayant son adresse professionnelle à Diwan

Amiri, boîte postale 923, Doha, Qatar.

Il résulte desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 12 juin 2013 jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2018, à la fonction d'administrateur de la Société:

- Madame Hind Hamad KH. H. Al-Thani, née le 15 août 1984 au Qatar, ayant son adresse professionnelle à Diwan

Amiri, boîte postale 923, Doha, Qatar.

Depuis lors, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:
- Madame Hind Hamad KH. H. Al-Thani, prénommée,
- Monsieur Victor Nazeem R. Agha, ayant son adresse professionnelle à Al Sadd Travel, boîte postale 17127, Doha,

Qatar.

- Monsieur Alan Dundon, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg,

- Monsieur Frédéric Salvadore, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 juillet 2013.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature

Référence de publication: 2013087428/32.
(130108819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Dylux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 107.388.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 29 novembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- DYLUX SA (RCS: B 107388)
Ce même jugement a nommé comme juge commissaire Madame Carole BESCH, et a désigné comme liquidateur Me

Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à L-2111 Luxembourg, 1, rue Guillaume de Machault.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Pour extrait conforme
Me Pierre BRASSEUR
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013087117/18.
(130107583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

95749

L

U X E M B O U R G

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 67.654.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 31 mai 2013:

Monsieur Joseph G. Wheatley a été élu président du conseil d'administration et réélu en qualité d'administrateur de

la Société et Messieurs David J. Micallef, Dean V. Fletcher, Mark Mannion et Madame Carol M. Andrews ont été réélus,
en leur qualité d'administrateur de la Société, pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de
2014.

KPMG Luxembourg S.àr.l., L-2520 Luxembourg, Allée Scheffer 9, ont été réélus en leur qualité de réviseurs d'entre-

prises de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2014.

Adresse professionnelle de:
Monsieur Joseph G. Wheatley - Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland
Madame Carol M. Andrews et Monsieur Mark Mannion - Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
David Micallef / Claudia Vago
<i>Managing Director / Corporate Secretary

Référence de publication: 2013087136/21.
(130106390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2013.

Digital Realty (St Denis) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.278.

Il est à noter la nouvelle adresse du gérant, Monsieur Joshua Mills, comme suit:
- Monsieur Joshua MILLS, 4, Embarcadero Center, Suite 3200 San Francisco, CA 94111, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Digital Realty (Redhill) S.àr.l
TMF Corporate Service S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2013087426/15.
(130108682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Cole Objekt Kistlerhofstrasse GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 152.050.

En date du 13 juin 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Rita-Rose Gagné, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 13

juin 2013.

- Nomination de Monsieur Tony Roy, né le 12 avril 1969 à Rivière du Loup, au Canada, ayant pour adresse profes-

sionnelle le 1001, rue Square-Victoria, Montréal, H2Z 2B5, Québec, Canada, en qualité de nouveau gérant de la Société
avec effet au 13 juin 2013 et pour une durée indéterminée.

- Nomination de Monsieur Jean-Philippe Gachet, né le 02 août 1956 à Strasbourg, en France, ayant pour adresse

professionnelle le 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de nouveau gérant de la Société avec effet au
lier juillet 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

95750

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 juin 2013.

<i>Pour la Société
J.J. Josset
<i>Gérant

Référence de publication: 2013087339/22.
(130108979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Bluegreen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 64.425.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 1 

<i>er

<i> juillet 2013 à 15.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE,

administrateurs. Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre
2013.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant que nouvel administrateur la société JALYNE S.A., 1, rue Joseph

Hackin L-1746 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 158.952
représentée par Monsieur Jacques BONNIER 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg né le 4 mai 1949 à Wervik
(Belgique). Le mandat de JALYNE S.A. prendra fin lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2013.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat de Monsieur Pierre SCHILL, Commissaire aux Comptes pour

un terme venant à échéance lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2013.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013087302/20.
(130108885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Anchorage Venture Lab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 99.225.

En date du 14 Juin 2013, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur de la société ANCHORAGE VENTURE LAB

S.A., ayant son siège social à 26-28 rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 99225.

Luxembourg, le 1 

er

 Juillet 2013.

Pour extrait conforme
Monsieur Vincent WILLEMS

Référence de publication: 2013087223/12.
(130108786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

AA - Iberian Venture Capital Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.752.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 juin 2013

- Il est pris acte de la démission de Monsieur Alain RENARD de son mandat d'administrateur avec effet au 20 juin

2013.

- Il est pris acte de la démission de Madame Françoise DUMONT de son mandat d'Administrateur avec effet au 20

juin 2013.

- Madame Anne-Marie GREGIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Alain RENARD, démissionnaire, avec
effet à ce jour, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

95751

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 juin 2013.

AA-EBERIAN VENTURE CAPITAL INVEST S.A.
J-R. BARTOLINI / A. BOULHAIS
<i>Administrateur Et Président du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2013087173/20.
(130107927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

AC Nordic Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 166.815.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'associé unique de la Société tenue à Luxembourg le 3 juin 2013

1. La démission de Madame Laura Laine, en tant que gérante de catégorie A de la Société, a été acceptée avec effet au

3 juin 2013.

2. Madame Ana Dias, employée privée, née le 12 juillet 1968 à Penafiel, Portugal, avec adresse professionnelle au 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvelle gérante de catégorie A de la Société,
avec effet au 3 juin 2013, pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AC Nordic Management S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2013087179/17.
(130107821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Cyclone International Holdings Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 154.948.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 mai 2013 que:
1. La démission de Madame Davina Ho en tant gérant de la Succursale a été acceptée avec effet au 14 juin 2013;
2. Monsieur Scott McKinlay, né le 11 avril 1983 à Dunfermline, Angleterre, résidant professionnellement au 16 rue du

couvent, L-1363 Howald, Luxembourg a été nommé gérant de la Succursale avec effet 15 juin 2013 et ce pour une durée
indéterminée.

La Succursale sera engagée par la signature conjointe d'au moins un administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 27 juin 2013.

Référence de publication: 2013087372/17.
(130108734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Argos Soditic Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 50.717.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1 

<i>er

<i> juillet 2013

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2013:

- Monsieur Louis GODRON, directeur de société, demeurant au 58, route de l'Etang-la-Ville F- 78750 Marail-Marly,

France;

- Monsieur Gilles MOUGENOT, directeur de société, demeurant au 12, avenue du Venezuela B-1000 Bruxelles, Pré-

sident;

- Monsieur Guy SEMMENS, directeur de société, demeurant au 42, Quai Gustave Ador CH-1206 Genève, Suisse;
- Madame Anna Karin PORTUNATO, consultante indépendante, demeurant au 5, route de Pierre-Grand, CH- 1256

Troinex, Suisse.

95752

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2 avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2013.

Référence de publication: 2013087236/24.
(130108690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

COGEP S.A., Compagnie Générale de Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 85.181.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013 les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
Les mandats des administrateurs et administrateurs-délégués Monsieur Bernard Olmedo, Monsieur Gilbert Thibo,

Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach sont venus à l'expiration, l'assemblée a décidé à l'unanimité de les
renommer pour une durée de six ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice
2018.

Le mandat du commissaire aux comptes, la société Arend Consult S.à r.l., est venu également à l'expiration, l'assemblée

a décidé à l'unanimité de la renommer pour une durée de six ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur l'exercice 2018.

Le commissaire aux comptes Arend Consutl S.à r.l. a transféré son siège social à L-7535 MERSCH, 14, rue de la Gare.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à Monsieur Bernard

Olmedo, Monsieur Gilbert Thibo, Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur-délégué du groupe A

et d'un administrateur-délégué du groupe B.

<i>Groupe A

- Bernard Olmedo
- Gilbert Thibo

<i>Groupe B

- Nico Arend
- Carlo Fischbach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bernard OLMEDO / Nico AREND
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013087397/30.
(130108342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

All Consulting Europe S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 83.386.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les

informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,

L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS
B 99746 et ayant son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en
remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146

Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et
ayant son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement
de Madame Rika Mamdy.

95753

L

U X E M B O U R G

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,

L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B
99739  et  ayant  son  siège  social  au  12D  Impasse  Drosbach,  L-1882  Luxembourg,  à  partir  du  15  avril  2013  et  ce  en
remplacement de Madame Rika Mamdy.

Luxembourg, le 15 avril 2013.

<i>Pour ALL CONSULTING EUROPE S.A.

Référence de publication: 2013087210/24.
(130107686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

CEREP AIR 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.555.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Rensonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée; et

- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:
- CEREP Management S.à r.l.;
- M. Guy Harles;
- M. Damien Rensonnet;
- M. David Pearson; et
- M. Robert Konigsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088424/30.
(130109817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

CEREP Ambroise S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.673.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Rensonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée; et

95754

L

U X E M B O U R G

- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:
- CEREP Management S.à r.l.;
- M. Guy Harles;
- M. Damien Rensonnet;
- M. David Pearson; et
- M. Robert Konigsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 juillet 2013.

Référence de publication: 2013088425/30.
(130109818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

M Group Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.793.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 28 juin 2013

- Les mandats d'administrateurs de catégorie A de Monsieur Dominique MONTEL, Administrateur de société, de-

meurant avenue de Fontlong, F-15100 Saint Flour et de la société MONTEL SAS, Société par Actions Simplifiées, ayant
son siège social rue Lavoisier, F-43100 Brioude, Saint Férréol, représentée par Madame Margaux MONTEL, Représentant
permanent, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2019.

- Les mandats d'administrateurs de catégorie B de Monsieur Christian FRANÇOIS, employé privé, demeurant pro-

fessionnellement  au  412F  route  d'Esch,  L-2086  Luxembourg,  de  Monsieur  Serge  KRANCENBLUM,  diplômé  M.B.A,
demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Stéphane BAERT, employé
privé, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

- le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-Contrôle S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au

12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2013.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR M GROUP INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2013087836/24.
(130107734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Adeo Management S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 74.223.

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les

informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,

L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite au numéro RCS
B 99746 et ayant son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en
remplacement de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Jean-Bernard Zeimet, né à Luxembourg le 05 mars 1953 avec adresse au 51, Rue de Merl, L-2146

Luxembourg est le représentant permanent de la société Tyndall Management S.A. inscrite au numéro RCS B 99747 et
ayant son siège social au 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, à partir du 15 avril 2013 et ce en remplacement
de Madame Rika Mamdy.

- que Monsieur Patrick Goldschmidt, né à Luxembourg le 2 février 1970 avec adresse au 13, Rue Arthur Herchen,

L-1727 Luxembourg est le représentant permanent de la société Alpmann Management S.A. inscrite au numéro RCS B
99739  et  ayant  son  siège  social  au  12D  Impasse  Drosbach,  L-1882  Luxembourg,  à  partir  du  15  avril  2013  et  ce  en
remplacement de Madame Rika Mamdy.

95755

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 avril 2013.

<i>Pour ADEO Management S.A.

Référence de publication: 2013087185/24.
(130107681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

Natixis-Cape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 85.137.

<i>Résumé des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la Société le 25 juin 2013:

1. L'Assemblée a décidé de réélire aux fonctions d'administrateurs pour une période venant à expiration à l'issue de

l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31
décembre 2013:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Vincent Goy, demeurant au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- NATIXIS TRUST, société anonyme, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Administrateur de catégorie B:

- Monsieur Jean de Séverac, demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75340 Paris.
2. L'Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Nicolas Homassel, administrateur de catégorie B, avec effet

immédiat.

3. L'Assemblée a décidé d'élire Monsieur Dominique Sabassier, demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75340 Paris,

aux fonctions d'administrateur de catégorie B, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2013.

4. L'Assemblée a décidé de réélire Deloitte Audit, une société à responsabilté limitée, ayant son siège social au 560,

rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 67.895 en tant que reviseur d'entreprises agréé, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre
2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2013088852/30.
(130109154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Benetton International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 78.734.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale annuelle en date du 14 mai 2013 que le mandat des personnes

suivantes a été renouvelé/donné jusqu'à l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des comptes annuels de la
Société au 31 décembre 2013:

- Monsieur Bernard Basecqz, né le 15 octobre 1945 à Enghien (Belgique), et résidant au 1, Rue Plaetis, L-2338 Lu-

xembourg (Grand Duché de Luxembourg), administrateur et président du conseil d'administration;

- Monsieur Daniele Bandiziol, né le 15 mars 1961, à Spinea (Italie), et résidant au 28, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg

(Grand Duché de Luxembourg), administrateur;

- Monsieur Andrea Ghiringhelli, né le 2 octobre 1965, à Bellinzona (Suisse), et résidant Via Dogana 10, Bellinzona

(Suisse), administrateur;

- Monsieur Giuseppe Mazzocato, né le 11 août 1958 à Montebelluna (Italie), et résidant au 24, am Stronck, L-6915

Roodt-Sur-Syre (Grand Duché de Luxembourg), administrateur;

- Monsieur Mauro Fava, né le 14 janvier 1957 à Treviso (Italie), et résidant au 5/B, Vicolo S. Antonino, I-31100 Treviso

(Italie), administrateur;

- Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège à 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach (Grand Duché de Luxembourg),

réviseur d'entreprises agrées.

95756

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013087260/24.
(130108203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2013.

CEREP Bellini 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 141.150.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Rensonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée; et

- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:
- CEREP Management S.à r.l.;
- M. Guy Harles;
- M. Damien Rensonnet;
- M. David Pearson; et
- M. Robert Konigsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 juillet 2013.

Référence de publication: 2013092282/30.
(130112810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

CEREP Bellini 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 141.126.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Rensonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée; et

- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:
- CEREP Management S.à r.l.;
- M. Guy Harles;

95757

L

U X E M B O U R G

- M. Damien Rensonnet;
- M. David Pearson; et
- M. Robert Konigsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 juillet 2013.

Référence de publication: 2013092283/30.
(130112811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Crismagand, société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-

moine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 62.351.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 juillet 2013

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2013:

<i>Signatures de catégorie A

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Signature de catégorie B

- Monsieur Charly PERNOUD, diplômé de l'école supérieure d'ingénieur de Marseille, demeurant au 25, avenue Felix

Faure, F-75015 Paris, France.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2013:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 3 juillet 2013.

Référence de publication: 2013092315/24.
(130113617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

CEREP Benelux Students S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 130.290.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Rensonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée; et

- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:
- CEREP Management S.à r.l.;
- M. Guy Harles;
- M. Damien Rensonnet;

95758

L

U X E M B O U R G

- M. David Pearson; et
- M. Robert Konigsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 juillet 2013.

Référence de publication: 2013092284/30.
(130112812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6648 Wasserbillig, 2, rue des Sports.

R.C.S. Luxembourg B 47.433.

<i>Gesellschafterbeschluss vom 18. Juni 2013

<i>Erster und einziger Beschluss

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass die persönlichen Daten des alleinigen Gesellschafters wie folgt abgeän-

dert werden: Herrn CONRAD Nikolaus wohnhaft in D-54338 Schweich, 1, Zur Zementbrücke

CONRAD Nikolaus.

Référence de publication: 2013092304/12.
(130113097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Challenger Reassurance, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 29.820.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2013

<i>Quatrième Résolution: renouvellement du mandat du réviseur d'Entreprises

Le mandat du Réviseur d'Entreprises MAZARS dont siège social à L - 2530 Luxembourg 10A, rue Henri M. Schnadt,

arrivant à échéance à l'issue de cette Assemblée, il est reconduit à l'unanimité jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Référence de publication: 2013092295/12.
(130113146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

CEREP Bac S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 111.533.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 18 juin 2013, les associés de la Société ont décidé:
- de nommer M. Guy Harles, avocat, né le 04 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 14, rue de Luxembourg, 8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. Damien Rensonnet, directeur associé, né le 07 mai 1977 à Verviers, Belgique, ayant son adresse

professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;

- de nommer M. David Pearson, directeur général, né le 13 décembre 1968 à Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée; et

- de nommer M. Robert Konigsberg, directeur général, né le 25 mars 1969 à New Mexico, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505,
Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 18 juin 2013, constitué des personnes suivantes:
- CEREP Management S.à r.l.;
- M. Guy Harles;
- M. Damien Rensonnet;
- M. David Pearson; et

95759

L

U X E M B O U R G

- M. Robert Konigsberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 juillet 2013.

Référence de publication: 2013092287/30.
(130112809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Regulus Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 157.889.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2013:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Madame Carine MOURAT, avec adresse professionnelle au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonc-

tions d'administrateur;

- Monsieur Christoph PIEL, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions

d'administrateur;

- Monsieur Claudio TOMASSINI, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2013.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 05 Juillet 2013.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2013092759/24.
(130112926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Schleich Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 122.657.

Lors de l'assemblee generale annuelle tenue en date du 27 juin 2013, les actionnaires ont decide de:
1. de renouveler les mandats des administrateurs suivant:
- Nadia Dziwinski, administrateur Hg, avec adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
- Paul Kraut Junior, Manager Co-Investor administrateur, avec adresse professionnelle au 2, Untere Gasse, D 73574

Iggingen

- Justin Von Simson, administrateur Hg, avec adresse professionnelle au 58, Siesmayerstrasse, D 60323 Frankfurt
- Frank Przygodda, administrateur Hg, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Erich Schefold, administrateur, avec adresse professionnelle au 69, Am Limes, D 73527 Schwabisch Gmund Allemagne
Pour une periode venant a echeance lors de l'assemblee generale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social

se cloturant au 31 decembre 2013 et qui se tiendra en 2014

2. de renouveler le mandat de KPMG, avec siege social au 31 allee Scheffer, L-2520 Luxembourg en tant que com-

missaire pour une periode venant a echeance lors de l'assemblee generale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice
social se cloturant au 31 decembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2013086937/23.

(130107287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

95760


Document Outline

AA - Iberian Venture Capital Invest S.A.

ACM RE S.A.

AC Nordic Management S.à r.l.

Adeo Management S.A.

Alfred

All Consulting Europe S.A.

Almacantar Shaftesbury S.à r.l.

Anchorage Venture Lab S.A.

a-part s.à r.l.

Argos Soditic Partners S.A.

Benetton International S.A.

BHR Luxembourg S.à r.l.

Bluegreen S.A.

CEREP AIR 2 S.à r.l.

CEREP Ambroise S.à.r.l.

CEREP Bac S.à.r.l.

CEREP Bellini 1 S.à r.l.

CEREP Bellini 2 S.à r.l.

CEREP Benelux Students S.à r.l.

Challenger Reassurance

Cilaos S.à r.l.

Cole Objekt Kistlerhofstrasse GmbH

COMAGRAF Electronic-Grafic-Systems S.à r.l.

Compagnie Générale de Promotion S.A.

Crismagand, société de gestion de patrimoine familial

Cyclone International Holdings Branch

Degato International S.à r.l.

dfl Group S.à r.l.

Digital Realty (St Denis) S.à r.l.

Divine Investments S.A.

Dylux S.A.

Glasswall Europe S.à r.l.

M Group Investments S.A.

Natixis-Cape S.A.

Professional Care Holding S.à r.l.

Professional Classic Ballet School

Quaesta Capital Umbrella SICAV-SIF

Regulus Investments S.A.

RN S.C.A. SICAR

S&amp;B Minerals Participations S.A.

Schenkenberg S.A.

Schleich Luxembourg S.A.

SC Invest S.A.

SC Luxembourg Investments S.à r.l.

SVL-LuxInvest SCS SICAF-SIF

Tasselot S.A.

TCC Investments Luxembourg S.à r.l.

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Thomson Reuters Finance S.A.

Tierra S.A.

Tiledrasi S.A.

Timaru S.A. SPF

Tornio Investments S.A.

Trilantic Events Management S.à r.l.

UBS Third Party Management Company S.A.

Unibeton Luxembourg S.A.

Verone S.A.

VH Estates S.A.

VIII F Chateau S.à r.l.

Zwickau Arcaden Luxco