logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1965

13 août 2013

SOMMAIRE

Barlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94278

Dartmouth Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

94274

Dominion DMG Luxembourg S.A.  . . . . . . .

94274

Eastern Beverage Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

94276

Euro Holiday Properties S.A. . . . . . . . . . . . .

94276

Euroports Port Acquisitions Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94275

Euroports SHRU Holdings S.à r.l. . . . . . . . .

94274

F.C.D. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94275

Fidex Audit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94279

G4S General Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

94276

Gaillon S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94274

Geldilux-TS-2010 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94275

General Electric International Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94286

Globus Equity SICAV SIF  . . . . . . . . . . . . . . .

94275

Grand Vision Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

94279

Gutburg Immobilien S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

94292

Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94278

Holbourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94278

Horizon French Property Partnership Ma-

nagement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94277

Ice Cream  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94278

Jona Universal Corporation S.A. . . . . . . . . .

94278

Jona Universal Corporation S.A. . . . . . . . . .

94279

KBC Participations Renta  . . . . . . . . . . . . . . .

94277

Kiribati S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94279

Kochab S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94279

Lemon Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94277

Libertim Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

94277

Logistis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

94280

Lombard International Assurance S.A. . . .

94305

Lumber Liquidators Overseas Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94280

Marigny Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .

94320

Marjin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94309

Masselotte S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94320

Maxalice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94276

Merloffice S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94320

Milford Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94284

Milford Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94284

Mindgate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94280

Miraumont S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94284

Multi-Solar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94284

Nobil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94283

Noga S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94283

Oceaneering Holdings Sarl  . . . . . . . . . . . . . .

94283

Oceaneering International Holdings LLC

SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94283

Oceaneering Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

94283

OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94284

PAH Luxembourg 2 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

94317

Probat Construction s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

94282

Probat Construction s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

94282

Promo Petrole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94281

Pusan S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94280

Q Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94282

Q Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94281

Quo Vadis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94281

Quo Vadis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94281

Quo Vadis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94281

Q.Y S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94285

Raystown Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94282

Ricoh Luxembourg PSF S.à r.l.  . . . . . . . . . .

94282

Sopasa Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

94313

94273

L

U X E M B O U R G

Dartmouth Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.937.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

Dartmouth Luxembourg S.à r.l.
Martin P. Galliver
<i>Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2013083855/14.
(130103646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Dominion DMG Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 143.340.

<i>Extrait du procès-verbal d'une réunion (la «Réunion») du conseil d'administration de la société du 7 juin 2013.

<i>Résolution

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe au 33, Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat.

<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013083871/12.
(130104126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Euroports SHRU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.202.

EXTRAIT

Par les résolutions écrites du 24 juin 2013 les gérants de la Société ont décidé de transférer, à compter du 24 juin

2013, le siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 44, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013083891/13.
(130103619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Gaillon S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 140.113.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2013

L'assemblée renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société Deloitte Audit S.àr.l., ayant son siège

social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 67895.

Le mandat de réviseur d'entreprises agréé ainsi nommée viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se

tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013083968/15.
(130103308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94274

L

U X E M B O U R G

Globus Equity SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 158.639.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

<i>Pour: GLOBUS EQUITY SICAV SIF
Société Anonyme sous la forme de SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé
Experta Luxembourg
Société anonyme
Nathalie Lett / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013084004/16.
(130103570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Geldilux-TS-2010 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 155.505.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 24 juin 2013

Le conseil décide de transférer avec effet au 1 

er

 juillet 2013 le siège social de la société du 43 boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg au 11 rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2013.

Référence de publication: 2013083972/12.
(130103222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

F.C.D. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 146.678.

<i>Résolution 1.

Changement d'adresse siège social
Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117, Val des Bons Malades. L-2121 Luxembourg,

Luxembourg à partir du 19 

ème

 Juin 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Juin 2013.

Référence de publication: 2013083928/13.
(130103603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Euroports Port Acquisitions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.542.

EXTRAIT

Par les résolutions écrites du 24 juin 2013 les gérants de la Société ont décidé de transférer, à compter du 24 juin

2013, le siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 44, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013083890/13.
(130103618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94275

L

U X E M B O U R G

Eastern Beverage Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 161.286.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

Pour extrait conforme
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013083898/12.
(130103783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Euro Holiday Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 59.766.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2013083921/13.
(130103949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

G4S General Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 17.614.

En modification du dépôt initial L130102631, le bilan ECDF modifié au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 Juin 2013.

Anne PERINO
<i>Directeur Financier

Référence de publication: 2013084012/13.
(130103336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Maxalice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 128.954.

<i>I. Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au 12, rue Eugène Ruppert L-2453

<i>Luxembourg, le 25 juin 2013

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution:

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet au 6 juin 2013 de Monsieur Christophe Blondeau, administrateur.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de l'Administrateur sortant, avec effet au 6 juin 2013,

Madame Brigitte DENIS, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen. Elle terminera le mandat
de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MAXALICE S.A.

Référence de publication: 2013084160/16.
(130103599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94276

L

U X E M B O U R G

Lemon Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 130.722.

I. Monsieur Philippe STOCK, employé privé demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 LUXEM-

BOURG est nommé, en tant qu'Administrateur de la Société en remplacement de Madame Isabelle SCHUL. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2016.

II. Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

Madame Françoise DUMONT est nommée en tant que Président du Conseil d'Administration. Elle assumera cette fonc-
tion pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Le 17 juin 2013.

C. PISVIN / F.DUMONT
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013084128/16.
(130103691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Libertim Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.611.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

TMF Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2013084130/12.
(130103288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

KBC Participations Renta, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 73.076.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2013.

<i>Pour la société
Karel De Cuyper
<i>Directeur

Référence de publication: 2013084096/13.
(130103455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Horizon French Property Partnership Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 115.159.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Juin 2013.

Jean-Jacques Josset
<i>Gérant B

Référence de publication: 2013084030/13.
(130103521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94277

L

U X E M B O U R G

Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 146.838.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084014/11.
(130103815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Holbourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 105.781.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013084029/11.
(130104077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Ice Cream, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.114.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

Jabir Chakib
<i>Gérant

Référence de publication: 2013084038/12.
(130103857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Jona Universal Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 104.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013084084/11.
(130104127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Barlux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 28.300.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013084544/9.
(130104866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2013.

94278

L

U X E M B O U R G

Fidex Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 48.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDEX AUDIT S. à r.l.
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013083949/11.
(130103700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Grand Vision Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 165.333.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher.

Carlo GOEDERT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013084006/12.
(130104110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Jona Universal Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 104.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013084085/11.
(130104128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Kiribati S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013084100/10.
(130103346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Kochab S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 164.289.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013084102/10.
(130103508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94279

L

U X E M B O U R G

Logistis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 22.191.497,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.171.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013084133/10.
(130104250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.675.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 26 juin 2013

1. Monsieur Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
2. Madame Valérie PECHON a démissionné de son mandat de gérante de classe A.
3. Monsieur Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né le 23 mai 1978 à Schiltigheim (France), demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de classe
A pour une durée indéterminée.

4. Monsieur Christophe Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés, né le 22 janvier 1985 à Ottignies (Belgique),

demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant de classe A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26 juin 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084119/20.
(130103837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Mindgate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 113.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 26/06/2013.

Référence de publication: 2013084178/10.
(130104223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Pusan S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 54.027.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 juin 2013

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, bou-

levard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, comme Président du Conseil d'Administration pour une période venant à
échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013084275/14.
(130103678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94280

L

U X E M B O U R G

Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 22.275.

Les comptes annuels au 31/12/2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013084282/10.
(130103475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 22.275.

Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013084283/10.
(130103476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Quo Vadis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 25, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 22.275.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013084284/10.
(130103477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Q Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 121.797.

Conformément à l'article 150 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en liquidation, le bilan

au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013084278/11.
(130104034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Promo Petrole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.829.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Steinfort, le 21 JUIN 2013.

<i>Pour PROMO PETROLE S.A.
World Hopper s.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2013084272/13.
(130103316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94281

L

U X E M B O U R G

Probat Construction s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.637.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013084270/10.
(130104002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Probat Construction s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.637.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013084271/10.
(130104003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Raystown Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.351.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

Référence de publication: 2013084297/10.
(130104063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Q Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 121.797.

Conformément à l'article 150 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en liquidation, le bilan

au 30 juin 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2013084277/11.
(130104033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Ricoh Luxembourg PSF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.652.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 37, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 111.300.

EXTRAIT

Monsieur Eric DE BOSSCHERE a démissionné avec effet au 30 juin 2013 de son mandat de gérant.

Pour extrait sincère et conforme
Delphine de Timary
<i>Avocat

Référence de publication: 2013084293/13.
(130104069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94282

L

U X E M B O U R G

Oceaneering Holdings Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Oceaneering Holdings Sarl
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084205/11.
(130103559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Oceaneering International Holdings LLC SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 165.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Oceaneering International Holdings LLC SCS
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084206/11.
(130103567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Oceaneering Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.108.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Oceaneering Luxembourg Sarl
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084207/11.
(130103568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Nobil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 163.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour NOBIL S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013084196/11.
(130103531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Noga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 62.682.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013084197/10.
(130103624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94283

L

U X E M B O U R G

Milford Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Référence de publication: 2013084175/10.
(130104030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Milford Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2013.

Référence de publication: 2013084176/10.
(130104071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Miraumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.287.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013084179/10.
(130103519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.113.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2013.

Figen EREN
<i>Gérant

Référence de publication: 2013084215/12.
(130103337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Multi-Solar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 56.339.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire tenu le 19 juin 2013 que Monsieur ROLLINGER Sammy,

employé privé, demeurant au L-8126 Bridel 2, rue Guillaume Stolz, a été nommé nouvel administrateur jusqu'à l'Assemblée
Générale à tenir en 2014 en remplaçant Monsieur ROLLINGER Serge, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013084187/12.
(130103401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

94284

L

U X E M B O U R G

Q.Y S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 100, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 178.168.

STATUTS

L'an deux mille treize.
Le trente mai.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU

1.- Monsieur Jianping CHEN, restaurateur, né à Fujian (Chine) le 13 octobre 1962
demeurant à B-1030 Bruxelles, 335, chaussée de Louvain
ici représenté par Monsieur Xiaobo XU, comptable, demeurant à L-354 9 Dudelange, 5, rue de la Rivière,
agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé annexée au présent acte.
2.- Madame Qing CHEN, serveuse, née à Fujian (Chine) le 03 décembre 1965,
demeurant à B-1030 Bruxelles, 335, chaussée de Louvain
ici représenté par Monsieur Xiaobo XU, comptable, demeurant à L-3549 Dudelange, 5, rue de la Rivière,
agissant en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé annexée au présent acte.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

Q.Y S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet la gestion et l'exploitation des stands au sein des surfaces commerciales dont l'activité

principale consiste à préparer et commercialiser des produits relevant de l'appelation générale de sushis ainsi que la
distribution d'autres aliments frais élaborés sur place.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch/Alzette.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

94285

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Jianping CHEN, prénommé, SOIXANTE-DIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Madame Qing CHEN, prénommée, TRENTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, présents ou représentés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

générale et à l'unanimité des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Est nommé gérant technique de la société: Monsieur Jianping CHEN, prénommé,
II.- Est nommé gérant administratif de la société: Madame Qing CHEN, prénommée,
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à L-4340 Esch/Alzette, 100, rue de l'Usine.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Xu, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 juin 2013. Relation: EAC/2013/7055. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013084280/78.
(130103659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

General Electric International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.439.480,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 62.841.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-first day of May,
Before Maître Marc LOESCH, notary residing at Mondorf (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of

Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep the original
of this deed,

there appeared:

(1) General Electric Services Luxembourg S.à r.l., having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxem-

bourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under no. B.
62.661 ("GESL"), duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing pro-
fessionally at Esch/Alzette, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a power of attorney given on May
21 

st

 , 2013 and

(2) GE Holdings Luxembourg &amp; Co S.à r.l., having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg,

the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry under no. B. 56.198
("GEHL"), duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally
at Esch/Alzette, Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a power of attorney given on May 21 

st

 ,

2013.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereinabove, requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing parties are the sole legal and economic beneficiaries of the entire issued and paid up share capital of

General Electric International Holdings S.à r.l., a private company with limited liability according to the laws of the Grand

94286

L

U X E M B O U R G

Duchy  of  Luxembourg  (société  à  responsabilité  limitée),  having  its  registered  offices  at  5,  rue  des  Capucins,  L-1313
Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Registry (Registre
de Commerce et des Sociétés) under no. B. 62.841, incorporated on December 18, 1997 by deed of Maître Gérard
LECUIT, published in the Official Gazette of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of April 30,
1998, number 300, whose articles of association were last amended on June 9, 2010 by notarial deed of Maître Martine
SCHAEFFER, published in the Official Gazette of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of
August 27, 2010, number 1755 (such company hereinafter: the "Company");

II. The appearing parties wish to proceed to an extraordinary general meeting of shareholders of the Company, of

which the agenda is worded as follows:

a) Waiver of convening formalities.
b)  Acknowledgement  by  the  shareholders  of  the  Company,  that  the  Company's  issued  and  paid  up  share  capital

amounts to two million four hundred thirty-nine thousand four hundred eighty euro (EUR 2,439,480.-) and is divided into
(i) thirty-nine thousand one hundred seventy-eight (39,178) class A shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-)
each (the "Class A Shares") all held by GESL and that the share premium account attaching to the Class A Shares as per
the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to three hundred sixty seven
million four hundred fourteen thousand one hundred eighty eight Euro and seventy nine Euro cents (EUR 367,414,188.79)
and (ii) twenty-one thousand eight hundred and nine (21,809) class B shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-)
each (the "Class B Shares"), all held by GEHL and that the share premium account attaching to the Class B Shares as per
the date of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to sixteen million two hundred
eighty nine thousand six hundred and seven Euro and seventy eight Euro cents (EUR 16,289,607.78).

c) Redenomination of the Company's share capital by reduction of the nominal value of the shares class A and the

shares class B from forty Euro (EUR 40.-) to one Euro cent (EUR 0.01) and simultaneous cancellation of the different
share classes in the Company's capital and emission of two hundred and forty three million nine hundred and forty eight
thousand (243,948,000) ordinary shares of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each in replacement of the Class
A Shares and the Class B Shares (the "Replacement Shares").

d) Amendment of the provisions of Art. 5.1. of the articles of association of the Company as follows:

Art. 5.1. The share capital of the company is set at two million four hundred thirty-nine thousand four hundred eighty

euro  (EUR  2,439,480),  represented  by  two  hundred  and  forty  three  million  nine  hundred  and  forty  eight  thousand
(243,948,000) ordinary shares of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, in registered form, all subscribed and
fully paid-up."

e) Abolishment of the separate share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class B Shares, as a

result of which the Company shall only have one share premium reserve, amounting as per the date of this notarial deed
to a value of three hundred eighty three million seven hundred three thousand seven hundred ninety six Euro and fifty
seven Euro cents (EUR 383,703,796.57) in aggregate.

f)  Acknowledgement  of  the  redenomination  of  the  share  capital  by  each  of  GEHL  and  GESL,  evidencing  that  the

economic entitlement of each of GEHL and GESL shall pre- and post redenomination of the Company's share capital and
pre- and post redenomination of the Company's share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class
B Shares remain unaltered, and reallocation of the Replacement Shares among GESL and GEHL whereby GESL shall hold
two hundred and thirty three million one hundred and five thousand eight hundred and thirty nine (233,105,839) registered
ordinary shares of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each in the share capital of the Company entitling GESL
to an amount of three hundred sixty six million six hundred fifty thousand two hundred fifty Euro and forty Euro cents
(EUR 366,650,250.40) of the share premium reserve of the Company and GEHL shall hold ten million eight hundred and
forty two thousand one hundred and sixty one (10,842,161) ordinary registered shares of a nominal value of one Euro
cent (EUR 0.01) each, entitling GEHL to an amount of seventeen million fifty three thousand five hundred forty six Euro
and seventeen Euro cents (EUR 17,053,546.17) of the share premium reserve of the Company.

g) Amendment of the provisions of Article 6.2. of the Company's articles of association to read as follows:

Art. 6.2. Each share gives right to a fraction of the total net assets and profits of the Company proportionate to the

total number of shares in issue."

h) Amendment of the provisions of article 15.2 of the Company's articles of association to read as follows:

Art. 15.2. Each shareholder shall be entitled to a fraction of the balance remaining, proportionate to the participation

by a shareholder in the issued share capital of the company."

i) Miscellaneous.
The general meeting of shareholders of the Company ("Meeting") then took the following resolutions unanimously:

<i>First resolution

The entire share capital being present or validly represented, the Meeting waived any and all formalities in relation to

the holding of a general meeting of shareholders of the Company, considered itself as duly convened and declared to
have full knowledge of the agenda of the present resolutions which was communicated in advance.

94287

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Meeting resolved to acknowledge that the Company's issued and paid up share capital amounts to two million

four hundred and thirty nine thousand four hundred and eighty Euro (EUR 2,439,480.-) and is divided into (i) thirty-nine
thousand one hundred seventy-eight (39,178) class A shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "Class
A Shares") all held by GESL and that the share premium account attaching to the Class A Shares as per the date of the
extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to three hundred sixty seven million four hun-
dred fourteen thousand one hundred eighty eight Euro and seventy nine Euro cents (EUR 367,414,188.79) and (ii) twenty-
one thousand eight hundred and nine (21,809) class B shares of a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "Class
B Shares"), all held by GEHL and that the share premium account attaching to the Class B Shares as per the date of the
extraordinary general meeting of shareholders of the Company amounts to sixteen million two hundred eighty nine
thousand six hundred and seven Euro and seventy eight Euro cents (EUR 16,289,607.78).

<i>Third resolution

The Meeting resolved to re-denominate the Company's share capital by reduction of the nominal value of the shares

class A and the shares class B from forty Euro (EUR 40.-) to one Euro cent (EUR 0.01) and simultaneous cancellation of
the different share classes in the Company's capital and emission of the Replacement Shares.

<i>Fourth resolution

Consequently, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 5.1. of the articles of association of the Com-

pany as follows:

Art. 5.1. The share capital of the company is set at two million four hundred thirty-nine thousand four hundred eighty

thousand euro (EUR 2,439,480.-), represented by two hundred and forty three million nine hundred and forty eight
thousand (243,948,000) ordinary shares of a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, in registered form, all
subscribed and fully paid-up."

<i>Fifth resolution

Following the redenomination of the Company's share capital, the Meeting resolved to abolish the notion of separate

share premium reserves attaching to the Class A Shares and the Class B Shares, as a result of which the Company shall
only have one share premium reserve, amounting as per the date of this notarial deed to a value of three hundred eighty
three  million  seven  hundred  three  thousand  seven  hundred  ninety  six  Euro  and  fifty  seven  Euro  cents  (EUR
383,703,796.57) in aggregate.

<i>Sixth resolution

Further to the redenomination of the Company's share capital and its share premium reserves, the Meeting resolved

that the economic entitlement of each of GEHL and GESL pre- and post redenomination of the Company's share capital
and pre-and post redenomination of the Company's share premium reserves attaching to the Class A Shares and the
Class B Shares should remain unaltered, and consequently resolved to reallocate the Company's issued share capital to
each of GESL and GEHL, as a result of which GESL is allocated two hundred and thirty three million one hundred and
five thousand eight hundred and thirty nine (233,105,839) registered ordinary shares of a nominal value of one Euro cent
(EUR 0.01) each in the share capital of the Company (the "New GESL Shares"), entitling GESL to an amount of three
hundred sixty six million six hundred fifty thousand two hundred fifty Euro and forty Euro cents (EUR 366,650,250.40)
of the share premium reserve of the Company and GEHL is allocated ten million eight hundred and forty two thousand
one hundred and sixty one (10,842,161) ordinary registered shares of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each
(the "New GEHL Shares"), entitling GEHL to an amount of seventeen million fifty three thousand five hundred forty six
Euro and seventeen Euro cents (EUR 17,053,546.17) of the share premium reserve of the Company.

Thereupon GESL and GEHL, duly represented by their proxy as referred to hereinabove, intervened and accepted

the New GESL Shares and the New GEHL Shares allocated to each of them and declared to accept their entitlement to
the share premium reserve of the Company proportionate to their participation in the Company's issued share capital,
thus entitling GESL as from the date of these resolutions to three hundred sixty six million six hundred fifty thousand
two hundred fifty Euro and forty Euro cents (EUR 366,650,250.40) of the share premium reserve of the Company and
entitling GEHL to an amount of seventeen million fifty three thousand five hundred forty six Euro and seventeen Euro
cents (EUR 17,053,546.17) of the share premium reserve of the Company.

<i>Seventh resolution

Further to the resolutions referred to hereinabove, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 6.2. of

the articles of association of the Company as follows:

Art. 6. Each share gives right to a fraction of the total net assets and profits of the Company proportionate to the

total number of shares in issue."

94288

L

U X E M B O U R G

<i>Eighth resolution

Further to the resolutions referred to hereinabove, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 15.2. of

the articles of association of the Company as follows

Art. 15.2. Each shareholder shall be entitled to a fraction of the balance remaining, proportionate to the participation

by a shareholder in the issued share capital of the company."

<i>Estimated costs

The cost, remuneration or expenses, which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at

approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that as per the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a version in French.

At the request of the same appearing parties it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the

French version of this deed, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf, on the date first mentioned above. The notarial deed

having been read to the representatives of the appearing parties, the said persons signed together with the notary, this
present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille treize, le vingt-et-unième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en rem-

placement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) lequel
dernier restera dépositaire de la présente minute,

ont comparu:

(1) General Electric Services Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B. 62.661 («GESL»), ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de
résidence professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 21 mai 2013 et

(2) GE Holdings Luxembourg &amp; Co S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand

Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 56.198
(«GEHL»), ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence
professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 21 mai 2013, lesquelles procurations, après
avoir été signées "ne varietur" par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Les parties comparantes, par leur mandataires, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I Les parties comparantes représentent l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée établie à

Luxembourg sous la dénomination "General Electric International Holdings S. à r.l.", ayant son siège social au 5, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B. 62.841, constituée suivant acte de Maître Gérard LECUIT reçu en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 30 avril 1998 no. 300, dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant
acte de Maître Martine SCHAEFFER, reçu en date du 9 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du 27 août 2010, no. 1755 (ci-après: la «Société»).

II Les parties comparantes souhaitent de procéder à une assemblée générale des associés extraordinaire de la Société,

dont l'ordre du jour et libellé comme suit:

a) Renonciation aux formalités de convocation de l'assemblée générale des associés de la Société;
b) Constatation par les associés de la Société, que le capital social de la Société est fixé à deux million quatre cent

trente neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (2 439 480 EUR) divisé en trente neuf mille cent soixante-dix-huit (39
178) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune (les «Parts Sociales de
Catégorie A») toutes détenues par GESL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie
A en date des présentes s'élève trois cent soixante-sept million quatre cent quatorze mille cent quatre-vingt huit euros
et soixante dix-neuf centimes d'euro (367 414 188.79 EUR) et (ii) vingt et un mille huit cent neuf (21 809) parts sociales
de catégorie B d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B»), toutes
détenues par GEHL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie B en date des
présentes s'élève à seize million deux cent quatre-vingt neuf mille six cent sept euro et soixante dix-huit centimes d'euro
(16 289 607.78 EUR)

c) Redénomination du capital social de la Société par réduction de la valeur nominale des parts sociales de catégorie

A et les parts sociales de catégorie B de quarante euros (40.- EUR) à un centime d'euro (0,01 EUR) et l'annulation
simultanément des différentes catégories de parts sociales dans le capital social de la Société et l'émission de deux cent
quarante trois million neuf cent quarante huit mille parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro

94289

L

U X E M B O U R G

(0,01 EUR) en remplacement les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales
de Remplacement»).

d) Modification des dispositions de l'article 5.1. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante: "Art.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux million quatre cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt euros (2
439 480.-EUR), représenté par deux cent quarante trois million neuf cent quarante-huit mille (243 948 000) parts sociales
ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, sous forme nominative, toutes souscrites et
entièrement libérées.»

e) Suppression des réserves distinctes de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts

Sociales de Catégorie B, à la suite de laquelle la Société aura seulement une réserve de prime d'émission d'un montant
qui s'élève en date des présentes à trois cent quatre-vingt trois million sept cent trois mille sept cent quatre-vingt seize
euros et cinquante-sept centimes d'euro (383 703 796.57 EUR) au total.

f) Constatation par chacun de GEHL et GESL, attestant que les droits économiques de chacun de GEHL et GESL, pré-

et post redénomination du capital social de la Société et pré- et post redénomination des réserves de prime d'émission
de la Société attachés aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B resteront inchangés et
réaffectation des Parts Sociales de Remplacement parmi GESL et GEHL, par suite de laquelle GESL détiendra deux cent
trente-trois million cent cinq mille huit cent trente-neuf (233,105,839) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune dans le capital de la Société, donnant droit à GESL pour un montant de trois
cent soixante-six million six cent cinquante mille deux cent cinquante euro et quarante centimes d'euro (366 650 250.40
EUR) au compte de prime d'émission et GEHL détiendra dix million huit cent quarante-deux mille cent soixante-et-un
(10 842 161) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacun, donnant droit à
GEHL pour un montant dix-sept million cinquante-trois mille cinq cent quarante-six euro et dix-sept centimes d'euro (17
053 546.17 EUR) au compte de prime d'émission de la Société.

g) Modification des dispositions de l'article 6.2. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

« Art. 6.2. Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif net total et les bénéfices de la société proportionnelle

au nombre total de parts sociales en circulation.»

h) Modification des dispositions de l'article 15.2. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

Art. 15.2. Chaque associé a droit à une fraction du solde restant, proportionnelle à la participation d'un associé au

capital social de la Société.

i) Divers.
L'assemblée générale des associés de la Société («l'Assemblée») a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant présent ou représentée à l'assemblée générale des associés, l'Assemblée

décide de renoncer aux toutes formalités de convocation d'une assemblée générale des associés de la Société, se considère
comme être dûment convoqué et déclare avoir pleinement connaissance de l'objet des présentes résolutions qui ont été
communiquées au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée constate que le capital social de la Société est fixé à deux million quatre cent trente-neuf mille quatre

cent quatre-vingt euros (2 439 480.- EUR) et divisé en (i) trente neuf mille cent soixante-dix-huit (39 178) Parts Sociales
de Catégorie A d'une valeur nominale de quarante euros (40.- EUR) chacune toutes détenues par GESL, et que le compte
de prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A en date des présentes s'élève à trois cent soixante-sept
million quatre cent quatorze mille cent quatre-vingt huit euros et soixante dix-neuf centimes d'euro (367 414 188.79
EUR) et (ii) vingt et un mille huit cent neuf (21 809) Parts Sociales de Catégorie B d'une valeur nominale de quarante
euros (40.- EUR) chacune, toutes détenues par GEHL, et que le compte de prime d'émission attachant aux Parts Sociales
de Catégorie B en date des présentes s'élève à seize million deux cent quatre-vingt neuf mille six cent sept euro et soixante
dix-huit centimes d'euro (16 289 607.78 EUR).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de redéfinir le capital social de la Société par réduction de la valeur nominale des parts sociales

de catégorie A et les parts sociales de catégorie B de quarante euros (40.- EUR) à un centime d'euro (0,01 EUR) et
d'annuler simultanément les différentes catégories de parts sociales dans le capital social de la Société et d'émettre les
Parts Sociales de Remplacement.

<i>Quatrième Résolution

L'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'Article 5.1. des statuts de la Société, afin de leur donner la teneur

suivante:

Art. 5.1. Le capital social de la société est fixé à deux million quatre cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt

euros (2 439 480.-EUR), représenté par deux cent quarante trois million neuf cent quarante-huit mille (243 948 000)

94290

L

U X E M B O U R G

parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, sous forme nominative, toutes
souscrites et entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

Suite à la redénomination du capital social de la Société, l'Assemblée décide de supprimer les réserves distinctes de

prime d'émission attachant aux Parts Sociales de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B, à la suite de laquelle
la Société aura seulement une réserve de prime d'émission d'un montant en date des présentes trois cent quatre-vingt
trois million sept cent trois mille sept cent quatre-vingt seize euros et cinquante-sept centimes d'euro (383 703 796.57
EUR) au total.

<i>Sixième résolution

Suite à la redéfinition du capital social de la Société et la suppression des réserves distinctes de prime d'émission,

l'Assemblée décide que le droits économiques de chacun de GEHL et GESL, pré- et post redénomination du capital social
de la Société et pré- et post redénomination des réserves de prime d'émission de la Société attachés aux Parts Sociales
de Catégorie A et aux Parts Sociales de Catégorie B, resteront inchangés et décide de réaffecter des Parts Sociales de
Remplacement parmi GESL et GEHL, par suite de laquelle l'Assemblée constate que GESL détiendra deux cent trente-
trois million cent cinq mille huit cent trente-neuf (233,105,839) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un
centime d'Euro (0,01 EUR) chacune («Les Nouvelles Parts Sociales GESL») dans le capital de la Société, donnant droit à
GESL à partir du date des présentes pour un montant de trois cent soixante-six million six cent cinquante mille deux cent
cinquante euro et quarante centimes d'euro (366 650 250.40 EUR) au compte de prime d'émission et GEHL détiendra
dix million huit cent quarante-deux mille cent soixante-et-un (10 842 161) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacun («Les Nouvelles Parts Sociales GEHL»), donnant droit à GEHL pour un montant
de dix-sept million cinquante-trois mille cinq cent quarante-six euro et dix-sept centimes d'euro (17 053 546.17 EUR).

A ce stade GESL et GEHL sont intervenues, dûment représentée par leur mandataire telle que décrite ci-dessus, et

ont accepté Les Nouvelles GESL Parts Sociales et Les Nouvelles GEHL Parts Sociales attribuées à chacun d'entre eux et
ont déclaré d'accepter leur droits à la réserve de prime d'émission de la Société proportionnellement à leur participation
dans le capital social de la Société, donc donnant droit à GESL à partir du date des présentes pour un montant de trois
cent soixante-six million six cent cinquante mille deux cent cinquante euro et quarante centimes d'euro (366 650 250.40
EUR)et donnant droit à GEHL pour un montant de dix-sept million cinquante-trois mille cinq cent quarante-six euro et
dix-sept centimes d'euro (17 053 546.17 EUR) du compte de prime d'émission de la Société.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide, à la suite de résolutions prises ci-dessus, de modifier les dispositions de l'article 6.2. de statuts

de la Société, afin de leur donner la teneur suivante:

« Art. 6.2. Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif net total et les bénéfices de la société proportionnelle

au nombre total de parts sociales en circulation.»

<i>Huitième résolution

En fin, l'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'article 15.2. des statuts de la Société, afin de leur donner

la teneur suivante:

Art. 15.2. Chaque associé a droit à une fraction du solde restant, proportionnelle à la participation d'un associé au

capital social de la Société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont ACTE, passé à Mondorf, date qu'en tête.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: Conde, Loesch.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 mai 2013. Relation: EAC/2013/6662. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013083238/300.
(130102700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

94291

L

U X E M B O U R G

Gutburg Immobilien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 177.713.

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of June,
before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Gutburg Immobilien S.A., a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 177.713 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand

Duchy  of  Luxembourg,  acting  in  replacement  of  Maître  Henri  Beck,  notary  residing  in  Echternach,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, on May 30, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles
of association of the Company (the Articles) have been amended once pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on June 14, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Ms Peggy Simon, private employee, residing professionally at Echternach, 9, Rabatt.
She appoints herself as scrutineer and elects as secretary Ms Mariette Schou residing professionally at Echternach, 9,

Rabatt (the Chairpeson, the secretary and the scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the
Meeting).

The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment of the corporate object of the Company which should forthwith read as follows:

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object".

3. Amendment to article 5 of the Articles to (i) authorise the board of directors of the Company to increase the

corporate capital with a total amount of EUR 500,000.- and (ii) limit or withdraw the shareholders' preferential sub-
scription rights to the new shares

4. Subsequent amendment and full restatement of the articles of association of the Company (the Articles); and
5. Miscellaneous.
II. The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of

shares they hold are indicated on an attendance list (the Attendance List). Such Attendance List after having been signed
ne varietur by the proxyholder(s) of the Shareholders, the Bureau of the Meeting and the undersigned notary shall remain
attached to the present deed.

III. It appears from the Attendance List, that one hundred per cent (100%) of the shares in the share capital of the

Company are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of
the agenda which has previously been communicated to the Shareholders of the Company.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

94292

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being present or represented at the Meeting, the Bureau of the

Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and de-
claring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend the corporate object of the Company which should forthwith read as follows:

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object".

<i>Third resolution

The Meeting acknowledges the special report of the board of directors of the Company established in accordance

with article 32-3(5) of the Law. Said report, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of
the Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Meeting then resolves to amend article 5 fifth indent of the Articles which shall henceforth read as follows:
"The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the shareholders' resolutions

inserting the authorisation of an authorised capital in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations) to:

(i) increase the share capital, in one or several times, in cash and/or in kind, with a total amount of five hundred thousand

euro (EUR 500,000.-), by the issue of twenty five thousand (25,000) new shares having a par value of twenty euro (EUR
20.-), having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons

who are authorised to subscribe to the new shares; and

(iii) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register accordingly.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend and fully restate the articles which shall henceforth read as follows:

I. "Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is Gutburg Immobilien S.A. (the Company). The Company is a public company

limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-

94293

L

U X E M B O U R G

porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at four million eight hundred teen thousand sixty six hundred euro (EUR 4,810,660.-),

represented by two hundred forty thousand five hundred fifty three (240,553) shares in registered form, each shares
having a nominal value of twenty euro (EUR 20) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting, acting in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the shareholders'

resolutions inserting the authorisation of an authorised capital in the Luxembourg official gazette (Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations) to:

(i) increase the share capital, in one or several times, in cash and/or in kind, with a total amount of five hundred thousand

euro (EUR 500,000.-), by the issue of twenty five thousand (25,000) new shares having a par value of twenty euro (EUR
20.-), having the same rights as the existing shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons

who are authorised to subscribe to the new shares; and

(iii) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register accordingly.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed

and dated by either:

(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Company,
following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil

Code.

6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both

parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.6. Payment on shares not fully paid up at the time of subscription shall be made at the time and upon conditions

determined by the Board.

6.7. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.

94294

L

U X E M B O U R G

III. Management - Representation

Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors need

not be shareholders.

(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of

their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment
at the expiry of their term of office.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The

permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions
in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it
represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on

a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.

7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a

director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any director, at the place indicated in the notice, which

in principle shall be in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman
shall have a casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chair-
person, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other

means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held

Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which

conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the
minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A
special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any
vote on any other resolution.

7.4. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom

special signatory powers have been delegated by the Board.

94295

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an

additional shareholder; and

(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a

reference to that sole director, as appropriate.

8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded

in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

Art. 9. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and
the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting) or

by way of written resolutions where appropriate. The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and
operations which are consistent with the Company's corporate object.

(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders

must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10)
of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must

contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form
must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return
the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be
taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor
an abstention shall be considered void.

(viii) Provided that the shareholders unanimously and expressly agree to (i) the waiver of the convening notice as

required by Article 10.2 (ii) of the Articles and (ii) vote in favour of the proposed resolutions, without any amendment
whatsoever, written resolutions signed by all the shareholders shall be valid and binding as if passed at a duly convened
and held General Meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the pro-

portion of share capital represented.

(x) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented

and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to
the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of
notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results
of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of
capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two- thirds of the votes cast.

(xi) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

Art. 11. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one ( 1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

94296

L

U X E M B O U R G

(ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole

shareholder, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first ( 1 

st

 ) of January and ends on the thirty-first (31 

st

 ) of December of each

year.

12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory

stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by the officers, director(s) and statutory auditor(s) to the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on,

and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor shall then prepare a report setting out
their proposals.

12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of

the registered office, as specified in the notice, on the third (3rd) Friday of June of each year at 10.00 a.m. If that day is
not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 13. Auditors.
13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external

auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entre-

prises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the
statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

14.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as ap-

plicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets
and pay its liabilities.

15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by

fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video

94297

L

U X E M B O U R G

conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall
constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time."

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at request of the above appearing

parties, this deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancy between the English and
the German texts, the English version shall prevail.

This deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the date first written above.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the us, the notary, the present
original deed.

Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendunddreizehn, am zwanzigsten Tag des Monats Juni,
Vor mir, dem unterzeichneten Notar Maître Henri Beck, mit Amtssitz in Echternach, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Gutburg Immobilien S.A., eine Aktiengesellschaft

(société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 177.713 (die Gesellschaft), gegründet gemäß notarieller Urkunde
aufgenommen durch Notar Maître Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Henri BECK,
mit dem Amtssitz in Echternach, am 30. Mai 2013, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations. Die Gesellschaftssatzung (die Satzung) wurde seit der Gründung einmal geändert gemäß Urkunde von Notar
Maître Henri Beck, vom 14. Juni 2013, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, beruflich ansässig in Echternach, 9, Ra-

batt.

Sie beruft sich selbst zur Stimmzählerin und ernennt zur Schriftführerin Frau Mariette Schou, Privatbeamtin, beruflich

ansässig in Echternach, 9, Rabatt (die Vorsitzende, die Schriftführerin und die Stimmenzählerin hier nachfolgend das Prä-
sidium der Versammlung).

Das Präsidium der Versammlung ist daher konstituiert und der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes

festzuhalten:

I. dass die Tagesordnung der Versammlung folgende ist:
1. Verzicht auf den Erhalt von Einberufungen;
2. Änderung von Artikel 3 der Gesellschaft (Zweck der Gesellschaft), welcher zukünftig folgenden Inhalt haben wird:

3.1. "Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in¬oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder
Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus
Kreditverbindlichkeiten,  an  ihre  Zweigniederlassungen,  Tochtergesellschaften  und  andere  Gesellschaft  verleihen.  Des
Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforder-
liche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investitionen

effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

94298

L

U X E M B O U R G

3.3. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind."

3. Änderung von Artikel 5 der Satzung um (i) den Verwaltungsrat das Stammkapital der Gesellschaft bis zu einem

Betrag von fünf hunderttausend Euro (EUR 500,000.-) zu erhöhen and (ii) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der
Aktionären für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu widerrufen;

4. Nachträgliche Änderung und vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft (die Satzung); und
5. Sonstiges.
II. Die an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre der Gesellschaft (die Aktionäre) und die Anzahl

der Aktien, welche vom jeweiligen Aktionär gehalten werden, sind in der Anwesenheitsliste vermerkt (die Anwesen-
heitsliste). Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie ne varietur von den Bevollmächtigen der Aktionäre, vom Präsidium
der Versammlung, und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet worden ist, dieser Urkunde angehängt.

III. Gemäss Anwesenheitsliste sind ein hundert Prozent (100%) der Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft anwe-

send oder vertreten an der heutigen Versammlung, daher kann die Versammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung
entscheiden, welche zuvor den Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt worden sind.

Die Versammlung beschliesst folgendes:

<i>Erster Beschluss

Da das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist, verzichtet das Präsidium der Versammlung

auf Einberufungsschreiben, die Aktionäre erachten sich als gültig einberufen und erklären, vollkommene Kenntnis über
die Tagesordnung zu haben, welche ihnen im Voraus mitgeteilt wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 3 der Satzung (Zweck der Gesellschaft) abzuändern, welcher zukünftig folgenden

Inhalt haben wird:

3.1. "Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in¬oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder
Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus
Kreditverbindlichkeiten,  an  ihre  Zweigniederlassungen,  Tochtergesellschaften  und  andere  Gesellschaft  verleihen.  Des
Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforder-
liche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investiti-

onen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind."

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung anerkennt den Sonderbericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft, welche in Übereinstimmung mit

Artikel 32-3 (5) des Gesetzes gegründet wird und, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die erscheinenden Parteien
und Notar, wird dieser Urkunde beigefügt bleiben, um zur gleichen Zeit wie die Urkunde bei den Registrierbehörden
eingereicht zu werden.

Die Versammlung beschließt Artikel 5 der Satzung abzuändern, welcher zukünftig folgenden Inhalt haben wird:
"Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, ist der Verwaltungsrat berechtigt

(i) das Stammkapital der Gesellschaft bis zu einem Betrag von fünf hunderttausend Euro (EUR 500,000.-) zu erhöhen,

durch die Ausgabe von fünfundzwanzig tausend (25,000) Aktien mit einem Nennwert von zwanzig Euro (EUR 20.-), welche
mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien und

94299

L

U X E M B O U R G

(ii)  die  bevorrechtigten  Zeichnungsrechte  der  Aktionären  für  die  neu  ausgegebenen  Aktien  zu  limitieren  oder  zu

widerrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu zeichnen; und

(iii) Jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister ent-

sprechend abzuändern

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Satzungen vollständig neu zu formulieren, welcher zukünftig folgenden Inhalt haben

wird:

Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet Gutburg Immobilien S.A. (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine

Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung
(das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss

des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt wer-
den. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die Hauptversammlung) in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass außerge-
wöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese
Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung
zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur voll-
ständigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Jegliche solcher
vorübergehenden Maßnahmen beeinflussen die Nationalität der Gesellschaft nicht, die ungeachtet einer vorübergehenden
Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder
Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus
Kreditverbindlichkeiten,  an  ihre  Zweigniederlassungen,  Tochtergesellschaften  und  andere  Gesellschaft  verleihen.  Des
Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforder-
liche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investiti-

onen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.

Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, In-

solvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft, aufgelöst.

II. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vier Millionen achthundertzehntausend sechshundert sechzig Euro (EUR

4.810.660,-), bestehend aus zweihundertvierzigtausendfünfhundert dreiundfünfzig Euro (Euro 240.553,-) Gesellschaftsan-
teilen mit einem Nennwert von zwanzig Euro (EUR 20,-).

94300

L

U X E M B O U R G

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Hauptversammlung in Über-

einstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3 Während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach der Veröffentlichung dieser Gründungsurkunde, ist der Ver-

waltungsrat berechtigt:

i) Das aktuelle Stammkapital einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrag von fünf hunderttausend Euro (EUR 500.000,-)

zu erhöhen, durch die Ausgabe von fünfundzwanzig tausend (25.000) Aktien mit einem Nennwert von zwanzig Euro (EUR
20,-), welche mit denselben Rechten ausgestattet sind, wie die bereits existierenden Aktien.

ii) die bevorrechtigten Zeichnungsrechte der Aktionären für die neu ausgegebenen Aktien zu limitieren oder zu wi-

derrufen und zu bestimmen, welche Personen berechtigt sein sollen, die neuen Aktien zu zeichnen; und

iii) Jede Stammkapitalerhöhung in Form einer notariellen Urkunde zu dokumentieren und das Aktienregister entspre-

chend abzuändern.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind und bleiben Namensaktien (actions nominatives).
6.3 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters einge-

sehen werden kann.

6.4 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung in das Aktienregister einer Erklärung der Übertragung,

datiert und unterzeichnet durch:

(i) sowohl den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte Stellvertreter oder
(ii) einen Bevollmächtigten der Gesellschaft,
Eintragung welche einer Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Artikel 1690 des luxem-

burgischen Zivilgesetzbuches folgt.

6.5. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen, die die zwischen

dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.6. Die Zahlung auf Aktien, die zum Zeitpunkt der Zeichnung nicht vollständig gezahlt sind, sollt vom und nach den

Bedingungen des Verwaltungsrats bestimmt werden.

6.7. Die Gesellschaft kann unter Beachtung des Gesetzes ihre eigenen Aktien zurückerwerben.

III. Verwaltung - Vertretungsmacht

Art. 7. Verwaltungsrat.
7.1 Zusammensetzung des Verwaltungsrats
(i) Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher sich aus mindestens drei (3) Verwaltungs-

ratsmitgliedern zusammensetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein.

(ii) Die Hauptversammlung der Gesellschaft ernennt die einzelnen Verwaltungsmitglieder und bestimmt deren Anzahl,

Vergütung und Amtszeit. Die Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern darf einen Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht
überschreiten; Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.

(iii) Verwaltungsratsmitglieder können durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit (mit oder ohne Grund) ab-

berufen werden.

(iv) Sofern eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese einen ständigen Stellvertreter

bestimmen, welcher diese in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied vertritt. Der ständige Stellvertreter unterliegt
denselben Regelungen und haftet als habe er sein Amt in eigenem Namen für sich selbst handelnd vorgenommen, unab-
hängig von der gesamtschuldnerischen Haftung der juristischen Person die er vertritt.

(v) Sollte der ständige Stellvertreter nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben, hat die juristische Person umgehend

einen neuen ständigen Stellvertreter zu bestimmen.

(vi) Sollte das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds frei werden, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder

durch einfachen Mehrheitsbeschluss die freie Stelle vorläufig neu besetzen, bis die nächste Hauptversammlung einen neues
Verwaltungsratsmitglied ernennt.

7.2 Befugnisse des Verwaltungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung den Aktionären vorbehalten

sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Verwaltungsrat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen

oder mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen.

(iii) Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis die Gesell-

schaft in diesem Zusammenhang zu vertreten, auf einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Vorstände, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich bei diesen Personen um Aktionäre
handelt oder nicht, welche sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich handeln können. Sofern die Verwaltung des laufenden

94301

L

U X E M B O U R G

Geschäftsverkehrs auf ein oder mehrere Verwaltungsgratsmitglieder übertragen worden sein sollte, muss der Verwal-
tungsrat der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt, Gebühren und/oder Vorteile diesem/diesen Verwal-
tungsratsmitglied(ern) während des jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

7.3 Verfahren
(i) Der Verwaltungsrat muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen und kann einen Schriftführer

auswählen, der nicht zwangsläufig ein Verwaltungsratsmitglied sein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher
Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen zuständig ist.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von einem (1) Verwaltungsratsmitglieder trifft sich der Verwaltungs-

rat, an einem in der Bekanntmachung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Bekanntmachung einer jeden Versammlung des Verwaltungsrates geht allen Verwaltungsratsmit-

gliedern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art
und Umstand sodann in der Bekanntmachung darzulegen sind.

(iv) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates bei der Versammlung an-

wesend oder vertreten sind und jeder von ihnen erklärt, dass ihm die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt
ist. Auf eine Bekanntmachung kann ein Verwaltungsratsmitglied zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig
verzichten. Gesonderte schriftliche Bekanntmachungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung han-
delt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Verwaltungsrat
verabschiedet wurde.

(v)  Ein  Verwaltungsratsmitglied  kann  einem  anderen  Verwaltungsratsmitglied  eine  Vollmacht  erteilen,  um  sich  bei

Versammlung des Verwaltungsrates vertreten zu lassen.

(vi)  Der  Verwaltungsrat  ist  nur  tagungs-  und  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrheit  seiner  Mitglieder  anwesend  oder

vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden. Im Falle einer Stimmengleichheit steht dem Vorsitzenden die
streitentscheidende Stimme zu. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche
von dem Vorsitzenden oder von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom
Schriftführer (wenn vorhanden) unterzeichnet werden müssen.

(vii) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare

Kommunikationsmittel, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören
und miteinander zu kommunizieren, an einer Versammlung des Verwaltungsrates teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist
einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(viii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind (Zirkularbeschlüsse der

Verwaltungsratsmitglieder), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen
und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

(ix) Ein Verwaltungsratsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer

über das tägliche Geschäft hinausgehenden Transaktion hat, muss den Verwaltungsrat darüber unterrichten und hierüber
eine Niederschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied
darf an den Beratungen nicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist den Aktionären auf der
nächsten Hauptversammlung vor jeglicher Beschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten.

7.4 Stellvertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von

mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift einer jeden Person, an welche der Ver-

waltungsrat Spezialvollmachten übertragen hat, verpflichtet.

Art. 8. Alleiniger Direktor.
8.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert ist:
(i) kann die Gesellschaft, bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung welche nach der Aufnahme eines weiteren

Aktionärs erfolgt, durch einen alleinigen Direktor verwaltet werden; und

(ii) sind alle Verweise der Satzung die sich auf den Verwaltungsrat, die Verwaltungsratsmitglieder, einige Verwaltungs-

ratsmitglieder oder ein Verwaltungsmitglied beziehen, auf den alleinigen Direktor sinngemäß anzuwenden.

8.2. Transaktionen welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen protokolliert werden wenn sich das

alleinige Verwaltungsratsmitglied in einem Interessenkonflikt befinden könnte. Dies trifft nicht auf Transaktionen zu, die
im Rahmen des allgemeinen Tagesgeschäft der Gesellschaft durchgeführt werden.

Art. 9. Haftung der Verwaltungsratsmitglieder. Verwaltungsratsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich

haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche
Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften sind.

94302

L

U X E M B O U R G

IV. Aktionär(e)

Art. 10. Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Vollmachten und Stimmrechte
(i)  Beschlüsse  der  Aktionäre  werden  bei  Hauptversammlungen  der  Aktionäre  (die  Hauptversammlung)  oder  bei

schriftliche  Gesellschafterbeschlüsse  der  Aktionäre  verabschiedet.  Die  Hauptversammlung  hat  das  umfassende  Recht
jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Aktie gewährt eine (1) Stimme.
10.2 Bekanntmachung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Die Aktionäre können durch den Rat oder den/die Wirtschaftsprüfer zur Hauptversammlung einberufen werden.

Eine Generalversammlung muss auf Anfrage von Aktionären, welche mehr als ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einberufen werden.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung einer jeden Hauptversammlung geht allen Aktionären spätestens acht (8) Tage

im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Bekanntmachung dazulegen
sind.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Bekanntmachung genannten Ort, zur in der Bekanntmachung

genannten Zeit statt.

(iv) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung

informiert betrachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Bekanntmachung abgehalten werden.

(v) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Jeder Aktionär kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, welches

es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommuni-
zieren,  an  einer  Hauptversammlung  teilnehmen.  Eine  solche  Teilnahme  ist  einer  persönlichen  Teilnahme  an  dieser
Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Jeder Aktionär gibt seine Stimme auf einem von der Gesellschaft zu diesem Zweck ausgegebenen Wahlzettel ab.

Die Wahlzettel müssen das Datum, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung, sowie den vorgeschlagenen Text
der Beschlüsse angeben. Für jeden Beschluss muss der Wahlzettel drei Felder enthalten, welche es dem Aktionär er-
möglichen, sich für oder gegen den Beschluss zu entscheiden oder sich von der Wahl zu enthalten. Die Aktionäre müssen
die Wahlzettel an den Gesellschaftssitz zurücksenden. Nur die Wahlzettel, die bis zum Beginn der Hauptversammlung
eingegangen sind, können bei der Berechnung der Beschlussfähigkeit berücksichtigt werden. Wahlzettel die weder eine
Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss), noch eine Enthaltung enthalten, sind nichtig.

(viii)  Sofern  die  Aktionären  einstimmig  sind  und  ausdrücklich  zustimmen  auf  (i)  den  Verzicht  auf  die  Einberufung/

schriftliche Bekanntmachung gemäß Artikel 10.2(ii) der Satzung erforderlich ist und (ii) für die vorgeschlagenen Beschlüsse
abstimmen, ohne Änderung auch immer, schriftliche Gesellschafterbeschlüsse, welche von allen Aktionäre unterzeichnet
sind, sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Haupt-
versammlung der Aktionäre gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

(ix) Beschlüsse der Hauptversammlung können durch eine einfache Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden

Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertretenen Stammkapitals.

(x)  Eine  außerordentliche  Hauptversammlung  kann  die  Satzung  nur  abändern,  wenn  die  Hälfte  des  Stammkapitals

vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie den Text der vorgeschlagenen
Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht
erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Bekanntmachung in einem
fünfzehn (15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltung der Hauptversammlung im Mé-
morial und in zwei luxemburgischen Zeitungen, einberufen werden. Diese Bekanntmachung muss die Tagesordnung der
Hauptversammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung wiedergeben. Die zweite
Hauptversammlung kann unabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlich entscheiden. Bei beiden
Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(xi) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber

der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre und Inhaber von Schuldtiteln (wenn vorhanden).

Art. 11. Alleiniger Aktionär.
11.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird:
(i) übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zustehen;
(ii) Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf

den alleinigen Aktionär; und

(iii) die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

94303

L

U X E M B O U R G

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
12.2 Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine

Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der
Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Verwaltungsratsmitglieder und dem/der satzungsmäßigen
Wirtschaftsprüfer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3  Einen  Monat  vor  der  jährlichen  Hauptversammlung  legt  der  Verwaltungsrat  dem/den  satzungsmäßigen  Wirt-

schaftsprüfer(n) Urkundenbeweise hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Der/die satzungsmäßige(n) Wirt-
schaftsprüfer erstell(t/en) daraufhin einen Bericht, der ihre Erkenntnisse und Vorschläge enthält.

12.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Bekanntmachung

angegebenen Ort der Gemeinde, am dritten Freitag im Juni eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in
Luxemburg kein Werktag, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

Art. 13. Wirtschaftsprüfer.
13.1 Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem oder mehreren satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert

(commissaires).

13.2 Sofern dies vom Gesetz vorgeschrieben ist, wird der Betrieb der Gesellschaft von einem oder mehreren geneh-

migten externen Wirtschaftsprüfern (réviseurs d'entreprises agréés) überprüft.

13.3 Die Hauptversammlung ernennt die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer (commissaires) / genehmigten externen

Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) und bestimmt deren Anzahl, Vergütung und Amtszeit. Die Amtszeit der
satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer darf den Zeitraum von sechs (6) Jahren nicht überschreiten, aber sie können wie-
dergewählt werden.

Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1 Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage

zugeführt (die Gesetzliche Rücklage). Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die Gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2 Die Hauptversammlung entscheidet auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns

zu verfügen ist. Sie kann mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto
einzahlen oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen als Gewinn vortragen.

14.3 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) der Verwaltungsrat fertigt einen Zwischenabschluss an;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagios) zur Aus-

schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um
die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der ge-
setzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Verwaltungsrat innerhalb von zwei

(2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) in ihrem Bericht an den Verwaltungsrat müssen die satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfer (commissaires), oder die

genehmigten externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d' entreprises agréé) soweit anwendbar, prüfen, ob die oben genannten
Bedingungen erfüllt wurden.

VI. Auflösung und Liquidation

15.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung unter Beachtung der für die Sat-

zungsänderung geltenden Bestimmungen aufgelöst werden. Die Hauptversammlung ernennt einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt
ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Hauptversammlung, haben
die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen.

15.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten, wird unter den Aktionären

im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Aktien aufgeteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1  Mitteilungen  und  Benachrichtigungen  können  angefertigt  oder  es  kann  darauf  verzichtet  werden,  Zirkularbe-

schlüsse der Verwaltungsratsmitglieder und Wahlzettel der Aktionäre können durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im
Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert werden.

94304

L

U X E M B O U R G

16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Verwaltungsratssitzung können von einem Verwaltungsratsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat
genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt es werden alle

gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüs-
sen der Verwaltungsratsmitglieder oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen
auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und
dasselbe Dokument bilden.

16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-

enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Vorsitzende die Versammlung.

WORÜBER URKUNDE, Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit

auf Verlangen der oben genannten, erschienenen Parteien, diese Urkunde ist in englischer Sprache erstellt worden ist,
gefolgt von einer deutschen Version. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Version,
hat die englische Version Vorrang.

Diese Urkunde ist in Echternach, Grossherzog Luxemburg, am oben zuerst genannten Datum erstellt worden.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem insturmentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unteschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 juin 2013. Relation: ECH/2013/1180. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 21. Juni 2013.

Référence de publication: 2013084011/742.
(130103263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Lombard International Assurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 37.604.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of the month of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Me Rachel Germain, maître en droit, residing in Luxembourg, as delegate duly appointed by the board of directors

(the "Board") of Lombard International Assurance S.A. (the "Company"), a société anonyme incorporated under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 37.604, incorporated on 26 July 1991 by deed of Me Christine
Doerner, notary residing in Bettembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mé-
morial C") number 338 of 13 

th

 September 1991. The articles of association of the Company were last amended on 12

November 2012 by deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C
number 2996 of 11 December 2012.

The appearing party, acting in its capacity as delegate of the Board pursuant to a proxy, requested the notary to record

the following declaration:

(I) Article 5 paragraphs (1) and (3) of the articles of association of the Company provide as follows:

5.1.  The  Company  has  an  issued  share  capital  of  two  million  six  thousand  eight  hundred  and  seventy  five  euro

(€2,006,875) represented by a total of two hundred million six hundred eighty-seven thousand five hundred (200,687,500)
fully  paid  Shares,  each  with  a  nominal  value  of  one  euro  cent  (€0.01)  divided  into  various  Classes,  Sub-Classes  and
Categories of Shares as follows, with such rights and obligations as set forth in the present Articles:

one hundred ninety-nine million eight hundred twenty-four thousand six hundred eighty-eight (199,824,688) FP Shares;
two hundred eighty-seven thousand six hundred four (287,604) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-

Classes  as  follows:  eight  thousand  six  hundred  seventy-six  (8,676)  Category  BC1  Shares,  ninety-two  thousand  nine
hundred seventy-six (92,976) Category BC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category
BC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC4 Shares;

94305

L

U X E M B O U R G

two hundred eighty-seven thousand six hundred four (287,604) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-

Classes  as  follows:  eight  thousand  six  hundred  seventy-six  (8,676)  Category  CC1  Shares,  ninety-two  thousand  nine
hundred seventy-six (92,976) Category CC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category
CC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC4 Shares;

two hundred eighty-seven thousand six hundred four (287,604) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-

Classes  as  follows:  eight  thousand  six  hundred  seventy-six  (8,676)  Category  DC1  Shares,  ninety-two  thousand  nine
hundred seventy-six (92,976) Category DC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category
DC3 Shares and ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC4 Shares.

(...)

5.3. Upon the acquisition of any SR Shares by the holder(s) of the FP Shares after the Restatement Date (other than

the Reserve SR Shares) or with respect to Reserve SR Shares held by the Reserve Holder after Year 6, such SR Shares
(including for the avoidance of doubt, the Reserve SR Shares) shall automatically be re-classified as FP Shares on an one
to one ratio. The Board of Directors (or its delegates) shall record such re-classification in the register of Shareholders
of the Company and in the Articles and have the present Articles amended accordingly.

(II) Pursuant to share transfers effective 28 May 2013, eighty-four thousand three hundred (84,300) BC2 shares, eighty-

four thousand three hundred (84,300) CC2 shares and eighty-four thousand three hundred (84,300) DC2 shares, being
a total of two hundred fifty-two thousand nine hundred (252,900) SR Shares (as defined in the Company's articles of
association), have been transferred to the Reserve Holder (as defined in the Company's articles of association) (the
"Transfer").

(III) In accordance with the terms of article 5.3 of the Company's articles of association, the two hundred fifty-two

thousand nine hundred (252,900) SR Shares transferred to the Reserve Holder, have automatically been reclassified into
FP Shares on a one to one ratio, being two hundred fifty-two thousand nine hundred (252,900) FP Shares as a result of
the transfer.

(IV) As a consequence of the above reclassification, the shares currently issued by the Company are divided into

different classes and categories as follows:

two hundred million seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (200,077,588) FP Shares;
two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes

as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six
(8,676) Category BC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC3 Shares and ninety-
two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes

as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six
(8,676) Category CC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC3 Shares and ninety-
two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes

as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six
(8,676) Category DC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC3 Shares and ninety-
two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC4 Shares.

The appearing party then requested the notary to record the reclassification described above and further requested

that as a result of such reclassification, paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company be amended,
so as to read as follows:

5.1. The Company has an issued share capital of two million six thousand eight hundred and seventy five euro

(€2,006,875) represented by a total of two hundred million six hundred eighty-seven thousand five hundred (200,687,500)
fully  paid  Shares,  each  with  a  nominal  value  of  one  euro  cent  (€0.01)  divided  into  various  Classes,  Sub-Classes  and
Categories of Shares as follows, with such rights and obligations as set forth in the present Articles:

two hundred million seventy-seven thousand five hundred eighty-eight (200,077,588) FP Shares;
two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class B Shares divided into four Capitalising Sub-Classes

as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category BC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six
(8,676) Category BC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC3 Shares and ninety-
two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category BC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class C Shares divided into four Capitalising Sub-Classes

as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category CC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six
(8,676) Category CC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC3 Shares and ninety-
two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category CC4 Shares;

two hundred three thousand three hundred four (203,304) Class D Shares divided into four Capitalising Sub-Classes

as follows: eight thousand six hundred seventy-six (8,676) Category DC1 Shares, eight thousand six hundred seventy-six
(8,676) Category DC2 Shares, ninety-two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC3 Shares and ninety-
two thousand nine hundred seventy-six (92,976) Category DC4 Shares."

94306

L

U X E M B O U R G

(V) Pursuant to the terms of articles 16.4, 16.5 and 16.6 of the articles of association of the Company, the Entitlement

(as defined in the articles of association of the Company) relating to each category of SR Shares shall be reduced accor-
dingly to the decrease of the number of SR Shares as a result of the Transfer.

As a consequence, the appearing party requested the notary as a result of the reclassification and the decrease of SR

Shares, to amend each time the first sentence of articles 16.4.2.1, 16.5.2.1, 16.6.2.1, of the articles of incorporation of the
Company, so as to read as follows:

16.4.2.1. Categories BC2 and BD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the B Trigger at the end

of Year 4, in the aggregate to an amount of one hundred eighty thousand seven hundred fifty euro (€180,750) (the "B2
Entitlement")."

16.5.2.1. Categories CC2 and CD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the C Trigger at the end

of Year 4, in the aggregate to 0.434% of the C Excess (the "C2 Entitlement")."

16.6.2.1. Categories DC2 and DD2 entitle the holders thereof, subject to the occurrence of the D Trigger at the

end of Year 4, in the aggregate to 0.289% of the D Excess (the "D2 Entitlement")."

<i>Costs

The approximate amount of the costs, expenses or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the

Company as a result of the present deed, is approximately evaluated to thousand five hundred Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de juin.
Par-devant, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Me Rachel Germain, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de ses pouvoirs de délégué du conseil

d'administration (le «Conseil») de Lombard International Assurance S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son
siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 37.604, constituée suivant acte de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à
Bettembourg, en date du 26 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»)
sous le numéro 338 du 13 septembre 1991. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu le 12 novembre
2012 suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C numéro
2996 du 11 décembre 2012.

La partie comparante, agissant en sa qualité de délégué du Conseil conformément à une procuration, a demandé au

notaire d'acter ses déclarations comme suit:

(I) L'Article 5 paragraphes (1) et (3) des statuts de la Société prévoit ce qui suit:

5.1. La Société a un capital social émis de deux millions six mille huit cent soixante-quinze euros (2.006.875 €) repré-

senté par un total de deux cent millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (200.687.500) Actions entièrement
libérées, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (€0,01) par action, divisées comme suit en diverses
Classes, Sous-Classes et Catégories d'Actions, avec les droits et obligations tels que précisés dans les présents Statuts:

cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-huit (199.824.688) Actions FP;
deux cent quatre-vingt-sept mille six cent quatre (287.604) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Ca-

pitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC1, quatre-vingt-douze mille
neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC2r quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976)
Actions de Catégorie BC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC4;

deux  cent  quatre-vingt-sept  mille  six  cent  quatre  (287.604)  Actions  de  Classe  C  divisées  en  quatre  Sous-Classes

Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC1r quatre-vingt-douze mille
neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976)
Actions de Catégorie CC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC4;

deux  cent  quatre-vingt-sept  mille  six  cent  quatre  (287.604)  Actions  de  Classe  D  divisées  en  quatre  Sous-Classes

Capitalisantes comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC1, quatre-vingt-douze mille
neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976)
Actions de Catégorie DC3 et quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC4.»

(...)

5.3. Suite à l'acquisition d'Actions SR par le(s) détenteur(s) des Actions FP après la Date de Refonte (autres que les

Actions SR de Réserve) ou en ce qui concerne les Actions SR de Réserve détenues par le Détenteur de Réserve après

94307

L

U X E M B O U R G

l'Année 6r de telles Actions SR (y compris, afin d'éviter tout doute, les Actions SR de Réserve) seront automatiquement
reclassées comme Actions FP sur base d'un taux de un à un. Le Conseil d'Administration (ou ses délégués) enregistrera
une telle reclassification dans le registre des Actionnaires de la Société et dans les Statuts et fera modifier les présents
Statuts en conséquence».

(II) Suite à des transferts d'actions avec effet au 28 mai 2013, quatre-vingt-quatre mille trois cents (84.300) actions

BC2, quatre-vingt-quatre mille trois cents (84.300) actions CC2, quatre-vingt-quatre mille trois cents (84.300) actions
DC2, étant un total de deux cent cinquante-deux mille neuf cents (252.900) Actions SR (telles que définies dans les statuts
de la Société) ont été transférées au Détenteur de Réserve (tel que défini dans les statuts de la Société) (le «Transfert»).

(III) Conformément aux termes de l'article 5.3 des statuts de la Société, les deux cent cinquante-deux mille neuf cents

(252.900) Actions SR transférées au Détenteur de Réserve, ont automatiquement été reclassifiées en Actions FP sur base
d'un taux de un à un, étant deux cent cinquante-deux mille neuf cents (252.900) Actions FP résultant du transfert.

(IV) En conséquence de la reclassification sus- mentionnée, les actions actuellement émises par la Société sont divisées

en différentes classes et catégories comme suit:

deux cents millions soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (200.077.588) Actions FP;
deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes

comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)

Actions de Catégorie BC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC3 et

quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes

comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)
Actions de Catégorie CC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC3 et
quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes

comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)
Actions de Catégorie DC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC3 et
quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC4.

La partie comparante a ensuite demandé au notaire de constater la reclassification décrite ci-dessus et a en plus

demandé qu'en résultat de cette reclassification, le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société sera modifié comme
suit: «5.1 La Société a un capital social émis de deux millions six mille huit cent soixante-quinze euros (2.006.875 €)
représenté par un total de deux cent millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (200.687.500) Actions entièrement
libérées, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (€0,01) par action, divisées comme suit en diverses
Classes, Sous-Classes et Catégories d'Actions, avec les droits et obligations tels que précisés dans les présents Statuts:

deux cents millions soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (200.077.588) Actions FP;
deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe B divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes

comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie BC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)
Actions  de  Catégorie  BC2,  quatre-vingt-douze  mille  neuf  cent  soixante-seize  (92.976)  Actions  de  Catégorie  BC3  et
quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie BC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe C divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes

comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie CC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)
Actions de Catégorie CC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC3 et
quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie CC4;

deux cent trois mille trois cent quatre (203.304) Actions de Classe D divisées en quatre Sous-Classes Capitalisantes

comme suit: huit mille six cent soixante-seize (8.676) Actions de Catégorie DC1, huit mille six cent soixante-seize (8.676)
Actions de Catégorie DC2, quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC3 et
quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-seize (92.976) Actions de Catégorie DC4.»

(V) Selon les termes des articles 16.4, 16.5 et 16.6 des Statuts de la Société, le Droit (tel que défini dans les statuts de

la Société) relatif à chaque catégorie d'Actions SR sera réduit conformément à la réduction du nombre d'actions SR
résultant du Transfert.

En conséquence, la partie comparante a demandé au notaire de modifier, en résultat de la reclassification et de la

réduction des Actions SR, les articles 16.4.2.1, 16.5.2.1 et 16.6.2.1, afin de se lire comme suit:

« 16.4.2.1. Les Catégories BC2 et BD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du B

Trigger à la fin de l'Année 4, à un montant total de cent quatre-vingt mille sept cent cinquante euros (180.750 €) (le "Droit
B2").»

« 16.5.2.1. Les Catégories CC2 et CD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du C

Trigger à la fin de l'Année au total à 0,434% de l'Excès C (le "Droit C2").»

« 16.6.2.1. Les Catégories DC2 et DD2 donnent droit aux présents détenteurs, sous réserve de la survenance du D

Trigger à la fin de l'Année 4, au total à 0,289% de l'Excès D (le "Droit D2").»

94308

L

U X E M B O U R G

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés

à mille cinq cents Euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent

constat est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, la mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: R.GERMAIN, J.ELVINGER
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 20 juin 2013. Relation: LAC/2013/28355. Reçu soixante quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I.THILL.

Référence de publication: 2013084134/212.
(130103811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Marjin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.138.

STATUTS

L'an deux mille treize, le onze juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Jérôme MARTINELLE, né le 29 mars 1975 à Crehange, demeurant au 17, rue des Maraichers à F-67560

Rosheim,

ici représenté par:
Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme de participations financières que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «MARJIN S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet l'acquisition, la gestion d'investissement immobilier, ainsi que la mise en valeur de ce

propre patrimoine immobilier.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions six cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 3.690.000.-) divisé trois mille

six cent quatre-vingt-dix (3.690) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.

Les actions sont nominatives.

94309

L

U X E M B O U R G

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
La société peut en outre émettre des actions rachetables et procéder au rachat de celles-ci dans les conditions de

l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000.-) qui sera représenté par cinquante (50.000)

actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents

statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans
les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec
ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
La société peut en outre émettre des actions rachetables et procéder au rachat de celles-ci dans les conditions de

l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Usufruit et Nue-propriété

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée

soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour l'assemblée se prononçant sur la

mise en liquidation de la société,

- droit aux dividendes.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun pour autant qu'ils n'aient pas été expressément réservés ci-avant à l'usufruitier et en particulier le droit
au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie, par inscription dans le registre

des actionnaires, de la façon suivante:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit»,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété».

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

94310

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société sera engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de

catégorie B, soit par la signature individuelle du Président.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 2013.

94311

L

U X E M B O U R G

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

<i>Souscription et Libération

Monsieur Jérôme MARTINELLE, prénommé, déclare souscrire à toutes les actions et décide de les libérer entièrement

par un apport:

- d'un million deux cent cinquante-deux mille neuf cent cinquante-neuf (1.252.959) actions avec bons de souscription

d'actions (ABSA) de la société par actions simplifiée «Technology &amp; Strategy Group», ayant son siège social au 4, avenue
de la Paix, F-67000 Strasbourg, évaluées à un million cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante euros (EUR
1.591.250.-);

- d'un million huit cent soixante-dix-neuf mille quatre cent trente-huit (1.879.438) obligations convertibles en actions

(OCA) de la société par actions simplifiée «Technology &amp; Strategy Group», ayant son siège social au 4, avenue de la Paix,
F-67000 Strasbourg, évaluées à deux millions quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 2.098.750.-);

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 7 juin 2013, par GSL Révision Sàrl, réviseur

d'entreprises, Esch-sur-Alzette, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport
restera, annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l'apport en nature de 3.690.000 EUR, déterminée selon les méthodes décrites ci-dessus, ne correspond pas au moins à
3.690 actions d'une valeur nominale de 1.000 EUR de MARJIN S.A. à émettre en contrepartie.»

La preuve de la propriété des actions apportées et le transfert de celles-ci au profit de la Société a été rapportée au

notaire soussigné.

Le souscripteur garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits

en faveur de tiers et qu'aucun consentement ou agrément n'est requis pour le présent apport.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinq mille euros.

<i>Décision de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

<i>Administrateurs de catégorie A:

1) Monsieur Jérôme MARTINELLE, né le 29 mars 1975 à Crehange, demeurant au 17, rue des Maraichers à F-67560

Rosheim,

<i>Administrateurs de catégorie B:

2) Monsieur Alain GEURTS, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, demeurant pro-

fessionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Madame Frédérique MIGNON, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au

12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

4) Monsieur Guillaume SCROCCARO, né le 9 septembre 1977 à Thionville, demeurant professionnellement au 12,

rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Monsieur Jérôme MARTINELLE, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
«A&amp;C Management Services S.à r.l.», ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l'an 2017.

94312

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire de la partie comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 juin 2013. Relation: EAC/2013/7688. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013083387/214.
(130102820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

Sopasa Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 117.145.

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of May.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue

de la Liberté (RCS Luxembourg B.103.336), here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in
Junglinster, 3, route de Luxembourg; by virtue of one proxy under private seal,

holding One Hundred Twenty-Four (124) shares in the share capital of the Company ("ATC");
2) RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue

de la Liberté (RCS Luxembourg B.103.337), here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in
Junglinster, 3, route de Luxembourg; by virtue of one proxy under private seal,

holding One Hundred Twenty-Four (124) shares in the share capital of the Company ("RCS").
The said proxies, signed "ne varietur' by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

ATC and RCS (the "Shareholders"), represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact

the following:

- the Shareholders are the current shareholders of SOPASA PARTICIPATIONS SA, a société anonyme, organised and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 117.145, and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary residing
then in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), dated 1 

st

 June 2006 the articles of which have been published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 August 2006 page number 1761 (hereafter referred as to the
"Company");

- the articles of incorporation of the Company (the "Articles") have not been amended since the incorporation of the

Company.

All this having been declared, the appearing parties, holding Two Hundred Forty Eight (248) shares corresponding to

100% of the share capital of the Company, represented as stated here above, have immediately proceeded to hold an
extraordinary general meeting and have taken the following resolutions:

<i>1. First resoltion

The Shareholder decide to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 11,561,250

(eleven million five hundred sixty-one thousand two hundred fifty Euros) so as to bring the Company's share capital from
its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) to EUR 11,592,250 (eleven million five hundred ninety-
two thousand two hundred fifty Euros) by the issue of the 92,490 (ninety-two thousand four hundred ninety) new ordinary
shares (the "New Shares"), each having a par value of EUR 125 (one hundred twenty - five Euros) subject to the payment
of a share premium in the amount of premium of EUR 62,52 (sixty-two Euros and fifty-two Cents).

<i>2. Second resolution

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Payment - Description of the contribution

ATC and RCS having waived to their subscription right, the Shareholders accept the subscription of the New Shares

as follows:

94313

L

U X E M B O U R G

- Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement, having registered address at 16 bou-

levard des Tranchées, 1206 Genève, Switzerland ("Butterfield") here represented by Mr Max MAYER, prenamed, by virtue
of a proxy given under private seal, declares to subscribe to 92,490 (Ninety-Two Thousand Four Hundred Ninety) New
Shares of the Company for a total subscription price of 11,561,250 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand
Two Hundred Fifty Euros) and to pay up a total share premium amounting to Sixty-Two Euros and Fifty- Two Cents
(EUR 62.52-) and to have the New Shares and the total share premium fully paid up by way of the contribution in kind
hereafter described:

1) Description of the contribution
A liquid, certain and immediately payable claim amounting to EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-

One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents) in aggregate held by Butterfield as represented here
above against the Company (the «Claim»).

2) Evidence of the contribution's existence and value
Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by a contribution in

kind report drawn up by Alter Audit, independent auditor (réviseur d'entreprises), having its professional address at 2
place de Strasbourg, L-2962 Luxembourg, and which concludes as follows in his report:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des  apports  ne  correspond  pas  au  moins  au  nombre  et  à  la  valeur  nominale  des  actions  à  émettre  en  contrepartie
augmentés de la prime d'émission».

3) Evaluation of the contribution in kind
The value of the contribution in kind is deemed to amount to EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-

One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents).

4) Effective implementation of the contribution in kind
Butterfield, contributor, represented as stated above, hereby declares that:
- it currently holds the Claim against the Company amounting to a EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred

Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents);

-  the  contributed  liquid,  certain  and  immediately  payable  Claim  is  currently  outstanding  for  an  amount  of  EUR

11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and Fifty-Two Cents).

The General Meeting representing one hundred percent (100%) of the issued share capital of the Company accepts

unanimously the subscription to the New Shares by Butterfield.

The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Payment

All the 92,490 (Ninety-Two Thousand Four Hundred Ninety) New Shares to be issued have been fully subscribed and

paid up and the share premium of EUR 62.52 (Sixty-Two Euros and Fifty-Two Cents) has been paid by Butterfield so that
the amount of EUR 11,561,312.52 (Eleven Million Five Hundred Sixty-One Thousand Three Hundred Twelve Euros and
Fifty-Two Cents) is at the free disposal of the Company as it has been certified to the notary by the report of the
independent auditor above-mentioned.

- Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company

is owned as follows:

Shareholder

Total

number

of

Shares

Share

capital

in EUR

Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement . . . . . . . . . . . . .

92,490 11,561,250

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

15,500

RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

15,500

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92,738 11,592,250

<i>3. Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company so that

it will henceforth read as follows:

« Art. 5. The corporate capital is fixed at eleven million five hundred ninety-t thousand two hundred fifty Euros (EUR

11,592,250) represented by ninety-two thousand seven hundred thirty-Eight (92,738) with a par value of one hundred
and twenty-five Euro (125.- EUR) each.

There being no further business, the meeting is terminated.

94314

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 5,200.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the

beginning of this deed.

After  the  document  having  been  read  and  explained  to  the  empowered  of  the  appearing  persons,  known  to  the

officiating notary, by name, surname, civil status and residence, he signed together with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente-et-un mai,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la

Liberté, (RCS Luxembourg B.103.336) ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnelle-
ment à Junglinster, 3, route de Luxembourg; en vertu d'une (1) procuration sous seing privé,

détenant cent vingt-quatre (124) actions ( «ATC»);
2) RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la

Liberté (RCS Luxembourg B.103.337), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnelle-
ment à Junglinster, 3, route de Luxembourg; en vertu d'une (1) procuration sous seing privé,

détenant cent vingt-quatre (124) actions («RCS»).
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietuf par les parties comparantes et le notaire ins-

trumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

ATC et RCS (les «Actionnaires») représentés comme dit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant qu'il établisse

que:

- Les Actionnaires sont les actionnaires actuels de SOPASA PARTICIPATIONS SA, une société anonyme, organisée

et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de
la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 117.145, et constituée par acte notarié par devant Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence
à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1 

er

 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations du 17 août 2006 (ci-après la «Société»);

- Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis la constitution de la Société;
Ces faits ayant été déclarés, les parties comparantes, détenant Deux cent Quarante Huit (248) actions correspondant

à 100% du capital social de la Société, représentées comme ci-dessus, ont immédiatement procédé à la tenue d'une
assemblée générale extraordinaire et pris les résolutions suivantes:

<i>1. Première résolution

Les Actionnaires décident d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 11.561.250,- EUR (onze millions cinq

cent soixante et un mille deux cent cinquante Euros) afin de le porter du montant de son montant actuel de 31.000,- EUR
(trente et un mille Euros) à 11.592.250,- EUR (onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent cinquante Euros)
par  la  création  et  l'émission  de  92.490  (quatre-vingt-douze  mille  quatre  cent  quatre-vingt-dix)  actions  nouvelles  (les
«Nouvelles Actions») d'une valeur nominale de 125,- EUR (cent vingt-cinq Euros) chacune ensemble avec une prime
d'émission d'un montant de 62,52 EUR (soixante-deux Euros et cinquante-deux Cents).

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale accepte la souscription des Nouvelles Actions

comme suit:

Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement, ayant pour adresse le 16 boulevard des

Tranchées, 1206 Genève, Suisse, («Butterfield»), ici représenté par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire 92.490 (quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix)
Nouvelles Actions de la Société pour un prix total de souscription de EUR 11.561.250,- EUR (onze millions cinq cent
soixante et un mille deux cent cinquante Euros) et payer une prime d'émission d'un montant total de 62,52 EUR (soixante-
deux Euros et cinquante-deux Cents), et libérer intégralement les actions et payer la prime d'émission par un apport en
nature comme décrit ci-après:

94315

L

U X E M B O U R G

<i>2. Seconde résolution

ATC et RCS ayant renoncé à leur droit de souscription, les Actionnaires acceptent la souscription des Nouvelles

Actions comme suit:

<i>Souscription - Libération - Description de l'apport

1) Description de l'apport
Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-

et-un  mille  trois  cent  douze  Euros  et  cinquante-deux  Cents)  détenue  par  Butterfield  à  l'encontre  de  la  Société  (la
«Créance»).

2) Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution

a été donnée au notaire instrumentant par un rapport d'apport en nature établi par Alter Audit, réviseur d'entreprises,
ayant son adresse professionnelle au 2 place de Strasbourg, L-2962 Luxembourg, et qui conclut de la manière suivante
dans son rapport:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des  apports  ne  correspond  pas  au  moins  au  nombre  et  à  la  valeur  nominale  des  actions  à  émettre  en  contrepartie
augmentés de la prime d'émission».

3) Evaluation de l'apport en nature
La valeur de l'apport en nature est estimée à EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille

trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents).

4) Réalisation effective de l'apport en nature
Butterfield, apporteur, représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il détient la Créance d'une valeur de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent

douze Euros et cinquante-deux Cents) à l'encontre de la Société;

-  la  Créance  apportée  est  actuellement  liquide,  certaine,  et  immédiatement  exigible  pour  un  montant  de  EUR

11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents).

L'Assemblée Générale, réunissant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, accepte à l'unanimité la sou-

scription des actions nouvelles par Butterfield.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants représentés comme dit ci-avant et par

le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre
et de l'enregistrement.

<i>Libération

Toutes les 92.490 (quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-dix) Nouvelles Actions ont été intégralement

souscrites et libérées et la prime d'émission de 62,52 EUR,- (Soixante Deux Euros et Cinquante Deux Cents) a été payée
par les souscripteurs, de sorte que la somme de EUR 11.561.312,52 EUR (onze millions cinq cent soixante-et-un mille
trois cent douze Euros et cinquante-deux Cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant par le rapport du réviseur susmentionné.

- Suite à l'augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital de la Société est détenu comme

suit:

Actionnaire

Nombre

total

d’actions

Capital

social

en EUR

Butterfield Trust (Switzerland) Limited as trustee of the Magnolia Settlement . . . . . . . . . . .

92.490 11.561.250

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

15.500

RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

15.500

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.738 11.592.250

<i>3. Troisième résolution

Les Actionnaires DECIDENT de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, lequel devra

désormais être lu comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à 11.592.250,- EUR (onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent

cinquante Euros) représenté par quatre-vingt-douze mille sept cent trente-huit (92.738) d'une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

L'Ordre du Jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 5.200,- EUR.

94316

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les parties comparantes ont requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdites parties comparantes,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster (Grand - Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant,

connu du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2013. Relation GRE/2013/2316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013083580/217.
(130102450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

PAH Luxembourg 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.884.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette.

THERE APPEARED:

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, a limited liability company (société à responsabilité limitée), ex-

isting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 93.997, represented by Me James MURPHY, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
in Luxembourg, on November 27, 2012.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, is the sole part holder in PAH LUXEM-

BOURG  2  SARL,  incorporated  on  December  21,  2011,  with  registered  office  at  51  avenue  JF  Kennedy,  L-1885
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 165884, published in the
Mémorial C number 385, on February 14 2012 (the "Company"), by deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in
Niederanven.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The sole part holder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of TWENTY ONE MILLION

THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE U.S. DOLLARS (USD 21,388,251.-)
to bring it from its present amount of SEVEN HUNDRED TWENTY THREE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOU-
SAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 723,611,749.-) to the amount of SEVEN HUNDRED
FORTY FIVE MILLION U.S. DOLLARS (USD 745,000,000.-) by the creation and the issue of TWENTY ONE MILLION
THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE (21,388,251) new shares having a par
value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each (the "New Shares"), having the same rights and obligations as the existing
shares, together with total issue premium of ONE HUNDRED SEVENTY NINE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN
THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 179,611,749.-).

The aggregate contribution of TWO HUNDRED AND ONE MILLION U.S. DOLLARS (USD 201,000,000.-) in relation

to the New Shares is allocated as follows: (i) TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND
TWO HUNDRED FIFTY ONE U.S. DOLLARS (USD 21,388,251.-) to the share capital of the Company and (ii) ONE
HUNDRED SEVENTY NINE MILLION SIX HUNDRED ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY NINE U.S.
DOLLARS (USD 179,611,749.-) to the share premium account of the Company.

<i>Subscription

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, prenamed, represented as stated hereabove has declared to sub-

scribe for the TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY
ONE (21,388,251) New Shares, and to pay them a total price of TWENTY ONE MILLION THREE HUNDRED EIGHTY
EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY ONE U.S. DOLLARS (USD 21,388,251.-) together with total issue pre-
mium  of  ONE  HUNDRED  SEVENTY  NINE  MILLION  SIX  HUNDRED  ELEVEN  THOUSAND  SEVEN  HUNDRED
FORTY NINE U.S. DOLLARS (USD 179,611,749.-) by a contribution in kind consisting of (18.000) shares in the capital

94317

L

U X E M B O U R G

of PAH Oceania B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having
its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (address: 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, the
Netherlands, trade register number: 54836549), ("PAH Oceania") hereinafter be referred to as the "Contributed Shares".

The above contribution in kind has been dealt with in a valuation statement issued by the management of the Company,

which certifies that the total value of the contribution in kind is equal to the value of the New Shares issued in consideration
for the Contributed Shares.

The said report, a copy of the list of the Contributed Shares, has been given.

<i>Effective implementation of the contribution:

The Contributor, PFIZER LUXEMBOURG SARL here represented as stated hereabove, declares that:
- it is the sole full owner of the Contributed Shares and possessing the power to dispose of the Contributed Shares;
- the Contributed Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge

or usufruct on the Contributed Shares;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the Contributed Shares be transferred to it;

- according to the laws of the Netherlands the Contributed Shares are freely transferable;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in Luxembourg, in order to duly

formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Second resolution

The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect

such increase of capital, which now reads as follows:

Art. 7. First paragraph. "The corporate capital of the company is set at SEVEN HUNDRED FORTY FIVE MILLION

U.S. DOLLARS (USD 745,000,000.-) divided into SEVEN HUNDRED FORTY FIVE MILLION (745,000,000.-) shares having
a par value of ONE US DOLLAR (USD 1.00) each."

<i>Valuation - Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby

grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussigné;

A COMPARU

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL constituée suivant acte reçu par acte du notaire instrumentant en

date du 3 octobre 2001, ayant son siège au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 93.997 (la «Société»)
représenté par Me James MURPHY, maître en droit, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée en Luxembourg le 27 novembre 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnom-

mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, est l'associé unique de PAH LUXEM-

BOURG 2 SARL, constituée suivant acte reçu par acte du Maître Paul BETTINGEN, en date du 21 décembre 2012, ayant
son siège au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B165.884, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 385 du 14 février 2012 (la «Société») par acte du notaire Paul BETTINGEN, notaire de résidence
à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg).

Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

94318

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de VINGT ET UN MILLIONS

TROIS  CENT  QUATRE-VINGT-HUIT  MILLE  DEUX  CENT  CINQUANTE  ET  UN  DOLLARS  AMERICAINS  (USD
21.388.251,-) pour le porter de son montant actuel de SEPT CENT VINGT TROIS MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE
SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 723.611.749,-) à un montant de SEPT CENT QUA-
RANTE-CINQ MILLIONS DOLLARS (USD 745.000.000.-) par l'émission de VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT
QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UNE (21.388.251) de nouvelles parts sociales ayant une
valeur D'UN DOLLAR AMERICAIN (USD 1,00) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MIL-
LIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 179.611.749,-).

L'apport total de DEUX CENT UN MILLIONS DOLLARS AMERICAINS (USD 201.000.000,-) relativement aux Nou-

velles Parts Sociales est alloué comme suit: (i) VINGT-ET-UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE
DEUX CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS AMERICAINS (USD 21.388.251,-) au capital social de la Société et (ii)
CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS AME-
RICAINS (USD 179.611.749,-) au compte de prime d'émission de la Société.

<i>Souscription

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMADIATE SARL, prénommée, ici représentée comme dit ci-avant a déclaré sou-

scrire toutes les VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE
ET UNE (21.388.251) nouvelles parts sociales et les libérer pour un prix total de VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT
QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN DOLLARS AMERICAINS (USD 21.388.251,-) en-
semble avec une prime d'émission de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE SEPT CENT
QUARANTE-NEUF DOLLARS AMERICAINS (USD 179.611.749,-), par un apport en nature consistant dans les (18.000)
parts sociales, dans le capital de PAH Oceania B.V., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les
lois des Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce hollandais sous le numéro d'entreprise 54836549 ayant son siège
social au 2909 LD Capelle aan den Ijssel, Rivium Westlaan 142, Pays-Bas ("PAH Oceania"), les «Parts Apportés».

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été produite, par la délivrance d'un certificat d'éva-

luation daté du 27 novembre 2012 émis par la Société.

<i>Réalisation effective de l'apport:

L'Apporteur, PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE SARL, précitée, ici représentée comme dit ci-avant, déclare

que:

- il est le seul plein propriétaire de Parts Sociales apportées et possède les pouvoirs d'en disposer,
-  les  Parts  Sociales  apportées  ne  sont  encombrées  d'aucun  gage  ou  usufruit  et  qu'il  n'existe  aucun  droit  aux  fins

d'acquérir un tel gage ou usufruit sur lesdites parts;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en

acquérir une ou plusieurs;

- suivant le droit des Pays Bas et les statuts de ladite société, les Parts Sociales apportées sont librement transmissibles;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir AUX Pays-Bas aux fins d'effectuer la cession

et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter

l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à SEPT CENT QUARANTE-CINQ MILLIONS

DOLLARS AMERICAINS (USD 745.000.000,-) divisé en SEPT CENT QUARANTE-CINQ MILLIONS (745.000.000,-)
parts sociales ayant une valeur nominale d'UN DOLLAR AMERICAIN (USD 1.00) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à

tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête e la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

94319

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Murphy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16044. Reçu soixante-quinze euros

75,00€

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2013083464/160.
(130102696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2013.

Merloffice S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg E 217.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts d'intérêts dûment acceptée par la société civile immobilière MERLOFFICE

S.C.I. en date du 13 janvier 2012 que Monsieur Gerhard Nellinger, né à Trèves, Allemagne, le 22 avril 1949, agissant en
sa qualité d'associé de la société civile immobilière de droit luxembourgeois MERLOFFICE S.C.I, a cédé à Monsieur Marco
Moes, demeurant à L-3333 Hellange, 67, Beetebuergerstrooss, 100 (cent) parts d'intérêts de la société MERLOFFICE
S.C.I précitée.

Après la cession ci-avant décrite le capital de la Société se trouve réparti comme suit:

Monsieur Marco Moes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Monsieur Gérard Decker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Monsieur Liesch Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
G-Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Total: six cents parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2013.

Référence de publication: 2013084169/21.
(130103687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Marigny Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 93.828.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2013.

Référence de publication: 2013084154/10.
(130103962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Masselotte S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 171.379.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 28 mai 2013

Acceptation de la démission du directeur général,
- Monsieur Olivier NOBLOT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013084156/12.
(130103441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

94320


Document Outline

Barlux S.A.

Dartmouth Luxembourg S.à r.l.

Dominion DMG Luxembourg S.A.

Eastern Beverage Holding S.à r.l.

Euro Holiday Properties S.A.

Euroports Port Acquisitions Luxembourg S.à r.l.

Euroports SHRU Holdings S.à r.l.

F.C.D. S.à r.l.

Fidex Audit S.à r.l.

G4S General Services S.A.

Gaillon S.C.A.

Geldilux-TS-2010 S.A.

General Electric International Holdings S.à r.l.

Globus Equity SICAV SIF

Grand Vision Trust S.A.

Gutburg Immobilien S.A.

Hansa Hydrocarbons (Luxembourg) S.à r.l.

Holbourg S.A.

Horizon French Property Partnership Management S.à r.l.

Ice Cream

Jona Universal Corporation S.A.

Jona Universal Corporation S.A.

KBC Participations Renta

Kiribati S.à r.l.

Kochab S.A.

Lemon Finance S.A.

Libertim Luxembourg S.A.

Logistis Luxembourg S.A.

Lombard International Assurance S.A.

Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l.

Marigny Development S.A.

Marjin S.A.

Masselotte S.A.

Maxalice S.A.

Merloffice S.C.I.

Milford Lux S.A.

Milford Lux S.A.

Mindgate S.A.

Miraumont S.A.

Multi-Solar S.A.

Nobil S.à r.l.

Noga S.A.

Oceaneering Holdings Sarl

Oceaneering International Holdings LLC SCS

Oceaneering Luxembourg S.à r.l.

OCM Luxembourg Ice Cream Holdings S.à r.l.

PAH Luxembourg 2 Sàrl

Probat Construction s.à r.l.

Probat Construction s.à r.l.

Promo Petrole S.A.

Pusan S.A. SPF

Q Invest S.A.

Q Invest S.A.

Quo Vadis S.à r.l.

Quo Vadis S.à r.l.

Quo Vadis S.à r.l.

Q.Y S.à r.l.

Raystown Lux S.A.

Ricoh Luxembourg PSF S.à r.l.

Sopasa Participations S.A.