logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1843

31 juillet 2013

SOMMAIRE

Al-Ain Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Alizeos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Alpina Real Estate GP I  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88421

Alter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88419

Am Trading  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

ANTHEA - Contemporary Art Investment

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88421

Anthus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88423

Askania S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88419

Astrolabe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88418

Baie Bleue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

BCK Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

Beckman Coulter Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

88419

Beech Tree S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88421

Beggen PropCo Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

Bertrange Capital s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88423

Bluestar Silicones International S.à r.l.  . . .

88420

Bluestar Silicones International S.à r.l.  . . .

88419

B.M. (Building Management) SA . . . . . . . . .

88419

Boretsch Investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

88421

Boulle Mining Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

88422

Branta S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88422

BRASSERIE SIMON Participations et Cie

S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88421

Brookfield Aylesbury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

88422

Carvi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88423

Cathians S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88422

Centrix Beteiligungen AG  . . . . . . . . . . . . . .

88423

Codralux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88422

Dolpa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88464

DSC Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

88464

E. De Nil & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88464

Elmer Capital s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88464

Gase International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88464

Gigaplex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88463

Inntechinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88451

International Sales Services  . . . . . . . . . . . . .

88427

J. Maet & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

KKR Retail Partners Topco S.à r.l.  . . . . . . .

88428

Knupp S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Kottla Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88444

Krisken S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Landwehr I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

NGP III Managers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88449

Pfizer Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

88418

PIE Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88457

Plansee Group Service S.A.  . . . . . . . . . . . . .

88429

Pontavedra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88459

Sailor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88424

Sandlark Investments Holdings S.à.r.l.  . . .

88418

Sidcor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Sinos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88424

Société de Participations Dauphinoise S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88423

Société Financière d'Octobre S.A., SPF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88425

Sogim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88425

South Mogul Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

88418

Special Movie Production S.A. . . . . . . . . . . .

88425

Strategic Credit Funding S.à r.l.  . . . . . . . . .

88424

Surassur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88425

Theos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88424

Tovra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Treck S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88425

UP Luxembourg Holdings  . . . . . . . . . . . . . .

88424

World Immo Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

WP VI Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

88426

88417

L

U X E M B O U R G

Pfizer Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 84.125.

EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 09 novembre 2012 que la société Pfizer Shareholdings Intermediate

S.à r.l. transfère les 18,678,817 parts sociales de Classe AB et toutes les 8,899,183 parts sociales de Classe C qu'elle
détient dans la Société à la société Pfizer Luxembourg Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, en-
registrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B165.901, ayant son siège social
au 51 Avenue J.F. Kennedy, L-1855.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2013.

Référence de publication: 2013078038/15.
(130095947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

South Mogul Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 778.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 160.682.

EXTRAIT

En date du 30 mai 2013 les associés de la Société ont accepté avec effet immédiat la démission de Monsieur Harvey

Sawikin en tant que gérant de la Société.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de Monsieur James Passin, Monsieur Steven Gorelik et

Monsieur Marc Liesch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2013.

<i>Pour South Mogul Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2013078088/16.
(130096009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

Sandlark Investments Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.343.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Sandlark Investments Holdings S.à.r.l.

Référence de publication: 2013078091/10.
(130095907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

Astrolabe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 156.363.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Astrolabe S.A.
Signature
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013078294/13.
(130097021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88418

L

U X E M B O U R G

Beckman Coulter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 69.032.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.341.

Les comptes annuels, pour la période du 8 septembre 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2012, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078306/11.
(130097032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Bluestar Silicones International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.291.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2011 de sa société
mère, BLUESTAR SILICONES INVESTMENT CO. LTD ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078309/13.
(130097323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

B.M. (Building Management) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3441 Dudelange, 61, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.190.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078303/10.
(130096627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Askania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078293/10.
(130097009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Alter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 101.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2013.

Référence de publication: 2013078268/10.
(130097294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88419

L

U X E M B O U R G

Am Trading, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 172.590.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078269/10.
(130097477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Beggen PropCo Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.

R.C.S. Luxembourg B 154.993.

Les comptes annuels au 15 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013078308/10.
(130097557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

BCK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 160.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078324/10.
(130097041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Bluestar Silicones International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.291.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de sa société
mère, BLUESTAR SILICONES INVESTMENT CO. LTD ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2013.

Référence de publication: 2013078310/13.
(130097441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Baie Bleue, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 95.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013078305/11.
(130097394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88420

L

U X E M B O U R G

ANTHEA - Contemporary Art Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 165.859.

Aux membres du Collège de Gérance
Par la présente, je tiens à vous annoncer ma décision de démissionner de mon poste de Gérant au sein du Collège de

Gérance et ceci avec effet au 31 juillet 2013.

Luxembourg, le 31 mai 2013

Hanna ESMEE DUER.

Référence de publication: 2013078279/11.
(130096332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Boretsch Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 175.946.

EXTRAIT

En date du 15 mars 2013, le gérant unique a décidé de transférer le siège social de la société au 61, avenue de la Gare,

L-1611 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Boretsch Investments Sàrl

Référence de publication: 2013078311/13.
(130097357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Beech Tree S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 85.327.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013078307/10.
(130097482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Alpina Real Estate GP I, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 131.952.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2013.

Référence de publication: 2013078266/10.
(130096498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

BRASSERIE SIMON Participations et Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-9550 Wiltz, 14, rue Joseph Simon.

R.C.S. Luxembourg B 91.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078347/10.
(130096634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88421

L

U X E M B O U R G

Brookfield Aylesbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.227.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013078314/10.
(130097292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Branta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.689.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 17 juin 2013.

Référence de publication: 2013078344/10.
(130097595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Cathians S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 147.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078391/10.
(130097264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Boulle Mining Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.199.

Le bilan au 31 décembre 2011 de la société a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Walferdange.

<i>Un Administrateur

Référence de publication: 2013078312/11.
(130096469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Codralux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 84.489.

Le bilan au 31 décembre 2012 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CODRALUX S.A.
Signature
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013078403/13.
(130097018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88422

L

U X E M B O U R G

Carvi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 143.680.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013078389/10.
(130096446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Centrix Beteiligungen AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 101.602.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17.06.2013.

<i>Pour: CENTRIX BETEILIGUNGEN AG
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013078392/15.
(130097224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Bertrange Capital s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.910.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 14/06/2013.

Référence de publication: 2013078332/10.
(130096561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Anthus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.790.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 17 juin 2013.

Référence de publication: 2013078281/10.
(130097593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Société de Participations Dauphinoise S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 51.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013078992/9.
(130096983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88423

L

U X E M B O U R G

Sinos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 134.145.

Par la présente, je soussigné Yannick Kantor, vous communique ma décision de démissionner immédiatement de mes

fonctions de membre du Conseil d' Administration de la société Sinos S.A. avec effet immédiat en date du 11.06.13.

Luxembourg, le 11.06.13

Yannick Kantor.

Référence de publication: 2013078990/10.
(130096619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Sailor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 73.867.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Mr Ian James NAYLOR avec effet au 1 

er

 novembre

2012. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2014.

Luxembourg, le 13 Mai 2013.

<i>Pour SAILOR S.A.
Signatures

Référence de publication: 2013078976/14.
(130096367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Strategic Credit Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 147.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078975/10.
(130097365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Theos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 102.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013079032/10.
(130097180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

UP Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 162.765.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013079047/10.
(130097500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88424

L

U X E M B O U R G

Surassur, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 52.440.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société SURASSUR
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013079011/11.
(130097073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Treck S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 158.381.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2013079036/13.
(130097404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Sogim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 23.062.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013079001/10.
(130096631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Société Financière d'Octobre S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 35.865.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013078993/10.
(130096676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Special Movie Production S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 76.371.

Die Aktionäre haben in der ordentlichen Hauptversammlung vom 14.06.2013 beschlossen, die Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, Moore Stephens Audit S.à r.l., 2-4 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, R.C.S. Luxemburg B
155.334, als Réviseur d'entreprises bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2014 zu ernen-nen.

Référence de publication: 2013079003/10.
(130097386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88425

L

U X E M B O U R G

Tovra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 172.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013079018/9.
(130096930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Sidcor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 73.984.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013078989/9.
(130097464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

World Immo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 77.758.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013079072/9.
(130097086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

WP VI Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.919.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013079074/9.
(130097210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Al-Ain Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 118.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013079184/9.
(130098623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2013.

Alizeos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 158.454.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013079186/9.
(130097705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2013.

88426

L

U X E M B O U R G

Krisken S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 1, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 171.511.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'administrateur unique que:
- Le siège social de la société a été transféré du 20 avenue du Bois, L-1251 Luxembourg au 1 rue des Dahlias, L-1411

Luxembourg à compter du 22 avril 2013.

<i>Pour la société
Janice Allgrove
<i>Administrateur unique

Référence de publication: 2013078704/14.
(130097405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Landwehr I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.937.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078726/10.
(130097006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Knupp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 118.572.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078700/10.
(130097353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

J. Maet &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 132.572.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078674/10.
(130096721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

International Sales Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 134.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078662/10.
(130096916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88427

L

U X E M B O U R G

KKR Retail Partners Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 176.273.

In the year two thousand and thirteen, on the third of June.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

"KKR Retail Partners Capco S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 176.405,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Luxembourg on the 31 of May 2013.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "KKR Retail Partners Topco S.à r.l." (hereinafter the "Company"), a

société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
59 Rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 176.273, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary
dated 22 March 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial
C"). The articles have been amended pursuant to a notarial deed dated 31 May 2013, not yet published.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to amend the financial year of the Company with immediate effect, which will run from

st

 January to 31 

st

 December.

As a consequence of the above, the Shareholder resolves to amend accordingly article 11 of the Company's articles

of incorporation, which shall read as follows:

"The accounting year begins on 1 

st

 January and ends on the 31 

th

 December of the same year."

<i>Second resolution

The Shareholder acknowledges, as a consequence of the above and for the avoidance of doubt, that the current financial

year, which started on 1 

st

 of June 2013, will be closed on 31 

st

 December 2013.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trois juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«KKR Retail Partners Capco S.à r.l..», une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.405,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, ayant son adresse professionnelle à Howald, Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 31 mai 2013.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «KKR Retail Partners Topco S.à r.l.» (ci après la «Société»), une

société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 59 Rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 176.273, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 22 mars 2013, dont

88428

L

U X E M B O U R G

les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»).
Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 mai 2013, pas encore publié au
Mémorial C.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'exercice social de la Société, avec effet immédiat, lequel commencera le 1 

er

janvier et se terminera le 31 décembre.

Par conséquent, l'associé unique décide de modifier conformément l'Article 11 des statuts de la Société, qui se lira

désormais comme suit:

«L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.»

<i>Deuxième résolution

L'associé unique reconnaît, comme conséquence de ce changement et afin d'éviter tout doute, que l'année sociale

actuelle, qui a débuté le 1 

er

 juin 2013 prendra fin le 31 décembre 2013.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, le comparant

a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 juin 2013. Relation: EAC/2013/7278. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013077914/80.
(130095864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

Plansee Group Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 110.469.

In the year two thousand and thirteen, on the third day of June.
Before Us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Plansee Group Service S.A., a public

limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, of 16 

th

 August 2005, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations number 97 of 16 

th

 January 2006, having its registered office at 101, route de

Holzem, L-8232 Mamer, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B
110.469. The Articles of Incorporation have been lastly amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on De-
cember 21, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 446 of February 20, 2012.

The Meeting begins at 3.00 p.m. and is chaired by Me Pierre-Alexandre LECHANTRE, lawyer, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the Meeting Mr Yevgeniy SADOV, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer of the Meeting Mrs Nathalie STEFFEN, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
(The chairman, the secretary and the scrutineer being collectively referred to hereafter as the "Bureau").
The Bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the two thousand

five hundred eleven (2,511) Class A Shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each, and all the two
thousand five hundred elven (2,511) B Shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each representing the
entirety of the share capital of the Company of five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000.-) are duly repre-
sented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after
examination of the agenda.

88429

L

U X E M B O U R G

The attendance list, signed by all the shareholders present or represented at the Meeting, the members of the Bureau

and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration
authorities.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

<i>Agenda

1. To change the management of the Company from a one tier system to a two tier system by the creation of a

supervisory board and a management board in accordance with articles 60bis-1 and following of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended;

2.  To  acknowledge  the  resignation  of  (i)  Mr.  John  O'HARA,  (ii)  Mr.  Bernhard  SCHRETTER,  (iii)  Dr.  Michael

SCHWARZKOPF and (iv) Mr. Karlheinz WEX from their office as directors of the Company with effect as of 3 

rd

 June

2013 and to grant them discharge for the performance of their duties;

3. To fully restate the articles of association of the Company, including the corporate object clause, which shall read

as set out hereafter, in order to reflect the resolutions to be adopted under the foregoing items of the agenda:

2.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management and
operation of patents and other intellectual property rights, the acquisition and granting of licences, sub-licences and similar
rights under any name whatsoever, and, if required, the protection of such rights derived from patents and other intel-
lectual property rights, licences, sub-licences and similar rights against infringement by third parties.

2.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

2.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including cash pooling, factoring, techniques and instruments designed to protect
the Company, its subsidiaries, affiliated companies or any other company of the same group of companies, against credit
risks, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. The Company may engage
in any other lawful act or activity for which a public limited liability company may be organised under the Law.";

4. To appoint Dr. Michael SCHWARZKOPF and Mr. Karlheinz WEX as members of the supervisory board and to set

the term of their mandate;

5. To appoint Mr. John O'HARA, Mr. Bernhard SCHRETTER and Mr. Werner KOFELENZ as members of the mana-

gement board and to set the term of their mandate;

6. Miscellaneous.
After approval of the statement of the chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to change the management of the Com-

pany from a one tier system to a two tier system by the creation of a supervisory board and a management board in
accordance with articles 60bis-1 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to acknowledge the resignation of (i)

Mr. John O'HARA, (ii) Mr. Bernhard SCHRETTER, (iii) Dr. Michael SCHWARZKOPF, and (iv) Mr. Karlheinz WEX from
their office as directors of the Company with effect as of 3 

rd

 June 2013 and to grant them discharge for the performance

of their duties.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to fully restate the articles of association

of the Company, including the corporate object clause, which shall from now on read as follows:

88430

L

U X E M B O U R G

Art. 1. Company name and Registered office.
1.1 The name of the public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and
the present articles of association (the "Articles of Association") is "Plansee Group Service S.A." (the "Company").

1.2 The Company has its registered office in the municipality of Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, and the mana-

gement  board  of  the  Company  (the  "Management  Board")  may  decide  to  transfer  the  registered  office  within  the
boundaries of that municipality and/or to establish branches, subsidiaries and/or offices either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad.

1.3 The Company has been established for an unlimited duration.
1.4 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general shareholders' meeting of the Company

adopted in the manner required for amendment of the Articles of Association.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management and
operation of patents and other intellectual property rights, the acquisition and granting of licences, sub-licences and similar
rights under any name whatsoever, and, if required, the protection of such rights derived from patents and other intel-
lectual property rights, licences, sublicences and similar rights against infringement by third parties.

2.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

2.3 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including cash pooling, factoring, techniques and instruments designed to protect
the Company, its subsidiaries, affiliated companies or any other company of the same group of companies, against credit
risks, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

2.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. The Company may engage
in any other lawful act or activity for which a public limited liability company may be organised under the Law.

Art. 3. Share capital.
3.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at five million twenty-two thousand euro (EUR 5,022,000)

represented by two thousand five hundred eleven (2,511) class A shares (the "Class A Shares") and by two thousand five
hundred eleven (2,511) class B shares (the "Class B Shares"), having a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

3.2. All shares shall be in registered form. The Class A Shares and the Class B Shares are collectively referred to as

the "Shares" unless the context otherwise requires.

3.3. Subject to the provisions of these Articles of Association, the Class A Shares and the Class B Shares grant special

rights as to the payment in any form whatsoever of any reserve funds constituted by issue premiums, whereby any issue
premium shall always track the class of Shares in respect of which the premium was paid in; apart from this right the Class
A Shares and the Class B Shares grant the same rights to their respective holders.

3.4. Notwithstanding any decision of the general shareholders' meeting to the contrary in case of an increase of the

share capital of the Company, each shareholder is entitled to subscribe for newly issued Shares within its class of Shares
only on a pro rata basis.

Art. 4. Shares.
4.1. The Management Board will keep a register at the office of the Company, where it will be available for inspection

by any shareholder, in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded as well as the date on which
they have acquired the Shares, the date of acknowledgement or serving, the amount paid on every Share and the transfer
of Shares and the dates of such transfers. Ownership of Shares will be established by the entry in this register.

4.2 Upon request, the Management Board will, without charge, provide a holder of Shares with an extract from the

register as regards that holder's right to a Share.

4.3. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.
4.4. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and in conformity with the principle

of equal treatment of all shareholders.

88431

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Management Board.
5.1. The Company shall be managed by a Management Board composed of minimum two (2) members, unless the

Management Board may be composed of one member in accordance with the provisions of article 60bis-2 of the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended. They shall be elected initially for a term of three (3) years
renewable for successive annual periods thereafter.

5.2. The members of the Management Board shall be elected by the Shareholders at a general meeting of Shareholders

in accordance with the procedure further described in this Article V and the general meeting of Shareholders shall further
determine the number of directors (within the limit of this Article V), and the term of their office.

5.3. Inasmuch as permitted by the Luxembourg law, a legal entity may be appointed as member of the Management

Board. In such case, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name
and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its representative if it appoints his successor
at the same time.

5.4. At any time, any member of the Management Board may be removed with or without cause or be replaced (in

accordance  with  the  composition  rules  applying  to  the  Management  Board  as  set  forth  under  this  Article  V):  (i)  by
resolution adopted by a simple majority of the votes present or represented at a duly convened general meeting of
Shareholders without quorum requirement, or (ii) by resolution of the Supervisory Board at a simple majority decision
of the members of the Supervisory Board present or represented with a simple majority quorum.

5.5. In the event of a vacancy in the office of a member of the Management Board, the remaining members of the

Management Board may temporarily fill such vacancy while respecting the various representations of certain Shareholders
as set out above in this Art. V., until the next general meeting of Shareholders which will be asked to a final decision
regarding such nomination in accordance with the provisions of this Art. V.

Art. 6. Meetings of the Management Board.
6.1. The Management Board will choose a chairman from among its members. It may choose a secretary, who does

not  have  to  be a member  of the  Management  Board,  who  shall write and keep the  minutes  of  the  meetings of  the
Management Board and of the meetings of Shareholders.

6.2. The chairman shall preside at the meetings of the Management Board. In his absence, the other members of the

Management Board shall decide by a majority vote that another member of the Management Board shall be in the chair
of such meeting.

6.3. Subject to Article 6.10, the members of the Management Board may only act at duly convened meetings of the

Management Board. The Management Board shall meet upon call by the chairman or any member of the Management
Board, at the place indicated in the notice of meeting.

6.4. Written Notices of any meeting of the Management Board shall be given to all members of the Management Board

prior to the date for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meetings. If all the members of the Management Board are present or represented, they
may waive all convening requirements and formalities. Separate notice shall not be required for meetings held at times
and places fixed in a resolution adopted by the Management Board in a meeting where all members of the Management
Board are present or represented.

6.5. Any member of the Management Board may act at any meeting by appointing in writing, by telefax, electronic mail

or any other similar means of communication another member of the Management Board as his proxy. A member of the
Management Board may also appoint another member of the Management Board to represent him by telephone, such
appointment to be confirmed in writing at a later stage. A member of the Management Board may represent several of
his colleagues.

6.6. Any members of the Management Board may participate in a meeting of the Management Board by conference

call or similar means of communications equipped whereby (i) all the members attending the meeting can be identified,
(ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the members can properly deliberate, and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meetings. A meeting of the Management Board held by such means of
communication will be deemed to be held in Luxembourg.

6.7. Unless specified otherwise by law or in these articles of association, the Management Board shall validly deliberate

with a quorum of a majority of the members of the Management Board being present or represented and resolutions
will be taken at simple majority vote of the members of the Management Board present or represented. In the event that
at any meeting the number of votes for or against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall not have a
casting vote.

6.8. Meetings, resolutions and protocols of the Management Board shall be recorded in minutes signed by the chairman

of the meeting. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two (2) members of the Management Board.

6.9. Votes can also be cast by telefax, electronic mail, or telephone provided that, in the case of a vote cast by telephone,

such vote is confirmed in writing.

88432

L

U X E M B O U R G

6.10. Resolutions in writing approved and signed by all members of the Management Board shall have the same effect

as resolutions voted at the Management Board's meetings; each member of the Management Board shall approve such
resolution in writing, by telefax, electronic mail or any other similar means of communication. Such approval shall be
confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

Art. 7. Powers of the Management Board.
7.1. The Management Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration

within the Company's purpose and interest.

7.2. All powers not expressly reserved by the Law of 10 August 1915 or by the present Articles to the general meeting

of Shareholders or to the Supervisory Board are in the competence of the Management Board.

Art. 8. Delegation of Powers by the Management Board.
8.1. The Management Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company

and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Ma-
nagement Board or other agents, legal or physical persons who need not be shareholders but to the exclusion of any
member or the Supervisory Board, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Mana-
gement Board shall determine.

8.2. The Management Board may also confer all powers and special mandates to any person, who need not be a member

of the Management Board, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 9. Corporate Signature.
9.1. Vis-à-vis third parties, in all circumstances, the Company is validly bound by the joint signature of any two (2)

members of the Management Board or by the joint or single signature of any person(s) to whom such signatory authority
has been delegated in writing by the Management Board but only within the limits of such power. For the avoidance of
doubt, the Members of the Management Board may not bind the Company by their individual signatures, except if spe-
cifically authorised thereto by resolutions of the Management Board.

9.2. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also if a daily manager has been appointed in order

to conduct the daily management and affairs of the Company and represent the Company in such daily management and
affairs, be bound by the sole signature of the daily manager within the boundaries of the daily management.

Art. 10. Members of the Supervisory Board.
10.1. The Company shall be managed by the Management Board under the overall supervision of the Supervisory

Board. The members of the Supervisory Board need not be Shareholders. The members of the Supervisory Board shall
be elected for a term not exceeding three (3) years and shall be eligible for re-appointment.

10.2. The members of the Supervisory Board shall be elected by the general meetings of Shareholders, which shall also

determine the term of their office and their indemnities.

10.3. No person can be simultaneously a member of the Management Board and a member of the Supervisory Board.
10.4. Inasmuch as permitted by the Luxembourg law, a legal entity may be appointed as member of the Supervisory

Board. In such case, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name
and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its representative if it appoints his successor
at the same time.

10.5. Any member of the Supervisory Board may be removed with or without cause by resolution adopted by a simple

majority of the votes present or represented at a duly convened general meeting of Shareholders without quorum re-
quirements.

10.6. In the event of a vacancy in the office of a member of the Supervisory Board, the remaining members of the

Supervisory Board may temporarily fill such vacancy, until the next general meeting of Shareholders which will be asked
to a final decision regarding such nomination in accordance with the provisions of this Article IX.

Art. 11. Meetings of the Supervisory Board.
11.1 The Supervisory Board will appoint a chairperson among its members.
11.2. The Supervisory Board shall meet as often as necessary to fulfil its function but in any event no less than two (2)

times per annum. The chairperson of the Supervisory Board will preside at all the meetings of the Supervisory Board. In
his/her absence, the other members of the Supervisory Board will appoint another chairperson pro tempore who will
preside at the relevant meetings by simple majority vote of the members of the Supervisory Board present or represented
at such meetings.

11.3. The Supervisory Board shall meet upon call by the chairperson of the Supervisory Board or any two (2) members

of the Supervisory Board at the place indicated in the notice of meeting. The chairperson of the Supervisory Board must
call a meeting at the request of the Management Board. Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be
given to all the members of the Supervisory Board at least three (3) days in advance of the date set for such meetings,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting. If all the members of the Supervisory Board are present or represented, they may waive all convening require-

88433

L

U X E M B O U R G

ments and formalities. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution
adopted by the Supervisory Board in a meeting where all members of the Supervisory Board are present or represented.

11.4. The Supervisory Board may invite the members of the Management Board or other persons to attend its meetings

as observers without voting rights.

11.5. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting by appointing in writing, whether in original, by

telefax or electronic mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another
member as his or her proxy. A member of the Supervisory Board may represent more than one of his or her colleagues,
under the condition however that at least two members of the Supervisory Board are present at the meeting or parti-
cipating at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and by the Law of
10 August 1915.

11.6. Unless specified otherwise by law or in these Articles, the Supervisory Board shall validly deliberate with a quorum

of a majority of the members of the Supervisory Board present or represented and resolutions will be taken at simple
majority of the members of the Supervisory Board present or represented.

11.7. In case of a tied vote, the chairperson of the Supervisory Board shall have a casting vote.
11.8. Any members of the Supervisory Board may participate in a meeting of the Supervisory Board by conference

call, video conference or similar means of communications equipped whereby (i) all the members attending the meeting
can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of
the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the members can properly deliberate, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meetings. A meeting of the Supervisory Board held by such
means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

11.9. Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all members of the Supervisory

Board shall have the same effect as resolutions voted at the Supervisory Board's meetings; each member of the Supervisory
Board shall approve such resolutions in writing, by telefax, electronic mail or any other similar means of communication.
Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has
been taken.

11.10. The minutes of any meetings of the Supervisory Board shall be signed by the chairperson of the Supervisory

Board or the member of the Supervisory Board who presided at such meeting. Copies of extracts of such minutes to be
produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairperson of the Supervisory Board, or any
two (2) members of the Supervisory Board.

Art. 12. Powers of the Supervisory Board.
12.1. The Supervisory Board shall have the duty to carry out a permanent supervision of the management of the

Company. The Supervisory Board cannot interfere with the management of the Company.

Art. 13. Delegation of Powers by the Supervisory Board.
13.1. The Supervisory Board may appoint one or more of its members for the performance of one or more specific

tasks.

13.2. The Supervisory Board may also decide to form internal committees in order to assist it in the fulfilment of its

functions. The composition and the activities of such committees will be determined by the Supervisory Board and they
will act under its control. However, the Supervisory Board cannot delegate to any committee the powers which are
expressly attributed to the Supervisory Board itself by the Law of 10 August 1915 or the Articles, and such delegation
to any committee cannot result in a reduction or limitation of powers of the Management Board.

Art. 14. Fiscal year, Annual financial statements and Audit.
14.1. The fiscal year of the Company shall commence on the first day of March and end on the last day of February.
14.2. Each year after the end of the fiscal year, the Management Board shall draw up annual financial statements and

an annual report on that fiscal year.

14.3. The annual financial statements shall be signed by all the members of the Management Board and shall provide

the annual report and all other documentation as required under Luxembourg law.

14.4. The annual financial statements shall be made available to all shareholders and any of the members of the Su-

pervisory Board for inspection and/or obtaining of copies.

14.5. The Company shall utilise accounting systems and procedures in accordance with mandatory provisions of Lu-

xembourg law and in accordance with the Luxembourg Accounting Standards.

14.6. One or more statutory auditors shall be elected by the general shareholders' meeting for a period not exceeding

6 (six) years; statutory auditors can be elected for one or more consecutive terms. The statutory auditors may be removed
by the general shareholders' meeting at any time, without cause. The general shareholders' meeting decides on the fees
of the statutory auditors.' Each statutory auditor has the unlimited right to review all and any transactions of the Company
and its affiliated companies and to review, inspect and audit all financial documents, correspondence, protocols, minutes
and all other documents of the Company and its affiliated companies. The auditors have to inform the general sharehol-
ders' meeting about the result of the audit of the consolidated and the non-consolidated financial statements of the

88434

L

U X E M B O U R G

Company and its affiliated companies, the kind and nature of inspection of the inventory and present any proposals for
improvement, if at all.

Art. 15. Dividend policy.
15.1. An amount corresponding to at least 5 (five) % of the annual distributable profits shall be allocated to the legal

reserve as long as the legal reserve does not exceed the tenth part of the share capital of the Company or the greater
part as determined in these Articles of Association.

15.2. The Management Board is authorised to effect advance (interim) payments on dividends in accordance with the

Law.

Art. 16. General shareholders' meetings.
16.1 The annual general shareholders' meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Mamer at the

address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may
be specified in the convening notice of meeting, on the first Tuesday of June of each year at 10.00 a.m. If such day is not
a business day for banks in Luxembourg, the annual general shareholders' meeting shall be held on the next following
business day.

16.2 The annual general shareholders' meeting of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judge-

ment of the Management Board of the Company, exceptional circumstances so require.

16.3 Other general shareholders' meeting, including ordinary and extraordinary general meetings of the shareholders

of the Company, may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

16.4 The general shareholders' meeting shall be called by the Management Board by means of written notices to be

sent to the shareholders registered in the register referred to in Article IV. at least fifteen (15) days before the date on
which the meeting is to be held. If all shareholders participate at a general shareholders' meeting and if all shareholders
consent to vote on the presented agenda, such meeting can also be held without prior notice.

16.5 A general shareholders' meeting shall also be called without delay if shareholders whose shares representing one

tenth of the share capital of the Company submit a written request demanding the call and stating the purpose. If the
Management Board does not comply with such a request within 14 (fourteen) days of the demand, the entitled share-
holders themselves may call the general shareholders' meeting and shall give an account of the facts when doing so. In
such case, the general shareholders' meeting shall decide on whether the Company is to bear the costs relating to that
call.

16.6 Each shareholder is entitled to authorize another person, which need not be a shareholder, in writing to represent

him and vote in the general shareholders' meeting.

16.7 The notice of convening a general shareholders' meeting shall indicate the date, time and place where the meeting

shall be held, together with the agenda of the meeting, in compliance with mandatory rules of Luxembourg law.

16.8 Any general shareholders' meeting shall be directed by the chairman of the Supervisory Board.
16.9 Unless the mandatory provisions of Luxembourg law or the provisions of these Articles of Association provide

otherwise, at least 51 (fifty-one) % of the issued and paid-up share capital of the Company shall be present or duly
represented at general shareholders' meeting to constitute a quorum at such a meeting. If such a quorum is not present
at a meeting, a second meeting, which shall be limited to the same agenda of the preceding meeting, shall be called, together
with a statement referring to the lack of quorum at the preceding meeting and shall constitute a quorum regardless of
the amount of the share capital represented at it.

16.10 Unless mandatory provisions of the Luxembourg law or these Articles of Association determine otherwise,

ordinary shareholders' resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Extraordinary shareholders'
resolutions shall always require a majority of 2/3 (two thirds) of the votes cast.

16.11 The copies and/or excerpts of the minutes of the general shareholders' meeting which have to be presented to

the Court or any other person, shall be certified by the chairman having directed the relevant meeting.

Art. 17. Sole shareholder.
17.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the general shareholders' meeting.

17.2 Any reference in these Articles of Association to the general shareholders' meeting or the shareholders is to be

read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

17.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

Art. 18. Dissolution, Liquidation.
18.1 The general shareholders' meeting can decide on the dissolution of the Company at any time.
18.2 If the general shareholders' meeting decides to dissolve the Company, it also has to appoint at least one liquidator

which can be a natural or legal person and to decide on the fees for the liquidator. If the general shareholders' meeting
does not appoint the liquidator, the members of the Management Board will be the liquidators.

88435

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Miscellaneous. These Articles of Association have to be interpreted, construed and amended in accordance

with the Law."

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company, after having acknowledged that the Company

currently only has one shareholder, resolved to appoint the following persons as members of the supervisory board for
a term ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2016:

- Dr. Michael SCHWARZKOPF, private employee, with professional address at Metallwerk Planseestrasse 71, A-6600

Reutte;

- Mr. Karlheinz WEX, private employee, with professional address at Metallwerk Planseestrasse 71, A-6600 Reutte.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to appoint the following persons as

members of the management board for a term ending at the annual general meeting to be held in 2016:

- Mr. John O'HARA, private employee, with professional address at 101, route de Holzem, L-8232 Mamer;
- Mr. Bernhard SCHRETTER, private employee, with professional address at Metallwerk Planseestrasse 71, A-6600

Reutte;

- Mr. Werner KOFELENZ, private employee, with professional address at Metallwerk Planseestraße 71, A-6600 Reutte.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

There being no further business on the agenda, the chairman adjourns the meeting at 3.15 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and German version, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Es Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den dritten Juni.
Vor mir, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.
Wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (nachstehend "Versammlung") der Plansee Group Ser-

vice S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet nach Luxemburger Recht gemäss Urkunde des Notars
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 16. August 2005, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 97 vom 16. Januar 2006, mit Sitz in 101, route de Holzem,
L-8232 Mamer, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 110.469, abge-
halten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine Urkunde des Notars, Maître Henri Hellinckx, mit

Amtssitz in Luxemburg, vom 21. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 446 vom 20. Februar 2012.

Die Versammlung beginnt um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von M 

e

 Pierre-Aexandre LECHANTRE, Rechtsanwalt,

mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt Herr Yevgeniy SADOV, Jurist, mit Berufsanschrift in Luxemburg, zum Schriftführer der Ver-

sammlung.

Zum Stimmenzähler der Versammlung wählt die Versammlung Frau Nathalie STEFFEN, Jurist, mit Berufsanschrift in

Luxemburg.

(Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler werden nachstehend gemeinsam das "Büro" genannt).
Nachdem das Büro somit gebildet wurde, erklärt und bittet der Vorsitzende den Notar wie folgt zu Protokoll zu

nehmen:

I. Aus einer von den Büro-Mitgliedern erstellten und bestätigten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle zweitau-

sendfünfhundertelf  (2.511)  Klasse  A  Aktien  mit  einem  Nennwert  von  je  eintausend  Euro  (EUR  1.000,-),  und  alle
zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse B Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-), die zu-
sammen das Aktienkapital der Ge- sellschaft in Höhe von fünf Millionenzweiundzwanzigtausend Euro (EUR 5.022.000,-)
bilden, bei der Versammlung ordnungsgemäß vertreten sind, so dass die Versammlung ordnungsgemäß konstituiert ist
und  über  die  nachfolgend  wiedergegebenen  Tagesordnungspunkte  verhandeln  kann,  wobei  die  bei  der  Versammlung

88436

L

U X E M B O U R G

vertretenen Gesellschafter sich ohne vorherige Einladungen darauf geeinigt haben, nach Prüfung der Tagesordnung zu-
sammenzutreffen.

Die Anwesenheitsliste, die von allen bei der Versammlung anwesenden und vertretenen Gesellschaftern, den Mitglie-

dern des Büros und dem Notar unterzeichnet wird, wird dieser Urkunde zusammen mit den Vollmachten, die bei den
Registrierbehörden einzureichen sind, beigefügt.

II. Die Tagesordnung hat den folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Umwandlung der Geschäftsführung der Gesellschaft von einem monistischen System in ein dualistisches System

durch die Schaffung eines Aufsichtsrats und Vorstandes gemäß Artikel 60bis-1 et seq. des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert;

2. Kenntnisnahme der Amtsniederlegung von Verwaltungsratsmitglie- dern (i) Herrn John O'HARA, (ii) Herrn Bern-

hard SCHRETTER, (iii) Dr. Michael SCHWARZKOPF, und (iv) Herrn Karlheinz WEX mit Wirkung zum 3. Juni 2013 und
Abstimmung über Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;

3. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, Gesell schaftszweck inklusive, welcher den nachfolgenden

Wortlaut haben soll, um die Beschlüsse bezüglich der oben genannten Punkte der Tagesordnung wiederzugeben;

„ 2.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Eigentumsbeteiligungen in Luxemburg oder im Ausland, an Gesell-

schaften oder Unternehmen jedweder Form und die Verwaltung solcher Eigentumsbeteiligungen. Die Gesellschaft kann
insbesondere alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Zeichnung, Kauf
oder Tausch oder jeder anderen Form, jede Aktie, Gesellschaftsanteile oder andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldver-
schreibungen, und andere Schuldtitel und Depositenquittungen allgemein jegliche Wertpapiere und Finanzinstrumente
welche durch öffentliche oder private Gesellschaften inklusive Partnerschaften jedweder Art ausgegeben wurden, er-
werben. Sie kann sich an der Gründung, der Entwicklung, der Verwaltung und der Kontrolle jeder Gesellschaft oder jedes
Unternehmens beteiligen. Die Gesellschaft kann ebenfalls in den Erwerb, die Verwaltung und den Handel mit Patenten,
Markenschutzrechten, den Erwerb und die Vergabe von Lizenzen, Unterlizenzen und ähnlichen Rechten unter jeglichem
Namen  investieren,  und  soweit  erforderlich  den  Schutz  der  Rechte  die  aus  der  Erwerbung  dieser  Patente,  Marken-
schutzrechte, Lizenzen Unterlizenzen und ähnlichen Rechten Dritten gegenüber bei Verletzung durchsetzen.

2.2.  Die  Gesellschaft  kann  Darlehen  jeglicher  Form  aufnehmen.  Sie  darf  Schuldverschreibungen,  Obligationen  und

Schuldscheine und jedwede Schuld und/oder Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann an Zweigniederlassungen
Tochtergesellschaften und jeder anderen Gesellschaft Geldmittel einschließlich der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten
verleihen und oder Schuldtitel ausgeben. Die Gesellschaft kann auch Sicherheiten jedweder Art (Bürgschaften, Garantien,
Grundschulden) in eigenem Namen sowie für Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, gegenüber Dritten stellen. Die
Gesellschaft kann außerdem alle oder einige Ihrer Aktiva verkaufen mit Hypothek, oder Verpfändung belasten oder sie
auf jede andere Weise hypothekarisch belasten.

2.3. Die Gesellschaft darf im allgemeinen jede Maßnahme anwenden und sich eines jeden Mittels bedienen um ihre

Investitionen einschließlich Cash Pooling, Factoring effizient zu verwalten, darunter Maßnahmen und Instrumente welche
dem Schutz der Gesellschaft, deren Tochtergesellschaften, verbundenen (assoziierten) Gesellschaften oder anderen Ge-
sellschaften  der  gleichen  Gruppe  gegen  Kreditrisiken,  Währungsschwankungen,  Zinssatzschwankungen  und  andere
Risiken dienen.

2.4. Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, finanzielle oder industrielle Operation ausführen und jeder Transaktion

im Zusammenhang mit Immobilien oder beweglichem Vermögen, welche direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschafts-
zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft jede andere legale Handlung oder Aktivität vornehmen, welche einer Aktien-
gesellschaft im Sinne des Gesetzes zusteht.";

4. Ernennung von Dr. Michael SCHWARZKOPF und Herrn Karlheinz WEX als Aufsichtsratsmitglieder und Bestätigung

der Dauer ihrer Amtszeit;

5. Ernennung von Herrn John O'HARA, Herrn Bernhard SCHRETTER und Herrn Werner KOFELENZ als Mitglieder

des Vorstandes und Bestätigung der Dauer ihrer Amtszeit;

6. Sonstiges.
Nach Genehmigung der Erklärung des Vorsitzenden, sowie nach Prüfung der Beschlussfähigkeit der Versammlung,

erlässt die Versammlung nach erfolgter Beratung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die a.o. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt die Geschäftsführung der Gesellschaft von einem

monistischen System in ein dualistisches System zu ändern durch die Schaffung eines Aufsichtsrats und Vorstandes gemäß
Artikel 60bis-1 et seq. des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Zweiter Beschluss

Die a.o. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt die Amtsniederlegung als Mitglied des Verwal-

tungsrates der Gesellschaft von (i) Herrn John O'HARA, (ii) Herrn Bernhard SCHRETTER, (iii) Dr. Michael SCHWARZ-

88437

L

U X E M B O U R G

KOPF, und (iv) Herrn Karlheinz WEX mit Wirkung zum 3. Juni 2013 zur Kenntnis und beschließt die ausscheidenden
Verwaltungsratsmitglieder für ihre Tätigkeit im Rahmen ihres Mandates zu entlasten.

<i>Dritter Beschluss

Die a.o. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig zu

ändern, Gesellschaftszweck inklusive, so dass die Satzung nunmehr folgenden Wortlaut hat:

Art. 1. Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft.
1.1 Der Name der Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,

insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz")
und dieser Satzung (die "Satzung") unterliegt, ist "Plansee Group Service S.A." (die "Gesellschaft").

1.2 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mamer, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann in-

nerhalb  der  Grenzen  derselben  Gemeinde  durch  Beschluss  des  Vorstandes  (der  "Vorstand")  verlegt  werden.  Durch
Beschluss des Vorstandes können Niederlassungen, Zweigstellen und/oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg
als auch im Ausland errichtet werden.

1.3 Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit errichtet.
1.4 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welche die gesetzlich vorgeschrie-

benen Voraussetzungen für eine Satzungsänderung erfüllen muss, aufgelöst werden.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Eigentumsbeteiligungen in Luxemburg oder im Ausland, an Gesell-

schaften oder Unternehmen jedweder Form und die Verwaltung solcher Eigentumsbeteiligungen. Die Gesellschaft kann
insbesondere alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Zeichnung, Kauf
oder Tausch oder jeder anderen Form, jede Aktie, Gesellschaftsanteile oder andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldver-
schreibungen, und andere Schuldtitel und Depositenquittungen allgemein jegliche Wertpapiere und Finanzinstrumente
welche durch öffentliche oder private Gesellschaften inklusive Partnerschaften jedweder Art ausgegeben wurden, er-
werben. Sie kann sich an der Gründung, der Entwicklung, der Verwaltung und der Kontrolle jeder Gesellschaft oder jedes
Unternehmens beteiligen. Die Gesellschaft kann ebenfalls in den Erwerb, die Verwaltung und den Handel mit Patenten,
Markenschutzrechten, den Erwerb und die Vergabe von Lizenzen, Unterlizenzen und ähnlichen Rechten unter jeglichem
Namen  investieren,  und  soweit  erforderlich  den  Schutz  der  Rechte  die  aus  der  Erwerbung  dieser  Patente,  Marken-
schutzrechte, Lizenzen Unterlizenzen und ähnlichen Rechten Dritten gegenüber bei Verletzung durchsetzen.

2.2  Die  Gesellschaft  kann  Darlehen  jeglicher  Form  aufnehmen.  Sie  darf  Schuldverschreibungen,  Obligationen  und

Schuldscheine und jedwede Schuld und/oder Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann an Zweigniederlassungen
Tochtergesellschaften und jeder anderen Gesellschaft Geldmittel einschließlich der Erlöse aus Kreditverbindlichkeiten
verleihen und oder Schuldtitel ausgeben. Die Gesellschaft kann auch Sicherheiten jedweder Art (Bürgschaften, Garantien,
Grundschulden) in eigenem Namen sowie für Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, gegenüber Dritten stellen. Die
Gesellschaft kann außerdem alle oder einige Ihrer Aktiva verkaufen mit Hypothek, oder Verpfändung belasten oder sie
auf jede andere Weise hypothekarisch belasten.

2.3 Die Gesellschaft darf im allgemeinen jede Maßnahme anwenden und sich eines jeden Mittels bedienen um ihre

Investitionen einschließlich Cash Pooling, Factoring effizient zu verwalten, darunter Maßnahmen und Instrumente welche
dem Schutz der Gesellschaft, deren Tochtergesellschaften, verbundenen (assoziierten) Gesellschaften oder anderen Ge-
sellschaften  der  gleichen  Gruppe  gegen  Kreditrisiken,  Währungsschwankungen,  Zinssatzschwankungen  und  andere
Risiken dienen.

2.4 Die Gesellschaft kann jede kommerzielle, finanzielle oder industrielle Operation ausführen und jeder Transaktion

im Zusammenhang mit Immobilien oder beweglichem Vermögen, welche direkt oder indirekt mit Ihrem Gesellschafts-
zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft jede andere legale Handlung oder Aktivität vornehmen, welche einer Aktien-
gesellschaft im Sinne des Gesetzes zusteht.

Art. 3. Gesellschaftskapital.
3.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird auf fünf Millionen zweiundzwanzigtausend Euro (EUR

5.022.000) festgelegt und besteht aus zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse A Aktien (die "Klasse A Aktien") und
zweitausendfünfhundertelf (2.511) Klasse B Aktien (die "Klasse B Aktien"), mit einem Nennwert von jeweils eintausend
Euro (EUR 1.000).

3.2 Sämtliche Aktien sind Namensaktien. Die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien werden zusammen als "Aktien"

bezeichnet, außer wenn der Kontext es anders verlangen sollte.

3.3 Gemäß den Bestimmungen dieser Satzung verleihen die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien spezielle Rechte,

bezüglich der Auszahlung in jedweder Form aus Rücklagenfonds, die durch Kapitalrücklagen konstituiert wurden, wobei
jedwede solcher Kapitalrücklagen immer derjenigen Aktienklasse zugeordnet werden, auf welche die Kapitalrücklage
eingezahlt wurde. Abgesehen von diesen Rechten verleihen die Klasse A Aktien und die Klasse B Aktien dieselben Rechte
an ihre jeweiligen Inhaber.

88438

L

U X E M B O U R G

3.4 Ungeachtet eines jeden anderslautenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre hat, im Falle einer

Kapitalerhöhung, jeder Aktionäre das Recht, innerhalb seiner Klasse, auf einer pro-rata Basis neu ausgegebene Aktien zu
erwerben.

Art. 4. Aktien.
4.1 Der Vorstand führt ein Aktienregister am Gesellschaftssitz, wo es zur Einsicht einem jeden Aktionär zur Verfügung

steht, in dem die Namen und Adressen aller Aktionäre registriert werden, sowie das Datum an dem sie die Aktien
erworben haben, das Datum dessen Bestätigung oder Vollstreckung, der eingezahlte Betrag für jede Aktie und die Über-
tragung von Aktien und das Datum einer solchen Übertragung. Das Eigentum an den Aktien wird durch die Eintragung
in dieses Register begründet.

4.2 Auf Verlangen eines jeden Aktionärs hat der Vorstand kostenlos einen Auszug des Registers an jeden Aktionär

auszustellen.

4.3 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an.
4.4 Die Gesellschaft darf innerhalb der gesetzlichen Einschränkungen und gemäß dem Prinzip der Gleichbehandlung

sämtlicher Aktionäre ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 5. Vorstand.
5.1 Der Gesellschaft wird von einem Vorstand verwaltet und geführt werden, bestehend aus mindestens zwei (2)

Mitgliedern, sofern der Vorstand nicht aus einem Mitglied bestehen kann gemäß den Bestimmungen des Artikels 60bis-2
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert. Die Vorstandsmitglieder werden
anfänglich für eine Amtszeit von drei (3) Jahren ernannt und können für neue jährliche aufeinanderfolgende Amtszeiten
ernannt werden.

5.2 Die Vorstandsmitglieder werden gemäß der unter diesem Art. V. näher erläuterten Verfahrensweise von der

Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt und die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt ebenfalls die Anzahl der
Vorstandsmitglieder (im Rahmen der Beschränkungen dieses Art. V.) sowie ihre Amtszeit.

5.3  Soweit  rechtlich  zulässig,  darf  eine  juristische  Person  als  Mitglied  des  Vorstandes  ernannt  werden.  Wird  eine

juristische Person als Vorstandsmitglied bestellt, so hat diese eine natürliche Person als ständigen Vertreter zu bestimmen,
der diese Rolle im Namen und auf Rechnung der juristischen Person ausübt. Die betroffene juristische Person darf ihren
ständigen Vertreter nur abberufen wenn ein entsprechender Nachfolger zur gleichen Zeit bestimmt wird.

5.4 Ein Mitglied des Vorstandes kann jederzeit mit oder ohne Grund (gemäß den Bestimmungen bzgl. der Zusammen-

setzung des Vorstandes wie in diesem Art. V. dargestellt) wie folgt abberufen oder ersetzt werden: (i) durch Beschluss
mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre in einer ordnungsgemäß einberufenen
Hauptversammlung der Aktionäre ohne Einhaltung von Quorumerfordernissen, oder (ii) durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder unter Einhaltung eines einfachen Mehrheitsquorums.

5.5 Bei freigewordenem Vorstandssitz können die restlichen Vorstandsmitglieder den freien Vorstandsposten beset-

zen, jedoch unter Wahrung der verschiedenen Vertretungen gewisser Aktionäre wie oben in diesem Art. V. beschrieben,
und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre anlässlich welcher eine endgültige Entscheidung in Bezug auf
die Nominierung gemäß der Bestimmungen dieses Art. V. getroffen wird.

Art. 6. Sitzungen des Vorstandes.
6.1 Der Vorstand wählt einen Vorsitzenden aus seinen Reihen. Der Vorstand kann ebenfalls einen Schriftführer er-

nennen, der kein Mitglied des Vorstandes zu sein braucht, und der für die Aufnahme und Aufbewahrung der Sitzungs-
protokolle des Vorstandes und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich ist.

6.2 Sitzungen des Vorstandes werden durch den Vorsitzenden geführt. In seiner Abwesenheit entscheiden die anderen

Mitglieder des Vorstandes per Mehrheitsbeschluss, dass ein anderes Vorstandsmitglied den Vorsitz dieser Sitzung innehält.

6.3 Vorbehaltlich Artikel 6.10, dürfen Vorstandsmitglieder nur im Rahmen von ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen

des Vorstandes wirken. Der Vorstand tritt aufgrund einer Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch jedes Mitglied
des Vorstandes am im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.

6.4 Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen bei denen die Umstände einer solchen Dringlichkeit im Einberufungsschrei-

ben angegeben werden, werden die Sitzungen des Vorstandes im Voraus allen Vorstandsmitgliedern schriftlich angekün-
digt.  Wenn  alle  Vorstandsmitglieder  anwesend  oder  vertreten  sind,  können  sie  auf  die  für  die  Einberufung
vorgeschriebenen Voraussetzungen und Formvorschriften verzichten. Für Sitzungen, für die der Sitzungstermin und der
Sitzungsort in einem Beschluss des Vorstandes festgelegt wurden während einer Sitzung an der alle Vorstandsmitglieder
anwesend oder vertreten sind, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

6.5 Jedes Vorstandsmitglied kann an jeder Sitzung teilnehmen und ein anderes Mitglied des Vorstandes schriftlich, per

Telefax, elektronischer Post oder jedes ähnliche Kommunikationsmittel, als Vertreter benennen. Ein Vorstandsmitglied
kann ein anderes Mitglied des Vorstandes auch per Telefon, mit nachträglicher schriftlicher Bestätigung, mit seiner Ver-
tretung beauftragen. Ein Vorstandsmitglied kann mehrere Vorstandsmitglieder vertreten.

6.6 Jedes Mitglied des Vorstandes kann per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnlichen Kom-

munikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, bei dem (i) alle Mitglieder, die an der Sitzung teilnehmen, identifiziert
werden können, (ii) alle teilnehmenden Personen untereinander sich hören und sprechen können, (iii) die Wiedergabe

88439

L

U X E M B O U R G

der Sitzung fließend erfolgt (iv) und die Mitglieder sich ordnungsgemäß beraten können. Eine solche Teilnahme gilt als
einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichwertig. Eine Vorstandssitzung mittels solchen Kommunikations-
mitteln gilt als in Luxemburg stattfindend.

6.7 Sofern nicht anders in den Bestimmungen des geltendes Rechts oder dieser Satzung angegeben, ist der Vorstand

nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind
und Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Vor-
standsmitgliedern gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden nicht entscheidend

6.8 Sitzungen, Beschlüsse und Protokolle der Vorstandsmitglieder werden in einem Protokoll festgehalten und vom

Sitzungsvorsitzenden unterzeichnet. Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, die während eines Gerichtsverfah-
rens oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

6.9  Die  Vorstandsmitglieder  können  ihre  Stimme  ebenfalls  per  Telefax,  elektronischer  Post  oder  per  Telefon,  im

letzteren Falle mit folgender schriftlicher Bestätigung, abgeben.

6.10 Schriftliche, von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso wirksam wie Beschlüsse, die

anlässlich von Vorstandssitzungen gefasst wurden; jedes Vorstandsmitglied stimmt schrift- lich einem solchem Beschluss
per Telefax, elektronischer Post, Telefon oder mittels jedem ähnlichen Kommunikationsmittel zu. Die Zustimmung ist
schriftlich zu bestätigen und jegliche Unterlagen dienen als Beweismittel einer solchen Beschlussfassung.

Art. 7. Befugnisse des Vorstandes.
7.1 Der Vorstand ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Verwaltungs- und Verfügungs-

handlung auszuführen, welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist.

7.2 Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915 oder durch die vorliegende Satzung aus-

drücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des
Vorstandes.

Art. 8. Übertragung von Befugnissen des Vorstandes.
8.1 Der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich einer solchen

täglichen Geschäftsführung an jedes Mitglied des Vorstandes, Beauftragte oder andere bevollmächtigte, juristische oder
natürliche Personen übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen, jedoch mit Ausschluss jedes allein oder gemeinschaftlich
handelnden Aufsichtsratsmitglieds, wobei diese Übertragung unter den durch den Vorstand bestimmten Bedingungen und
Befugnissen erfolgt.

8.2 Der Vorstand kann ebenfalls alle Befugnisse oder spezielle Vollmachten an andere von ihnen auserwählte Personen

oder Vertreter übertragen, die nicht Vorstandsmitglieder sein müssen, Beauftragte und Angestellte ernennen und abbe-
rufen und ihre Bezüge bestimmen.

Art. 9. Vertretung der Gesellschaft.
9.1 Die Gesellschaft wird in allen Fällen gegenüber Dritten entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier (2)

Mitglieder des Vorstandes rechtsverbindlich verpflichtet oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Ein-
zelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Vorstand schriftlich übertragen wurden,
rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt. Um jeden Zweifel
auszuschließen, dürfen die Mitglieder des Vorstandes die Gesellschaft nicht rechtsverbindlich durch ihre Einzelunterschrift
verpflichten, es sei denn eine spezielle Ermächtigung hierzu mittels Beschluss des Vorstandes erfolgt.

9.2 Falls ein täglicher Geschäftsführer für die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich

solcher täglichen Geschäftsführung bestellt worden ist, wird die Gesellschaft in allen Fällen gegenüber Dritten durch die
Einzelunterschrift des täglichen Geschäftsführers innerhalb des Rahmens der täglichen Geschäftsführung rechtsverbindlich
verpflichtet.

Art. 10. Mitglieder des Aufsichtsrates.
10.1 Die Gesellschaft wird vom Vorstand verwaltet unter der Gesamtaufsicht des Aufsichtsrates. Die Mitglieder des

Aufsichtsrates müssen keine Aktionäre sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für eine Amtszeit von drei (3) Jahre
ernannt und können wiederernannt werden.

10.2 Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die ebenfalls die

Dauer ihrer Mandate, sowie ihre Bezüge bestimmt.

10.3 Keine Person kann gleichzeitig Mitglied des Vorstandes und Mitglied des Aufsichtsrates sein.
10.4 Soweit rechtlich zulässig, darf ein juristische Person als Mitglied des Aufsichtsrates ernennt werden. Wird eine

juristische Person als Aufsichtsratsmitglied bestellt, so hat diese eine natürliche Person als ständigen Vertreter zu be-
stimmen, der diese Rolle im Namen und auf Rechnung der juristischen Person ausübt. Die betroffene juristische Person
darf ihren ständigen Vertreter nur abberufen wenn ein entsprechender Nachfolger zur gleichen Zeit bestimmt wird.

10.5 Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der

Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Aktionäre in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der
Aktionäre ohne Einhaltung von Quorumerfordernissen abberufen oder ersetzt werden.

88440

L

U X E M B O U R G

10.6 Bei freigewordenem Aufsichtsratssitz können die restlichen Aufsichtsratsmitglieder den freien Aufsichtsratsposten

besetzen bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre anlässlich welcher eine endgültige Entscheidung in Bezug auf
die Nominierung gemäß der Bestimmungen dieses Art. X. getroffen wird.

Art. 11. Sitzungen des Aufsichtsrates.
11.1 Der Aufsichtsrat wählt aus seinen Reihen einen Vorsitzenden.
11.2 Der Aufsichtsrat hat, sooft es die Belange der Gesellschaft erfordern, mindestens jedoch zweimal (2) jährlich,

zusammenzutreten. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates leitet alle Sitzungen des Aufsichtsrates. Im Falle seiner Abwe-
senheit tritt an seiner Stelle ein anderes von einem Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsrats-
mitglieder bestimmtes Aufsichtsratsmitglied zur zeitweiligen Führung solcher Sitzung des Aufsichtsrates.

11.3 Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) Aufsichtsratsmitglieder. Die Sitzungen des

Aufsichtsrates finden an dem Ort statt, der in der Einberufung genannt wird. Eine Sitzung des Aufsichtsrates soll ferner
einberufen werden, wenn es der Vorstand beantragt. Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen die Sitzungen des
Aufsichtsrates mindestens drei (3) Tage vorher schriftlich angekündigt werden. In Dringlichkeitsfällen sollen die Umstände
solcher Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden. Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Auf-
sichtsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und auf der für die Einberufung vorgeschriebenen Voraussetzungen
und Formvorschriften verzichten. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem
früheren Beschluss des Aufsichtsrates festgelegt wurden während einer Sitzung bei der alle Aufsichtsratsmitglieder an-
wesend oder vertreten waren, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

11.4 Der Aufsichtsrat kann die Mitglieder des Vorstandes oder andere Personen einladen an seinen Sitzungen als

Beobachter ohne Stimmrecht teilzunehmen.

11.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an jeder Sitzung teilnehmen und ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates schriftlich,

in Original, per Telefax, elektronischer Post mit elektronischen Unterschrift (die gemäß Luxemburgischem Recht wirksam
ist), mit seiner Vertretung beauftragen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere Aufsichtsratsmitglieder vertreten, jedoch
unter der Bedingung dass mindestens zwei (2) Aufsichtsratsmitglieder bei der Sitzung anwesend sind oder unter Zuhil-
fenahme jedes Kommunikationsmittels gemäß der Satzung und des Gesetzes an solcher Sitzung teilnehmen.

11.6 Sofern nicht anders angegeben in den Bestimmungen des geltendes Rechts oder dieser Satzung, ist der Aufsichtsrat

nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern anwesend oder vertreten
sind und Beschlüsse des Aufsichtsrates mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Auf-
sichtsratsmitgliedern gefasst werden.

11.7 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates.
11.8 Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnlichen

Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, bei dem (i) alle Mitglieder, die an der Sitzung teilnehmen, identifiziert
werden können, (ii) alle teilnehmenden Personen untereinander sich hören und sprechen können, (iii) die Wiedergabe
der Sitzung fließend erfolgt (iv) und die Mitglieder sich ordnungsgemäß beraten können. Eine solche Teilnahme gilt als
einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichwertig. Eine Aufsichtsratssitzung mittels solcher Kommunikations-
mittel gilt als in Luxemburg stattfindend.

11.9 Ungeachtet obigem sind schriftliche, von allen Aufsichtsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse genauso wirk-

sam wie Beschlüsse, die anlässlich von Aufsichtsratssitzungen gefasst wurden; jedes Aufsichtsratsmitglied stimmt schriftlich
einem solchem Beschluss per Telefax, elektronischer Post, Telefon oder mittels jedem ähnlichen Kommunikationsmittel
zu. Die Zustimmung ist schriftlich zu bestätigen und jegliche Unterlagen dienen als Beweismittel einer solchen Beschluss-
fassung.

11.10 Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dem stellvertre-

tenden Vorsitzenden unterzeichnet. Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, die während eines Gerichtsverfah-
rens oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder von zwei (2) Mitgliedern des
Aufsichtsrats unterzeichnet.

Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrates.
12.1 Der Aufsichtsrat obliegt der permanenten Überwachung und Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Gesell-

schaft durch den Vorstand. Der Aufsichtsrat kann in die Geschäftsführung der Gesellschaft nicht eingreifen.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen des Aufsichtsrates.
13.1 Der Aufsichtsrat kann ein oder mehrere ihrer Mitglieder zur Ausübung einer oder mehrerer spezifischer Aufgaben

bestellen.

13.2 Der Aufsichtsrat kann ebenfalls zur Unterstützung bei der Erfüllung seiner Aufgaben interne Ausschüsse bilden.

Die Zusammensetzung und Aktivitäten dieser Ausschüsse werden von dem Aufsichtsrat festgelegt und die Ausschüsse
handeln unter der Aufsicht des Aufsichtsrates. Sämtliche Befugnisse, die durch das Gesetz oder durch die vorliegende
Satzung ausdrücklich dem Aufsichtsrat vorbehalten sind, können jedoch durch den Aufsichtsrat nicht an einen jeweiligen
Ausschuss übertragen werden und eine solche Übertragung kann keine Reduzierung oder Beschränkung der Befugnisse
des Vorstandes mit sich ziehen.

88441

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Abschlussprüfung.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten März und endet am letzten Tag des Monats Februar.
14.2 Jedes Jahr nach Ende des Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss und einen Jahresbericht be-

züglich dieses Geschäftsjahres.

14.3 Der Jahresabschluss wird von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und muss den Jahresbericht und alle vom

luxemburgischen Gesetz vorgeschriebenen Unterlagen beinhalten.

14.4 Der Jahresabschluss muss den Aktionären und jedem der Aufsichtsratsmitglieder zur Einsichtnahme und/oder

Erhalt von Kopien zur Verfügung gestellt werden.

14.5 Die Gesellschaft muss das Rechnungswesen und das Buchhaltungsverfahren gemäß den zwingenden Vorschriften

des luxemburgischen Rechts und in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Bilanzrichtlinien anwenden.

14.6 Ein oder mehrere Abschlussprüfer werden von der Hauptversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von

maximal  (6)  sechs  Jahren  gewählt.  Abschlussprüfer  können  für  eine  oder  mehrere  Amtszeiten  ernannt  werden.  Ab-
schlussprüfer  können  von  der  Hauptversammlung  der  Aktionäre  jederzeit  und  ohne  Grund  abberufen  werden.  Die
Hauptversammlung der Aktionäre entscheidet über die Vergütung der Abschlussprüfer. Jeder Abschlussprüfer hat ein
uneingeschränktes  Recht  zur  Prüfung  aller  Geschäfte  der  Gesellschaft  und  ihrer  Tochtergesellschaften  und  kann  alle
finanziellen Dokumente, Korrespondenzen, Protokolle, Unterlagen sowie alle anderen Dokumente der Gesellschaft und
ihrer Tochtergesellschaften prüfen und untersuchen. Die Abschlussprüfer müssen die Hauptversammlung der Aktionäre
über das Ergebnis der Abschlussprüfung des konsolidierten und des unkonsolidierten Jahresabschlusses der Gesellschaft
und ihrer Tochtergesellschaften, die Art und Weise der Prüfung der Inventur informieren und müssen, falls notwendig,
Verbesserungsvorschläge einreichen.

Art. 15. Dividendenpolitik.
15.1 Ein Betrag von 5 (fünf) Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinns ist der gesetzlichen Rücklage

zuzuführen, bis diese ein Zehntel des Gesellschaftskapitals oder einen in der Satzung bestimmten höheren Anteil des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

15.2 Unter Berücksichtigung des Gesetzes ist der Vorstand ermächtigt, Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 16. Hauptversammlungen der Aktionäre.
16.1 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz, in

Mamer am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort der Gemeinde, am
ersten Dienstag im Juni eines jeden Jahres um 10 Uhr morgens statt. Ist dieser Tag kein gesetzlicher Arbeitstag für Banken
in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre am nächsten Arbeitstag statt.

16.2 Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre kann im Ausland stattfinden wenn dies aufgrund eines außerge-

wöhnlichen Umstandes nach der Einschätzung des Vorstandes notwendig ist.

10.3 Andere Hauptversammlungen der Aktionäre, einschließlich ordentliche und außerordentliche Hauptversamm-

lungen der Aktionäre der Gesellschaft, werden an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten, wie dies in dem
entsprechenden Einberufungsschreiben angegeben wird.

16.4 Die Hauptversammlung der Aktionäre wird vom Vorstand durch eine schriftliche Benachrichtigung welche an alle

im Register, auf welches in Artikel IV Bezug genommen wird, genannten Aktionäre gesandt wird, mindestens fünfzehn
(15) Tage vor dem geplanten Termin einberufen. Sind alle Aktionäre anwesend und einverstanden um über die vorgelegte
Tagesordnung abzustimmen, so kann die Hauptversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

16.5 Eine Hauptversammlung der Aktionäre kann auch unverzüglich einberufen werden falls Aktionäre, die mindestens

ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, in einen schriftlichen Antrag unter Angabe der Tagesordnung dazu auf-
fordern. Falls der Vorstand den Antrag innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nicht befolgt, können die berechtigten Aktionäre
selbst die Hauptversammlung der Aktionäre unter Angabe des Zwecks und der Gründe einberufen. In diesem Fall soll
die Hauptversammlung der Aktionäre entscheiden, ob die Gesellschaft die Kosten der Einberufung tragen soll.

16.6 Jeder Aktionär ist berechtigt eine andere Person, die kein Aktionäre sein muss, zu bevollmächtigen, ihn zu ver-

treten und an seiner Stelle bei der Hauptversammlung der Aktionäre abzustimmen.

16.7 Das Einberufungsschreiben der Hauptversammlung der Aktionäre soll, in Übereinstimmung mit den zwingenden

Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes, das Datum, die Zeit und den Ort der Hauptversammlung der Aktionäre,
sowie die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre, bekannt geben.

16.8 Jede Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates geleitet.
16.9 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen, müssen

mindestens 51 (einundfünfzig) Prozent des ausgegebenen und eingezahlten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft anwe-
send  oder  ordnungsgemäß  vertreten  sein,  damit  die  Hauptversammlung  der  Aktionäre  beschlussfähig  ist.  Falls  diese
Beschlussfähigkeit bei der Versammlung nicht erfüllt ist, wird eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen,
welche auf die Tagesordnung der vorangegangenen Versammlung beschränkt ist und unabhängig des vertretenen Gesell-
schaftskapitals, beschlussfähig ist.

88442

L

U X E M B O U R G

16.10 Sofern zwingende gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieser Satzung nichts anderes bestimmen, wer-

den Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre durch eine einfache Mehrheit der Stimmen gefasst.
Außerordentliche Beschlüsse bedürfen immer der Mehrheit von 2/3 (zwei Drittel) der Stimmen.

16.11 Kopien und/oder Auszüge der Protokolle der Hauptversammlung der Aktionäre, die dem Gericht oder irgend-

einer  Person  vorgelegt  werden  müssen,  werden  von  dem  Vorsitzenden  der  die  jeweilige  Versammlung  geleitet  hat,
beglaubigt.

Art. 17. Alleiniger Aktionär.
17.1 Wenn die Anzahl der Aktionäre auf einen (1) reduziert wird, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die

nach dem Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre zustehen.

17.2 Die in dieser Satzung auf die Hauptversammlung der Aktionäre bezugnehmenden Vorschriften sind auf den allei-

nigen Aktionär entsprechend anwendbar.

17.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

Art. 18. Auflösung und Liquidation.
18.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschließen.
18.2 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst, so hat diese mindestens

einen Liquidator zu bestimmen, der eine natürliche oder juristische Person sein kann. Die Hauptversammlung der Akti-
onäre bestimmt auch über die Höhe der Vergütung des Liquidators. Falls die Hauptversammlung der Aktionäre keinen
Liquidator bestellt, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Vorstandes durchgeführt.

Art. 19. Allgemeine Bestimmung. Diese Satzung muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz interpretiert, ausgelegt und

ergänzt werden.".

<i>Vierter Beschluss

Die a.o. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt,nach Kenntnisnahme, dass die Gesellschaft zur

Zeit nur einen einzigen Aktionär hat, folgende Personen als Aufsichtsratsmitglieder für eine Amtszeit bis zur ordentlichen
Hauptversammlung der Aktionäre, welche im Jahr 2016 stattfindet zu bestellen:

- Dr. Michael SCHWARZKOPF, Privatangestellter, geschäftsansässig in Metallwerk Planseestrasse 71, A-6600 Reutte;
- Herrn Karlheinz WEX, Privatangestellter, geschäftsansässig in Metallwerk Planseestrasse 71, A-6600 Reutte.

<i>Fünfter Beschluss

Die a.o. Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt folgende Personen als Vorstandsmitglieder für

eine Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, welche im Jahr 2016 stattfindet zu bestellen:

- Herrn John O'HARA, Privatangestellter, geschäftsansässig in 101, route de Holzem, L-8232 Mamer;
- Herrn Bernhard SCHRETTER, Privatangestellter, geschäftsansässig in Metallwerk Planseestrasse 71, A-6600 Reutte;
- Herrn Werner KOFELENZ, Privatangesteller, geschäftsansässig in Metallwerk Planseestraße 71, A-6600 Reutte.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde

entstehen, werden auf eintausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.

Da keine weiteren Angelegenheiten auf der Tagesordnung sind, beschließt der Vorsitzende die Versammlung um 15.15

Uhr.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Wunsch der erschienenen Personen in englischer Sprache verfasst und von einer deutschen Fassung gefolgt
wird; auf Wunsch der erschienenen Personen soll die englische Fassung im Falle von Abweichungen zwischen der engli-
schen und deutschen Version die maßgebliche Fassung sein.

Worüber diese Urkunde, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg angefertigt wurde.
Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: P.-A. LECHANTRE, Y. SADOV, N. STEFFEN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 05 juin 2013. Relation: DIE/2013/7174. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 13. Juni 2013.

Référence de publication: 2013078024/808.
(130095852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

88443

L

U X E M B O U R G

Kottla Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.922.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth of May.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Kottla Holding S.à r.l., a limited liability company,

having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share
capital of Euro 32,500.- registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 113
922 and incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, dated 7 December
2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial C") under number 812 dated 22
April 2006 (the "Company").

The meeting is presided by Mr Raymond THILL, maître en droit, professionally residing in L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo.

The Chairman appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, professionally residing in L-1750 Luxem-

bourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, private employee, professionally residing in L-1750 Luxem-

bourg, 74, avenue Victor Hugo.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholder present or represented and the number and class of shares held by him are shown on an attendance

list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said
attendance list as well as the proxy "ne varietur" will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 250 Ordinary Shares and 400 Preferred Shares, representing the entirety

of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. The sole shareholder
declares having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and
formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the afore cited agenda of
the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Approval of the distribution of EUR 2,750.- to the legal reserve.
2. Approval of the redemption of all Class A Preferred Shares at an Interim Share Redemption Price as determined

by the Board pursuant to the articles of the Company so as to proceed to the liquidation of an entire class of shares of
the Company, cancellation of 100 Class A Preferred Shares and consequential reduction of the issued share capital of the
Company.

3. Delegation of power.
4. Consequential amendment of articles eight and ten of the articles of association of the Company so as to delete all

references to Class A Preferred shares and to provide for the new issued share capital amount of the Company.

After approval of the foregoing, the sole shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The sole shareholder approved the interim accounts established by the board of managers as at May 7, 2013 showing

a profit of EUR 2,958,846.-.

He decided to allot from this profit an amount of two thousand seven hundred and fifty euro (EUR 2,750.-) to the

legal reserve.

<i>Second resolution

The sole shareholder approved the repurchase, by the Company pursuant to a resolution of the board of managers

of the Company, passed on 8 May 2013 and based on the interim accounts as at 7 May 2013, of one hundred (100) Class
A Preferred Shares in the Company with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each (the "Repurchased Shares").

Pursuant to the repurchase, the meeting decides to decrease the share capital amount by EUR 5,000.- (five thousand

euro) in order to bring it from its current amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred euro) to EUR
27,500.- (twenty-seven thousand five hundred euro), by way of reimbursement to the shareholders of an amount of EUR
5,000.- for the repurchased class A Preferred Shares proportionally to their shareholding and by cancellation of 100 Class
A Preferred Shares.

The Company paid for the Repurchased Shares a global amount of two million nine hundred and thirty-seven thousand

seven hundred and eighty-four Euro (EUR 2,937,784.-), composed of the par value of the shares being EUR 5,000.- and

88444

L

U X E M B O U R G

an amount of EUR 2,932,784.- from the net profit of the Company, as proved by the presaid interim accounts, to the
shareholders.

REIMBURSEMENT DELAY
The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial

companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to
the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the
present deed in the Luxembourg Memorial C.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to confer all powers to any member of the board of managers in order to implement

the necessary bookkeeping amendments, to cancel the redeemed shares and to organise the payment of the redemption
price to the shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend articles 8 and 10 of the Articles

of association of the Company so as to delete all references to Class A shares. Articles 8 and 10 now shall be read as
follows:

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 27,500.- (twenty-seven thousand five hundred euro), represented by 550

(five hundred and fifty) shares of EUR 50.- (fifty euro) each, distributed amongst the types and classes of shares as set out
below:

- 250 (two hundred fifty) ordinary shares, each of EUR 50.- (fifty euro), hereafter altogether referred to as the "Ordinary

Shares";

- 300 (three hundred) redeemable shares, each of EUR 50.- (fifty euro), hereafter altogether referred to as the "Pre-

ferred Shares'Which are divided into 3 (three) classes of 100 (one hundred) shares each."

Art. 10. The rights and preferences of the shares issued by the Company shall be the following:
The Ordinary Shares are non-redeemable shares.
The Preferred Shares are redeemable shares, at the option of the Company only under the terms and conditions

stipulated in the present clause, such as follows:

a) In the event the Company decides to exercise its option of redemption, it may not redeem part only of a specific

class of shares, but may only redeem all of the shares comprised into a class of shares, in their entirety.

b) The Company may only exercise the option to redeem a class of shares under the condition that at the time of the

redemption such as described below, the Company has made profits or holds reserves available for distribution according
to the approved annual accounts of the last closed financlal year of the Company, or as the case may be according to an
interim balance-sheet of the Company drawn up on the date of the redemption.

c) Any class of redeemable shares may only be redeemed at the time and during the period, such as described below:
- The Class B Shares relates to the financial year ending on 31 December 2006 (hereafter referred to as "FY 2"), and

may only be redeemed during a period starting on 1 July 2006 and ending on 31 December 2007;

- The Class C Shares relates to the financial year ending on 31 December 2007 (hereafter referred to as "FY 3"), and

may only be redeemed during a period starting on 1 July 2007 and ending on 31 December 2008;

- The Class D Shares relates to the financial year ending on 31 December 2008 (hereafter referred to as "FY 4"), and

may only be redeemed during a period starting on 1 July 2008 and ending on 31 December 2009;

d) In the case where a class of shares has not been redeemed for any reason, then the Company may opt for the

redemption of the same class of shares during the financial years subsequent to FY 4, and, in case of numerous classes of
shares not redeemed after FY 4, pursuant to the increasing order of the number of the classes of shares. Any class of
shares that has not been redeemed may, pursuant to this increasing order, be indefinitely redeemed, without any limitation
of time, until the option to redeem is finally exercised by the Company. Such second round redemption shall occur
pursuant to the same terms and conditions as the first round redemption, such as described in the present article 10, to
the exception of sub-paragraph c) above.

e) The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders adopted at an

extraordinary general meeting at the unanimity of the shareholders as the case may be, upon proposal by the manager,
or in case of plurality of managers, by the board of managers.

f) The redemption price per share (the "Share Redemption Price") shall be calculated as follows:
Share Redemption Price = Share Nominal Value + (Distributable sums / Number of the shares in the Class of shares

redeemed)

Where:
- The Share Nominal Value is the nominal value of each share of the Class of Shares redeemed at the time where the

option of redemption is exercised by the Company;

88445

L

U X E M B O U R G

- The Distributable sums are ail distributable sums pursuant to the approved annual accounts of the financial year to

which the Class of Shares concerned relates, in the meaning of article 72-1 of the Law.

g) The interim redemption price per share (the "Interim Share Redemption Price") shall be calculated as follows:
Interim Share Redemption Price = Interim Share Nominal Value + (Interim Distributable sums / Number of the shares

in the Class of shares redeemed)

Where:
- The Interim Share Nominal Value is the nominal value of each share of the Class of Shares redeemed at the time

where the option of redemption is exercised by the Company;

- The Interim Distributable Sums are the realised profits since the end of the last financial year preceding the one to

which the Class of Shares concerned is related to, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the
Articles, as resulting from the Interim Accounts.

h) Any redeemed shares shall be cancelled immediately as soon as they are received and owned by the Company, and

therefore the Company's share capital shall be decreased accordingly.

i) Any amendment of any stipulations of the present article 10 as well as any amendment relating to articles 17 and 18

shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, adopted at the extraordinary general
meeting of the shareholders at the unanimity of all the shareholders."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred and fifty Euro (EUR 1,350.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le huit mai.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Kottla Holding S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
ayant un capital social de 32.500,- euros, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 113 922 et constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 décembre
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial C»), numéro 812 du 22 avril 2006 ( la
«Société»).

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désdigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à

L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et les procurations «ne varietur», une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) et quatre cents (400)

parts sociales préférentielles représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les associés ont été préalablement informés. L'assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut
délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises:

88446

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1) Distribution à la réserve légale un montant de EUR 2.750,-.
2) Approbation du rachat de toutes les parts sociales préférentielles de Classe A à un Prix intérimaire de rachat des

Parts déterminé par le Conseil de Gérance par application des statuts de la Société afin de procéder à la liquidation d'une
classe entière de parts sociales de la Société, à l'annulation de 100 parts sociales préférentielles de Classe A et à la
réduction du capital social de la Société.

3) Délégation de pouvoir
4) Modification de l'article huit et dix des statuts de la Société de manière à éliminer toute référence aux parts sociales

préférentielles de Classe A et à mentionner le nouveau montant du capital social de la Société.

Après approbation de ce qui précède, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit:

<i>Première résolution

L'associé unique approuve le bilan intérimaire établi par le conseil de gérance à la date du 7 mai 2013 montrant un

bénéfice de EUR 2.958.846,-.

Il décide d'allouer de ce bénéfice une somme de deux mille sept cent cinquante euros (EUR 2.750,-) à la réserve légale.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique approuve le rachat, par la Société suivant une résolution du conseil de gérance du 8 mai 2013 sur

base des comptes intérimaires du 7 mai 2013, de cent (100) parts sociales préférentielles de Classe A dans la Société avec
une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune (les "Parts Rachetées").

Suite au rachat, l'associé décide de réduire le montant du capital social à concurrence de EUR 5.000,- (cinq mille euros)

pour le ramener de son montant actuel de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros) à EUR 27.500,- (vingt-sept
mille cinq cents euros), par remboursement aux associés d'un montant de EUR 5.000,- pour les parts sociales préféren-
tielles de Classe A rachetées proportionnellement à leur détention et par l'annulation de 100 parts sociales préférentielles
de Classe A.

La Société a payé pour les parts rachetées un montant global de deux millions neuf cent trente-sept mille sept cent

quatre-vingt-quatre euros (EUR 2.937.784,-) aux associés, composé de la valeur nominale des parts soit EUR 5.000,- et
un montant de EUR 2.932.784,- du bénéfice net de la Société, comme prouvé par les comptes intérimaires prédécrits.

DELAI DE REMBOURSEMENT
Le notaire soussigné a attiré l'attention de l'assemblée aux dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés com-

merciales établissant une protection légale en faveur de créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif aux
associés ne peut pas avoir lieu librement et sans recours de leur part avant 30 (trente) jours après la publication du
présent acte au Mémorial C du Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'associé unique octroie tous pouvoirs à chacun des membres du conseil de gérance pour procéder aux écritures

comptables qui s'imposent, pour annuler les parts rachetées et organiser le paiement du prix de rachat aux associés de
la Société.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'associé unique décide de modifier les articles 8 et 10 des statuts de la

Société de manière à éliminer toute référence aux parts sociales préférentielles de Classe A. Les articles 8 et 10 auront
désormais la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 27.500,- (vingt-sept mille cinq cent euros), représenté par 550 (cinq cent

cinquante) parts sociales entièrement souscrites, d'une valeur de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, réparties en types
et classes de parts comme suit:

- 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires chacune de EUR 50.-(cinquante euro) ci-après mentionné comme

les "Parts Sociales Ordinaires";

- 300 (trois cents) parts sociales rachetables, chacune de EUR 50.-(cinquante euro) ci-après mentionné comme les

"Parts Sociales Préférentielles", qui sont divisées en 3 (trois) catégories de 100 (cent) parts sociales chacune.»

Art. 10. Les droits et les préférences des parts sociales souscrites par la Société seront établit comme suit:
Les Parts Sociales Ordinaires sont des parts non rachetables.
Les Parts Sociales Préférentielles sont des parts sociales achetables à l'option de la Société, et seulement sous les

conditions générales stipulées dans la présente clause, à savoir.

a) Dans le cas où la Société décide d'exercer son option de rachat, elle ne peut pas racheter seulement une partie

spécifique d'une classe de parts sociales, mais peut seulement racheter toutes les parts sociales comprises dans une classe
de parts sociales, dans leur intégralité.

88447

L

U X E M B O U R G

b) La Société ne peut exercer l'option de rachat d'une classe de parts sociales que si et seulement si, au moment du

rachat comme décrit ci-dessous, les comptes annuels approuvés du dernier exercice financier de la Société, ou, le cas
échéant, un bilan Intérimaire de la Société établi à la date du rachat, établissent que la Société a fait des profits ou dispose
de réserves disponibles pour la distnbution, d'un montant suffisant.

c) Quelle que soit la classe de Parts Sociales Préférentielles, elle ne peut être rachetée qu'au moment et durant les

pénodes ci-après définies:

- Les Parts Sociales de classe B se rapportent à l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 (ci-après men-

tionné comme "FY 2") et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1er juillet 2006 et se
terminant le 31 décembre 2007;

-  Les  Parts  Sociales  de  classe  C  se  rapportent  à  l'exercice  financier  se  terminant  le  31  décembre  2007  (ci-après

mentionné comme "FY 3") et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1 

er

 juillet 2007 et

se terminant le 31 décembre 2008;

-  Les  Parts  Sociales  de  classe  D  se  rapportent  à  l'exercice  financier  se  terminant  le  31  décembre  2008  (ci-après

mentionné comme "FY 4") et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1er juillet 2008 et se
terminant le 31 décembre 2009;

d) Au cas où, pour quelque raison que ce soit, une classe de parts sociales n'a pas été rachetée, la Société peut opter

pour le rachat de cette même classe de parts sociales pendant les exercices financiers ultérieurs à FY4 et, en cas de
nombreuses classes de parts sociales non rachetées après FY 4, par ordre croissant des numéros des classes de parts
sociales. N'importe quelle classe de parts sociales qui n'a pas été rachetée peut, en respectant cet ordre croissant, être
indéfiniment rachetable, sans aucune limitation de temps, jusqu'à ce que l'option d'achat soit finalement exercée par la
Société. Un tel deuxième tour de rachat se déroulera conformément aux mêmes conditions générales que le premier
tour de rachat, comme décrit dans l'article présent 10, à l'exception de sous-paragraphe c) ci-dessus.

e) Le rachat sera effectué par une décision de l'associé unique ou à l'unanimité des associés adoptée lors d'une as-

semblée générale extraordinaire des associés suivant le cas, sur proposition du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants,
par le conseil de gérance.

f) Le prix de rachat des parts sociales (le "Prix de rachat des Parts") sera calculé de la manière suivante:
Prix de rachat des Parts = Valeur nominale de la part + (Sommes distribuables / Nombre de parts dans la classe de

parts Rachetées)

Où:
- La Valeur nominale de la part correspond à la valeur nominale de chaque part de classe rachetable au moment de

l'exercice de l'option de rachat par la Société;

- Les sommes distribuables correspondent aux sommes distribuables sur base des comptes annuels approuvés de

l'exercice financier auquel se rapporte la classe d'action dans le sens de l'article 72-1 de la Loi.

g) Le prix intérimaire de rachat des parts sociales (le "Prix Intérimaire de rachat des Parts") sera calculé de la manière

suivante:

Valeur nominale Prix intérimaire de rachat des Parts = intérimaire de la part + (Sommes intérimaires distribuables
/ Nombre de parts dans la classe de parts rachetée)
Où:
La valeur nominale intérimaire de rachat de part correspond à la valeur nominale de chaque part de classe rachetable

au moment de l'exercice de l'option de rachat par la Société;

Les sommes intérimaires distribuables correspondent aux profits réalisés à compter de la clôture du dernier exercice

financier  précédent  celui  auquel  la  classe  d'action  rachetable  se  rapporte,  augmenté  des  profits  à  terme  et  réserves
distribuables, mais diminué des pertes à terme et sommes devant être allouées à une réserve devant être établi en
conformité avec la Loi et les Articles comme résultant de comptes intérimaires.

h) Toute part rachetée sera immédiatement annulée aussitôt qu'elle aura été reçue et acquise par la Société, et dès

lors le capital social de la Société sera réduit d'autant.

i) Toute modification d'une quelconque stipulation du présent article 10 ainsi que toute modification relative aux articles

17 et 18 sera décidée par résolution de l'associé unique ou adoptée lors d'une assemblée générale des associés à l'una-
nimité de tous les associés."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ mille trois cent cinquante euros (EUR 1.350,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

88448

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Thill, C. Petit, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 mai 2013. Relation: LAC/2013/22666. Reçu soixante-quinze euros Eur

75,-.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 28 mai 2013.

Référence de publication: 2013077900/285.
(130096422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

NGP III Managers, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 170.162.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth day of May,
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. InArena GmbH, a Swiss private limited liability company (GmbH), having its registered office at Bahnhofstrasse 12,

6370 Stans, Canton of Nidwalden, Switzerland and registered with the Canton of Nidwalden commerce registry under
number CH-150.4.003.745-4, holder of five thousand five hundred (5,500) shares of the Company;

here represented by Me Aurélien Favier, Avocat à la Cour, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal;

2. Mr. John E. Gardner, a United States of America citizen, born on 23 December 1961, in Ohio, USA, with address

at 1545 Beach Street, San Francisco, CA 94123; USA, holder of five thousand five hundred (5,500) shares of the Company;

here represented by Me Aurélien Favier, Avocat à la Cour, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal; and

3. Mr. Paul J. Asel, a United States of America citizen, born on 27 March 1964, in Vermont, USA, with address at 300

North Cherry St., Falls Church, VA 22046, USA, holder of five thousand five hundred (5,500) shares of the Company;

here represented by Me Aurélien Favier, Avocat à la Cour, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represents sixteen thousand five hundred (16,500) shares of the Company in registered form,

having a par value of one US dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up, so that all the shareholders of the
Company representing 100% of the share capital of the Company are represented at the present extraordinary general
meeting of the shareholders of the Company (the "Meeting") and all shareholders state that they have been duly informed
of the agenda of the Meeting as set out hereafter, so that the Meeting is validly constituted and can validly decide on all
the item on the agenda.

The agenda of the Meeting is the following:
1. Change of the corporate object of the Company which shall read as follows:

Art. 3. Corporate Object.
3.1. The purpose of the Company is to act as the managing general partner (associé gérant commandité) of Nokia

Growth Partners III (S.C.A.) SICAV-SIF a Luxembourg specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé or
SIF) governed by the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds as amended.

3.2. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

2. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting duly represented, unanimously

decides the following resolutions:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves to change the corporate object of the Company which shall now read as follows:

88449

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Corporate Object.
3.1. The purpose of the Company is to act as the managing general partner (associé gérant commandité) of Nokia

Growth Partners III (S.C.A.) SICAV-SIF a Luxembourg specialised investment fund fonds d'investissement spécialisé or
SIF) governed by the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds as amended.

3.2. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

No further item being on the agenda of the Meeting, the Meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately nine hundred euros (EUR 900.-).

<i>Information

The undersigned notary informs the appearing parties that before amending the corporate object of the company, or

should the company be submitted to any particular and specific law in connection with its activity; the appearing parties
have to carry out all formalities in order to render the activity of the Company effective anywhere and towards any third
party; which is hereby acknowledges be the appearing parties.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties who signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-quatre mai,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. InArena GmbH, a société à responsabilité limitée de droit Suisse (GmbH), ayant son siège social à Bahnhofstrasse

12, 6370 Stans, Canton de Nidwalden, Suisse et immatriculée au Registre de Commerce du Canton de Nidwalden sous
le numéro CH-150.4.003.745-4, détenteur de cinq mille cinq cents (5.500) parts dans le capital social de la Société;

ici représentée par Me. Aurélien Favier, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé;

2. M. John E. Gardner, citoyen des Etats-Unis d'Amérique, né le 23 décembre 1961, dans l'Ohio, USA, et résidant à

1545 Beach Street, San Francisco, CA 94123; USA, détenteur de cinq mille cinq cents (5.500) parts dans le capital social
de la Société;

ici représenté par Me. Aurélien Favier, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé; et

3. M. Paul J. Asel, citoyen des Etats-Unis d'Amérique, né le 27 mars 1964, dans le Vermont, USA, et résidant à 300

North Cherry St., Falls Church, VA 22046, USA, détenteur de cinq mille cinq cents (5.500) parts dans le capital social de
la Société;

ici représenté par Me. Aurélien Favier, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d'une procuration sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les  parties  comparantes,  représentant  les  seize  mille  cinq  cents  (16.500)  parts  sociales  de  la  Société  sous  forme

nominatives et ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées, de sorte que tous les associés de la Société représentant 100% du capital social de la Société sont représentés
à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société (l'«Assemblée») et tous les associés déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée tel que reproduit ci-après de sorte que l'Assemblée est valablement
constituée et peut valablement délibérer des points à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'objet social de la Société qui sera rédigé comme suit:

88450

L

U X E M B O U R G

« Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est d'être désignée et d'agir en tant qu'associé gérant commandité de Nokia Growth Partners

III (S.C.A.) SICAV-SIF un fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi du 17 février 2007 relative aux fonds d'inves-
tissement spécialisé, telle que modifiée.

3.2. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»

2. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'Assemblée dûment représentée, décide à l'unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide de changer l'objet social de la Société qui devra désormais être rédigé comme suit:

« Art. 3. Objet social.
"3.1. L'objet de la Société est d'être désignée et d'agir en tant qu'associé gérant commandité de Nokia Growth Partners

III (S.C.A.) SICAV-SIF un fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi du 17 février 2007 relative aux fonds d'inves-
tissement spécialisé, telle que modifiée.

3.2. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social..»

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent

à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

<i>Information

Le notaire soussigné a informé les parties comparantes qu'avant toute modification de l'objet social, ou bien dans

l'éventualité ou la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, celles-ci doivent s'acquitter
de toutes formalités aux fins de rendre effective l'activité de la Société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties; ce
qui est expressément reconnu par les parties comparantes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Signé: A. FAVIER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 28 mai 2013. Relation: LAC/2013/24170. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013078003/133.
(130096241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

Inntechinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 177.877.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the sixth of June.
Before us, Maitre Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Aidar Galeev, born on 25/06/1960 in Kazan, Russia, residing at 6, Kurskaya str., Kazan, Republic of Tatarstan,

Russia,

2) Mr Vladimir Chendarev, born on 02/09/1960, in Kazan, Russia, residing at 107, Zarechnaya str., Kazan, Republic of

Tatarstan, Russia,

88451

L

U X E M B O U R G

3) Mr Ilshat Zaripov born on 29/04/1964, in Kazan, Russia, residing at 2 Nikitina str., Aznakaevo, Republic of Tatarstan,

Russia,

all here represented by Mr Emile WIRTZ, residing professionally in Luxembourg, 6, avenue Guillaume,
by virtue of three proxies given under private seal, wich will remain attached hereto.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited company ("société anonyme") in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of "INNTECHINVEST S.A.".

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

participation or in which it has a direct or indirect interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The corporate capital is fixed at THIRTY-THREE THOUSAND EURO (33,000,- EUR) represented by three

hundred and thirty (330) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a
general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director
may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that
one shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director

may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which  may  be  given by letter,  telegram,  telex or telefax, being permitted.  In  case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they

88452

L

U X E M B O U R G

need not be shareholders of the company. The first managing director may be appointed by the general meeting of
shareholders.

Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature

of the managing director or any delegate of the board.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of

the sole director.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It

has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the second Tuesday of the month of May at 11.00 a.m..

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply in so far as these Articles of

Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and thirteen.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and fourteen.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named party has subscribed the shares as follows:

1) Mr Aidar GALEEV, prenamed: ONE HUNDRED AND TEN shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2) Mr Vladimir CHENDAREV, prenamed: ONE HUNDRED AND TEN shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3) Mr Ilshat ZARIPOV, prenamed: ONE HUNDRED AND TEN shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
TOTAL. THREE HUNDRED AND THIRTY shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

All these shares have been entirely paid up by payments in cash to the extent of 25 %, so that the sum of EUR 8,250

(eight thousand two hundred and fifty euros) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to
the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 1,800.-.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

88453

L

U X E M B O U R G

2) The following are appointed directors:
a) Mr Emile WIRTZ, born at Luxembourg, on September 27, 1963, resding professionally at L-1650 Luxembourg, 6,

avenue Guillaume,

b) Mr Alexander MATVEEV, born at Moscow, Russia, on July 26, 1959, residing at D-66809 Nalbach, Eisenbahnstrasse

2, Germany.

c) Mr Vladimir Chendarev, born on September 2, 1960, in Kazan, Russia, residing at 107, Zarechnaya str., Kazan,

Republic of Tatarstan, Russia,

3) Has been appointed as managing director:
Mr Emile WIRTZ, prenamed.
4) Has been appointed auditor:
INVEST CONTROL SERVICES ADMNISTRATIFS S.à r.l., having its registered office at L-1650 Luxembourg, 6, avenue

Guillaume, RCS Luxembourg B 23230.

5) The mandates of the directors, the managing director and of the auditor shall expire immediately after the annual

general meeting of the two thousand and eighteen.

6) The registered office is fixed at L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le six juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Aidar Galeev, né le 25/06/21960 à Kazan Russie, demeurant à 6, Kursakaya str., Kazan, République de

Tatarstan, Russie,

2) Monsieur Vladimir Chendarev né le 02/09/1960 à Kazan, Russie, demeurant à 107, Zarechnaya str., Kazan, Répu-

blique de Tatarstan, Russie.

3) Monsieur Ilshat Zaripov né le 29/04/1964, à Kazan, Russie, demeurant à 2, Nikitina str., Aznakaevo, République de

Tatarstan, Russie,

tous ici représentés par Monsieur Emile WIRTZ, demeurant professionnellement à Luxembourg, 6, avenue Guillaume,

en vertu de trois procurations sous seing privé ci-annexées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "INNTECHINVEST S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

88454

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-TROIS MILLE EUROS (33.000.- EUR) représenté par trois cent trente (330)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant

au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non. Le premier administrateur-délégué pourra être nommée par l'assemblée générale des ac-
tionnaires.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de l'administrateur-délégué ou de tout autre délégué du conseil.

Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature indivi-

duelle de l'administrateur unique.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

88455

L

U X E M B O U R G

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

treize.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:

1 ) Monsieur Aidar Galeev, prénommé: Cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2) Monsieur Vladimir Chendarev, prénommé: Cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3) Monsieur Ilshat Zaripov, prénommé: Cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de

EUR 8.250.- (huit mille deux cent cinquante euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5

de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de EUR 1.800.-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Emile WIRTZ, né à Luxembourg, le 27 septembre 1963, demeurant professionnellement à L-1650 Lu-

xembourg, 6, avenue Guillaume,

b) Monsieur Alexander MATVEEV, né à Moscou, le 26 juillet 1959, demeurant à D-66809 Nalbach, Allemagne, Eisen-

bahnstrasse 2,

c) Monsieur Vladimir Chendarev, né le 2 septembre 1960 à Kazan, Russie, demeurant à 107, Zarechnaya str., Kazan,

République de Tatarstan, Russie.

3) Monsieur Emile WIRTZ, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire:
INVEST CONTROL SERVICES ADMINISTRATIFS S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume,

RCS Luxembourg B 23230.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée

générale annuelle de deux mille dix-huit.

6) Le siège social est fixé à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. WIRTZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2013. Relation: LAC/2013/26571. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

88456

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 juin 2013.

Référence de publication: 2013077884/274.
(130095703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

PIE Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.812.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,
ON THE ELEVENTH DAY OF THE MONTH OF JUNE,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PIE Group S.A., a société anonyme governed by the

laws of Luxembourg, with registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of 7 October 2005, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1335 of 6 December 2005 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-111812 (the "Company"). The articles of incorpo-
ration of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 17 December
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 262 of 4 February 2013.

The meeting was declared open at 9.30 a.m. by Manuel MOUGET, employee, with professional address in Luxembourg,

in the chair, who appointed as secretary Thomas MORANA, employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Thomas MORANA, employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) so

as to reduce it from its current amount of four hundred thousand euro (EUR 400,000.-) to three hundred thousand euro
(EUR 300,000.-) for the purpose and by cancellation of the eighty thousand (80,000) class D shares having a par value of
one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each, which have been repurchased by the Company on 11 June 2013 following
the resolutions of the board of director as per the authorisations and instructions provided by the general meeting of
shareholders and the share repurchase agreements dated 11 June 2013.

2 To amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital reduction.
(i) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(ii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iii) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented

declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.

(iv) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(v) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to reduce, with immediate effect, the corporate capital of the Company by an amount

of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) so as to reduce it from its current amount of four hundred thousand
euro (EUR 400,000.-) to three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) for the purpose and by cancellation of the eighty
thousand (80,000) class D shares having a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each, which have been
repurchased by the Company on 11 June 2013 following the resolutions of the board of director as per the authorisations
and instructions provided by the general meeting of shareholders and the share repurchase agreements dated 11 June
2013.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect

the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

88457

L

U X E M B O U R G

5.1. Capital. The subscribed capital of the Corporation is set at three hundred thousand euro (EUR 300,000.-) divided

into eighty thousand (80,000) class A shares, eighty thousand (80,000) class B shares, and eighty thousand (80,000) class
C shares, all with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share.".

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE ONZIEME JOUR DU MOIS DE JUIN
par devant Nous Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PIE Group S.A., une société anonyme régie par

le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1335 du 6 décembre 2005 et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B-111812 (la «Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 17 décembre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 262, en date du 4 février 2013.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de Manuel MOUGET, employé, domicilié pro-

fessionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Thomas MORANA, employé, domiciliée profession-
nellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Thomas MORANA, employé, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(ii) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) afin de le porter de son

montant actuel de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) en vue de et par
annulation de quatre-vingt mille (80.000) actions de catégorie D ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents
(EUR 1,25) chacune, qui ont été rachetées par la Société le 11 juin 2013 à la suite des résolutions du conseil d'adminis-
tration prises en vertu des autorisations et instructions données par l'assemblée générale des actionnaires et les contrats
de rachat d'actions en date du 11 juin 2013.

2 Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital.
(i) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(ii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du

bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iii) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés

ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.

(iv) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points

portés à l'ordre du jour.

(v) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé, avec effet immédiat, de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent mille

euros (EUR 100.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) à trois cent
mille euros (EUR 300.000,-) en vue de et par annulation de quatre-vingt mille (80.000) actions de catégorie D ayant une
valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, qui ont été rachetées par la Société le 11 juin 2013 à la

88458

L

U X E M B O U R G

suite des résolutions du conseil d'administration prises en vertu des autorisations et instructions fournies par l'assemblée
générale des actionnaires et les contrats de rachat d'actions en date du 11 juin 2013.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les

résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5.1. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) divisé en quatre-

vingt mille (80.000) actions de catégorie A, quatre-vingt mille (80.000) actions de catégorie B et quatre-vingt mille (80.000)
actions de catégorie C, toutes ayant une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25)."

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signés avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: M. MOUGET, T. MORANA, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 12 juin 2013. Relation: RED/2013/934. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 14 juin 2013.

e

 Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013078042/131.
(130096216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

Pontavedra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 177.879.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-deux mai.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1.- EURFINANCE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du

Prince Henri, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 38.453;

2.- Monsieur Jean-Bernard ZEIMET, réviseur d'entreprises, né le 5 mars 1953 à Luxembourg, demeurant profession-

nellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

Tous les deux sont ici représentés par Madame Ekaterina DUBLET, juriste, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de PONTAVEDRA S.A. (ci-après la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

88459

L

U X E M B O U R G

La Société peut également réaliser toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion

d'immeubles,  à  l'exclusion  des  activités  spécialement  réglementées  d'agent  immobilier,  de  promoteur  immobilier,  et
d'administrateur de biens - syndic de copropriété.

La Société peut aussi acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et

immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non
un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu'administrateur de sociétés

du groupe ainsi que l'administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute
prestation d'assistance stratégique, administrative ou commerciale.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre

forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription
ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions, chacune

d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

88460

L

U X E M B O U R G

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

88461

L

U X E M B O U R G

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.

88462

L

U X E M B O U R G

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2014.

<i>Souscription et Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- EURFINANCE S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Jean-Bernard ZEIMET, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

TOTAL: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE

EURO (31.000.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le  notaire  soussigné  déclare  avoir  vérifié  l'existence  des  conditions  énumérées  à  l'article  26  de  la  Loi  et  déclare

expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cent cinquante euros (EU 1.150,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Christophe ANTINORI, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnel-

lement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue;

b) Monsieur Xavier FABRY, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-1660

Luxembourg, 30, Grand-Rue;

c) Madame Delphine POILLOT, employée privée, née à Reims (France), le 3 octobre 1970, demeurant professionnel-

lement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

3. A été nommée commissaire aux comptes de la Société:
La société à responsabilité limitée READ S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard

du Prince Henri, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B45083.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statutaire de 2018.

5. L'adresse de la Société est établie à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ekaterina DUBLET, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mai 2013. Relation GRE/2013/2170. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013078045/233.
(130095742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2013.

Gigaplex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 88.373.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GIGAPLEX S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2013078578/11.
(130097167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

88463

L

U X E M B O U R G

Elmer Capital s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.884.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 14/06/2013.

Référence de publication: 2013078483/10.
(130096565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

DSC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 133.387.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66511 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013078451/10.
(130097188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

E. De Nil &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 122.608.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013078454/10.
(130096480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Gase International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 103.286.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenu en date du 11 juin 2013

En accord avec l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, le conseil d'adminis-

tration décide de nommer Monsieur Philippe RICHELLE en tant que Président du conseil d'administration.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GASE INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2013078569/13.
(130097414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Dolpa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 79.973.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2013078443/12.
(130096614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

88464


Document Outline

Al-Ain Luxembourg S.A.

Alizeos S.A.

Alpina Real Estate GP I

Alter S.A.

Am Trading

ANTHEA - Contemporary Art Investment S.à r.l.

Anthus S.à r.l.

Askania S.à r.l.

Astrolabe S.A.

Baie Bleue

BCK Holdings S.à r.l.

Beckman Coulter Holding S.à r.l.

Beech Tree S.A.

Beggen PropCo Sàrl

Bertrange Capital s.àr.l.

Bluestar Silicones International S.à r.l.

Bluestar Silicones International S.à r.l.

B.M. (Building Management) SA

Boretsch Investments Sàrl

Boulle Mining Group S.à r.l.

Branta S.à r.l.

BRASSERIE SIMON Participations et Cie S.e.c.s.

Brookfield Aylesbury S.à r.l.

Carvi S.A.

Cathians S.A.

Centrix Beteiligungen AG

Codralux S.A.

Dolpa S.à r.l.

DSC Luxembourg S.à r.l.

E. De Nil &amp; Cie

Elmer Capital s.àr.l.

Gase International S.A.

Gigaplex S.A.

Inntechinvest S.A.

International Sales Services

J. Maet &amp; Cie

KKR Retail Partners Topco S.à r.l.

Knupp S.A.

Kottla Holding S.à r.l.

Krisken S.A., SPF

Landwehr I S.à r.l.

NGP III Managers

Pfizer Luxembourg S.à r.l.

PIE Group S.A.

Plansee Group Service S.A.

Pontavedra S.A.

Sailor S.A.

Sandlark Investments Holdings S.à.r.l.

Sidcor S.A.

Sinos S.A.

Société de Participations Dauphinoise S.A.

Société Financière d'Octobre S.A., SPF

Sogim S.A.

South Mogul Holdings S.à r.l.

Special Movie Production S.A.

Strategic Credit Funding S.à r.l.

Surassur

Theos S.A.

Tovra S.A.

Treck S.à r.l.

UP Luxembourg Holdings

World Immo Invest S.A.

WP VI Investments S.à r.l.