This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1689
15 juillet 2013
SOMMAIRE
2Gears S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81033
Aabar Commodities S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
81032
Aabar Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
81032
AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . .
81037
Appoint Solutions S.a.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81033
Ayo Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81071
Beltrama Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
81027
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81054
Bom S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81027
Branca AC Fund SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81033
Canal Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81033
Capital United S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81034
CBRE GMM Global Osiris Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81036
CCEF II Sailing HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . .
81034
Climate Change Capital Carbon Fund S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81033
Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81035
Courteline Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
81032
D'co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81027
D.M. INVESTMENTS Spf S.A. . . . . . . . . . . .
81037
Driege Participations s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
81026
Ecogest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81070
EMC International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81034
Eudemis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81026
Excalibur Development S.A. . . . . . . . . . . . .
81052
Experian U.S. Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
81035
FGL Lux Holdings, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81036
Fiduciaire Centrale du Luxembourg, Salai-
res et Social S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81071
Gabbro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81037
GMT Connect S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81069
Great Pacific Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
81053
H2L S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81035
Habitus Promotions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
81035
Hoerstiffchen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81036
Husky Injection Molding Systems . . . . . . . .
81034
Immobilière Félix GIORGETTI s.à r.l. . . . .
81027
Imomix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81032
Indiact S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81068
Inesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81029
Inesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81029
Intech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81031
Intelimat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81028
Interbasic Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81031
Intrepid Aviation Luxembourg Borrower 1
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81071
I.P. Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81068
Irroma Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81030
Irroma Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81029
Isatis Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81030
Jecolux gmbh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81028
JPMorgan European Property Fund Mana-
gement Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
81028
JPMorgan European Property Fund Mana-
gement Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
81031
Kadorian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81030
Kase World Wide S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81029
KBC Group Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81031
Kullu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81035
Lag International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81028
Leasinvest Immo Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81028
Libidama International S.A. SPF . . . . . . . . .
81036
Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . .
81072
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Bel-
gium) - Luxembourg Branch . . . . . . . . . . .
81071
Morgina Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
81030
Morgina Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
81067
Neucol Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81072
Noiseworks Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81026
Paunsdorf Centre Luxco . . . . . . . . . . . . . . . .
81068
81025
L
U X E M B O U R G
Noiseworks Records, Association sans but lucratif.
Siège social: L-8081 Bertrange, 38, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg F 827.
Entre les soussignés:
1° Giordano Bruno
2° Patrick Obach
3° Jeff Lenert
Ainsi que ceux qui acceptant ultérieurement les statuts ci-après, il est constitué une association sans but lucrative qui
est régie par les présents statuts et par la loi du 21.04.1928 ainsi que celles qui l'ont modifiée.
Art. 2. L'association a comme objet:
- promouvoir et développer la musique amplifiée luxembourgeoise, étrangère et défendre ses intérêts
- l'établissement de liens avec médias et l'índustrie de musique au Luxembourg et à l'étranger
- production de CD, DVD, VINYL, BLURAY et cassettes sans but commercial
- production de t-shirts, sweat-shirts et accessoires promotionnels sans but commercial
- booking et organisation d'événements amplifiés
- l'accomplissement de toutes opérations se rattachant à l'objet social et facilitant sa réalisation
Art. 3. Le siège est établi à 38 rue de Mamer L-8081 Betrange. Il poura être transféré en tout autre lieu par simple
décision du conseil d'administration.
Art. 12. La durée du mandat des administrateur est illimité. Ils sont rééligibles. Le conseil d'adminstration gère les
affaires et les avoirs de l'association. Il représente l'association auprès de tiers. Les pouvoirs du conseil d'adminstration
doivent être conformes à la loi et aux statuts.
Art. 19. G Chord sera définie comme marque de distribution appartenant à Noisework Records
Signatures.
Référence de publication: 2013069569/27.
(130085441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.
Driege Participations s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 134.526.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DRIEGE PARTICIPATIONS s.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013069740/11.
(130086191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Eudemis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 58.861.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 septembre 2012.i>
Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A., 39, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.
Madame Nadine LAMBALLAIS, née le 1
er
janvier 1972 à Thionville (F), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.
<i>Pour la société
i>EUDEMIS S.A.
Référence de publication: 2013069777/16.
(130085998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81026
L
U X E M B O U R G
Beltrama Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.056.
En date du 30 mai 2013, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:
- La démission d'Elke Leenders, en tant qu'administrateur de la société, est acceptée avec effet au 16 avril 2013.
- Wim Rits, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé adminis-
trateur de la société avec effet au 16 avril 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069627/13.
(130086309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Bom S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 135.371.
<i>Protokoll der außerordentlichen Versammlung der Bom S.ar.L. am Montag, 06.05.2013i>
Bom S.ar.L.-B 135371
100% des Kapitals sind anwesend
Beginn: 09:30 Uhr
Top 1 Wechsel des Geschäftsführers
Es wird einstimmig beschlossen, dass mit sofortiger Wirkung Frau Birgit Johannes, wohnhaft in D- 66780 Rehlingen-
Siersburg, geb. am 21.02.1964 in Eimersdorf, als Geschäftsführerin aus o.g. Gesellschaft ausscheidet.
Top 2 Neue Geschäftsführer
Als neue Geschäftsführer wird Herr Thomas Johannes, Wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg, Im Brühl 6b, geb.
am 06.02.1963 in Merzig - Saar, Comptable, ernannt.
Top 3 Weitere Beschlüsse wurden durch die Geschäftsführung nicht getroffen.
Der neue Geschäftsführer beendet die außerordentliche Versammlung um 09:45 Uhr.
Stadtbredimus, den 06.05.2013.
Thomas Johannes / Birgit Johannes
<i>Comptable Geschäftsfüher / -i>
Référence de publication: 2013069632/22.
(130085893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
D'co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 102.708.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069723/10.
(130086386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Immobilière Félix GIORGETTI s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 29.788.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013069864/9.
(130086429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81027
L
U X E M B O U R G
Intelimat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8152 Bridel, 1, allée des Sorbiers.
R.C.S. Luxembourg B 170.907.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013069867/9.
(130086420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Jecolux gmbh, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 157.375.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013069911/9.
(130086174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Leasinvest Immo Lux, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 35.768.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Senningerberg, le 29 mai 2013.
Référence de publication: 2013069946/10.
(130085770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Lag International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 111.026.
Les Comptes Consolidés au 31 décembre 2009, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013069938/10.
(130085938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 104.923.
Suivant l'assemblée générale annuelle tenue par les associés en date du 29 mai 2013, il a été décidé renouveler le
mandat des Délégués à la gestion journalière avec effet immédiat et pour une période se terminant lors de l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2014:
- Mark Doherty;
- Jean-Christophe Ehlinger.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2013069914/16.
(130085907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81028
L
U X E M B O U R G
Inesia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 66.931.
EXTRAIT
Il a résulté du procès verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires tenue en date du 8 mai 2013 que:
1. L'assemblée a réélu aux postes d'administrateurs pour un terme jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se
tenir en 2014:
- Anne-Marie Kidd;
- Michael Kidd;
- Paolo Alonzi;
2. L'assemblée a également réélu la société Montbrun Révision S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour un
terme de jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2014.
Référence de publication: 2013069884/16.
(130086072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Kase World Wide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 173.394.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 mai 2013i>
1. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Madame Katia CAMBON, administrateur de sociétés, née le 24 mai 1972 à Le RAINCY (France), demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante de
catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 29.05.2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kase World Wide S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013069916/16.
(130085750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Inesia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 66.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069883/11.
(130086071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Irroma Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 13, an de Gaalgen.
R.C.S. Luxembourg B 151.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IRROMA SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013069901/11.
(130086520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81029
L
U X E M B O U R G
Kadorian, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 173.891.
<i>Extrait de la résolution unique prise par le conseil d'administration en date du 04 avril 2013i>
<i>Résolution Unique:i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet au 27 janvier 2013, Madame Valérie FILY, demeurant au
114, Boulevard de la Marne, F-94210 Saint-Maur-des-Fossés à la fonction d'Administrateur de la Société en remplacement
de Monsieur Eric FIASTRE dont le décès est intervenu en date du 27 janvier 2013. Son mandat viendra à échéance lors
de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
<i>Pour KADORIANi>
Référence de publication: 2013069917/16.
(130086381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Morgina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 96.218.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique en date du 2 mai 2012i>
1. Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France) le 14 août 1980, demeurant
professionnellement à L-1331, Luxembourg, 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 29.5.2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Morgina Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013069968/16.
(130085968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Irroma Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 13, an de Gaalgen.
R.C.S. Luxembourg B 151.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IRROMA SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013069900/11.
(130086497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Isatis Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 93.660.
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013069902/11.
(130085636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81030
L
U X E M B O U R G
KBC Group Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 30.328.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013069918/11.
(130086165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Interbasic Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 11.340.
Le Bilan consolidé de la société mère (Diego Della Valle & C. S.A.P.A. Group) au 31 décembre 2011 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2013.
Interbasic Holding S.A.
Jacob Mudde
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013069888/14.
(130085963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Intech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 52.838.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société extraordinairement en date du 20 décembrei>
<i>2012 à 19.30 heuresi>
L'assemblée décide à l'unanimité de ne plus renouveler le mandat du réviseur d'entreprises agréé FIDEWA AUDIT
S.A.
Schifflange, le 20 décembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2013069887/14.
(130086489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 104.923.
Suivant l'assemblée générale annuelle tenue par les associés en date du 29 mai 2013, il a été décidé de renouveler le
mandat du réviseur d'entreprises agréé PricewaterhouseCoopers S.à r.l., RCS N°B 65477, avec siège social au 400, Route
d'Esch, L-1014 Luxembourg, et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2013069913/15.
(130085747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81031
L
U X E M B O U R G
Aabar Commodities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 158.824.
EXTRAIT
En date du 22 mai 2013, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat;
- Monsieur Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau
gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
Référence de publication: 2013069574/15.
(130085730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Aabar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 752.800,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 145.459.
EXTRAIT
En date du 22 mai 2013, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad, en tant que gérant A, est acceptée avec effet immédiat;
- Monsieur Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau
gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
Référence de publication: 2013069575/15.
(130085793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Imomix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 147.233.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069879/10.
(130086217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Courteline Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.044.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2013i>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Madame Catherine Peuteman en tant qu’administrateur avec effet au
23 avril 2013
Extrait sincère et conforme
COURTELINE HOLDINGS S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013069708/13.
(130086199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81032
L
U X E M B O U R G
2Gears S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Appoint Solutions S.a.r.l.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.267.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2013.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2013069518/13.
(130084768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2013.
Branca AC Fund SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 158.506.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 30 mai 2013i>
Il est décidé de renouveler le mandat de Clerc S.A., 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, comme réviseur d'entreprises
indépendant et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2014.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour Branca AC Fund , S.C.A., SICAV-FIS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2013069651/14.
(130085865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Climate Change Capital Carbon Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 108.587.
<i>Extrait de la résolution de l'actionnaire unique prise en date du 29 mai 2013i>
L'actionnaire prend connaissance du décès de Monsieur H. William Koster en date du 30 janvier 2013.
Le conseil de gérance se compose désormais des personnes suivantes:
- Monsieur Pierre Carras, gérant;
- Monsieur Mark Simon Bell, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069657/15.
(130086481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Canal Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 139.138.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société CANAL RE S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013069676/11.
(130086052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81033
L
U X E M B O U R G
Capital United S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 172.206.
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Munsbach en date du 17 mai 2013 que:
L'Assemblée confirme la nomination de Mlle Hursuline Matos Da Silva, née le 23 avril 1988 à Boa Vista, Roraima, Brésil,
demeurante à 379 route de la turbie, résidence Etoile d'eue, 06360 EZE France, en tant que gérante supplémentaire de
la société.
Fait à Munsbach, le 17 mai 2013.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2013069678/14.
(130086326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
CCEF II Sailing HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.606.
EXTRAIT
Il résulte de décisions de l'associé unique prises en date du 27 mai 2013 que:
- Monsieur Willem Jan Pieter PELLE, gérant de la Société, a démissionné avec effet au 1
er
avril 2013,
- Monsieur Roderik MULDER, né le 29 septembre 1968 à La Haye (Pays-Bas), demeurant professionnellement à Suite
3418, 34
th
Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, a été nommé gérant de la Société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013069695/16.
(130086110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
EMC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 89, Parc d'Activité, Westside Village, Bâtiment B.
R.C.S. Luxembourg B 110.173.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 17 mai 2013i>
L'Associé Unique en date du 17 mai 2013 révoque Monsieur Steven LEONARD de ses fonctions de gérant de la société
EMC International S.à.r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013069763/13.
(130086264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Husky Injection Molding Systems, Société Anonyme.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 21.683.
Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013069859/10.
(130086049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81034
L
U X E M B O U R G
Experian U.S. Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.216.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 137.114.
Le bilan au 31 mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013069752/11.
(130086129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Habitus Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 119, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.273.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HABITUS PROMOTIONS S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013069848/11.
(130086435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Kullu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 125.751.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KULLU S.A.i>
Référence de publication: 2013069926/10.
(130086540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
H2L S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 145.821.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013069861/10.
(130085929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 785.925,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.678.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
Référence de publication: 2013069704/11.
(130086462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81035
L
U X E M B O U R G
Libidama International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 20.717.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
<i>Pour compte de Libidama International S.A. SPF
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2013069953/12.
(130085771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
CBRE GMM Global Osiris Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 139.527.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour CBRE Global Osiris Luxembourg S.à.r.l.
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Référence de publication: 2013069694/12.
(130086171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
FGL Lux Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.497.
Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 29 mai 2013 de la Société la décision suivante a été prise:
- Nomination du gérant de catégorie B suivant en date du 29 mai 2013 pour une durée indéterminée:
Monsieur Justin Haskell Harrison, né le 9 mai 1973 dans le Connecticut, Etats-Unis d'Amerique, demeurant au 40,
Boulder Brook Road RD, Wellesley, MA 02481-1144, Etats-Unis d'Amerique
Résultant de la décision susmentionnée, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Manacor (Luxembourg) S.A., gérant de catégorie A;
- Catherine Bird, gérant de catégorie B;
- Justin Haskell Harrison, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2013069803/19.
(130085779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Hoerstiffchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8526 Colpach-Bas, 17, Uewerpallenerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HOERSTIFFCHEN SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013069853/11.
(130086348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81036
L
U X E M B O U R G
Gabbro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 82.320,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 151.758.
Suite aux résolutions du gérant unique prises en date du 24 mai 2013, il a été décidé que la société Gabbro S.à r.l. a
changé d'adresse comme suit:
Du: 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg
Au: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marie-Pierre Ghedin.
Référence de publication: 2013069826/14.
(130086006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
D.M. INVESTMENTS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.550.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29.05.2013 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, MARECHAL Joël, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant
qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant que
commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2019
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013069719/17.
(130086300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 223.150.411,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 129.314.
In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of May.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of "AB Acquisitions Luxco 1 S.à
r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129.314, incorporated pursuant to a deed of Maître
Jean-Joseph Wagner dated 27 June 2007, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 9 August 2007 (the "Mémorial C"). The Articles have been
amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger dated 3
rd
May 2013 and not yet published in the
Mémorial C.
The meeting is presided by Flora Gibert residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Sara Lecomte, residing in Luxembourg.
The names of the Shareholders, represented at the meeting, the proxies of the represented Shareholders and the
number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the
appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.
I. It appears from the attendance list, that 100 % of the share capital of the Company, are represented at this meeting.
The Shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting beforehand and that they waive the convening
requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.
III. The agenda of the meeting is the following:
81037
L
U X E M B O U R G
A. To increase the share capital of the Company by an amount of five thousand three hundred and sixty-two British
Pounds and fifty cents (GBP 5,362.50) so as to raise it from its current amount of two hundred and twenty-three million
one hundred and fifty-one thousand seven hundred and eighty-six British Pounds (GBP 223,151,786.-) to two hundred
and twenty-three million one hundred and fifty-seven thousand one hundred and forty-eight British Pounds and fifty pence
(GBP 223,157,148.50) by creating and issuing the following new shares (the "New Shares"):
- twenty thousand nine hundred and ninety-one (20,991) Class A2 Shares;
- fifty-one (51) Class B2 Shares;
- fifty-one (51) Class C2 Shares;
- fifty-one (51) Class D2 Shares;
- fifty-one (51) Class E2 Shares;
- fifty-one (51) Class F2 Shares;
- fifty-one (51) Class G2 Shares;
- fifty-one (51) Class H2 Shares;
- fifty-one (51) Class I2 Shares; and
- fifty-one (51) Class J2 Shares,
each share with a par value of twenty-five pence (GBP 0.25).
B. Subscription and payment of the New Shares.
C. To reduce the Company's share capital with immediate effect by an amount of six thousand seven hundred and
thirty-seven British Pounds and fifty cents (GBP 6,737.50) so as to reduce it from its current amount of two hundred and
twenty-three million one hundred and fifty-seven thousand one hundred and forty-eight British Pounds and fifty pence
(GBP 223,157,148.50) to two hundred and twenty-three million one hundred and fifty thousand four hundred and eleven
British Pounds (GBP 223,150,411,-) by the cancellation of:
- twenty-six thousand three hundred and seventy-four (26,374) Class A2 Shares;
- sixty-four (64) Class B2 Shares;
- sixty-four (64) Class C2 Shares;
- sixty-four (64) Class D2 Shares;
- sixty-four (64) Class E2 Shares;
- sixty-four (64) Class F2 Shares;
- sixty-four (64) Class G2 Shares;
- sixty-four (64) Class H2 Shares;
- sixty-four (64) Class I2 Shares; and
- sixty-four (64) Class J2 Shares,
D. To convert one million two hundred and twenty-eight thousand three hundred and twenty-five (1,228,325) Class
A2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class B2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-
five (2,975) Class C2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class D2 Shares; two thousand nine
hundred and seventy-five (2,975) Class E2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class F2 Shares;
two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class G2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975)
Class H2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class I2 Shares; and two thousand nine hundred
and seventy-five (2,975) Class J2 Shares currently held by Alliance Boots GmbH, a company incorporated under the laws
of Switzerland, whose registered office is at Untermattweg 8, 3027 Bern, Switzerland into one million two hundred and
twenty-eight thousand three hundred and twenty-five (1,228,325) Class A1 Shares; two thousand nine hundred and
seventy-five (2,975) Class B1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class C1 Shares; two thousand
nine hundred and seventy-five (2,975) Class D1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class E1
Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class F1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-
five (2,975) Class G1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class H1 Shares; two thousand nine
hundred and seventy-five (2,975) Class I1 Shares; and two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class J1 Shares;
each share with a par value of twenty-five pence (GBP 0.25).
E. To amend the first paragraph of article 6 of the Articles.
F. To amend article 14.1 of the Articles.
G. To amend article 14.4.1 of the Articles.
H. To amend article 17.3 of the Articles.
I. To amend article 17.7 of the Articles.
J. To amend article 27.1.4 of the Articles.
K. To amend article 27.2.2 of the Articles.
L. To amend article 27.4.4 of the Articles.
M. To amend article 27.7 of the Articles.
81038
L
U X E M B O U R G
N. To amend the definitions of "Deemed Executive", "Deemed Executive's Shares", "Executive Proportion", "Galenica
MEP Shares", "Listing", "MEP Securities", "Subscription Price", "Target IRR" and "Walgreen Proportion" contained in the
article 31 of the Articles.
O. Miscellaneous
After careful and attentive deliberation, the Shareholders adopt the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of five thousand three hundred
and sixty-two British Pounds and fifty cents (GBP 5,362.50) so as to raise it from its current amount of two hundred and
twenty-three million one hundred and fifty-one thousand seven hundred and eighty-six British Pounds (GBP 223,151,786.-)
to two hundred and twenty-three million one hundred and fifty-seven thousand one hundred and forty-eight British
Pounds and fifty pence (GBP 223,157,148.50) by creating and issuing the following new shares (the "New Shares"):
- twenty thousand nine hundred and ninety-one (20,991) Class A2 Shares;
- fifty-one (51) Class B2 Shares;
- fifty-one (51) Class C2 Shares;
- fifty-one (51) Class D2 Shares;
- fifty-one (51) Class E2 Shares;
- fifty-one (51) Class F2 Shares;
- fifty-one (51) Class G2 Shares;
- fifty-one (51) Class H2 Shares;
- fifty-one (51) Class I2 Shares; and
- fifty-one (51) Class J2 Shares,
each share with a par value of twenty-five pence (GBP 0.25).
<i>Subscription and paymenti>
Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited, a limited liability company organised under the laws of Guernsey, having
its registered office at P O Box 41 Le Marchant House Le Truchot St Peter Port Guernsey GY1 3BE, registered under
number 24531, acting in its capacity as trustee of the Alliance Boots Management Equity Plan Employee Trust (the "Trust"),
declares to subscribe to the New Shares and such New Shares have been fully paid on behalf of the Trust by a contribution
in cash of an amount of five thousand three hundred and sixty-two British Pounds and fifty cents (GBP 5,362.50).
The total contribution of five thousand three hundred and sixty-two British Pounds and fifty cents (GBP 5,362.50) is
entirely allocated to the share capital of the Company.
Evidence of the contribution has been given to the notary.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve unanimously to reduce the Company's share capital with immediate effect by an amount of
six thousand seven hundred and thirty seven British Pounds and fifty cents (GBP 6,737.50) so as to reduce it from its
current amount of two hundred and twenty-three million one hundred and fifty-seven thousand one hundred and forty-
eight British Pounds and fifty pence (GBP 223,157,148.50) to two hundred and twenty-three million one hundred and
fifty thousand four hundred and eleven British Pounds (GBP 223,150,411,-) by the cancellation of:
- twenty-six thousand three hundred and seventy-four (26,374) Class A2 Shares;
- sixty-four (64) Class B2 Shares;
- sixty-four (64) Class C2 Shares;
- sixty-four (64) Class D2 Shares;
- sixty-four (64) Class E2 Shares;
- sixty-four (64) Class F2 Shares;
- sixty-four (64) Class G2 Shares;
- sixty-four (64) Class H2 Shares;
- sixty-four (64) Class I2 Shares; and
- sixty-four (64) Class J2 Shares,
each share with a par value of twenty-five pence (GBP 0.25), currently held by Barclays Wealth Trustees (Guernsey)
Limited, prenamed. This reduction of share capital shall be a Unanimous Shareholders Redemption as defined in article
8.3 of the Articles. An amount of three hundred and sixty-seven thousand eight hundred and two Swiss Francs and sixty-
nine cents (CHF 367,802.69) (or, if agreed with the Company, its equivalent in a different currency or currencies calculated
at an exchange rate agreed with the Company) will be paid to Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited, prenamed
or to its order.
81039
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to convert one million two hundred and twenty-eight thousand three hundred and twenty-
five (1,228,325) Class A2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class B2 Shares; two thousand nine
hundred and seventy-five (2,975) Class C2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class D2 Shares;
two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class E2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975)
Class F2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class G2 Shares; two thousand nine hundred and
seventy-five (2,975) Class H2 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class I2 Shares; and two
thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class J2 Shares currently held by Alliance Boots GmbH, a company
incorporated under the laws of Switzerland, whose registered office is at Untermattweg 8, 3027 Bern, Switzerland into
one million two hundred and twenty-eight thousand three hundred and twenty-five (1,228,325) Class A1 Shares; two
thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class B1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975)
Class C1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class D1 Shares; two thousand nine hundred and
seventy-five (2,975) Class E1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class F1 Shares; two thousand
nine hundred and seventy-five (2,975) Class G1 Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class H1
Shares; two thousand nine hundred and seventy-five (2,975) Class I1 Shares; and two thousand nine hundred and seventy-
five (2,975) Class J1 Shares, each share with a par value of twenty-five pence (GBP 0.25).
Further to the present and previous resolutions, the Shareholders acknowledge that Alliance Boots GmbH, prenamed,
holds the following shares:
- eight hundred and thirty million forty-six (830,000,046) Class A1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class B1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class C1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class D1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class E1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class F1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class G1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class H1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class I1 Shares,
- two million twelve thousand four hundred and sixty-two (2,012,462) Class J1 Shares,
- twenty million ninety-nine thousand nine hundred and twenty-five (20,099,925) Class A2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class B2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class C2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class D2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class E2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class F2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class G2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class H2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class I2 Shares,
- forty-eight thousand six hundred and seventy-five (48,675) Class J2 Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the first paragraph of article 6 of the Articles in order to reflect the previous
resolutions which shall henceforth be read as follows:
« Art. 6. Share capital.
6.1 The Company has a share capital of two hundred and twenty-three million one hundred and fifty thousand four
hundred and eleven British Pounds (GBP 223,150,411.-) divided into:
- eight hundred and thirty million fifty (830,000,050) class A1 shares (the "Class A1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class B1 shares (the "Class B1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class C1 shares (the "Class C1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class D1 shares (the "Class D1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class El shares (the "Class E1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class Fl shares (the "Class F1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class Gl shares (the "Class G1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class Hl shares (the "Class H1 Shares"),
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class Il shares (the "Class I1 Shares"), and
- two million twelve thousand four hundred and sixty-six (2,012,466) class Jl shares (the "Class J1 Shares"),
81040
L
U X E M B O U R G
The Class Al Shares, the Class Bl Shares, the Class Cl Shares, the Class Dl Shares, the Class El Shares, the Class Fl
Shares, the Class Gl Shares, the Class Hl Shares, the Class Il Shares and the Class Jl Shares shall be collectively referred
to as the "Holdco Ordinary Shares".
- forty-three million five hundred and forty thousand four hundred and forty (43,540,440) class A2 shares (the "Class
A2 Shares" and together with the Class Al Shares, the "Class A Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class B2 shares (the "Class B2 Shares" and together
with the Class Bl Shares, the "Class B Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class C2 shares (the "Class C2 Shares" and together
with the Class Cl Shares, the "Class C Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class D2 shares (the "Class D2 Shares" and together
with the Class Dl Shares, the "Class D Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class E2 shares (the "Class E2 Shares" and together
with the Class El Shares, the "Class E Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class F2 shares (the "Class F2 Shares" and together
with the Class Fl Shares, the "Class F Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class G2 shares (the "Class G2 Shares" and together
with the Class Gl Shares, the "Class G Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class H2 shares (the "Class H2 Shares" and together
with the Class Hl Shares, the "Class H Shares"),
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class I2 shares (the "Class I2 Shares" and together
with the Class Il Shares, the "Class I Shares"), and
- one hundred and five thousand four hundred and forty (l05,440) class J2 shares (the "Class J2 Shares" and together
with the Class Jl Shares, the "Class J Shares"),
all having a par value of zero point twenty-five sterling pound (GBP 0.25.-) each, and all fully subscribed and entirely
paid up.
The Class A2 Shares, the Class B2 Shares, the Class C2 Shares, the Class D2 Shares, the Class E2 Shares, the Class
F2 Shares, the Class G2 Shares, the Class H2 Shares, the Class I2 Shares and the Class J2 Shares shall be collectively
referred to as the "Class 2 Ordinary Shares".
The Holdco Ordinary Shares and the Class 2 Ordinary Shares are together referred as the "Ordinary Shares."
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 14.1 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 14. Transfer Restrictions.
14.1Notwithstanding any provision to the contrary in the Articles or the Warrant Instrument, no Securities may be
Transferred by an Executive or by the Investor (on behalf of the Executives) other than (and each Executive shall procure
that any Family Member or Family Trust or Related Corporation which holds any Securities allocated to him shall not
Transfer any Securities other than):
14.1.1 with Investor Manager Consent;
14.1.2 when required by Schedules 6, 9 or 11 of the Shareholders' Agreement;
14.1.3 when required by article 14.3;
14.1.4 pursuant to article 15;
14.1.5 when required by article 16,17, 18 or 27;
14.1.6 when permitted pursuant to articles 14.4 or 27.4;
14.1.7 to the Company in accordance with the provisions of the 1915 Law; or
14.1.8 (unless Holdco has notified the Executives that such transfers are no longer permitted because it believes in its
absolute discretion that the number of security holders may give rise to future difficulties under securities laws) to a
Family Member or a Family Trust or with the prior written consent of the Company to a Related Corporation or back
from such Family Member or Family Trust or Related Corporation to the Executives to whom such Shares were originally
allocated under the terms of the EBT Trust Deed). Any such Transfer of Securities must be in respect of (i) Securities of
all the classes of Securities owned by the relevant Executive, Family Member or Family Trust or Related Corporation and
(ii) the same proportion of the holdings of such person of each class of Securities, or
14.1.9 when otherwise required to do so by any provision of the Shareholders' Agreement or these Articles.
[...]"
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 14.4.1 of the Articles which shall be read as follows:
"[...]
81041
L
U X E M B O U R G
14.4 Right of First Offer
14.4.1 This article 14.4 applies if the Trustee proposes to transfer the legal and beneficial title to any Galenica MEP
Shares other than in connection with a Galenica Extraction, in connection with a Topco Transaction pursuant to Schedule
6 of the Shareholders Agreement (other than Part G), pursuant to articles 14.3, 15, 16, 17 or 27.4 or with the prior
written consent of the Investors Managers (a "Pre-Emption Transfer').[.]"
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 17.3 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 17. Exit. [...]
17.3 The Ordinary Shareholders agree that a Topco Transaction shall be achieved by requiring the Executives and the
Trustee and Related Holders to sell or transfer (or in the case of the Warrants to sell or transfer and/or to exercise and
sell or transfer the resulting shares and/or consent to the repurchase or redemption of the resulting shares) and/or by
permitting or requiring the Investor, the Executives and Related Holders to exchange through one or more transactions
all or a relevant proportion of their Securities for shares and/or warrants in Topco (the "Executives' Topco Securities")
(to be held by the Investor on behalf of the relevant Executives) in order for the Executives' Topco Securities to be sold
(at a price determined by Gibco with Investor Manager Consent (both of whom acting in good faith and in consultation
with the Manager Representatives subject as provided in Article 32.6), which might be nothing as a result of the application
of article 27) or listed as part of the Topco Transaction, or through some other means as determined by Gibco with
Investor Manager Consent (both of whom acting in good faith and in consultation with the Manager Representatives as
provided in Article 32.6 and 32.7) having reasonable regard to the tax position of Executives.
[...]"
<i>Eighth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 17.7 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 17. Exit. [...]
17.7 In order to implement a Topco Transaction in a manner permitted or required by Part B of Schedule 6 of the
Shareholders' Agreement, Holdco with Investor Manager Consent (both Holdco and the Investor Managers acting in
good faith and in consultation with the Executive Representatives) will determine the terms of a requirement or an
entitlement of the Executives, the Trustee and Related Holders to implement the Topco Transaction including to sell or
transfer (or in the case of the Warrants to sell or transfer and/or to exercise and sell or transfer the resulting shares)
on such terms as they so determine taking account of (but not being required to apply in every respect) the terms that
would have applied had the transaction analogous to the Topco Transaction been instead implemented by a disposal or
other transaction by or involving Holdco. The Executives, the Trustee and Related Holders will comply with any terms
so determined in all respects. For the avoidance of doubt, Holdco may in its absolute discretion treat Executives in
different manners according to the jurisdiction in which they are resident or tax resident if Holdco believes there are
tax, regulatory or legal benefits for the relevant Executives and/or any member of the Group in so doing."
<i>Ninth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 27.1.4 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 27. Distribution in case of Return of Capital / Share Sale / Listing and Galenica Extraction. [...]
27.1.4 fourthly, if Holdco has received an amount sufficient to give it the Target IRR and to the extent there remain
unallocated Proceeds following the distributions made pursuant to article 27.1.3 (the "Return of Capital Excess"), Holdco
shall receive the Gibco Percentage of the Return of Capital Excess, each Executive (through the Investor) shall receive
his Executive Proportion of the Executive Percentage of the Return of Capital Excess, each Deemed Executive shall
receive his Deemed Executive Proportion of the Executive Percentage of the Return of Capital Excess and the Trustee
shall receive the Trustee Warehouse Proportion of the Executive Percentage of the Return of Capital Excess. For the
avoidance of doubt, if there is no Return of Capital Excess, the Executives (through the Investor), any Deemed Executive
and the Trustee shall receive nothing pursuant to this article 27.1.4.
[...]"
<i>Tenth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 27.2.2 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 27. Distribution in case of Return of Capital / Share Sale / Listing and Galenica Extraction. [...]
27.2.2 secondly, Holdco shall receive in respect of the Walgreens' Proportion of the Relevant Securities held by Holdco
the Walgreens' Proportion of the Consideration remaining following the distributions made pursuant to article 27.2.1;
[...]"
<i>Eleventh resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 27.4.4 of the Articles which shall be read as follows:
81042
L
U X E M B O U R G
« Art. 27. Distribution in case of Return of Capital / Share Sale / Listing and Galenica Extraction. [...]
27.4.4 each Executive (or that Executive's spouse) may notify the Trustee in writing on or before the date of the
Galenica Extraction that the Trustee shall not exercise the rights set out in Article 27.4.2 above in respect of some or
all of such Executive's Galenica MEP Shares (such Galenica MEP Shares being "Excluded Galenica MEP Shares") or Galenica
MEP Warrants (such Galenica MEP Warrants being "Excluded Galenica MEP Warrants").
[...]"
<i>Twelfth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 27.7 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 27. Distribution in case of Return of Capital / Share Sale / Listing and Galenica Extraction. [...]
27.7 Examples of how payments might be made in respect of the Alliance Boots Management Equity Plan are set out
in article 30."
<i>Thirteenth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the definitions of "Deemed Executive", "Deemed Executive's Shares", "Executive
Proportion", "Galenica MEP Shares", "Listing", "MEP Securities", "Subscription Price", "Target IRR" and "Walgreen Pro-
portion" contained in the article 31 of the Articles which shall be read as follows:
« Art. 31. Definitions.
[...]
Deemed Executive
means such person or persons (other than Holdco, the Executives and the Investor) whom
the Investor Managers deem to be an Executive for these purposes and will include persons
who participate in the Management Equity Plan constituted by the Shareholders'
Agreement through different documentation;
[…]
Deemed Executive's
Shares
means shares in the Company held by any Deemed Executive or Related Holders (or held
on their behalf by the Trustee) from time to time;
[…]
Executive Proportion
means, in respect of an Executive, the proportion which the number of MEP Securities,
other than the Galenica MEP Securities, held by such Executive through the Investor bears
to the total number of MEP Securities other than Galenica MEP Securities in issue;
[…]
Galenica MEP Shares
means:
a) the Galenica Proportion of each Executive's Executives' Shares and each Deemed
Executive's Shares as at the date of the Galenica Extraction, together with any Executives'
Shares resulting from the exercise of Galenica MEP Warrants; and
b) the Galenica Proportion of any shares in the Company held by the Trustee as at the
date of the Galenica Extraction other than as nominee, together with any shares in the
Company resulting from the exercise of Galenica MEP Warrants held by the Trustee other
than as nominee;
[…]
Listing
means in relation to any Group Company:
(a) both the admission of any of that Group Company's shares to the Official List maintained
by the FSA becoming effective (in accordance with the Listing Rules) and the admission of
any of that Group Company's shares to trading on the LSE's market for listed securities
(in accordance with the Admission and Disclosure Standards of the LSE, for the time being
in force);
(b) the admission to trading of any of that Group Company's shares on the Alternative
Investment Market of the LSE becoming effective; or
(c) the admission to trading to or permission to deal on any other Recognised Investment
Exchange, or such other stock exchange as is nominated by Holdco, becoming effective in
relation to any of that Group Company's shares;
[…]
MEP Securities
means the Executives' Securities, Deemed Executive's Shares and any other shares in the
Company or Warrants held by the Trustee other than as nominee;
[…]
Subscription Price
means the total paid up on the Securities (including any premium) or, if Securities were
acquired by purchase, the purchase price paid. For these purposes any Ordinary Shares
issued upon exercise of a Warrant by the Leaver or his Related Persons shall be deemed
to have a Subscription Price equal amounts paid to acquire the corresponding Warrant
and exercise thereof;
Target IRR
means, in respect of a Return of Capital, Share Sale or Listing, an amount which gives
Holdco an internal rate of return on the Relevant Securities held by it (other than the
81043
L
U X E M B O U R G
Excluded Shares) equivalent to 8% per annum calculated from 26 June 2007 to the day of
completion of any Share Sale or Topco Transaction; provided that with respect to the
completion of the Initial Walgreens Transaction the date shall be 2 August 2012 was the
anticipated and actual date of the completion of the Initial Walgreens Transaction), the day
on which any Return of Capital is made or the day on which a Listing becomes effective,
as the case may be, and in each case, taking account of any previous Return of Capital in
respect of Relevant Securities (other than the Excluded Shares). For the purposes of this
definition of "Target IRR" the shares in the Company held by Holdco, Gibco or by the
Group Nominee as its nominee immediately following Completion will be deemed to have
been acquired by Holdco on 26 June 2007 at a cost of £1,960,737,627.24; provided that if
it is impracticable to calculate the internal rate of return up to the date of the relevant
Share Sale, Return of Capital, Listing or Topco Transaction, the internal rate of return may
instead be calculated up to such other date shortly prior to completion of the relevant
Share Sale, Return of Capital, Listing or Topco Transaction as the board of Holdco may
determine. For the avoidance of doubt, no amount received by Gibco on the Initial
Walgreens Transaction shall be taken into account in calculating the Target IRR for any
Return of Capital, Share Sale or Listing occurring after 2 August 2012; and no amount
received by Holdco on the Galenica Extraction shall be taken into account in calculating
the Target IRR for any Return of Capital, Share Sale or Listing occurring after the Galenica
Extraction. In the case of a partial exit which constitutes an Exit Event, Gibco with Manager
Director Consent (both of whom acting in good faith and in consultation with the Executive
Representatives) shall have the right to modify the basis on which the Target IRR is
calculated to reflect the fact that the Exit Event represents a partial exit only;
[…]
Walgreens Proportion
means, in relation to the distribution of Proceeds on a Return of Capital, the distribution
of Consideration on a Share Sale or the allocation of Listed Shares on a Listing (as the case
may be), the proportion (as calculated immediately prior to the relevant Return of Capital,
Share Sale or Listing) which the number of shares in Holdco held by Walgreens bears to
the aggregate number of shares in Holdco held by Walgreens and Gibco.
[…]"
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille treize le dix-sept mai.
Par-devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (les "Associés") de «AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l.» (ci
après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son
siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.314, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean-Joseph Wagner en date du 27 juin 2007 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 9 août 2007 (le «Mémorial C»). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à un
acte rédigé par Maître Joseph Elvinger en date du 3 mai 2013 et non encore publié au Mémorial C.
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Sara Lecomte demeurant à Luxembourg.
I. Les noms des Associés représentés à l'assemblée, les procurations des Associés représentés et le nombres de leurs
parts sociales sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et ces procurations signées "ne varietur"
par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront attachées au présent acte pour être
soumises aux autorités de l'enregistrement avec lui.
II. Il apparaît de la liste de présence que 100% du capital social de la Société sont représentées à cette assemblée. Les
Associés déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée à l'avance et renoncer aux exigences et formalités
81044
L
U X E M B O U R G
de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut validement délibérer sur tous les points à l'ordre
du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
A. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq mille trois cent soixante-deux Livres Sterling et
cinquante pence (GBP 5.362,50) afin de l'élever de son montant actuel de deux cent vingt-trois millions cent cinquante
et un mille sept cent quatre-vingt-six Livres Sterling (GBP 223.151.786,-) à deux cent vingt-trois millions cent cinquante-
sept mille cent quarante-huit Livres Sterling et cinquante pence (GBP 223.157.148,50) en créant et émettant les nouvelles
parts sociales suivantes (les "Nouvelles Parts Sociales"):
- vingt mille neuf cent quatre-vingt-onze (20.991) Parts Sociales de Catégorie A2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie B2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie C2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie D2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie E2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie F2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie G2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie H2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie I2, et
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie J2,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq pence (GBP 0,25).
B. Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales.
C. Réduire le capital social de la Société avec effet immédiat d'un montant de six mille sept cent trente-sept Livres
Sterling et cinquante pence (GBP 6.737,50) afin de le réduire de son montant actuel de deux cent vingt-trois millions cent
cinquante-sept mille cent quarante-huit Livres Sterling et cinquante pence Livres Sterling (GBP 223.157.148,50) à deux
cent vingt-trois millions cent cinquante mille quatre cent onze Livres Sterling (GBP 223.150.411,-) par l'annulation de:
- vingt-six mille trois cent soixante-quatorze (26,374) Parts Sociales de Catégorie A2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie B2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie C2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie D2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie E2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie F2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie G2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie H2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie I2, et
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie J2,
D. Convertir un million deux cent vingt-huit mille trois cent vingt-cinq (1.228.325) Parts Sociales de Catégorie A2,
deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie B2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975)
Parts Sociales de Catégorie C2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie D2, deux mille
neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie E2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts
Sociales de Catégorie F2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie G2, deux mille neuf
cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie H2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales
de Catégorie I2 et deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie J2, actuellement détenues
par Alliance Boots GmbH, une société constituée en vertu des lois de Suisse, dont le siège social est à Untermattweg 8,
3027 Bern, Suisse en un million deux cent vingt-huit mille trois cent vingt-cinq (1.228.325) Parts Sociales de Catégorie
A1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie B1, deux mille neuf cent soixante-quinze
(2.975) Parts Sociales de Catégorie C1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie D1, deux
mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie E1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts
Sociales de Catégorie F1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie G1, deux mille neuf
cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie H1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales
de Catégorie I1 et deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie J1; chaque part sociale ayant
une valeur nominale de vingt-cinq pence (GPB 0,25).
E. Modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts.
F. Modifier l'article 14.1 des Statuts.
G. Modifier l'article 14.4.1 des Statuts.
H. Modifier l'article 17.3 des Statuts.
I. Modifier l'article 17.7 des Statuts.
J. Modifier l'article 27.1.4 des Statuts.
81045
L
U X E M B O U R G
K. Modifier l'article 27.2.2 des Statuts.
L. Modifier l'article 27.4.4 des Statuts.
M. Modifier l'article 27.7 des Statuts.
N. Modifier les définitions de "Exécutif Considéré", "Parts Sociales de l'Exécutif Considéré", "Actions Galenica MEP",
"Cotation", "Titres MEP", "Prix de Souscription", "Cible IRR" et "Proportion Walgreen" contenues à l'article 31 des Statuts.
O. Divers.
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été adoptées unanimement:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq mille trois cent soixante-deux
Livres Sterling et cinquante pence (GBP 5.362,50) afin de l'élever de son montant actuel de deux cent vingt-trois millions
cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-six Livres Sterling (GBP 223.151.786,-) à deux cent vingt-trois millions
cent cinquante-sept mille cent quarante-huit Livres Sterling et cinquante pence (GBP 223.157.148,50) en créant et émet-
tant les nouvelles parts sociales suivantes (les "Nouvelles Parts Sociales"):
- vingt mille neuf cent quatre-vingt-onze (20.991) Parts Sociales de Catégorie A2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie B2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie C2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie D2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie E2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie F2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie G2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie H2,
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie I2, et
- cinquante et une (51) Parts Sociales de Catégorie J2,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq pence (GBP 0,25).
<i>Souscription et paiementi>
Barclays Wealth Trustees (Guernsey) Limited, une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de
Guernsey, ayant son siège social au P O Box 41 Le Marchant House Le Truchot St Peter Port Guernsey GY1 3BE et le
numéro d'immatriculation 24531, agissant en sa qualité de trustée de l'Alliance Boots Management Equity Plan Employee
Trust (le "Trust") déclare souscrire à toutes les Nouvelles Parts Sociales et ces Nouvelles Parts Sociales ont été intégra-
lement libérées pour le compte du Trust par un apport en numéraire d'un montant de cinq mille trois cent soixante-deux
Livres Sterling et cinquante pence (GBP 5.362,50).
L'apport total de cinq mille trois cent soixante-deux Livres Sterling et cinquante pence (GBP 5.362,50) est entièrement
alloué au capital social de la Société. La preuve de l'apport a été fournie au notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident unanimement de réduire le capital social de la Société avec effet immédiat d'un montant de six
mille sept cent trente-sept Livres Sterling et cinquante pence (GBP 6.737,50) afin de le réduire de son montant actuel de
deux cent vingt-trois millions cent cinquante-sept mille cent quarante-huit Livres Sterling et cinquante pence Livres Sterling
(GBP 223.157.148,50) à deux cent vingt-trois millions cent cinquante mille quatre cent onze Livres Sterling (GBP
223.150.411,-) par l'annulation de
- vingt-six mille trois cent soixante-quatorze (26,374) Parts Sociales de Catégorie A2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie B2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie C2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie D2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie E2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie F2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie G2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie H2,
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie I2, et
- soixante-quatre (64) Parts Sociales de Catégorie J2,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq pence (GBP 0,25) détenues actuellement par Barclays
Wealth Trustees (Guernsey) Limited, susmentionné. Cette réduction de capital social sera un Rachat à l'Unanimité des
Associés comme défini à l'article 8.3 des Statuts. Un montant de trois cent soixante-sept mille huit cent deux Francs
Suisses et soixante-neuf centimes (CHF 367.802,69) (ou si accepté par la Société, son équivalent dans une devise ou des
81046
L
U X E M B O U R G
devises différentes calculées à un taux de change accepté par la Société) sera payé à Barclays Wealth Trustees (Guernsey)
Limited, susmentionné ou à son ordre.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de convertir un million deux cent vingt-huit mille trois cent vingt-cinq (1.228.325) Parts Sociales
de Catégorie A2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie B2, deux mille neuf cent
soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie C2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de
Catégorie D2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie E2, deux mille neuf cent soixante-
quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie F2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie
G2, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie H2, deux mille neuf cent soixante-quinze
(2.975) Parts Sociales de Catégorie I2 et deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie J2,
actuellement détenues par Alliance Boots GmbH, une société constituée en vertu des lois de Suisse, dont le siège social
est à Untermattweg 8, 3027 Bern, Suisse en un million deux cent vingt-huit mille trois cent vingt-cinq (1.228.325) Parts
Sociales de Catégorie A1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie B1, deux mille neuf
cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie C1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales
de Catégorie D1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie E1, deux mille neuf cent
soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie F1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975)Parts Sociales de
Catégorie G1, deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie H1, deux mille neuf cent soixante-
quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie I1 et deux mille neuf cent soixante-quinze (2.975) Parts Sociales de Catégorie
J1; chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq pence (GPB 0,25).
Suite à la présente résolution et aux résolutions précédentes, les Associés prennent acte que Alliance Boots GmbH
susmentionné détient les parts sociales suivantes:
- huit cent trente millions quarante-six (830.000.046) Parts Sociales de Catégorie A1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie B1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie C1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie D1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie E1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie F1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie G1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie H1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie I1;
- deux millions douze mille quatre cent soixante-deux (2.012.462) Parts Sociales de Catégorie J1;
- vingt millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-cinq (20.099.925) Parts Sociales de Catégorie A2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie B2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie C2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie D2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie E2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie F2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie G2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie H2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie I2;
- quarante-huit mille six cent soixante-quinze (48.675) Parts Sociales de Catégorie J2.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts, afin de refléter les précédentes
résolutions, qui devra désormais se lire comme suit:
" Art. 6. Capital Social.
6.1 La Société a un capital social de deux cent vingt-trois millions cent cinquante mille quatre cent onze Livres Sterling
(GBP 223.150.411,-), représenté par:
- huit cent trente millions cinquante (830.000.050) parts sociales de catégorie A1 (les "Parts Sociales de Catégorie
A1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie B1 (les "Parts Sociales de
Catégorie B1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie C1 (les "Parts Sociales de
Catégorie C1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie D1 (les "Parts Sociales de
Catégorie D1"),
81047
L
U X E M B O U R G
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie E1 (les "Parts Sociales de
Catégorie E1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie F1 (les "Parts Sociales de
Catégorie F1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie G1 (les "Parts Sociales de
Catégorie G1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie H1 (les "Parts Sociales de
Catégorie H1"),
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie I1 (les "Parts Sociales de
Catégorie et
- deux millions douze mille quatre cent soixante-six (2.012.466) parts sociales de catégorie J1 (les "Parts Sociales de
Catégorie J1"),
Les Parts Sociales de Catégorie A1, les Parts Sociales de Catégorie B1, les Parts Sociales de Catégorie C1, les Parts
Sociales de Catégorie D1, les Parts Sociales de Catégorie E1, les Parts Sociales de Catégorie F1, les Parts Sociales de
Catégorie G1, les Parts Sociales de Catégorie H1, les Parts Sociales de Catégorie I1 et les Parts Sociales de Catégorie J1
seront collectivement dénommées "Parts Sociales Ordinaires Holdco".
- quarante-trois millions cinq cent quarante mille quatre cent quarante (43.540.440) parts sociales de catégorie A2 (les
"Parts Sociales de Catégorie A2" et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A1, les "Parts Sociales de Catégorie
A"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie B2 (les " Parts Sociales de Catégorie B2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie B1, les "Parts Sociales de Catégorie B"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie C2 (les " Parts Sociales de Catégorie C2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie C1, les "Parts Sociales de Catégorie C"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie D2 (les " Parts Sociales de Catégorie D2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie D1, les "Parts Sociales de Catégorie D"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie E2 (les " Parts Sociales de Catégorie E2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie E1, les "Parts Sociales de Catégorie E"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie F2 (les " Parts Sociales de Catégorie F2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie F1, les "Parts Sociales de Catégorie F"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie G2 (les " Parts Sociales de Catégorie G2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie G1, les "Parts Sociales de Catégorie G"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie H2 (les " Parts Sociales de Catégorie H2"
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie H1, les "Parts Sociales de Catégorie H"),
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie I2 (les " Parts Sociales de Catégorie I2" et
ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie I1, les "Parts Sociales de Catégorie I"), et
- cent cinq mille quatre cent quarante (105.440) parts sociales de catégorie J2 (les " Parts Sociales de Catégorie J2" et
ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie J1, les "Parts Sociales de Catégorie J"),
toutes ayant une valeur nominale de vingt-cinq pence (GBP 0,25.-) chacune, et ayant été intégralement souscrites et
payées.
Les Parts Sociales de Catégorie A2, les Parts Sociales de Catégorie B2, les Parts Sociales de Catégorie C2, les Parts
Sociales de Catégorie D2, les Parts Sociales de Catégorie E2, les Parts Sociales de Catégorie F2, les Parts Sociales de
Catégorie G2, les Parts Sociales de Catégorie H2, les Parts Sociales de Catégorie I2 et les Parts Sociales de Catégorie J2
seront collectivement dénommées "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie 2".
Les Parts Sociales Ordinaires Holdco et les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie 2 sont désignées ensemble comme
les "Parts Sociales Ordinaires".
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 14.1 des Statuts, qui devra désormais se lire comme suit:
« Art. 14. Restrictions de Transfert.
14.1 Nonobstant toutes dispositions contraires dans les présents Statuts ou dans l'Instrument des Warrants, aucun
Titre ne peut être Transféré par un Exécutif ou l'Investisseur (pour le compte des Exécutifs) autre que (et chaque Exécutif
et l'Investisseur garantiront que tout Membre de leur Famille ou Family trust ou une Société Liée qui détient des Titres
quelconques qui lui ont été alloués ne devra pas transférer l'un quelconque de ces Titres, autres que):
14.1.1 avec le Consentement du Gérant Investisseur;
14.1.2 lorsque cela est requis par les Annexes 6, 9 ou 11 du Pacte d'Associés;
14.1.3 lorsque cela est requis par l'article 14.3;
14.1.4 conformément à l'article 15;
81048
L
U X E M B O U R G
14.1.5 lorsque cela est requis par l'article 16, 17, 18 ou 27;
14.1.6 quand cela est permis par les articles 14.4 ou 27.4;
14.1.7 à la Société conformément aux dispositions de la Loi de 1915; ou
14.1.8 (sauf si Holdco a notifié les Exécutifs que de tels transferts ne sont plus autorisés car il estime à son entière
discrétion que le nombre de détenteurs de titres puisse engendrer de futures difficultés en vertu de la législation en
matière de valeurs mobilières) à un Membre de la Famille ou un Family Trust ou ou avec le consentement préalable écrit
de la Société à la Société Liée de ce Membre de la Famille ou de ce Family Trust ou Société Apparentée vers les Exécutifs
auxquels de telles Parts Sociales étaient à l'origine allouées selon les termes du EBT (Trust Deed). Ce type de Transfert
de Titres est opéré relativement aux (i) Titres de toutes les classes de Titres détenus par l'Exécutif en question, Membre
de Famille ou Family Trust ou Société Liée et (ii) la même proportion des détentions de chaque classe de Titres, appar-
tenant à une telle personne; ou
14.1.9 lorsque autrement requis d'agir ainsi en vertu de toute disposition de tout Pacte d'Associés ou de ces Statuts.
[...]."
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 14.4.1 des Statuts qui devra se lire comme suit:
" 14.4. Droit de première offre.
14.4.1 Cet article 14.4 s'applique si le Trustee propose de transférer le titre légal et effectif de toute Action Galenica
MEP autre qu'en lien avec une Extraction Galenica relative à une Transaction Topco en vertu de l'annexe 6 du Pacte
d'Associés (autre que la partie G), en vertu des articles 14.3, 15, 16, 17 ou 27.4 ou avec l'accord préalable écrit des
Gérants Investisseurs (un "Transfert Préemption"). [...]"
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 17.3 des Statuts qui devra désormais se lire comme suit:
" Art. 17. Exit. [...]
17.3 Les Associés Ordinaires s'accordent sur le fait qu'une Transaction Topco sera réalisée en requérant de l'Exécutif
et du Trustee et des Détenteurs Concernés de vendre ou transférer (ou dans le cas de Warrants de vendre ou transférer
et/ou d'exercer et de vendre ou transférer les parts sociales résultant et/ou de consentir au rachat ou remboursement
des parts sociales résultant) et/ou en permettant ou en requérant de l'Investisseur, des Exécutifs et leurs Détenteurs Liés
qu'ils échangent au moyen d'une ou plusieurs transactions l'ensemble ou une proportion appropriée de leurs Titres pour
des parts sociales et/ou warrants dans Topco (les "Titres Topco Exécutifs") (devant être détenus par l'Investisseur pour
le compte des Exécutifs concernés) en vue de la vente de ces Titres Topco Exécutifs (à un prix déterminé par Gibco avec
le Consentement du Gérant Investisseur (chacun d'eux agissant de bonne foi et en consultation avec les Représentants
du Gérant, sous réserve des dispositions de l'Article 32.6), ce qui pourrait n'être rien suite à l'application de l'article 27)
ou admis à la cote en tant que faisant partie d'une Transaction Topco, ou à travers d'autres moyens déterminés par Gibco
avec le Consentement du Gérant Investisseur (chacun d'eux agissant de bonne foi et en consultation avec les Représen-
tants du Gérant ainsi que disposé à l'Article 32.6 et 32.7) considérant de façon raisonnable la position fiscale des Exécutifs.
[...]"
<i>Huitième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 17.7 des Statuts qui devra désormais se lire comme suit:
" Art. 17. Exit. [...]
17.7 Afin de rendre effective une Transaction Topco d'une manière permise ou requise par la partie B de l'annexe 6
du Pacte d'Associés, Holdco avec le Consentement du Gérant Investisseur (tant Holdco que le Gérant Investisseur
agissant de bonne foi et en consultation avec les Représentant des Exécutifs) détermineront les termes d'une exigence
ou d'un droit des Exécutifs, du Trustee et des Détenteurs Liés pour la réalisation d'une Transaction Topco comprenant
la vente ou l'achat (ou dans le cas des Warrants, de vendre ou transférer et/ ou exercer et ventre ou transférer les parts
sociales en résultant) à de tels termes qu'ils décident de prendre en compte (mais sans être obligés de les appliquer à
tous les égards) les termes qu'ils auraient appliqué si une transaction analogue à une Transaction Topco avait été réalisée
à la place par une cession ou autre transaction par ou impliquant Holdco. Les Exécutifs, le Trustee et les Détenteurs Liés
se conformeront avec tous termes ainsi déterminés à tous égards. Pour écarter tous doutes, Holdco peut dans son entière
discrétion traiter les Exécutifs de manières différentes selon la juridiction dans laquelle ils sont résidents ou résidents
fiscaux si Holdco estime qu'il existe des bénéfices légaux, fiscaux ou règlementaires pour les Exécutifs et/ou tout membre
du Groupe en le faisant.
[...]."
<i>Neuvième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 27.1.4 des Statuts qui devra se lire comme suit:
81049
L
U X E M B O U R G
« Art. 27. Distribution en cas de Remboursement du Capital / Vente de Part Sociale / Admission à la Cote/ Extraction
Galenica. [...]
27.1.4 quatrièmement, si Holdco a reçu un montant suffisant pour lui donner la Cible IRR et dans la mesure où il reste
des Produits non-alloués suivant les distributions réalisées en vertu de l'article 27.1.3 (l'"Excès de Remboursement de
Capital"), Holdco recevra le Pourcentage Gibco du Remboursement de Capital, chaque Exécutif (via l'Investisseur) devra
recevoir sa Proportion de l'Exécutif du Pourcentage de l'Exécutif de l'Excès du Remboursement de Capital, chaque
Exécutif Considéré devra recevoir sa Proportion de l'Exécutif Considéré du Pourcentage de l'Exécutif de l'Excès du
Remboursement de Capital et le Trustee devra recevoir la Proportion Trustee Warehouse du Pourcentage de l'Exécutif
de l'Excès de Remboursement du Capital. Pour éviter tout doute, s'il n'y a pas d'Excès de Remboursement de Capital,
les Exécutifs (via l'Investisseur), tout Exécutif Considéré et le Trustee ne recevront rien en vertu du présent article 27.1.4.
<i>Dixième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 27.2.2 des Statuts qui devra se lire comme suit:
« Art. 27. Distribution en cas de Remboursement du Capital / Vente de Part Sociale / Admission à la Cote/ Extraction
Galenica. [...]
27.2.2 deuxièmement, Holdco recevra relativement à la Proportion Walgreens des Titres Concernés détenus par
Holdco, la Proportion Walgreens de la Contrepartie restante suivant les distributions réalisées en vertu de l'article 27.2.1;
[...]"
<i>Onzième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 27.4.4 des Statuts qui devront se lire comme suit:
« Art. 27. Distribution en cas de Remboursement du Capital / Vente de Part Sociale / Admission à la Cote/ Extraction
Galenica. [...]
27.4.4 chaque Exécutif (ou le conjoint de cet Exécutif) peut notifier le Trustee par écrit le jour de ou avant la date de
l'Extraction Galenica que le Trustee n'exercera pas les droits énoncés à l'article 27.4.2 ci-dessus en vertu d'une partie ou
de toutes les Actions Galenica MEP de cet Exécutif (de telles Actions Galenica MEP formant les "Actions Galenica MEP
Exclues") ou les Warrants Galenica MEP (de telles Warrants Galenica MEP formant les "Warrants Galenica MEP Exclus").
[...]"
<i>Douzième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 27.7 des Statuts qui devront se lire comme suit:
« Art. 27. Distribution en cas de Remboursement du Capital / Vente de Part Sociale / Admission à la Cote/ Extraction
Galenica. [...]
27.7 Des exemples de la manière dont les paiements peuvent être effectués en vertu de l'Alliance Boots Management
Equity Plan sont énoncés à l'article 30."
<i>Treizième résolutioni>
Les Associés décident de modifier les définitions de "Exécutif Considéré", "Parts Sociales de l'Exécutif Considéré",
"Actions Galenica MEP", "Cotation", "Titres MEP", "Prix de Souscription", "Cible IRR" et "Proportion Walgreen" conte-
nues à l'article 31 des Statuts qui devront se lire comme suit:
" Art. 31. Définitions.
[…]
Exécutif Considéré
Signifie une/de telle(s) personne(s) (autre que Holdco, les Exécutifs et les Investisseurs)
que les Gérants Investisseurs considèrent être des Exécutifs pour ces besoins et inclura
les personnes qui participent au Management Equity Plan constitué par le Pacte d'Associés
via différents documents;
[…]
Parts Sociales de
l' Exécutif Considéré
désigne les parts sociales de la Société détenues par tout Exécutif Considéré ou Détenteur
Lié (ou détenues en leur nom par le Trustee) de temps à autres;
[..]
Proportion de l'Exécutif
désigne à l'égard d'un Exécutif, la proportion dont le nombre de Titres MEP autre que les
Titres Galenica MEP, détenus par un tel Exécutif via l'Investisseur porte sur le nombre total
de Titres MEP autres que les Titres Galenica MEP émis;
[…]
Actions Galenica MEP
désigne
a) la Proportion Galenica des Actions Galenica des Exécutifs de chacun des Exécutifs et
chaque Part Sociale de l' Exécutif Considéré à la date de l'Extraction Galenica, ensemble
avec toutes Actions des Exécutifs résultant de l'exercice des Warrants Galenica MEP; et
b) la Proportion Galenica de toutes parts sociales dans la Société détenues par le Trustee
à la date de l'Extraction Galenica autre que le nominee, ensemble avec toute parts sociales
81050
L
U X E M B O U R G
dans la Société résultant de l'exercice des Warrants Galenica MEP détenues par le Trustee
autre qu'en qualité de nominee;
[…]
Cotation
Signifie, relativement à toute Société du Groupe:
a) À la fois l'admission de toutes parts sociales de cette Société du Groupe à la Liste
Officielle tenue par le FSA devenant effective (en accord avec les Règles de la Cotation) et
l'admission de toutes parts sociales d'une Société du Groupe à la négociation sur le marché
Les pour les titres admis à la cote (en accord avec les Admission and Disclosure Standards
en vigueur du LSE, pour le temps présent);
b) L'admission à la négociation de toutes parts sociales de cette Société du Groupe sur le
Alternative Investment Market du LSE devenant effective; ou
c) L'admission à la négociation ou la permission de négocier sur tout autre Lieu
d'Investissement Reconnu; ou tel autre lieu d'échange nommé par Holdco, devenant effectif
et relativement à toutes parts sociales de cette Société du Groupe.
[…]
Titres MEP
désigne les Titres des Exécutifs, les Parts Sociales de l'Exécutif Considéré et toutes autres
parts sociales de la Société ou Warrants détenus par le Trustee autre qu'en qualité de
nominee;
[…]
Prix de Souscription
Signifie le montant total payé sur les Titres (incluant toute prime d'émission) ou, si les Titres
ont été acquis, le prix d'achat qui a été payé. De ce fait, toutes Parts Sociales Ordinaires
émises lors de l'exercice d'un Warrant par le Sortant ou de ses Personnes Liées seront
considérées comme ayant eu un Prix de Souscription équivalent aux montants payés pour
acquérir les Warrants correspondants et l'exercice de cela."
[…]
Cible IRR
signifie à l'égard d'un Remboursement de Capital, d'une Vente de Parts Sociales ou Cotation
d' un montant qui donne à Holdco un taux interne de retour sur les Titres Appropriés qu'il
détient (autre que les Parts Sociales Exclues) équivalant à 8% par année, calculé à partir du
26 juin 2007 au jour de l'exécution de toute Vente de Parts Sociales ou Transaction Topco,
sous réserve qu'à l'égard de la Transaction Walgreen Initiale, la date devra être celle du 2
août 2012 étant la date anticipée et effective de la réalisation de la Transaction Initiale
Walgreen), le jour où tout Remboursement de Capital est fait ou le jour ou une Cotation
devient effective, suivant ce qui est applicable, et, dans chaque cas, prenant en compte tout
Remboursement de Capital antérieur relativement aux Titres Appropriés (autre que les
Parts Sociales Exclues). Pour les besoins de cette définition de "Cible IRR", les parts sociales
dans la Société détenues par Holdco, Gibco ou par l'Agent du Groupe en tant que nominee
immédiatement après la Réalisation sera considéré comme ayant été acquis par Holdco le
26 juin 2007 à un coût de GBP 1.960.737.627.24; étant entendu que s'il est impossible de
calculer le taux interne de rendement jusqu'à la date pertinente de la Vente de Parts
Sociales; Remboursement de Capital, de la Cotation ou de la Transaction Topco comme
le conseil d'Holdco peut le déterminer, le taux interne de rendement peut autrement être
calculé jusqu'à une date prise peu de temps avant la réalisation de la Vente de Parts Sociales
concernée, du Remboursement de Capital concerné, de la Cotation concernée ou de la
Transaction Topco concernée comme le conseil d'Holdco peut déterminer. Pour écarter
tout doute, aucun montant reçu par Gibco sur la Transaction Initiale Walgreen ne devra
être pris en compte pour calculer la Cible IRR pour tout Remboursement de Capital, Vente
de Parts Sociales ou Cotation se réalisant après le 2 août 2012, et aucun montant ne sera
reçu par Holdco lors de l'Extraction Galenica ne devra être pris en compte pour calculer
la Cible IRR pour tout Remboursement de Capital, Vente de Parts Sociales ou Listing se
réalisant après l'Extraction Galenica. Dans le cas d'une sortie partielle qui constitue un Cas
de Sortie, Gibco avec le Consentement du Gérant Investisseur (tous deux agissant de
bonne foi et en consultation aves les Représentants du Gérant) aura le droit de modifier
la base sur laquelle la Cible IRR est calculée pour refléter le fait que le Cas de Sortie
représente seulement une sortie partielle.
[…]
Proportion Walgreens
signifie, en ce qui concerne la distribution de Produits sur un Remboursement de Capital,
la distribution d'une Contrepartie sur une Vente de Part Sociale ou d'une allocation de Part
Sociale Côtée en vue d'une Cotation (le cas échéant), la proportion (telle que calculée
immédiatement avant le Remboursement de Capital concerné, Vente de Part Sociale ou
Cotation) que le nombre de parts sociales dans Holdco détenues par Walgreens porte au
nombre total de parts sociales dans Holdco détenues par Walgreens et Gibco. […]"
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille trois cents Euro.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
81051
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est suivi
d'une version française, à la demande des parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le
mandataire des parties comparantes signent l'acte avec le notaire.
Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 23 mai 2013. Relation: LAC/2013/23387. Reçu soixante quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2013.
Référence de publication: 2013069591/814.
(130086155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Excalibur Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.891.
L'an deux mille treize, le deux mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme «EXCALIBUR DEVELOPMENT S.A.» inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.891, constituée suivant acte reçu
par le notaire Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 26
janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 307 du 17 mars 2004. Les statuts de la
société n'ont pas encore été modifiés depuis.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Frédéric LECLERCQ, dirigeant de sociétés, avec adresse à L-1710
Luxembourg 47, rue Paul Henkes.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à
L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo,
et comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse professionnelle.
Le Président expose:
I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils
détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou
leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les pro-
curations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée «ne varietur» par les comparants et le notaire
instrumentant.
II. Qu'il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions de
la Société d'une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR), représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (31.000.- EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs
de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le quorum exigé
dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée est rempli.
III. Après avoir exposé les différents points de l'ordre du jour, le Président les soumet à l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l'ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions ci-après.
IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous les actionnaires présents ou
représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de ladite assemblée.
V. Que la société n'a émis aucun emprunt obligataire.
VI. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
81052
L
U X E M B O U R G
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l'accomplissement de son objet.
La société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou
susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.»
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé le point précité de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix la résolution
suivante:
<i>Première et Unique résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social afin
de lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l'accomplissement de son objet.
La société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou
susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes évalués à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR) sont
à charge de la Société.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le Relation: LAC/2012/ Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069789/83.
(130086243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Great Pacific Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 101.001.010,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 99.675.
Suite à l'assemblée générale annuelle tenue en date du 23 mai 2013 de la Société, les décisions suivantes ont été prises:
- Le mandat des gérants suivants est renouvelé à compter du 23 mai 2012:
Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant B, est nommé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
2014.
Monsieur Paul Galliver, gérant B, est nommé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
Monsieur Donald Crawford Joyce, gérant A, est nommé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.
Monsieur Ryan Barrington-Foote, gérant A, est nommé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.
Monsieur Emmanuel Réveillaud, gérant A, est nommé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.
81053
L
U X E M B O U R G
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- Monsieur Donald Crawford Joyce, gérant A;
- Monsieur Emmanuel Réveillaud, gérant A;
- Monsieur Ryan Barrington-Foote, gérant A;
- Monsieur Paul Galliver, gérant B;
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paul Galliver
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2013069830/25.
(130086427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.026.042,97.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 146.948.
In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of the month of May.
Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders (the "Shareholders") of BMG RM
Investments Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 6, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of four million
twenty-six thousand forty-two euro and ninety-seven euro cents (EUR 4,026,042.97-), registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 146.948, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 13 June 2009 published on 27 July 2009 in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 69234 (the "Mémorial") and last amended by a deed of
Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 14 June 2012 published on
27 July 2012 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 88336 (the "Company").
The Meeting was opened at 11.30am with Flora Gibert, notary's clerk, residing in Luxembourg, in the chair,
The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Hadrien Forterre residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the present or represented Shareholders, the proxy of the represented Shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the proxy of the represented Shareholders and by
the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
II. The proxy of the represented Shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialed
ne varietur by the appearing person.
III. That pursuant to the attendance list, the Shareholders hold all shares representing 100% of the share capital of the
Company, are present or represented at the Meeting and that the Shareholders present or represented consider itself
being duly informed of the agenda and waive any convening notice.
IV. That the Meeting is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Full restatement of the articles of association of the Company;
2. Allocation of the share capital of the Company;
3. Appointment of the managers of the Company;
4. Transfer of the registered office of the Company; and
5. Miscellaneous.
The Shareholders have unanimously requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company which shall now be read as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "BMG RM Investments
Luxembourg S.à r.l." (the "Company").
81054
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company's share capital is set at four million twenty-six thousand forty-two euro and ninety-seven euro cents
(EUR 4,026,042.97-), consisting of four hundred two million six hundred four thousand two hundred ninety-seven
(402,604,297) shares all with a nominal value of one cent of euro (EUR 0.01) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of
plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares without designation of their nominal value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
81055
L
U X E M B O U R G
6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6. The Company's shares are in registered form.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.
7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-
ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General Meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".
9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead
of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in
the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
81056
L
U X E M B O U R G
10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them
to take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers (the "Board") being the corporate body in
charge of the Company's management and representation. To the extent applicable and where the term "sole manager"
is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "Board" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole manager".
14.2. The Board is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate
object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder(s).
81057
L
U X E M B O U R G
14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the Board.
14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting
alone or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Election and Removal of managers and Term of the office.
15.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
15.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
15.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 16. Convening meetings of the Board.
16.1. The Board shall meet upon call by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting
as described in the next paragraph.
16.2. Written notice of any meeting of the Board must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication,
except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice.
Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or
by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening
notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the Board. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the Board are present or repre-
sented at a meeting of the Board or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.
Art. 17. Conduct of meetings of the Board.
17.1. Quorum
The Board can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of
the Board.
17.2. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the Board.
17.3. Any manager may act at any meeting of the Board by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing
by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
17.4. Any manager who participates in a meeting of the Board by conference-call, video-conference or by any other
means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the
meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present
for the computation of quorum and majority. A meeting of the Board held through such means of communication is
deemed to be held at the Company's registered office.
17.5. The Board may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at
a meeting of the Board duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all
managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any
other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the
entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the reso-
lutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of meetings of the Board.
18.1. The Board shall draw minutes of any meeting of the Board, which shall be signed by the members present or
represented at the meeting of the Board.
18.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
18.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.
Art. 19. Dealings with third parties and Representations of the Company. The Company shall be bound towards third
parties in all circumstances by the joint signatures of any two (2) managers or by the signature of the sole manager or by
the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the
Board or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to
whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to
the rules and the limits of such delegation.
81058
L
U X E M B O U R G
E. Supervision
Art. 20. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
20.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
20.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
20.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
20.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
20.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory
auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be
a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors
the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the Board shall
apply.
20.6. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 22. Profits.
22.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal
reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
22.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
22.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the Board, the general meeting
of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with
the law and these articles of association.
Art. 23. Interim dividends. The Board or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim
dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available,
(ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the
annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this
purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or
of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the Board that the
first two conditions have been satisfied.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 25. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended."
<i>Second resolutioni>
As the consequence of the above resolution the Meeting resolves to allocate the four hundred two million six hundred
four thousand two hundred and ninety-seven (402,604,297) representing one hundred per cent (100%) of the share capital
of the Company as follows:
81059
L
U X E M B O U R G
1. One hundred eighty-nine million two hundred thirty-nine thousand seven hundred and seventy-three (189,239,773)
shares with a nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each to Bertelsmann Investments Luxembourg S.à r.l. a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 45, boulevard Pierre Frieden,
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand euro (EUR 13,000.-), registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 146.727; and
2. Two hundred thirteen million three hundred sixty four thousand five hundred and twenty-four (213,364,524) shares
with a nominal value of one cent euro (EUR 0.01) each to Reinhard Mohn GmbH, a private limited liability company
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its registered office at 270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh,
Germany, registered with the Trade Register kept by the local court of Gütersloh (Handelsregister des Amtsgerichts
Gütersloh) under number HRB 3101.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to appoint the following persons as managers of the Company as of the date hereof:
1. Andrew Buckhurst, born on 23 October 1966 in Canterbury, United Kindgom, residing at 5, rue Michel Rodange,
L-7248 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg; and
2. Thomas Goetz, born on 18 July 1971 in Regensburg, Germany, residing at 270, Carl.Bertelsmann- Strasse, D-33311
Gütershloh, Germany.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company from its current registered office located at 6,
rue de Rollingergrund, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg with effect as of the date hereof.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at one thousand two hundred euro.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, who is known to the undersigned
notary by his surname, first name, civil status and residence, the proxyholder(s) of the appearing parties signed together
with us, the notary, the present original deed.
Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am siebenzehnten Tag des Monats Mai
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxem-
burg.
Hat eine Hauptversammlung der Gesellschafter der BMG RM Investments Luxembourg S.à r.l., einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, mit einem Stammkapital in
Höhe von vier Millionen sechsundzwanzigtausendzweiundvierzig Euro und siebenundneunzig Cent (EUR4.026.042,97),
eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 146.948, gegründet am 13. Juni 2009 durch no-
tarielle Urkunde der Notarin Martine Schaeffer, wohnhaft in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im
Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations (das „Memorial") Nr. 69234 vom 27. Juli 2009, zuletzt geändert am 14.
Juni 2012 durch Urkunde des Notars Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
veröffentlicht Memorial Nr. 88336 vom 27. Juli 2012 (die "Gesellschaft"), stattgefunden.
Die Versammlung wurde um 11.30H unter dem Vorsitz von Flora Gibert wohnhaft in Luxembourg eröffnet, welcher
Hadrien Forterre wohnhaft in Luxembourg zum Sekretär ernennt.
Die Hauptversammlung wählt also Hadrien Forterre zum Stimmenzähler.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt
Folgendes und ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, sowie
die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung
durch die Gesellschafter, Bevollmächtigten und den Versammlungsvorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um
zusammen mit dieser einregistriert zu werden.
II. Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung „ne varietur" durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
81060
L
U X E M B O U R G
III. Dass sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend beziehungsweise gültig vertre-
ten sind, und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, von der für diese Hauptversammlung
festgelegten Tagesordnung Kenntnis erhalten und ordnungsgemäß geladen worden zu sein.
IV. Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesord-
nungspunkte beraten kann.
<i>Tagesordnungi>
1. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
2. Zuordnung des Stammkapitals der Gesellschaft;
3. Ernennung der Geschäftsführer der Gesellschaft;
4. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; und
5. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter ersuchte den unterzeichnenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst die vollständige Neufassung der Satzung wie folgt:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société ä responsabilité limitée unter der Firma " BMG
RM Investments Luxembourg S.à r.l." (die "Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3. Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen.
Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-
burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.
81061
L
U X E M B O U R G
4.4. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-
schäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vier Millionen sechsundzwanzigtausendzweiundvierzig Euro und sie-
benundneunzig Cent (EUR 4.026.042,97) bestehend aus vierhundertzwei Millionen sechshundertviertausendzweihun-
dertsiebenundneunzig (402.604.297) Geschäftsanteile, alle mit einem Nominalwert von je ein euro cent (EUR 0.01).
5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-
schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden
Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-
anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile ohne Bezeichnung des Nominalwerts aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl
der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.
6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-
fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-
gekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend
herabgesetzt.
6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-
schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-
sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.
8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter
Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht¬Gesellschafter nur mit
81062
L
U X E M B O U R G
Einwilligung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimm-
rechte der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.
8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des
Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.
8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen
und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
"Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" gelesen werden.
9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
81063
L
U X E M B O U R G
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,
Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.
11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern
sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-
schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.
13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein
müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat. Der Geschäftsführerrat ist in
diesem Fall das zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan. Soweit anwendbar und
wo der Begriff "alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem
Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den "Geschäftsführerrat" als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer"
gelesen werden.
14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.
14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
15.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
15.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
15.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer
kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
81064
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
16.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung
zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
16.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
Art. 17. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrat.
17.1. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.2. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder gefasst.
17.3. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
17.4. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-
okonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
abgehalten wurde.
17.5. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E¬Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Der Vorstand, soll ein Protokoll über jede Sitzung des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches von den Mitglie-
dern bei der Sitzung des Geschäftsführerrats zugegen oder vertreten sind,, unterzeichnet wird.
18.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
18.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten und Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen
Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden,
der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen
worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesge-
schäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbin-
dung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.
E. Aufsicht
Art. 20. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
20.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
81065
L
U X E M B O U R G
20.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
20.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
20.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte
der Gesellschaft.
20.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher aus
seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.
20.6 Falls die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002
betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-
unddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Gewinne.
22.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
22.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
22.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
22.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-
versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.
Art. 23. Zwischendividenden. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden
zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind,
(ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Ge-
schäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener
Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener
Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind,
und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die
beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
H. Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
In Folge des ersten Beschlusses beschließt die Hauptversammlung, die vierhundertzwei Millionen sechshundertvier-
tausendzweihundertsiebenundneunzig (402.604.297) Geschäftsanteile, die einhundert Prozent (100%) des Stammkapitals
repräsentieren, wie folgt zuzuordnen:
81066
L
U X E M B O U R G
I. Einhundertneunundachzig Millionen zweihundertneununddreissigtausendsiebenhundertdreiundsiebzig (189,239,773)
Geschäftsanteile, alle mit einem Nominalwert von je ein euro cent (EUR 0.01) werden der Bertelsmann Investments
Luxembourg S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 45, boulevard
Pierre Frieden, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Stammkapital in Höhe von dreizehntausend Euro
(EUR 13.000), eingetragen im Luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 146.727, zuge-
teilt; und
2. Zweihundertdreizehn Millionen dreihundertvierundsechzigtausendfünfhundertvierundzwanzig (213.364.524) Ge-
schäftsanteile, alle mit einem Nominalwert von je ein euro cent (EUR 0.01) werden der Reinhard Mohn GmbH, einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 270 Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh, Deutschland, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Gütersloh unter der Nummer HRB 3101, zugeteilt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die folgenden Personen als Geschäftsführer zu ernennen zu diesem Datum gültig:
1. Andrew Buckhurst, geboren am 23. Oktober 1966 in Canterbury, Vereinigtes Königreich, wohnhaft in 5, rue Michel
Rodange, L-7248, Bereldange, Großherzogtum Luxemburg; und
2. Thomas Goetz, geboren am 18. Juli in Regensburg, Deutschland wohnhaft in 270, Carl.Bertelsmann- Strasse, D-33311
Gütershloh, Deutschland.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von deren gegenwärtigem Sitz in 6, rue
de Rollingergrund, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg nach 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die von der Gesellschaft im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Urkunde getragen werden sollen, werden auf ein tausend zwei hundert Euro geschätzt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben
erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische
Fassung vorrangig sein.
Diese Urkunde wurde in Luxemburg Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten
Tag aufgenommen.
Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat/haben der
Bevollmächtigte/die Bevollmächtigten diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: F. GIBERT, H. FORTERRE, J. EL VINGER.
Enregistré à Luxembourg AC, le 23 mai 2013. Relation: LAC/2013/23382. Reçu soixante quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 10 juin 2013.
Référence de publication: 2013069647/749.
(130086490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Morgina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 96.218.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 14 mai 2013i>
1. Monsieur Xavier SOULARD a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 30.5.2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Morgina Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2013069969/16.
(130086460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
81067
L
U X E M B O U R G
Paunsdorf Centre Luxco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 48.913.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 109.927.
Il résulte des résolutions prises par les associés de La Société en date du 28 mai 2013:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Guido Niesler en qualité de Gérant mfi Investor de La Société avec date
effective le 28 mai 2013.
2. Nomination du nouveau Gérant mfi Investor de La Société avec date effective le 28 mai 2013 et pour une durée
indéterminée:
Madame Katrin Knocke, née le 15 mai 1965 à Dessau en Allemagne, ayant son adresse privée au Wersener Landstrasse
39 b, 49076 Osnabrück, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
TMF Luxembourg S.A.
Jorge Pérez Lozano / J.J. Josset
Référence de publication: 2013070031/19.
(130086083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
I.P. Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.820.000,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 176.110.
<i>Extrait de la décision de l’Associé unique prise au siège social de la société en date du 29 avril 2013i>
L'Associé unique a décidé:
- de nommer M. Stéphane BIVER, né le 3 août 1968 à Watermael-Boitsfort (Belgique) demeurant professionnellement
au 128, boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, en qualité de gérant de la société pour une durée illimitée
- de déterminer le régime signature statutaire: la société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature con-
jointe de deux (2) gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013069862/17.
(130085935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Indiact S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 98.903.
L'an deux mille treize, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Madame Sylvie TALMAS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, agissant
en sa qualité de mandataire de:
1.- Monsieur Ali SHERWANI, né le 24 avril 1975 à Luxembourg, demeurant à L-1370 Luxembourg, 104, Val Ste Croix,
en vertu d'une procuration lui donnée.
2.- La société anonyme dénommée «GLOBAL UNIVERSAL S.A.», ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 83, rue
de Hollerich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89490, en vertu d'une
procuration lui donnée.
Lesquelles procurations après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentaire resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Le mandataire déclare que les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "INDIACT S.à
r.l.", établie et ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich,
81068
L
U X E M B O U R G
société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du
26 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 307 du 17 mars 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B 98903.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de
résidence à Junglinster en date du 16 juillet 2008, publié au Mémorial C numéro 2088 du 28 août 2008.
Ensuite les comparants dûment représentés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés dûment représentés décident d’augmenter le capital social de la société d'un montant de CENT MILLE
EUROS (€ 100.000,-) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) à
CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 112.500,-) par la création et l'émission de HUIT CENTS (800) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune, à souscrire et à libérer entiè-
rement par un apport en numéraire.
Les associés dûment représentés, après avoir constaté la renonciation par l'associé majoritaire à son droit de sou-
scription préférentiel, décident d’émettre et d'accepter la souscription de HUIT CENTS (800) nouvelles parts sociales,
par l'associé minoritaire Monsieur Ali SHERWANI, préqualifié, afin d’augmenter le nombre de parts sociales de CENT
(100) parts sociales à NEUF CENTS (900) parts sociales ayant une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€
125,-) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
La preuve de l'augmentation de capital au montant de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-) a été prouvée au notaire
instrumentant sur le vu d'un certificat bancaire.
Suite à ce qui précède, la répartition des parts sociales est dès lors la suivante:
1.- Monsieur Ali SHERWANI, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 parts sociales
2.- La société anonyme dénommée «GLOBAL UNIVERSAL S.A.» préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . .
99 parts sociales
TOTAL: neuf cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 parts sociales
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés dûment représentés décident de modifier l’article 6, des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 112.500,-), représenté
par NEUF CENTS (900) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
approximativement à € 1.400,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par
ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: TALMAS, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29/05/2013. Relation: EAC/2013/6789. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2013.
Référence de publication: 2013069865/63.
(130086127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
GMT Connect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 176.987.
Il est porté à la connaissance du public qu'à partir une vente en date du 16 mai 2013 (à la suite de la passation d'un
acte notarié), les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
1. GMT Communications Partners III, L.P., une société en commandite de droit d'Angleterre et du pays de Galles,
ayant son siège social au Trafalgar Court, Les Banques, St Pierre Port, Guernesey GY1 3QL, immatriculée auprès du
81069
L
U X E M B O U R G
Registraire des sociétés d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro LP11269, agissant par l'intermédiaire de son
associé commandité GMT III, General Partner L.P., une société en commandite de droit écossais, ayant son siège social
au Trafalgar Court, Les Banques, St Pierre Port, Guernesey GY1 3QL, immatriculée auprès du Registraire des sociétés
d'Écosse sous le numéro SL005734, détient 668.174 parts sociales de catégorie A, numérotées de A-1 à A-668.174;
2. GMT Communications Partners III - A L.P., une société en commandite de droit d'Angleterre et du pays de Galles,
ayant son siège social au Trafalgar Court, Les Banques, St Pierre Port, Guernesey GY1 3QL, immatriculée auprès du
Registraire des sociétés d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro LP12662, agissant par l'intermédiaire de son
associé commandité GMT III, General Partner L.P., une société en commandite de droit écossais, ayant son siège social
au Trafalgar Court, Les Banques, St Pierre Port, Guernesey GY1 3QL, immatriculée auprès du Registraire des sociétés
d'Écosse sous le numéro SL005734, détient 74.477 parts sociales de catégorie A, numérotées de A-668.175 à A-742.651;
3. GMT Associates III, L.P., une société en commandite de droit d'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège
social au Trafalgar Court, Les Banques, St Pierre Port, Guernesey GY1 3QL, immatriculée auprès du Registraire des
sociétés d'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro LP012176, agissant par l'intermédiaire de son associé com-
mandité GMT III, General Partner L.P., une société en commandite de droit écossais, ayant son siège social au Trafalgar
Court, Les Banques, St Pierre Port, Guernesey GY1 3QL, immatriculée auprès du Registraire des sociétés d'Écosse sous
le numéro SL005734, détient 7.349 parts sociales de catégorie A, numérotées de A-742.652 à A-750.000;
4. VSS Structured Capital II, L.P., une société en commandite de droit de l'état de New York, ayant son siège social
au 111 Eighth Avenue, New York, New York 10011, États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Département d'état
de l'état de New York, Division des sociétés sous le numéro 3683739, détient 434.534 parts sociales de catégorie B,
numérotées de B-1 à B-434.534; et
5. VSS Structured Capital Parallel II, L.P., une société en commandite de droit de l'état de New York, ayant son siège
social au 111 Eighth Avenue, New York, New York 10011, États-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Département
d'état de l'état de New York, Division des sociétés sous le numéro 3683802, détient 65.466 parts sociales de catégorie
B, numérotées de B-434.535 à B-500.000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
30 mai 2013.
GMT Connect S.à r.l.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013069837/40.
(130086444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Ecogest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 74.347.
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 mai 2013 que:
- Monsieur Romain NILLES, Expert-comptable, né à Ettelbruck le 29/08/1967 et Monsieur Dan Epps, conseil fiscal, né
le 25/07/1969 à Echternach demeurant tous deux professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg ont
été nommés administrateurs de la Société.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Romain NILLES et Monsieur Dan EPPS prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.
Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015:
- Monsieur Dan EPPS, Conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
- Monsieur Jean-Paul FRANK, Expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt
- Monsieur Max GALOWICH, Juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
(président du Conseil d'Administration)
- Monsieur Steve KIEFFER, Expert-comptable, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxem-
bourg
- Monsieur Romain NILLES, Expert-comptable, né à Ettelbruck le 29/08/1967 et demeurant professionnellement 4,
rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg
81070
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 mai 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013069760/28.
(130085795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Belgium) - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit
étranger.
Adresse de la succursale: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 158.412.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Avec effet au 30 novembre 2012, la succursale ci-haut mentionnée a cessé d'exister suite à une fusion.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 23 mai 2013.
Référence de publication: 2013069930/14.
(130085920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Intrepid Aviation Luxembourg Borrower 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ayo Investments S.à r.l.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 175.580.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 mai 2013.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2013069869/12.
(130086087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg, Salaires et Social S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 29.200.
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 mai 2013 que:
- Monsieur Romain NILLES, Expert-comptable, né à Ettelbruck le 29/08/1967 et demeurant professionnellement 4,
rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg a été nommé administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Romain NILLES prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2016.
Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2016:
- Monsieur Dan EPPS, Conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
(président du Conseil d'Administration)
- Monsieur Jean-Paul FRANK, Expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt
- Monsieur Max GALOWICH, Juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt
- Monsieur Steve KIEFFER, Expert-comptable, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxem-
bourg
- Monsieur Romain NILLES, Expert-comptable, né à Ettelbruck le 29/08/1967 et demeurant professionnellement 4,
rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg
81071
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 mai 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013069793/27.
(130085764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.054.295,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 140.337.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 29 mai 2013i>
En date du 29 mai 2013 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Stephen LEADBEATER en tant que Gérant A de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer James HILL, né le 22 février 1961,à Glasgow, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 18, Soho
Square, Londres W1D 3QL, Royaume- Uni en tant que Gérant A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec
effet immédiat.
- de nommer William SHOWALTER, né le 30 janvier 1963 dans l'Indiana, Etats-Unis d’Amérique, demeurant profes-
sionnellement au 18, Soho Square, Londres W1D 3QL, Royaume- Uni, en tant que Gérant A de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
- Sanjay K. MOREY
- James HILL
- William SHOWALTER
<i>Gérants B:i>
- Richard BREKELMANS
- Elizabeth TIMMER
- Johans DEJANS
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2013.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013069929/31.
(130086021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Neucol Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 600.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.851.
EXTRAIT
En date du 28 mai 2013, les associés de la Société ont approuvé les résolutions suivantes:
- La démission d'Ivo Hemelraad, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant
de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 28 mai 2013.
Référence de publication: 2013070005/15.
(130086063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
81072
2Gears S.à r.l.
Aabar Commodities S.à r.l.
Aabar Luxembourg S.à r.l.
AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l.
Appoint Solutions S.a.r.l.
Ayo Investments S.à r.l.
Beltrama Investments S.A.
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l.
Bom S. à r.l.
Branca AC Fund SCA
Canal Re S.A.
Capital United S.à r.l.
CBRE GMM Global Osiris Luxembourg S.à r.l.
CCEF II Sailing HoldCo S.à r.l.
Climate Change Capital Carbon Fund S.à r.l.
Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l.
Courteline Holdings S.A.
D'co S.à r.l.
D.M. INVESTMENTS Spf S.A.
Driege Participations s.à r.l.
Ecogest S.A.
EMC International S.à r.l.
Eudemis S.A.
Excalibur Development S.A.
Experian U.S. Finance S.à r.l.
FGL Lux Holdings, S.à r.l.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg, Salaires et Social S.A.
Gabbro S.à r.l.
GMT Connect S.à r.l.
Great Pacific Luxembourg S.à r.l.
H2L S.A.
Habitus Promotions S.à r.l.
Hoerstiffchen S.à r.l.
Husky Injection Molding Systems
Immobilière Félix GIORGETTI s.à r.l.
Imomix S.A.
Indiact S.à r.l.
Inesia S.A.
Inesia S.A.
Intech S.A.
Intelimat S.A.
Interbasic Holding S.A.
Intrepid Aviation Luxembourg Borrower 1 S.à r.l.
I.P. Holding S.à r.l.
Irroma Sàrl
Irroma Sàrl
Isatis Investment
Jecolux gmbh
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A.
JPMorgan European Property Fund Management Company S.A.
Kadorian
Kase World Wide S.à r.l.
KBC Group Re S.A.
Kullu S.A.
Lag International S.A.
Leasinvest Immo Lux
Libidama International S.A. SPF
Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l.
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Belgium) - Luxembourg Branch
Morgina Luxembourg S.à r.l.
Morgina Luxembourg S.à r.l.
Neucol Holding S.à r.l.
Noiseworks Records
Paunsdorf Centre Luxco