This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1634
9 juillet 2013
SOMMAIRE
Caisse Raiffeisen Bascharage-Reckange-
Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78386
Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Usel-
dange Société Coopérative . . . . . . . . . . . .
78386
Carpel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78386
Echternacher Tourismus Tage . . . . . . . . . .
78425
Emerging Markets Online Food Delivery
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78395
Enviro IP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78386
E Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78386
European Retail Asset Management
(ERAM) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78386
FCMS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78387
FCMS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78387
Fellow Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78387
Fellow Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78387
Financière Baucalaise S.A. . . . . . . . . . . . . . .
78387
Financière d'Ibis Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78387
Floann S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78388
Foodline Management Services S.A. . . . . .
78388
Foodline SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78388
Galilehorn Asset Management S.à r.l. . . . .
78388
G.C.C. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
78388
Golden Hawk Management S.à r.l. . . . . . . .
78388
H2O Hesperange S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
78390
Habersti SA, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78389
Habinvest S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78389
HELIOPSIS Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78389
Homilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78389
HSBC Amanah Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78432
HSH Luxembourg Coinvest S.à.r.l. . . . . . .
78389
HTC High Technology Coatings S.A. . . . .
78389
Hypericum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78390
Immolam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78390
Immo-Weimerskirch II S.A. . . . . . . . . . . . . .
78390
Infrabiz Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78390
Integer Ethical Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78390
Interassurances Pauly & Lamby et Associés
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78391
Le Gaselle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78391
LMA German Investments . . . . . . . . . . . . . .
78391
LMB German Investments . . . . . . . . . . . . . .
78391
LMC German Investments . . . . . . . . . . . . . .
78391
LMD German Investments . . . . . . . . . . . . . .
78392
LogiGest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78391
Lombok Capital Ventures S.A. . . . . . . . . . .
78392
LUX. FINANCIAL COMPANY Spf S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78392
Lux-Immo-Containers S.A. . . . . . . . . . . . . .
78392
M(a)Gsolutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78392
MAS ASSETS s.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
78393
Maxilly Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78393
Meigerhorn Espace Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
78393
Meigerhorn Etoy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78393
Meigerhorn Montreux, Sàrl . . . . . . . . . . . . .
78393
M.E.S. Company Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78392
MMS Mercury Management Services S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78393
Morgan Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
78431
NMC International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
78394
Peinture Backes & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78394
Pentair Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78394
PGO Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78394
PGO Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78394
Pomelos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78394
Pomelos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78395
Poncirus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78395
Poncirus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78395
RMJ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78395
Solix Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78425
78385
L
U X E M B O U R G
E Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 109.334.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066080/9.
(130081217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Carpel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 66.142.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066034/9.
(130081330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Caisse Raiffeisen Bascharage-Reckange-Soleuvre, Société Coopérative.
Siège social: L-4942 Bascharage, 2C, rue de la Résistance.
R.C.S. Luxembourg B 20.301.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066012/9.
(130081632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange Société Coopérative, Société Coopérative.
Siège social: L-8550 Noerdange, 3, Dikrecherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.446.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066022/9.
(130081629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Enviro IP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.139.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066109/9.
(130081843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
European Retail Asset Management (ERAM) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 103.456.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066097/9.
(130081325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78386
L
U X E M B O U R G
FCMS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1133 Luxembourg, 13A, rue des Ardennes.
R.C.S. Luxembourg B 120.946.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066135/9.
(130081467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
FCMS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1133 Luxembourg, 13A, rue des Ardennes.
R.C.S. Luxembourg B 120.946.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066136/9.
(130081468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Fellow Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 71.244.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066137/9.
(130081706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Fellow Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 71.244.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066138/9.
(130081707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Financière Baucalaise S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 36.879.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066139/9.
(130081406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Financière d'Ibis Spf S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 33.314.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066141/9.
(130081409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78387
L
U X E M B O U R G
Floann S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 4B, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 157.714.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066147/9.
(130081372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Foodline Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 64.607.
Le Bilan clos au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066148/9.
(130081225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Foodline SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7257 Walferdange, 12, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 64.484.
Le Bilan clos au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066149/9.
(130081224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
G.C.C. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1527 Luxembourg, 16, rue du Maréchal Foch.
R.C.S. Luxembourg B 136.796.
Le Bilan clos au 31 mars 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066156/9.
(130081530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Galilehorn Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 111.049.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066159/9.
(130081324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Golden Hawk Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 143.103.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066162/9.
(130081326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78388
L
U X E M B O U R G
Habersti SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 152.841.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066189/9.
(130082008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Habinvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.279.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066190/9.
(130081811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
HELIOPSIS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.650.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066197/9.
(130081410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Homilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 21.362.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066203/9.
(130081417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
HSH Luxembourg Coinvest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 512.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066208/9.
(130081340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
HTC High Technology Coatings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 152.978.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066209/9.
(130081732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78389
L
U X E M B O U R G
Hypericum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 99.626.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066213/9.
(130081423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
H2O Hesperange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 87.665.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066214/9.
(130081360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Integer Ethical Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.979.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066222/9.
(130081815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Immo-Weimerskirch II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-Rothermel.
R.C.S. Luxembourg B 163.799.
Les comptes annuels au 31 DECEMDRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066227/9.
(130081265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Immolam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 140.902.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066234/9.
(130081421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Infrabiz Holdings S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 99.081.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066235/9.
(130081206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78390
L
U X E M B O U R G
Interassurances Pauly & Lamby et Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 123.266.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066239/9.
(130082100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
LogiGest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3473 Dudelange, 10, An der Foxenhiel.
R.C.S. Luxembourg B 168.994.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066283/9.
(130081749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Le Gaselle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 99.388.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066293/9.
(130081745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
LMA German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 135.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066297/9.
(130081343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
LMB German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066299/9.
(130081342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
LMC German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.584.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066302/9.
(130081542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78391
L
U X E M B O U R G
LMD German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 141.012.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066304/9.
(130081671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Lombok Capital Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 83.061.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066306/9.
(130081649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
LUX. FINANCIAL COMPANY Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 73.856.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066314/9.
(130081654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Lux-Immo-Containers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 89.718.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066316/9.
(130081528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
M.E.S. Company Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 81.957.
Les Comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066321/9.
(130081611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
M(a)Gsolutions, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 11, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 171.262.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066322/9.
(130081962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78392
L
U X E M B O U R G
MAS ASSETS s.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-8035 Strassen, 3, Cité Pescher.
R.C.S. Luxembourg B 159.580.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066343/9.
(130081667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Maxilly Estate S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 138.473.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066347/9.
(130081963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Meigerhorn Espace Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 127.203.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066351/9.
(130081328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Meigerhorn Etoy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.548.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066352/9.
(130081327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Meigerhorn Montreux, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 126.968.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066353/9.
(130081329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
MMS Mercury Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 135.236.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066358/9.
(130081752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78393
L
U X E M B O U R G
NMC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 107.609.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066381/9.
(130081207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Peinture Backes & Cie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 7, rue d'Ell.
R.C.S. Luxembourg B 92.996.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066407/9.
(130081730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Pentair Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 81.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066421/9.
(130081758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
PGO Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 137.472.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066425/9.
(130081465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
PGO Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 137.472.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066426/9.
(130081466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Pomelos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 130.076.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066432/9.
(130081825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
78394
L
U X E M B O U R G
Pomelos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 130.076.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066433/9.
(130081826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Poncirus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 130.073.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066434/9.
(130081823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
Poncirus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 130.073.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013066435/9.
(130081824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
RMJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.450,00.
Siège social: L-4797 Linger, 66, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 176.702.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2013, que Monsieur Marco GAROFOLI né le 29 août 1983
à Niederkorn, demeurant à L-4797 Linger, 66, rue de la Libération, a été nommé dans sa fonction de gérant technique.
Monsieur Monsieur Raymond SABLONG, né le 11 septembre 1962 à Esch/Alzette, demeurant à L-4123 Esch/Alzette,
55a, rue du Fossé, a été nommé dans sa fonction de gérant administratif.
Monsieur Johann DEHENAIN, né le 7 juillet 1967 à Esch/Alzette, demeurant à L-4395 Pontpierre, 26, rue de Mon-
dercange, a été nommé dans sa fonction de gérant administratif.
Linger, le 17 mai 2013.
Marco GAROFOLI / Raymond SABLONG / Johann DEHENAIN.
Référence de publication: 2013065676/15.
(130080891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 175.738.
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of the month of April;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws
of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB
109262B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter "Rocket Internet"),
here represented by Katia GAUZÈS, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Berlin (Germany), on April 29, 2013, and
2. Kinnevik Online AB (formerly Kinnevik Online Ventures AB), a limited liability company (aktiebolag) existing under
the laws of Sweden registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815- 4958, having its
registered address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden (hereinafter "Kinnevik Online AB"),
78395
L
U X E M B O U R G
here represented by Katia GAUZÈS, prenamed, by virtue of a proxy, given in Stockholm (Sweden), on April 29, 2013,
and
3. Bambino 53. V V UG (haftungbeschränkt), a limited liability company (Unternehmensgesellschaft (haftungbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
"Bambino 53. V V"),
here represented by Katia GAUZÈS, prenamed, by virtue of a proxy, given in Berlin (Germany), on April 29, 2013,
and
4. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg (hereinafter "AI European Holdings"),
here represented by Katia GAUZÈS, prenamed, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on April 29, 2013, and
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under number B 176544, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter "Aismare Lux Holdings S.à r.l."),
here represented by Katia GAUZÈS, prenamed, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on April 26, 2013, and
6. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands (hereinafter "New Investor" or "Phenomen"), participating and voting only for purposes of
Agenda point 5 et seqq.,
here represented by Katia GAUZÈS, prenamed, by virtue of a proxy, given in London (United Kingdom), on April 29,
2013.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy-holder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1. through 5. (the "Existing Shareholders") are all the shareholders of Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 175.738 and incorporated pursuant to a deed of
the notary Jean-Joseph WAGNER, residing in Sanem, on 28 February 2013, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 956 dated 22 April 2013. The articles of incorporation were amended for the last time
pursuant to a deed of the notary Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg, on 16 April 2013, not yet published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the
general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the
New Investor participates and votes for purpose of Agenda point 5 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to convert the existing three thousand seven hundred fifty (3,750) series B shares, with a nominal value
of one euro (EUR 1.00), each into three thousand seven hundred fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1
Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
2. Decision to create one (1) additional class of shares referred to as the series B2 shares (hereinafter "Series B2
Shares") and to hence have eight (8) classes of shares in total.
3. Acceptance of Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws
of the Cayman Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9007, Cayman Islands (hereinafter the "Phenomen Ventures LP") as new shareholder of the Company.
4. Increase of the Company's share capital by an amount of four thousand six hundred and eighty-seven euro (EUR
4,687) so as to raise it from its current amount of twenty-eight thousand seven hundred and fifty euro (EUR 28,750) up
to thirty-three thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437) by issuing four thousand six hundred and
eighty-seven (4,687) Series B2 Shares.
5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-three thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437),
represented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common
Shares"), (ii) one hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series A1a Shares"), (iii) one thousand eight
hundred and seven (1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series
A1c shares (hereinafter "Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"),
78396
L
U X E M B O U R G
(vi) one thousand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand
seven hundred and fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1 Shares") and four thousand six hundred and eighty-
seven (4,687) series B2 shares (hereinafter the "Series B2 Shares" and, together with the Series B1 Shares, the "Series B
Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux
Holdings S.à r.l. and (v) Phenomen Ventures LP shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be
issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder
nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act
(AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party Investment") -
irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up
to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which
the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European
Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. and (v) Phenomen Ventures LP shall inform the Company by binding
declaration within three (3) weeks if Rocket Internet GmbH and/or Kinnevik Online AB and/or Al European Holdings
S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP intends to exercise its right pursuant to the
foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes
for further shares in the Company."
6. Subsequent amendment of article seven point four a (7.4a) of the articles of association of the Company so that it
shall henceforth read as follows:
"a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. and (v) Phenomen Ventures LP
(Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.a r.l., Aismare Lux Holdings S.a r.l. and Phenomen
Ventures LP hereinafter jointly referred to as "Investors"; each individually an "Investor") to a company affiliated within
the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) to the respective Investor;"
7. Subsequent amendment of articles twenty-five point 1 (25.1) and twenty-five point 3 (25.3) of the articles of asso-
ciation of the Company so that they shall henceforth read as follows:
" 25.1. The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of eight (8) voting members.
The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of
members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board."
" 25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification
towards the Company as follows:
a) four (4) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in
its sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.a r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.a r.l.
in its sole discretion; and
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion."
8. Decision to amend article 17 of the articles of association of the Company and article 22.8 of the articles of asso-
ciation of the Company.
9. Decision to amend and fully restate the articles of association of the Company.
10. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to convert the existing three thousand seven hundred fifty (3,750) series
B shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, into three thousand seven hundred fifty (3,750) series B1
shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, without cancellation of shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares referred to as series B2 shares
(hereinafter "Series B2 Shares") and to hence have eight (8) classes of shares in total.
78397
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated
and existing under the laws of the Cayman Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89
Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, as a new shareholder of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four
thousand six hundred and eighty-seven euro (EUR 4,687) so as to raise it from its current amount of twenty-eight thousand
seven hundred and fifty euro (EUR 28,750) up to thirty-three thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437)
by issuing four thousand six hundred and eighty-seven (4,687) Series B2 Shares.
<i>Subscriptioni>
Four thousand six hundred and eighty-seven (4,687) Series B2 Shares have been duly subscribed by Phenomen Ventures
LP, aforementioned, for the price of four thousand six hundred and eighty-seven euro (EUR 4,687).
<i>Paymenti>
The four thousand six hundred and eighty-seven (4,687) Series B2 Shares subscribed by the New Investor, aforemen-
tioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of four thousand six hundred and eighty-
seven euro (EUR 4,687).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of four thousand six hundred and eighty-seven euro (EUR 4,687) is entirely allocated
to the share capital.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledges that Phenomen Ventures LP has now become holder of the issued
four thousand six hundred and eighty-seven (4,687) Series B2 Shares.
As a consequence Phenomen Ventures LP, entitled to vote and here represented by Katia GAUZES, prenamed, by
virtue of the aforesaid proxy, joins the general meeting of shareholders for purpose of the following resolutions.
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the
Company so that it shall now henceforth read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-three thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437),
represented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common
Shares"), (ii) one hundred and eighty (180) series Ala shares (hereinafter "Series Ala Shares"), (iii) one thousand eight
hundred and seven (1,807) series Alb shares (hereinafter "Series Alb shares"), (iv) one hundred and nine (109) series Alc
shares (hereinafter "Series Alc Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one
thousand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand seven
hundred and fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series Bl Shares") and four thousand six hundred and eighty-seven
(4,687) series B2 shares (hereinafter the "Series B2 Shares" and, together with the Series B1 Shares, the "Series B Shares"),
with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.a r.l., (iv) Aismare Lux
Holdings S.a r.l. and (v) Phenomen Ventures LP shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be
issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder
nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act
(AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party Investment") -
irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up
to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which
the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European
Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. and (v) Phenomen Ventures LP shall inform the Company by binding
declaration within three (3) weeks if Rocket Internet GmbH and/or Kinnevik Online AB and/or Al European Holdings
S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP intends to exercise its right pursuant to the
foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes
for further shares in the Company."
78398
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article seven point four a (7.4a) of the articles of
association of the Company so that it shall now henceforth read as follows:
"a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. and (v) Phenomen Ventures LP
(Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l. and Phenomen
Ventures LP hereinafter jointly referred to as "Investors"; each individually an "Investor") to a company affiliated within
the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) to the respective Investor;"
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of articles twenty-five point 1 (25.1) and twenty-five
point three (25.3) of the articles of association of the Company so that they shall now henceforth read as follows:
25.1. The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of eight (8) voting members.
The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of
members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.
25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards
the Company as follows:
a) four (4) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in
its sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion;
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion.
<i>Eighth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 17 and article 22.8 of the articles of association
of the company so that they shall now henceforth read as follows:
« Art. 17. Decisions requiring specific majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent
of the Advisory Board:
a) disposition of all the Company's assets, of a significant part of the Company's assets or all or significant part of assets
of any direct or indirect subsidiary of the Company including the resolution with respect to the liquidation of the Company;
b) disposition of shares in direct or indirect subsidiaries of the Company, except for share transfers under the simplified
employee participation as agreed by the shareholders in any shareholders agreement;
c) amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to the
merger, separation and transformation of the Company;
d) appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits
to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
e) conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291 et seqq. of the
German Stock Corporation Act (AktG));
f) conclusion of company participations of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other
contractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of
the Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including
agreements concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners;
g) approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year and the annual accounts;
h) removal and appointment of managers.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the prior consent
of all of the Investors.
a) exclusion of subscription rights in case of capital increases;
b) acquisition of the Company's own shares, including redemption of shares with the exception of acquisitions in
accordance with article 9.2 and transfers in accordance with article 11.1 of these articles of association.
78399
L
U X E M B O U R G
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued shares of that class.
17.4 Any changes in the decision making process (including the competence of meetings of shareholders, Advisory
Board and any specific majority necessary for adoption of some of the decisions) of the Company to the unilateral
disadvantage of any of the Investors shall not be made without such Investor's consent. For the avoidance of doubt any
decrease of the number of votes or change of the voting rights of shareholders or directors necessary for adoption of
any decision will bring the unilateral disadvantage of the Investors.
17.5 Any of the following measures shall, irrespective of the consents or approvals otherwise required under any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company or
these articles, always require a % majority of the Investors: (i) sale of IP rights by the Company or any of its direct or
indirect subsidiaries; (ii) sale of a direct or indirect subsidiary by the Company."
" 22.8. The managers shall require the prior consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the
Company and its direct or indirect subsidiaries which are beyond the ordinary course of business of the Company, and
- in any case ¬for the legal transactions and measures of the Company and its direct or indirect subsidiaries specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders' meeting:
a) incorporation, acquisition or disposal of enterprises or partial-businesses;
b) amendment of articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise (or waiver)
of shareholders' rights in companies in which an interest is held directly or indirectly;
c) acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
d) material change to the nature of the business of the Company and the termination of any material business operation;
e) assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euro (EUR
200,000) in aggregate;
f) granting of loans in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate, excluding, however, such
loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
g) conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred
thousand euro (EUR 200,000) in aggregate and amendments to the credit framework, excluding, however, such agree-
ments between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
h) futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
i) granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
j) conclusion amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial impor-
tance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
k) institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than ten thousand euro (EUR 10,000) in the individual case;
l) disposition of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights including copyrights or any other
property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation by the enterprise and/or a third
party, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
m) business dealings of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be shareholders, affiliated companies, as well as relatives of direct or indirect shareholders as far as
the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to
this lit. (m) does not apply if the business dealing belongs to the ordinary course of business of the Company and is at
arm's length;
n) amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291
et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));
o) exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that
this exercise would require the consent of the shareholders' meeting under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this article 22.8 lit. a) to o), article 17.1 or 17.2.
Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the prior consent of the Advisory
Board."
<i>Ninth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
78400
L
U X E M B O U R G
"A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Emerging
Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-three thousand four hundred and thirty-seven euro (EUR 33,437),
represented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common
Shares"), (ii) one hundred and eighty (180) series Ala shares (hereinafter "Series A1a Shares"), (iii) one thousand eight
hundred and seven (1,807) series Alb shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series
A1c shares (hereinafter "Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"),
(vi) one thousand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand
seven hundred and fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1 Shares") and four thousand six hundred and eighty-
seven (4,687) series B2 shares (hereinafter the "Series B2 Shares" and, together with the Series B1 Shares, the "Series B
Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.a r.l., (iv) Aismare Lux
Holdings S.a r.l. and (v) Phenomen Ventures LP shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be
issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder
nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act
(AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party Investment") -
irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up
to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which
the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European
78401
L
U X E M B O U R G
Holdings S.a r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.a r.l. and (v) Phenomen Ventures LP shall, if applicable, inform the Company
by binding declaration within three (3) weeks if Rocket Internet GmbH and/or Kinnevik Online AB and/or Al European
Holdings S.a r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.a r.l. and/or Phenomen Ventures LP intends to exercise its right pursuant
to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors
subscribes for further shares in the Company.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions of
any shareholders agreement between the shareholders if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. and (v) Phenomen Ventures LP
(Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l. and Phenomen
Ventures LP hereinafter jointly referred to as "Investors"; each individually an "Investor") to a company affiliated within
the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) to the respective Investor;
b) in case of the transfer of shares of one Investor to a company or entity (x) which is directly or indirectly Controlling,
Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect shareholders of
the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or "Controlling" shall mean
the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a) managing the company as managing shareholder,
(b) holding the majority of shares, (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting pool, or (d)
the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person, whether
through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more share-
holders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
c) in case of a share transfer to a third party acquiring shares under the simplified employee participation, or by a
shareholder to the Company and/or any Investors pursuant to a call option under a vesting scheme.
7.5 To the extent a transfer of shares requires no additional consent of the shareholders' meeting pursuant to article
7.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or
drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a "Liquidity
78402
L
U X E M B O U R G
Event"), the proceeds ("Exit Proceeds") - subject to articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with
article 8.4 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level ("First Level") the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series B
Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company).
8.3 On a second level ("Second Level") the holders of Series Ala Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series
A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:
Share Class
Amount
per
Share
in Euro
Series A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,554.76
8.4 After the payments on the First Level and Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be
allocated on a third level (“Third Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be
allocated to such shareholder on the Third Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Third Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level and/or Second Level. The allocation
at Third Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or
not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation on the First Level and Second Level applies to each of the respective Series B Shares,
Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, S eries A2b Shares as long as on the respective
Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares the amount
stipulated in article 8.2 and/or in the table pursuant to article 8.3 has not yet been distributed once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
a) insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
b) the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the Law and the
Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer
in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
78403
L
U X E M B O U R G
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in Lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective decisions of the shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General meetings of shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
78404
L
U X E M B O U R G
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 16. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Decisions requiring specific majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent
of the Advisory Board:
a) disposition of all the Company's assets, of a significant part of the Company's assets or all or significant part of assets
of any direct or indirect subsidiary of the Company including the resolution with respect to the liquidation of the Company;
b) disposition of shares in direct or indirect subsidiaries of the Company, except for share transfers under the simplified
employee participation as agreed by the shareholders in any shareholders agreement;
c) amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to the
merger, separation and transformation of the Company;
d) appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits
to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
e) conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291 et seqq. of the
German Stock Corporation Act (AktG));
f) conclusion of company participations of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other
contractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of
the Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including
agreements concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners;
g) approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year and the annual accounts;
h) removal and appointment of managers.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the prior consent
of all of the Investors.
a) exclusion of subscription rights in case of capital increases;
b) acquisition of the Company's own shares, including redemption of shares with the exception of acquisitions in
accordance with article 9.2 and transfers in accordance with article 11.1 of these articles of association.
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued shares of that class.
17.4 Any changes in the decision making process (including the competence of meetings of shareholders, Advisory
Board and any specific majority necessary for adoption of some of the decisions) of the Company to the unilateral
disadvantage of any of the Investors shall not be made without such Investor's consent. For the avoidance of doubt any
decrease of the number of votes or change of the voting rights of shareholders or directors necessary for adoption of
any decision will bring the unilateral disadvantage of the Investors.
17.5 Any of the following measures shall, irrespective of the consents or approvals otherwise required under any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company or
these articles, always require a % majority of the Investors: (i) sale of IP rights by the Company or any of its direct or
indirect subsidiaries; (ii) sale of a direct or indirect subsidiary by the Company.
78405
L
U X E M B O U R G
D. Board of managers and Advisory board
Art. 18. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of office of managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, pursuant to
article 17.1 lit. g).
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the office of a manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening meetings of the board of managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
78406
L
U X E M B O U R G
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the prior consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the
Company and its direct or indirect subsidiaries which are beyond the ordinary course of business of the Company, and
- in any case -for the legal transactions and measures of the Company and its direct or indirect subsidiaries specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders' meeting:
a) incorporation, acquisition or disposal of enterprises or partial-businesses;
b) amendment of articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise (or waiver)
of shareholders' rights in companies in which an interest is held directly or indirectly;
c) acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
d) material change to the nature of the business of the Company and the termination of any material business operation;
e) assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euro (EUR
200,000) in aggregate;
f) granting of loans in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate, excluding, however, such
loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
g) conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred
thousand euro (EUR 200,000) in aggregate and amendments to the credit framework, excluding, however, such agree-
ments between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
h) futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
i) granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
j) conclusion amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial impor-
tance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
k) institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than ten thousand euro (EUR 10,000) in the individual case;
l) disposition of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights including copyrights or any other
property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation by the enterprise and/or a third
party, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
m) business dealings of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be shareholders, affiliated companies, as well as relatives of direct or indirect shareholders as far as
the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to
this lit. (m) does not apply if the business dealing belongs to the ordinary course of business of the Company and is at
arm's length;
n) amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291
et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));
o) exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that
this exercise would require the consent of the shareholders' meeting under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this article 22.8 lit. a) to o), article 17.1 or 17.2.
Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the prior consent of the Advisory
Board.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this article apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
78407
L
U X E M B O U R G
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of eight (8) voting members.
The shareholders' meeting may by way of unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of mem-
bers of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.
25.2 The shareholders' meeting shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of a
unanimous shareholders' resolution.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards
the Company as follows:
a) four (4) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in
its sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.á r.l.
in its sole discretion;
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.á r.l.
in its sole discretion; and
e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its
sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. One of the Rocket-Members shall be the
chairman of the Advisory Board and shall not have a casting vote. The rules of procedure of the Advisory Board shall
provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which the shareholders' meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these
articles of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iii) by way of shareholders' resolution or (iv) in any
shareholders' agreement.
25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the
Company by way of a unanimous shareholders' resolution.
25.7 In addition to the consent requirements provided for in article 22.8 and article 22.9, the Advisory Board has a
consultative function and will not interfere in the management of the Company.
E. Audit and Supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
78408
L
U X E M B O U R G
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual accounts and Allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders
and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these
articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter
partes and to the extent permitted by Luxembourg law.
These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and
the German text, the English version shall prevail."
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am dreißigsten Tag des Monats April;
78409
L
U X E M B O U R G
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstraße
20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket Internet"),
hier vertreten durch Katia GAUZES, Avocat ä la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom
29. April 2013, ausgestellt in Berlin (Deutschland), und
2. Kinnevik Online AB (vormals Kinnevik Online Ventures AB), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktiebolag)
nach schwedischem Recht, eingetragen im Gesellschaftsregister in Schweden (Bolagsverket), unter der Nummer
556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden („Kinnevik Online AB"),
hier vertreten durch Katia GAUZES, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 29. April 2013, ausgestellt in Stockholm
(Schweden), und
3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V"),
hier vertreten durch Katia GAUZÈS, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 29. April 2013, ausgestellt in Berlin
(Deutschland), und
4. AI European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
luxemburgischem Recht, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés), unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg („Al European
Holdings"),
hier vertreten durch Katia GAUZÈS, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 29. April 2013, ausgestellt in Luxemburg,
und
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
luxemburgischem Recht, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés), unter der Nummer B 176544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Lu-
xemburg („Aismare Lux Holdings S.à r.l."),
hier vertreten durch Katia GAUZÈS, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 26. April 2013, ausgestellt in Luxemburg,
und
6. Phenomen Ventures LP, eine exempted limited partnership nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), mit
der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands
(der „Neue Investor" oder „Phenomen"), der ausschließlich für Punkt 5 ff. teilnahme- und stimmberechtigt ist,
hier vertreten durch Katia GAUZÈS, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 29. April 2013, ausgestellt in London
(Vereinigtes Königreich).
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar
ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1 bis 5 (die „Bestehenden Gesellschafter") sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738, gegründet
am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim, veröf-
fentlicht am 22. April 2013 im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 956. Die Satzung der
Gesellschaft wurde zuletzt am 16. April 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz
in Luxemburg, abgeändert, und noch nicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei der Neue Investor ausschließlich für Punkt 5 ff. teilnahme- und stimmberechtigt
ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Umwandlung der bestehenden dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der Serie B
mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil in dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der Serie
B1 (die „Anteile der Serie B1"), mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
2. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, die als Anteile der Serie B2 bezeichnet
werden (die „Anteile der Serie B2"), wodurch nunmehr insgesamt acht (8) Anteilsklassen bestehen.
3. Annahme von Phenomen Ventures LP, einer exempted limited partnership nach dem Recht der Kaimaninseln, mit
der Eintragungsnummer OG -66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands
(„Phenomen Ventures LP") als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
78410
L
U X E M B O U R G
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtundzwanzigtausendsie-
benhundertfünfzig Euro (EUR 28.750) um einen Betrag von viertausendsechshundertsiebenundachtzig Euro (EUR 4.687)
auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendvierhundertsiebenunddreißig Euro (EUR 33.437) durch die Ausgabe von viert-
ausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteilen der Serie B2.
5. Anschließende Änderung von Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendvierhundertsiebenunddreißig Euro (EUR
33.437), aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii)
einhundertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807)
Anteile der Serie Alb (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie Alc (die „Anteile der Serie
Alc"), (v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsund-
fünfzig (1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b"), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile
der Serie B1 (die „Anteile der Serie Bl") und (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2
(die „Anteile der Serie B2" und gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 die „Anteile der Serie B") mit einem Nominalwert
von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (v) Phenomen Ventures LP ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne des Artikels
15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein "Drittinvestor") handelt), und der vom Beratenden Ausschuss zugestimmt
wurde (eine „Investition eines Dritten") -unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren
vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen
Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Rocket
Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (v)
Phenomen Ventures LP haben die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu
unterrichten, sofern Rocket Internet GmbH und/oder Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/
oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures LP ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses
Artikels 5.3 ausüben möchten. Für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser
Artikel 5.3 entsprechend anzuwenden."
6. Anschließende Änderung von Artikel sieben Punkt vier a (7.4 a) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und
(v) Phenomen Ventures LP (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l. und Phenomen Ventures LP im Folgenden gemeinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor")
an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktienge-
setzes (AM?);"
7. Anschließende Änderung der Artikel fünfundzwanzig Punkt eins (25.1) und fünfundzwanzig Punkt drei (25.3) der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lauten:
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus acht (8)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen."
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schrift-
liche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
78411
L
U X E M B O U R G
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures
LP nach eigenem Ermessen ernannt."
8. Beschluss bezüglich der Änderung von Artikel 17 und Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft.
9. Beschluss bezüglich der Änderung und gänzlichen Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
10. Verschiedenes.
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt die Umwandlung der bestehenden dreitausendsiebenhundert-
fünfzig (3.750) Anteile der Serie B mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil in dreitausendsiebenhun-
dertfünfzig (3.750) Anteile der Serie B1 mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, ohne Einziehung
von Anteilen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, die als Anteile
der Serie B2 bezeichnet werden (die „Anteile der Serie B2") und somit insgesamt acht (8) Anteilsklasen zu haben.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Phenomen Ventures LP, eine exempted limited partnership nach
dem Recht der Kaimaninseln, mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9007, Cayman Islands, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen
Betrag von achtundzwanzigtausend-siebenhundertfünfzig Euro (EUR 28.750) um einen Betrag von viertausendsechshun-
dertsiebenundachtzig Euro (EUR 4.687) auf einen Betrag von dreiunddreißigtausendvierhundertsiebenunddreißig Euro
(EUR 33.437) durch die Ausgabe von viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteilen der Serie B2 zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 wurden ordnungsgemäß vom Neuen Investor,
vorbenannt, zu einem Preis von viertausendsechshundertsiebenundachtzig Euro (EUR 4.687) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die vom Neuen Investor, vorbenannt, gezeichneten viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der
Serie B2 wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von viertausendsechshundertsiebenundachtzig Euro
(EUR 4.687).
Der Nachweis für die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von viertausendsechshundertsiebenundachtzig Euro (EUR 4.687) wird vollständig dem Gesell-
schaftskapital zugeführt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter erkennt an, dass Phenomen Ventures LP nun der Inhaber der ausgegebenen
viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 geworden ist.
Infolgedessen schließt sich Phenomen Ventures LP, stimmberechtigt und hier vertreten durch Katia GAUZES, vorge-
nannt, gemäß der vorgenannten Vollmacht, für die nachstehenden Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschafter
an.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendvierhundertsiebenunddreißig Euro (EUR
33.437), aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii)
einhundertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807)
Anteile der Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der
Serie Alc"), (v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsech-
sundfünfzig (1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b"), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750)
Anteile der Serie B1 (die „Anteile der Serie Bl") und (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der
Serie B2 (die „Anteile der Serie B2" und gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 die „Anteile der Serie B") mit einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
78412
L
U X E M B O U R G
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (v) Phenomen Ventures LP ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne des Artikels
15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein "Drittinvestor") handelt), und der vom Beratenden Ausschuss zugestimmt
wurde (eine „Investition eines Dritten") -unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren
vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen
Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Rocket
Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (v)
Phenomen Ventures LP haben die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu
unterrichten, sofern Rocket Internet GmbH und/oder Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/
oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures LP ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses
Artikels 5.3 ausüben möchten. Für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser
Artikel 5.3 entsprechend anzuwenden."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel sieben Punkt vier a (7.4 a) der Satzung der Gesellschaft
zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und
(v) Phenomen Ventures LP (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l. und Phenomen Ventures LP im Folgenden gemeinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor")
an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktienge-
setzes (AktG);"
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, die Artikel fünfundzwanzig Punkt eins (25.1) und fünfundzwanzig
Punkt drei (25.3) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welche nunmehr wie folgt lauten:
„25.1 Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus acht (8)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen."
„25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schrift-
liche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures
LP nach eigenem Ermessen ernannt."
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel 17 und Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft zu
ändern, welche nunmehr wie folgt lauten:
„ Art. 17. Beschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und die vorherige
Zustimmung des Beratenden Ausschusses:
a) Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens oder
des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Abwicklung der Gesellschaft;
b) Veräußerung von Anteilen in direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, mit Ausnahme von
Anteilsübertragungen unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung, wie von den Gesellschafter in einer Gesellschaf-
tervereinbarung vereinbart;
78413
L
U X E M B O U R G
c) Änderung dieser Satzung (einschließlich des vorliegenden Artikels 17) einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der
Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
d) Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher
Gewinne auf neue Konten: Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;
e) Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der Artikel 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
f) Abschluss von Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Gesellschaften und sämtlicher Verträge,
durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche
vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der
Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder An-
gestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge
zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;
g) Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr und des Jahresabschlusses;
h) Abberufung und Ernennung von Geschäftsführern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und die vorherige
Zustimmung aller Investoren:
a) Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
b) Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen mit Ausnahme der Erwerbe
gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Sofern das Gesellschaftskapital der Gesellschaft in unterschiedliche Anteilsklassen unterteilt ist, können die mit
jeder Klasse verbundenen speziellen Rechte und Pflichten mit der schriftlichen und einstimmigen Zustimmung der Ge-
sellschafter, welche die Gesamtheit der ausgegebenen Anteile dieser Klasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
17.4 Alle Änderungen im Beschlussfassungsprozess der Gesellschaft (einschließlich der Zuständigkeit der Gesellschaf-
terversammlungen, der Sitzungen des Beratenden Ausschusses und jeder notwendigen spezifischen Mehrheit zur Annah-
me einiger Beschlüsse) zum einseitigen Nachteil eines Investors sind nicht ohne Zustimmung dieses Investors
vorzunehmen. Zum Ausschluss von Zweifeln besteht ein einseitiger Nachteil der Investoren bei einer Herabsetzung der
Stimmanzahl oder bei einer Änderung der Stimmrechte von Gesellschaftern oder Direktoren, die zur Annahme eines
Beschlusses erforderlich sind.
17.5 Bei jeder der folgenden Handlungen bedarf es, unabhängig anderer Bestimmungen bezüglich der Zustimmung oder
der Annahme in anderen Gesellschaftervereinbarungen, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft
eingehen, oder dieser Satzung immer einer Dreiviertel-Mehrheit der Investoren:
(i) Veräußerung von Rechten geistigen Eigentums durch die Gesellschaft oder durch eine direkte oder indirekte Toch-
tergesellschaft der Gesellschaft;
(ii) Veräußerung einer direkten oder indirekten Tochtergesellschaft durch die Gesellschaft."
„22.8 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft und deren direkten oder indirekten
Tochtergesellschaften liegen, und - in jedem Fall - für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesell-
schaft und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert wurden und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung genehmigt wurden:
a) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen oder Teil-Gesellschaften;
b) Änderung der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Ausübung (oder der Aus-
schluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, mit denen ein direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis
besteht;
c) Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
d) Wesentliche Änderungen der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Einstellung eines wesentlichen Ge-
schäftsbetriebs;
e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihun-
derttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;
f) Gewährung von Darlehen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten,
unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft;
g) Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die einen Gesamtbetrag
von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, unter Ausschluss von
Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
h) Künftige Transaktionen bezüglich Devisen, Sicherheiten und börsengehandelten Gütern und Rechten sowie weitere
Transaktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
i) Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
78414
L
U X E M B O U R G
j) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher
Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
k) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert
von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;
l) Verfügung über Nutzungsrechte jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urhe-
berrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Weitergabe von Know-how zur eigenen Verwertung durch
die Firma und/oder Drittparteien, unter Ausschluss von Bestimmungen zwischen der Gesellschaft und direkten und in-
direkten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
m) Geschäfte der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen Personen und Einzelpersonen. Als
Gesellschafter werden verbundene Gesellschaften sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter angesehen,
sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmungsver-
pflichtung gemäß des vorliegenden Punktes m) ist nicht anwendbar, wenn das Geschäft zum gewöhnlichen Geschäftsgang
der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
n) Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der Artikel 291 ff. des deutschen Aktienge-
setzes (AktG));
o) Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter
ist, sofern diese Ausübung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß
dieses Artikels 22.8, a) bis o), Artikel 17.1 oder 17.2.
Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Beratenden Ausschusses."
<i>Neunter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die Änderung und
gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und ihr zur
Erreichung dieser Zwecke, im Hinblick auf die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, förderlich
erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst
werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form
gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
78415
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiunddreißigtausendvierhundertsiebenunddreißig Euro (EUR
33.437), aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii)
einhundertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie Ala"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807)
Anteile der Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der
Serie Alc"), (v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsech-
sundfünfzig (1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b"), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750)
Anteile der Serie B1 (die „Anteile der Serie Bl") und (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der
Serie B2 (die „Anteile der Serie B2" und gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1 die „Anteile der Serie B") mit einem
Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (v) Phenomen Ventures LP ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne des Artikels
15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein "Drittinvestor") handelt), und der vom Beratenden Ausschuss zugestimmt
wurde (eine „Investition eines Dritten") -unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren
vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen
Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Rocket
Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (v)
Phenomen Ventures LP haben die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu
unterrichten, sofern Rocket Internet GmbH und/oder Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/
oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures LP ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses
Artikels 5.3 ausüben möchten. Für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser
Artikel 5.3 entsprechend anzuwenden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nennwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann als Gegenleistung Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit") und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten-oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
78416
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine zusätzliche Einwilligung zur
Übertragung der Anteile nicht erforderlich:
a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und
(v) Phenomen Ventures LP (Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux
Holdings S.à r.l. und Phenomen Ventures LP im Folgenden gemeinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor")
an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktienge-
setzes (AktG);
b) bei der Übertragung von Anteilen eines Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welches direkt
oder indirekt über (i) einen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des Investors
herrscht, von diesem abhängig ist, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht (jeweils eine „Kontrollierte
Gesellschaft"), wobei die Worte „Kontrolle" oder „Abhängig" oder „Herrscht" die direkte oder indirekte Kontrolle der
Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) das
Halten der Mehrheit der Anteile, (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinba-
rung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, die Richtung der Geschäftsleitung und Geschäftspolitik einer Person, entweder
durch den Besitz von Wertpapieren oder anderweitig zu bewirken oder (y) in welcher der Investor oder einer oder
mehrere Gesellschafter des Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
c) bei einer Übertragung von Anteilen an einen Dritten, welcher Anteile unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbe-
teiligung erwirbt, oder von einem Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer
Kaufoption im Rahmen eines Übertragungssystems.
7.5 Sofern eine Übertragung von Anteilen gemäß Artikel 7.4 keiner weiteren Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung bedarf, gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitver-
kaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn die Zustimmung zu einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit (unter Ausschluss der Anteile des
verstorbenen Gesellschafters), erteilt wurde. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern,
Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Ge-
sellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehrerer Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis" bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse") - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel
8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR 1.600
pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend
aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderer Ka-
pitaleinlagen (Punkt 115 des Luxemburger Standard¬Kontenrahmens), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter
gezahlt wurden).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie
A1b, Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteils-
klasse (und zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der
entsprechenden Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro
Anteil
in Euro
Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.554,76
78417
L
U X E M B O U R G
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer dritten Ebene („ Dritte Ebene") an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung
am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen
Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Dritten Ebene und werden anschließend
entsprechend dieser Dritten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der
Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Dritten Ebene erfolgt solange,
bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines
Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für
den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zu-
rückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu
den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem
Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der
hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene ist auf alle entsprechenden Anteile der Serie
B, Anteile der Serie A1a, Anteile der Serie A1b, Anteile der Serie A1c, Anteile der Serie A2a und Anteile der Serie A2b
anwendbar, solange bei den jeweiligen Anteilen der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b, Anteilen der
Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b der in Artikel 8.2 und/oder der in der Tabelle in Artikel
8.3 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte jeder der von der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile werden aufgehoben, solange sie von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
a) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens aus Mangel an Vermögen abgelehnt wird;
b) ein Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil ein-
geleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Nach Erhalt der Rückkaufserklärung gesendet bei dem Geschäftsführungsrates durch diesen Gesellschafter werden
die Anteile automatisch zurückgekauft, wobei es keiner weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt ge-
meinsam mit der Rückkaufserklärung ein gültiges Schriftstück im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und
die Gesellschaft erkennt an und akzeptiert hiermit in einem solchen Fall die Übertragung der Anteile und verpflichtet sich
zur Eintragung der Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Hinter-
legung.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf im Bezug auf
eine Person ausreichend; unabhängig davon können die gemeinsam berechtigten Personen die Gesellschafterrechte nur
dann einheitlich ausüben, wenn eine dieser Personen zu diesem Zweck unverzüglich nach Aufkommen des gemeinsamen
Anteilsrechts ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Geschäftsführungsrat erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Tag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Tribunal d'Arrondissement bestimmt. Die Entscheidung des
Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem ersuchenden Ge-
sellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der von diesem Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rückkaufspreis
verrechnet und dieser entsprechend herabgesetzt wird. Sofern die vom Gesellschafter zu tragenden Kosten für das
Gutachten nicht vom Rückkaufspreis gedeckt werden, gehen die restlichen Kosten zu Lasten des Gesellschafters.
78418
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung des Anteils an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst wer-
den. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht
wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses
Verfahren gegenüber dem Geschäftsführungsrat der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein
Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehm-
enden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen
und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form
gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter nach den
Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Hauptversammlung der Gesellschafter" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zu-
sammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter werden
vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 13. Hauptversammlung der Gesellschafter.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der entsprechenden Einladung
genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Hauptversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4) Wochen
und bei außerordentlichen Hauptversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wochen einzuhalten
ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der
Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und auf
Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung begleitet oder von einem anderen
durch eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter, oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer unter der Berufsverschwiegenheitspflicht vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
78419
L
U X E M B O U R G
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 17. Beschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und die vorherige
Zustimmung des Beratenden Ausschusses:
a) Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens oder
des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Abwicklung der Gesellschaft;
b) Veräußerung von Anteilen in direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, mit Ausnahme von
Anteilsübertragungen unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung, wie von den Gesellschafter in einer Gesellschaf-
tervereinbarung vereinbart;
c) Änderung dieser Satzung (einschließlich des vorliegenden Artikels 17) einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der
Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
d) Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher
Gewinne auf neue Konten: Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;
e) Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der Artikel 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
f) Abschluss von Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Gesellschaften und sämtlicher Verträge,
durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche
vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der
Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder An-
gestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge
zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;
g) Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr und des Jahresabschlusses;
h) Abberufung und Ernennung von Geschäftsführern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und die vorherige
Zustimmung aller Investoren:
a) Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
b) Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen mit Ausnahme der Erwerbe
gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Sofern das Gesellschaftskapital der Gesellschaft in unterschiedliche Anteilsklassen unterteilt ist, können die mit
jeder Klasse verbundenen speziellen Rechte und Pflichten mit der schriftlichen und einstimmigen Zustimmung der Ge-
sellschafter, welche die Gesamtheit der ausgegebenen Anteile dieser Klasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
17.4 Alle Änderungen im Beschlussfassungsprozess der Gesellschaft (einschließlich der Zuständigkeit der Gesellschaf-
terversammlungen, der Sitzungen des Beratenden Ausschusses und jeder notwendigen spezifischen Mehrheit zur Annah-
me einiger Beschlüsse) zum einseitigen Nachteil eines Investors sind nicht ohne Zustimmung dieses Investors
vorzunehmen. Zum Ausschluss von Zweifeln besteht ein einseitiger Nachteil der Investoren bei einer Herabsetzung der
Stimmanzahl oder bei einer Änderung der Stimmrechte von Gesellschaftern oder Direktoren, die zur Annahme eines
Beschlusses erforderlich sind.
17.5 Bei jeder der folgenden Handlungen bedarf es, unabhängig anderer Bestimmungen bezüglich der Zustimmung oder
der Annahme in anderen Gesellschaftervereinbarungen, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft
eingehen, oder dieser Satzung immer einer Dreiviertel-Mehrheit der Investoren: (i) Veräußerung von Rechten geistigen
Eigentums durch die Gesellschaft oder durch eine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft; (ii) Ver-
äußerung einer direkten oder indirekten Tochtergesellschaft durch die Gesellschaft.
D. Geschäftsführungsrat und Beratender Ausschuss
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
78420
L
U X E M B O U R G
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als
Verweis auf den alleinigen Geschäftsführer auszulegen.
18.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehaltenen
Handlungen.
Art. 19. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche ihre
Bezüge und Amtszeit festlegt.
19.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund gemäß Artikel 17.1 g) gewählt oder abberufen werden.
19.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-
schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten werden und die Geschäftsführer sind der Kategorie zuzuordnen, der sie angehören.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Hauptversammlung der Gesellschafter neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
21.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Geschäftsfüh-
rungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsfüh-
rungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt haben und sie unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder ein anderes ver-
gleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis
dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
22.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
78421
L
U X E M B O U R G
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Geschäftsführungsrats nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können
ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft und deren direkten oder indirekten
Tochtergesellschaften liegen, und - in jedem Fall - für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesell-
schaft und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert wurden und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung genehmigt wurden:
a) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen oder Teil¬Gesellschaften;
b) Änderung der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Ausübung (oder der Aus-
schluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, mit denen ein direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis
besteht;
c) Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
d) Wesentliche Änderungen der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Einstellung eines wesentlichen Ge-
schäftsbetriebs;
e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihun-
derttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;
f) Gewährung von Darlehen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten,
unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft;
g) Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die einen Gesamtbetrag
von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, unter Ausschluss von
Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
h) Künftige Transaktionen bezüglich Devisen, Sicherheiten und börsengehandelten Gütern und Rechten sowie weitere
Transaktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
i) Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
j) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher
Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
k) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert
von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;
l) Verfügung über Nutzungsrechte jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urhe-
berrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Weitergabe von Know-how zur eigenen Verwertung durch
die Firma und/oder Drittparteien, unter Ausschluss von Bestimmungen zwischen der Gesellschaft und direkten und in-
direkten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
m) Geschäfte der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen Personen und Einzelpersonen. Als
Gesellschafter werden verbundene Gesellschaften sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter angesehen,
sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmungsver-
pflichtung gemäß des vorliegenden Punktes m) ist nicht anwendbar, wenn das Geschäft zum gewöhnlichen Geschäftsgang
der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
n) Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der Artikel 291 ff. des deutschen Aktienge-
setzes (AktG));
o) Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter
ist, sofern diese Ausübung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß
dieses Artikels 22.8, a) bis o), Artikel 17.1 oder 17.2.
Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Beratenden Ausschusses.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf und zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beratenden Ausschusses erfordern. Der Beratende Ausschuss kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten
von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für Geschäftsführer be-
schließen.
78422
L
U X E M B O U R G
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels, soweit gesetzlich möglich, auf
die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt oder
indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäfts-
führers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls
vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vor-
handen), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), durch gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführer der Kategorie A (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), durch gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und
eines (1) Geschäftsführer der Kategorie A (oder deren Vertreter).
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, wirksam verpflichtet;
sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich
Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 25. Beratender Ausschuss.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus acht (8)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung des Beratenden Ausschusses nur durch einen ein-
stimmigen Gesellschafterbeschluss genehmigen oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schriftliche
Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures
LP nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beratende Ausschuss hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Eines der Rocket-
Mitglieder ist der Vorsitzende des Beratenden Ausschusses und hat nicht die entscheidende Stimme. Die Geschäftsord-
nung des Beratenden Ausschusses hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des
Beratenden Ausschusses, zu enthalten.
25.5 Der Beratende Ausschuss ist zuständig für die Erteilung von Zustimmungen zu Transaktionen und Maßnahmen
der Geschäftsführer, die die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beratenden Ausschusses ent-
weder (i) in dieser Satzung, (ii) in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss
oder (iv) in jedweder Gesellschaftervereinbarung erteilt hat.
25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beratenden Ausschusses wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der
Gesellschaft durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.
25.7 Neben den in den Artikeln 22.8 und 22.9 vorgesehenen Zustimmungserfordernissen hat der Beratende Ausschuss
eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
78423
L
U X E M B O U R G
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Hauptversammlung der Ge-
sellschafter ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen
werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachten Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Gesellschafter im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung wie der verbleibende Jahresnettogewinns der Ge-
sellschaft verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt und
darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht
durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste
oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt
werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Ver-
mögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der
Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel
dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaf-
tervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach Luxemburger Recht zulässig, maßgebend.
78424
L
U X E M B O U R G
Die vorliegende Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend."
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten
erschienen und ordnungsgemäß vertretenen Parteien, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde,
gefolgt von einer deutschen Fassung. Gemäß dem Wunsch derselben erschienen Parteien und im Falle von Abweichungen
zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor
erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: K. GAUZÈS, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2013. LAC/2013/20301. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 17 mai 2013.
Référence de publication: 2013066912/1663.
(130082713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.
Solix Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.239.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 173.548.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2013.
Référence de publication: 2013065692/11.
(130080638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2013.
ETT, Echternacher Tourismus Tage, Association sans but lucratif.
Siège social: L-6486 Echternach, 2, Porte Saint Willibrord.
R.C.S. Luxembourg F 9.554.
STATUTS
<i>Préambulei>
L'Office du tourisme (cl-après nommé «Echternach Tourist Office» ou «Tourist Office») d'Echternach est la repré-
sentation officielle du tourisme de la ville d'Echternach. Il a pour mission de prendre des initiatives en vue de la promotion
et du développement du tourisme; d'assumer les missions d'accueil et d'information des touristes; de s'investir en colla-
boration avec les partenaires publics et autres dans l'embellissement afin de mettre en valeur le patrimoine touristique
et naturel de la ville d'Echternach; de promouvoir, d'organiser et de coordonner des manifestations et toutes les activités
sociales, culturelles ou généralement quelconques s'y rattachant; de favoriser une entente entre les associations, clubs et
autres intervenants afin de promouvoir le tourisme, la vie sociale et l'attractivité de la ville d'Echternach en général;
d'initier et d'organiser des événements afin de promouvoir l'intérêt et l'identification de la population locale au regard
de leur patrimoine historique, culturel et touristique.
L'Office Régional du Tourisme de la Région Mullerthal - Petite Suisse Luxembourgeoise (ci-après nommé «ORT») est
la représentation officielle de la région Mullerthal. L'ORT est responsable de la réalisation des intérêts du ministère du
tourisme dans la région et du développement touristique et de la promotion de la Région Mullerthal - Petite Suisse
Luxembourgeoise, du développement des concepts touristiques régionaux, de la coordination des mesures des acteurs
régionaux, du développement des produits touristiques régionaux ainsi que des concepts touristiques événementiels, du
renforcement du marketing touristique régional, de la protection et de la préservation du patrimoine de la nature, de la
78425
L
U X E M B O U R G
culture et de l'histoire de la région, de la coopération étroite avec les acteurs touristiques officiels et privés aux niveaux
national et régional, de la coopération transfrontalière avec les organisations de la région voisine en vue de la conception
des offres communes ainsi que la promotion. De plus l'ORT est l'Interlocuteur et le conseiller des acteurs professionnels
et bénévoles.
Créé en 2008, le TRIFOLION Echternach (ci-après nommé «le Trlfolion») est un lieu de rencontre prestigieux aux
plans local, régional, national et transfrontalier destiné à des événements culturels, des congrès et des manifestations
sociétales. Le Trifolion dispose d'une salle de concert exceptionnelle accueillant jusqu' à 700 visiteurs avec un équipement
technique hautement sophistiqué et adapté à l'encadrement d'événements ainsi que des salles de réunions jusqu'à 300
visiteurs, des salles de traductions ou de gastronomie. Son rayon d'action et ses visiteurs se recrutent aux niveaux local,
régional, national et international. Dans le cadre de sa promotion la mission supplémentaires du Trifolion consiste éga-
lement dans la promotion de l'offre de son environnement et de l'attractivité de l'ensemble de l'Echternach et la Région
Mullerthal - Petite Suisse Luxembourgeoise en leur qualité de destination pour la culture, le congrès et la nature et de
promouvoir par conséquent en même temps l'offre touristique par la mise en place et la combinaison d'activités touris-
tiques attrayantes déterminées avec des manifestations («packages») en collaboration avec les partenaires touristiques
afin d'encourager le développement économique de la Ville d'Echternach.
L'an deux mille treize, le 8 mai
Entre les personnes, membres fondateurs, désignées ci-après:
1. Le Tourist Office asbl, association sans but lucratif de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à
Syndicat d'Initiative et de Tourisme Echternach asbl, 9-10, parvis de la basilique, L-6456 Echternach représenté par son
président Raymond Becker
2. L'Office Régional du Tourisme de la Région Mullerthal - Petite Suisse Luxembourgeoise asbl, association sans but
lucratif de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 10, rue Hoovelecker Buurchmauer, L-6418 Echternach,
représenté par son président Marc Diederich ou sa gestionnaire Sandra Bertholet (avec le droit mutuel de substitution)
3. Le Trifolion Echternach asbl, association sans but lucratif de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
à 2, Porte St. Willibrord, L-6486 Echternach représenté par son directeur Ralf Britten
Ainsi que tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il a été constitué une association sans but lucratif,
régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que
modifiée.
Titre I
er
. Création et Dénomination
Art. 1
er
. Il est constitué une association sans but lucratif de droit luxembourgeois qui prend le nom de «Echternacher
Tourismus Tage» en abréviation ETT. Elle peut également agir sous les dénominations française «Les Journées du tourisme
d'Echternach» et anglaise «The Echternach Tourism Days» ci-après dénommée «l'association».
Art. 2. L'association a une vocation locale, régionale, nationale et internationale.
Titre II. Siège et Durée
Art. 3. Le siège social de l'association est situé au Trifolion Echternach - Centre Culturel et de Congrès, 2, porte Saint-
Willibrord, L-6486 à Echternach.
L'adresse de ce siège ne peut être modifiée que par une décision de l'Assemblée générale des membres conformément
à la procédure légalement prévue en cas de modification statutaire.
L'association est constituée pour une durée indéterminée.
Titre III. Objet de l'association
Art. 4.
(1) L'objet de l'association est l'organisation de congrès, de séminaires et de conférences ayant comme thème principal
le tourisme (ci-après nommé le «projet» ou les «manifestations»).
(2) L'association poursuit les objectifs suivants:
a. L'ascension du Trifolion Echternach, de la Ville d'Echternach et de la région
aa. en tant que lieu et destination de congrès, de conférences et de séminaires, bb. en tant que centre d'excellence
aux niveaux régional, national et transfrontalier pour la formation professionnelle des acteurs touristiques, bénévoles et
professionnels,
cc. en tant qu'un centre de réflexion («think tank») sur la mise en place de stratégies et de concepts ciblés sur la
promotion et le développement local, régional et transfrontalier du tourisme.
b. la création de synergies avec les acteurs du tourisme du secteur privé et public (l'hôtellerie, la gastronomie, les
parties prenantes) ainsi que de l'économie,
c. l'encouragement et le développement de l'économie de la Ville d'Echternach et de la région du Mullerthal- Petite
Suisse Luxembourgeoise
(3) Le planning d'un projet commence une année à l'avance par
78426
L
U X E M B O U R G
(a) la définition et l'élaboration d'une question et d'un sujet ciblé autour du tourisme, sujet d'actualité et pertinent
pour le développement du tourisme et ses liens avec le développement urbain et régional et
(b) la conception et la mise en oeuvre de la thématique choisie
(aa.) sous forme d'un congrès, d'un symposium avec des conférenciers compétents et éminents,
(bb.) encadrée par une offre de séminaires de perfectionnement, d'une formation continue, par la mise en place d'ate-
liers ou de workshops traitant des sujets du secteur du tourisme et s'adressant aux acteurs professionnels et bénévoles
du tourisme et organisée en collaboration avec des organisations de séminaires professionnels spécialisés,
(c) l'élaboration parallèle d'un programme-cadre approprié s'adressant à la population epternacienne et régionale.
(4) L'association poursuit également à moyen terme les objectifs supplémentaires suivants:
(aa.) la création d'un modèle et d'une ligne directrice et de synergie basée autour du tourisme de la Ville d'Echternach
(bb.) l'amélioration de la notoriété de la Ville d'Echternach et de la Région Mullerthal - Petite Suisse Luxembourgeoise
aux niveaux nationaux et International et l'ascension de la ville au rang des destinations touristiques principales du Grand-
Duché,
(ce.) la sensibilisation de la population locale et régionale de la Ville d'Echternach et de la Région Mullerthal - Petite
Suisse Luxembourgeoise, des acteurs bénévoles et professionnels du tourisme et les organisations du tourisme avec
l'importance du tourisme au coeur du développement de l'économie communale et régionale.
(5) Le projet ou la manifestation choisi aura lieu annuellement ou tous les deux ans et ceci en principe au courant du
quatrième trimestre de l'année. La durée du projet ou des manifestations s'étend chaque année sur un ou plusieurs jours.
Le lieu du projet ou des manifestations est le Trifolion Echternach -Centre Culturel et de Congrès.
(6) Afin d'assurer la réalisation des objectifs fixés, toutes les activités sont vérifiées et mesurées conformément aux
paramètres définis ci-dessus et adaptées selon les nécessités.
(7) Tous changements ou détails devront faire l'objet d'un écrit. Les détails obligatoires sont un dossier comprenant
a. les considérations stratégiques pour le choix du sujet
b. une description détaillée du projet, des mesures liées à sa réalisation, du déroulement précis et de la durée de celui-
ci,
c. un budget et un plan ferme et précis du financement du projet traitant également de la question des ressources
financières et des partenaires possibles,
d. un timing ferme et précis.
(8) L'association peut par ailleurs développer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la
réalisation des buts non lucratifs précités, en ce compris, dans les limites autorisées par la loi, des activités commerciales
et lucratives accessoires, dont le produit sera de tout temps affecté intégralement à la réalisation desdits buts non lucratifs.
Art. 5. L'association oeuvre dans une stricte neutralité sur le plan politique, philosophique et confessionnel.
Titre IV. Organisation et Fonctionnement
Les membres
Art. 6. Le nombre des membres de l'association n'est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Les premiers membres
sont les fondateurs soussignés.
Art. 7. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d'administration sous ré-
serve de ratification expresse ou tacite par l'assemblée générale.
Art. 8.
(1) La qualité de membre de l'association se perd par démission écrite adressée par courrier recommandé au conseil
d'administration ou par exclusion.
(2) Le conseil d'administration, statuant à la majorité absolue des voix, peut proposer à l'assemblée générale l'exclusion
de tout membre actif qui, par son fait ou sa faute, porte gravement atteinte aux intérêts ou à l'honneur de l'association
ou qui ne verse pas à l'association les sommes dont il est redevable dans les 60 jours suivant réception d'un avis écrit
signé du trésorier.
(3) Le membre faisant l'objet d'une proposition d'exclusion sera préalablement entendu par le conseil d'administration.
(4) Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des
cotisations qu'il a versées.
Cotisations
Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres actifs est fixée par l'assemblée générale. Le montant maximum de la
cotisation est de 50 €, index 100.
78427
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale
Art. 10.
(1) L'assemblée est composée de tous les membres de l'association. Elle est convoquée par le conseil d'administration
au moins une fols par an et chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le
demandent par écrit.
(2) L'assemblée générale ordinaire a lieu au cours du premier semestre de chaque année.
(3) Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales.
(4) Les convocations indiquant la date, l'heure et les lieux auxquels se tiendra l'assemblée générale seront envoyées
par lettre au moins huit jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale.
(5) L'ordre du jour doit être joint aux convocations. Aucune résolution ne pourra être prise en dehors des points
figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les membres l'autorisent.
Art. 11. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire notamment pour les objets suivants:
(1) Modification des statuts
(2) Nomination et révocation des membres du conseil d'administration
(3) Approbation du budget et des comptes
(4) Fixation des cotisations annuelles
(5) Décharge à donner au conseil d'administration
(6) Nomination des commissaires aux comptes
(7) Décharge aux commissaires aux comptes
(8) Autorisation des transactions immobilières dans les limites de l'article 15 de la loi du 21 avril 1928 sur les asso-
ciations et les fondations sans but lucratif;
(9) Autorisation des contrats d'emprunt et d'ouverture de crédit
(10) Recours sur les décisions d'exclusion de membres actifs
(11) Dissolution de l'association
Art. 12.
(1) Tous les membres ont un droit de vote égal au sein de l'assemblée générale. L'assemblée ne pourra valablement
délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
(2) Tout membre peut se faire représenter par un mandataire, porteur d'une procuration écrite. Chaque membre ne
peut être titulaire que d'une procuration.
(3) Sous réserve de l'article 13 (2) ci-dessous, si la majorité des membres ne sont pas présents ou représentés à la
première réunion, ils seront convoqués pour une seconde réunion qui délibérera quel que soit le nombre des membres
présents.
(4) Les résolutions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents, sous réserve des points
où la loi ou les statuts prévoient une majorité spéciale. L'exclusion d'un membre ne peut être décidée qu'à la majorité
des deux tiers des voix des membres de l'association.
(5) Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées par le secrétaire dans un rapport qui sera déposé au siège
de l'association où tous les membres et les tiers justifiant d'un intérêt pourront en prendre connaissance.
Art. 13.
(1) Toute modification aux statuts devra être publiée dans le délai légal au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
(2) Les règles applicables à la modification des statuts sont celles prévues par les articles 8 et 20 de la loi du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée.
Le conseil d'administration
Art. 14.
(1) L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de cinq membre au
maximum, élus par l'assemblée générale.
(2) A l'exception de la première désignation qui se fera par l'Assemblée Constituante, le conseil d'administration
désigne parmi ses membres un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire.
(3) Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
(4) En cas de nomination d'une personne morale, celle-ci ne peut accepter cette fonction qu'à condition que les
fonctions d'administrateurs ne soient pas incompatibles avec son propre but et objet social.
(5) Les administrateurs personnes morales sont également tenus de désigner un représentant permanent. Ce mandat
de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente; il doit être
renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
78428
L
U X E M B O U R G
(6) Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à l'association,
sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent; il en
est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
Art. 15. Le conseil d'administration peut s'adjoindre un ou plusieurs conseillers avec voix consultative, rémunérés ou
non.
Art. 16.
(1) Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
(2) Les administrateurs sont élus au premier tour à la majorité absolue des votants, au second tour, à la majorité
relative. En cas d'égalité de suffrage au second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
(3) En cas de vacance survenant au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, il est procédé, jusqu'au renouvel-
lement périodique, à une cooptation par les membres du conseil d'administration. Toute cooptation doit être confirmée
lors de l'assemblée générale suivante.
Art. 17.
(1) Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président. En son absence, elles sont présidées par
un des vice-présidents ou, en l'absence de ces derniers, par l'administrateur le plus âgé.
(2) Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président ou à la demande
du tiers de ses membres.
(3) Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés,
le mandat entre administrateurs, qui doit être donné par écrit, étant admis. Un administrateur présent peut représenter
au plus un seul de ses collègues.
(4) Sauf stipulation spéciale de la loi ou des présents statuts, les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité simple des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité des voix.
Art. 18.
(1) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association et faire ou
autoriser tous les actes et opérations, autres que ceux réservés à l'assemblée générale. Il a notamment pour rôle de:
a. représenter l'association vis-à-vis des tiers;
b. convoquer l'assemblée générale annuelle;
c. dresser le rapport annuel d'activités et le budget à soumettre à l'assemblée générale;
d. veiller à la bonne exécution des décisions de l'assemblée générale;
e. recruter le personnel nécessaire au fonctionnement de l'association;
f. ratifier les conventions avec les divers partenaires dans le cadre des objectifs de l'association.
(2) Il peut également, sans que cette énumératlon soit limitative et sans préjudice de tous autres pouvoirs dérivant de
la loi ou des statuts, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, conférer tous pouvoirs à des mandataires de
son choix, membres ou non, représenter l'association en justice, tant en défendant qu'en demandant.
Art. 19. Le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'association à l'un de ses membres
ou à un tiers, membre ou non.
Art. 20. L'Association est valablement engagée envers des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs
dont le président ou les vice-présidents, ou le trésorier, ou le secrétaire qui n'auront pas à justifier d'une délibération
préalable du conseil d'administration.
Art. 21. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont
responsables que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.
Art. 22.
(1) Le président prépare les propositions soumises pour approbation au conseil d'administration. Il peut recevoir une
délégation de pouvoir spécial par le conseil d'administration, respectivement par l'assemblée générale. Cette délégation
de pouvoir peut être retirée à tout moment.
(2) Le président, ayant reçu mandat de représenter l'association à l'égard des tiers, signera conjointement avec un
membre du conseil d'administration notamment les conventions nécessaires à la bonne gestion du centre.
(3) Les virements bancaires et les mandats de paiement sont à signer conjointement par le trésorier et un deuxième
membre du conseil d'administration.
(4) Le président est pareillement chargé de préparer le rapport d'activités annuel et en collaboration avec le trésorier
le budget soumis au conseil d'administration.
78429
L
U X E M B O U R G
Titre V. Règlement Interne
Art. 23.
(1) Les modalités détaillées de la gestion de l'association figurent dans un règlement interne qui est à la disposition de
tous les membres.
(2) Le règlement ainsi que toute modification subséquente sont approuvés par l'assemblée générale sur proposition
du conseil d'administration.
(3) Le premier règlement interne sera soumis à l'approbation de la première assemblée générale convoquée par le
conseil d'administration.
Titre VI. Dispositions financières et Comptables
Art. 24.
(1) L'assemblée générale désigne annuellement deux commissaires aux comptes qui ne peuvent être membres du
conseil d'administration. Ils ont pour mission de contrôler la comptabilité de l'association et de présenter un rapport
afférent à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice.
(2) Le conseil d'administration doit mettre à la disposition des commissaires aux comptes, à chaque fois qu'ils le
réclament et au moins trois semaines avant la tenue de l'assemblée générale à laquelle ils doivent présenter leur rapport,
tous les documents relatifs à la comptabilité et à la trésorerie de l'association. De même, il doit fournir aux commissaires
toutes explications que ceux-ci pourraient demander dans l'exercice de leurs fonctions. Au cas où un commissaire aux
comptes est empêché d'accomplir sa mission, il en informera le conseil d'administration, lequel procédera à la nomination
d'un remplaçant à choisir sur la liste des experts comptables agréés au Luxembourg.
(3) Les comptes de l'exercice sont soumis pour approbation à l'assemblée générale, laquelle est également appelée à
donner décharge au conseil d'administration après avoir entendu son rapport ainsi que les rapports des commissaires
aux comptes.
Art. 25. L'année comptable commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier
exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de l'association jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 26.
(1) En vue de financer ses activités et sous le respect des dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée, l'association peut obtenir le soutien financier du
secteur privé et public, à savoir:
a. les cotisations annuelles des membres mentionnées à l'article 9 ci-dessus
b. des Contributions supplémentaires des associés
c. le chiffre d'affaires généré par le projet (p.ex. prix d'entrées, frais de participation etc.)
d. les cotisations du cercle d'amis de l'association
e. des provisions de la gastronomie, des entreprises du secteur du tourisme, de loisir, du commerce etc.
f. des donations
g. des subsides notamment de la Ville d'Echternach, du ministère du tourisme, de l'Union Européenne relatives aux
projets
h. en cas de coopérations transfrontaliers des subsides des communes voisines
i. des fonds générés par des partenariats avec le secteur privé
j. les recettes propres provenant des activités rentrant dans l'objet social et de ses activités complémentaires;
k. les emprunts;
I. les dons et des legs;
m. les subventions d'organismes privés et publics;
n. d'autres recettes
(2) Des fonds doivent également être obtenus en vue du financement dans les secteurs d'activité des membres du
conseil de l'association.
(3) Chaque plan du financement contient un budget global incluant également les informations sur la question des
ressources financières nécessaires pour le financement intégral du projet.
Art. 27.
(1) Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom. Les administrateurs ne con-
tractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.
Titre VII. Dissolution, Liquidation.
Art. 28. L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue par les dispositions
légales. L'assemblée devra approuver le bilan définitif de clôture.
78430
L
U X E M B O U R G
Art. 29.
(1) En cas de dissolution, le conseil d'administration fera fonction de liquidateur.
(2) L'actif net sera distribué intégralement à la Fondation Les Journées d'Echternach, si celle-ci existe au jour de la
dissolution. Si tel n'est pas le cas, les liquidateurs donneront aux biens de l'association la destination qui se rapprochera
autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.
Art. 30. Tous les points non prévus par les présents statuts seront régis par les dispositions de la loi du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif et ses modifications ultérieures.
Suivent les signatures des membres fondateurs.
Echternach, le 8 mai 2013.
Raymond BECKER / Marc Diederich / Sandra BERTHOLET / Ralf BRITTEN
<i>Echternach Tourist Office / Office Régional du Tourisme / Office Régional du Tourisme / Trifolion Echternachi>
Référence de publication: 2013066905/299.
(130081939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.
Morgan Real Estate S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 108.274.
L'AN DEUX MILLE TREIZE
LE QUINZE MAI.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
S:T NICOLAI FASTIGHETS AB, une société anonyme (AB) constituée et dotée d'une existence juridique conformé-
ment au droit suédois, ayant un siège social en Suède situé à PO Box 16500, 200 25 Malmö, enregistrée au Registre du
Commerce suédois sous le numéro 556211-7118,
ici représentée par Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'un pouvoir donné en date du 14 mai 2013.
Une copie de ce pouvoir restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La société comparante, telle que représentée demande au notaire instrumentaire d'acter ses déclarations suivantes:
S:T NICOLAI FASTIGHETS AB détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la
société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MORGAN REAL ESTATE S.A., au capital de 31.000 euros, dont
le siège social est à Luxembourg, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.274, constituée par acte notarié en date du 19 mai 2005, publié au Mémorial
C 1027 du 12 octobre 2005,
et, en sa qualité d'actionnaire unique de MORGAN REAL ESTATE S.A., elle déclare que:
Un projet commun de fusion, établi par acte du notaire soussigné du 29 janvier 2013, publié au Mémorial C numéro
372 du 15 février 2013, a été conclu entre la prédite société suédoise «S:T NICOLAI FASTIGHETS AB» et la société
luxembourgeoise «MORGAN REAL ESTATE S.A.».
Le susdit projet a été rédigé en conformité avec les articles 261, 278 et 279 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Sur le vu:
A: du projet de fusion daté du 29 janvier 2013 prévoyant l'absorption de la Société luxembourgeoise par la société
anonyme suédoise dénommée «S:T NICOLAI FASTIGHETS AB», société au capital de SEK 100.000, dont le siège social
est à en Suède situé à PO Box 16500, 200 25 Malmô, enregistrée au Registre du Commerce suédois sous le numéro
556211 -7118, (ci-après nommée la société absorbante),
la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement
et passivement sans exception ni réserve de notre société luxembourgeoise à la société absorbante, ledit projet de fusion
ayant été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, le 8 février 2013, et ensuite publié au
Mémorial C n° 372 du 15 février 2013, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 tel que modifiée;
B: des rapports écrits des organes d'administration des sociétés fusionnantes, expliquant et justifiant du point de vue
juridique le projet de fusion;
C: En application des articles 265 et 267 de la loi précitée, applicables en matière de fusions transfrontalières, ont été
disponibles au siège social de la société absorbée pendant une période d'au moins 1 mois précédant la date de l'acte
constatant les décisions de l'associé unique de la société absorbante, les documents suivants:
a) le projet commun de fusion;
78431
L
U X E M B O U R G
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
c) l'élaboration des rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à
l'article 265 ayant été expressément dispensée par tous les associés des sociétés fusionnantes comme l'autorise ledit
article 265 (3);
La société absorbée, MORGAN REAL ESTATE S.A., décide de réaliser la fusion par absorption de notre société par
la société absorbante, aux conditions prévues par le projet de fusion dans son intégralité.
La fusion aura pour conséquence que tous les actifs et passifs de la société MORGAN REAL ESTATE S.A. seront
transférés à la Société absorbante S:T NICOLAI FASTIGHETS AB avec dissolution sans liquidation de MORGAN REAL
ESTATE S.A. comme suite de la fusion
La société comparante, es-qualité qu'elle agit, accorde décharge aux administrateurs et commissaires pour l'exécution
de leurs mandats respectifs.
La société comparante, es-qualité qu'elle agit, déclare que seront conservés pendant le délai de 5 ans, les documents
sociaux de la Société, au siège de la société absorbante.
En conséquence, le notaire soussigné atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société
absorbée et du projet commun de fusion telle que la législation luxembourgeoise le requiert.
La société comparante déclare en outre que les frais des présentes sont à la charge de la Société absorbante.
Pour l'exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en l'étude du notaire instrumentant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant et interprétation lui donnée en langue française, le comparant, connu du notaire
instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-H. DOUBET, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 16 mai 2013. Relation: RED/2013/768. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 22 mai 2013.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013066362/71.
(130081873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2013.
HSBC Amanah Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avanches.
R.C.S. Luxembourg B 74.964.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 17 mai 2013 a adopté les résolutions sui-
vantes:
1. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire qui se tiendra en 2014:
- Monsieur Edgar Ng (demeurant en Chine, Queen's Road Central 1, Hong-Kong);
- Monsieur Didier Deleage (demeurant en France, Place de la Pyramide 4, La Défense 9, 92800 Puteaux);
- Monsieur Thies Clemenz (demeurant en Arménie, 66 Teryan Street, 0009 Yerevan);
- Monsieur David Silvester (demeurant au Royaume-Uni, Canada Square 8, Canary Wharf, E14 5HQ Londres);
- Monsieur James Boucher (demeurant à l'Ile Maurice, CyberCity 18, Ebene);
- Monsieur George Efthimiou (demeurant au Royaume-Uni, Canada Square 8, Canary Wharf, E14 5HQ Londres);
- Monsieur Michael Boehm (demeurant en Allemagne, Konigsallee 21/23, 40212 Dusseldorf);
- Madame Sylvie Vigneaux (demeurant en France, Place de la Pyramide 4, La Défense 9, 92800 Puteaux).
3. L'Assemblée a ré-élu KPMG Luxembourg S.à r.l dont le siège social se situe 9 Allée Scheffer, L-2550 Luxembourg
à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2014.
<i>Pour HSBC AMANAH FUNDS SICAV
i>HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2013067020/24.
(130082485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
78432
Caisse Raiffeisen Bascharage-Reckange-Soleuvre
Caisse Raiffeisen Noerdange-Saeul-Useldange Société Coopérative
Carpel S.à r.l.
Echternacher Tourismus Tage
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.
Enviro IP S.A.
E Project S.A.
European Retail Asset Management (ERAM) S.à r.l.
FCMS S.à r.l.
FCMS S.à r.l.
Fellow Finance S.A.
Fellow Finance S.A.
Financière Baucalaise S.A.
Financière d'Ibis Spf S.A.
Floann S.A.
Foodline Management Services S.A.
Foodline SPF S.A.
Galilehorn Asset Management S.à r.l.
G.C.C. International S.A.
Golden Hawk Management S.à r.l.
H2O Hesperange S.à r.l.
Habersti SA, SPF
Habinvest S.A., SPF
HELIOPSIS Spf S.A.
Homilux S.A.
HSBC Amanah Funds
HSH Luxembourg Coinvest S.à.r.l.
HTC High Technology Coatings S.A.
Hypericum S.à r.l.
Immolam S.A.
Immo-Weimerskirch II S.A.
Infrabiz Holdings S.A.
Integer Ethical Funds
Interassurances Pauly & Lamby et Associés S.à r.l.
Le Gaselle S.A.
LMA German Investments
LMB German Investments
LMC German Investments
LMD German Investments
LogiGest S.à r.l.
Lombok Capital Ventures S.A.
LUX. FINANCIAL COMPANY Spf S.A.
Lux-Immo-Containers S.A.
M(a)Gsolutions
MAS ASSETS s.à r.l. SPF
Maxilly Estate S.A.
Meigerhorn Espace Sàrl
Meigerhorn Etoy S.à r.l.
Meigerhorn Montreux, Sàrl
M.E.S. Company Sàrl
MMS Mercury Management Services S.A.
Morgan Real Estate S.A.
NMC International S.à r.l.
Peinture Backes & Cie
Pentair Holdings
PGO Invest S.à r.l.
PGO Invest S.à r.l.
Pomelos S.à r.l.
Pomelos S.à r.l.
Poncirus S.à r.l.
Poncirus S.à r.l.
RMJ S.à r.l.
Solix Holding S.à r.l.