This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1572
2 juillet 2013
SOMMAIRE
Arrcom Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . .
75439
Blackfont Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75442
BNP Paribas Investment Partners Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75441
Boca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75441
Box Lines - Transportes Internacionais S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75440
Bufab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75441
Degomex Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
75438
Discovery A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75438
Doosan Power Systems S.A. . . . . . . . . . . . .
75439
Dynamic Materials Luxembourg 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75439
Emerging Markets Online Food Delivery
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75410
Fagus Multimanager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75438
Finamore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75410
Framel Net S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75454
FRBL022011 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75453
Frog Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
75454
Game Garden Company S.A. . . . . . . . . . . .
75453
Générale d'Hôtellerie S.A. . . . . . . . . . . . . . .
75452
Generali Investments SICAV . . . . . . . . . . . .
75452
GlobalSantaFe Financial Services (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75456
Golden Flax Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75453
Hattersley Centre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
75456
HSH Investment Holdings Coinvest-C S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75452
HSH Investment Holdings FSO S.à r.l. . . .
75451
IBC Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75449
IBC Ugod Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
75447
Iberint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75449
IDR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75443
Immo 55 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75443
Immobilière Building BE S.A. . . . . . . . . . . .
75449
Imperial Innovations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
75456
Inmet Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75442
Inmet Panama I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75442
Intent Ventures Parallel S.C.S. . . . . . . . . . .
75448
Investam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75447
Investcredit SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75448
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
75447
Kazanorgsintez S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75450
Kilderkin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75450
Kirchberg Development GP S.à r.l. . . . . . .
75449
Kosmoline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75450
Kosmo Luxembourg Holdings S.A. . . . . . .
75450
KPI III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75451
KP Interiors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75451
KP RSL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75451
Luxcare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75448
SCG STE Maurice 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
75455
SDL Investments I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
75455
Shing Shuan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75454
StarCap SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75455
T.T.V. Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75454
75409
L
U X E M B O U R G
Finamore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.726.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2013i>
Délibérations
L'assemblée générale décide de reconduire, pour une période d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle
de 2014, le mandat du Commissaires aux Comptes de M. Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant professionnelle-
ment au 24 rue Saint-Mathieu à L-2138 Luxembourg, né le 11 juin 1966 à Wilrijk.
Fait le 10-04-2013.
Pour extrait analytique certifié sincère et conforme à l’orignal
Bernard Bosquée
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2013061533/16.
(130076298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 28.750,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 175.738.
In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of April.
before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws
of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB
109262 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter "Rocket Internet"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin on 11 April 2013, and
2. Kinnevik Online AB (formerly Kinnevik Online Ventures AB), a limited liability company (aktiebolag) existing under
the laws of Sweden registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, having its
registered address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden (hereinafter "Kinnevik Online AB"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Stockholm on 11 April 2013, and
3. Bambino 53. V V UG (haftungbeschränkt), a limited liability company (Unternehmensgesellschaft (haftungbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
"Bambino 53. V V"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin on 11 April 2013, and
4. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg (hereinafter "AI European Holdings"),
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg on 11 April 2013, and
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, with the registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés) pending, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, the
Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter "New Investor" or "Aismare Lux Holdings S.à r.l."), participating and voting
only for purposes of Agenda point 4 et seqq.,
here represented by Katia Gauzès, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg on 12 April 2013.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
75410
L
U X E M B O U R G
The parties 1. through 4. (the "Existing Shareholders") are all the shareholders of Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 175.738 and incorporated pursuant to a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 28 February 2013, not yet published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 28 February 2013, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The Existing Shareholders representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the
general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the
New Investor participates and votes for purpose of Agenda point 4 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) additional class of shares referred to as the series B shares (hereinafter "Series B Shares")
and to hence have seven (7) classes of shares in total.
2. Acceptance of Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with the registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) pending, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter the "New Investor") as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of three thousand seven hundred and fifty euro (EUR 3,750)
so as to raise it from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to twenty-eight thousand seven
hundred and fifty euro (EUR 28,750) by issuing three thousand seven hundred and fifty (3,750) Series B Shares.
4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-eight thousand seven hundred and fifty euro (EUR 28,750), repre-
sented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"),
(ii) one hundred and eighty (180) series Ala shares (hereinafter "Series A1a Shares"), (iii) one thousand eight hundred and
seven (1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares
(hereinafter "Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thou-
sand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares") and (vii) three thousand seven
hundred and fifty (3,750) series B shares (hereinafter "Series B Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. shall be entitled
to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the
Advisory Board (a "Third Party Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Kinnevik Online AB,
(ii) Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. shall inform the Company by binding declaration within
three (3) weeks if Kinnevik Online AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3."
5. Subsequent amendment of article seven point four a (7.4a) of the articles of association of the Company so that it
shall henceforth read as follows:
"a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l. and (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (Rocket Internet GmbH,
Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. hereinafter jointly referred to as
"Investors"; each individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German
Stock Corporation Act ( AktG) to the respective Investor;"
6. Subsequent amendment of article eight (8) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
« Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
75411
L
U X E M B O U R G
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a "Liquidity
Event"), the proceeds ("Exit Proceeds") - subject to articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with
article 8.4 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level ("First Level") the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series B
Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company).
8.3 On a second level ("Second Level") the holders of Series Ala Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series
A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,554.76
8.4 After the payments on the First Level and Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be
allocated on a third level ("Third Level") to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be
allocated to such shareholder on the Third Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Third Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level and/or Second Level. The allocation
at Third Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or
not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation on the First Level and Second Level applies to each of the respective Series B Shares,
Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares as long as on the respective
Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares the amount
stipulated in article 8.2 and/or in the table pursuant to article 8.3 has not yet been distributed once."
7. Subsequent amendment of articles twenty-five point 1 (25.1) and twenty-five point 3 (25.3) of the articles of asso-
ciation of the Company so that they shall henceforth read as follows:
" 25.1. The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of six (6) voting members.
The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of
members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board."
" 25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification
towards the Company as follows:
a) three (3) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in
its sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion; and
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion."
8. Decision to amend and fully restate the articles of association of the Company.
9. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares referred to as series B shares
(hereinafter "Series B Shares").
75412
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Aismare Lux Holdings S.à r.l., a company incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with the registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés) pending, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, the
Grand Duchy of Luxembourg, as a new shareholder of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 3,750) so as to raise it from its current amount of twenty-five thousand euro
(EUR 25,000) up to twenty-eight thousand seven hundred and fifty euro (EUR 28,750) by issuing three thousand seven
hundred and fifty (3,750) Series B Shares.
<i>Subscriptioni>
Three thousand seven hundred and fifty (3,750) Series B Shares have been duly subscribed by Aismare Lux Holdings
S.à r.l., aforementioned, for the price of three thousand seven hundred and fifty euro (EUR 3,750).
<i>Paymenti>
The three thousand seven hundred and fifty (3,750) Series B Shares subscribed by the New Investor, aforementioned,
have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of three thousand seven hundred and fifty euro
(EUR 3,750).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of three thousand seven hundred and fifty euro (EUR 3,750) is entirely allocated to
the share capital.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledges that Aismare Lux Holdings S.à r.l. has now become holder of the
issued three thousand seven hundred and fifty (3,750) Series B Shares.
As a consequence Aismare Lux Holdings S.à r.l., entitled to vote and here represented by Katia Gauzès, Avocat à la
Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given, joins the general meeting of shareholders for
purpose of the following resolutions.
The said proxy initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the
Company so that it shall now henceforth read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-eight thousand seven hundred and fifty euro (EUR 28,750), repre-
sented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"),
(ii) one hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series Ala Shares"), (iii) one thousand eight hundred and
seven (1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares
(hereinafter "Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thou-
sand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares") and (vii) three thousand seven
hundred and fifty (3,750) series B shares (hereinafter "Series B Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. shall be entitled
to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the
Advisory Board (a "Third Party Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Kinnevik Online AB,
(ii) Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. shall inform the Company by binding declaration within
three (3) weeks if Kinnevik Online AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3.
75413
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article seven point four a (7.4a) of the articles of
association of the Company so that it shall now henceforth read as follows:
"a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l. and (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (Rocket Internet GmbH,
Kinnevik Online AB Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. hereinafter jointly referred to as
"Investors"; each individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German
Stock Corporation Act ( AktG) to the respective Investor;"
<i>Sixth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article eight (8) of the articles of association of the
Company so that it shall now henceforth read as follows:
« Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a "Liquidity
Event"), the proceeds ("Exit Proceeds") - subject to articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with
article 8.4 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level ("First Level") the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series B
Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company).
8.3 On a second level ("Second Level") the holders of Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series
A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,554.76
8.4 After the payments on the First Level and Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be
allocated on a third level ("Third Level") to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be
allocated to such shareholder on the Third Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Third Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level and/or Second Level. The allocation
at Third Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or
not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation on the First Level and Second Level applies to each of the respective Series B Shares,
Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares as long as on the respective
Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares the amount
stipulated in article 8.2 and/or in the table pursuant to article 8.3 has not yet been distributed once."
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of articles twenty-five point 1 (25.1) and twenty-five
point three (25.3) of the articles of association of the Company so that they shall now henceforth read as follows:
25.1. The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of six (6) voting members. The
shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of members
of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.
75414
L
U X E M B O U R G
25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards
the Company as follows:
a) three (3) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in
its sole discretion (such members the "Rocket-Members");
b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.
in its sole discretion; and
d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
in its sole discretion.
<i>Eighth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
"A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Emerging
Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-eight thousand seven hundred and fifty euro (EUR 28,750), repre-
sented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"),
(ii) one hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series Ala Shares"), (iii) one thousand eight hundred and
seven (1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares
(hereinafter "Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thou-
sand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares") and (vii) three thousand seven
75415
L
U X E M B O U R G
hundred and fifty (3,750) series B shares (hereinafter "Series B Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00)
each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.a r.l. and Aismare Lux Holdings S.a r.l. shall be entitled
to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the
Advisory Board (a "Third Party Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Kinnevik Online AB,
(ii) Al European Holdings S.a r.l. and Aismare Lux Holdings S.a r.l. shall inform the Company by binding declaration within
three (3) weeks if Kinnevik Online AB and/or Al European Holdings S.a r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.a r.l. intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions of
any shareholders agreement between the shareholders if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet GmbH, (ii)
Kinnevik Online AB (iii) Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. (Rocket Internet GmbH, Kinnevik
Online AB, Al European Holdings S.à r.l. and Aismare Lux Holdings S.à r.l. hereinafter jointly referred to as "Investors";
each individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration Act (AktG) to the respective Investor;
b) in case of the transfer of shares of one Investor to a company or entity (x) which is directly or indirectly Controlling,
Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect shareholders of
the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or "Controlling" shall mean
the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a) managing the company as managing shareholder,
(b) holding the majority of shares, (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting pool, or (d)
the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person, whether
through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more share-
holders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
c) in case of a share transfer to a third party acquiring shares under the simplified employee participation, or by a
shareholder to the Company and/or any Investors pursuant to a call option under a vesting scheme..
7.5 To the extent a transfer of shares requires no additional consent of the shareholders' meeting pursuant to article
7.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or
drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
75416
L
U X E M B O U R G
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a "Liquidity
Event"), the proceeds ("Exit Proceeds") - subject to articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with
article 8.4 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level ("First Level") the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series B
Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company).
8.3 On a second level ("Second Level") the holders of Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series
A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,554.76
8.4 After the payments on the First Level and Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be
allocated on a third level ("Third Level") to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be
allocated to such shareholder on the Third Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Third Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level and/or Second Level. The allocation
at Third Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or
not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation on the First Level and Second Level applies to each of the respective Series B Shares,
Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares as long as on the respective
Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares the amount
stipulated in article 8.2 and/or in the table pursuant to article 8.3 has not yet been distributed once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
a) insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings is
rejected for lack of assets;
b) the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and such
enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the Law and the
Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer
in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
75417
L
U X E M B O U R G
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in Lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective decisions of the shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General meetings of shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
75418
L
U X E M B O U R G
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14 Quorum and vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 16. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Decisions requiring specific majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent
of the Advisory Board:
a) disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
b) amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and
transformation of the Company;
c) appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits
to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
d) conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291 et seqq. of the
German Stock Corporation Act (AktG));
e) conclusion of company participations of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other
contractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of
the Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including
agreements concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners;
f) approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year and the annual accounts;
g) removal and appointment of managers.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the prior consent
of the Investors.
a) exclusion of subscription rights in case of capital increases;
b) acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with article 9.2 and
transfers in accordance with article 11.1 of these articles of association.
D. Board of managers and advisory board
Art. 18. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
75419
L
U X E M B O U R G
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, removal and term of office of managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, pursuant to
article 17.1 lit. g).
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the office of a manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening meetings of the board of managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
75420
L
U X E M B O U R G
22.8 The managers shall require the prior consent of the Advisory Board for legal transactions and measures which
are beyond the ordinary course of business of the Company, and - in any case - for the legal transactions and measures
specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in
advance been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders' meeting:
a) incorporation, acquisition or disposal of enterprises or partial-businesses;
b) amendment of articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise (or waiver)
of shareholders' rights in companies in which an interest is held;
c) acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
d) material change to the nature of the business of the Company and the termination of any material business operation;
e) assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euro (EUR
200,000) in aggregate;
f) granting of loans in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate, excluding, however, such
loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
g) conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred
thousand euro (EUR 200,000) in aggregate and amendments to the credit framework, excluding, however, such agree-
ments between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
h) futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-
actions with derivative financial instruments;
i) granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
j) conclusion amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial impor-
tance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
k) institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than ten thousand euro (EUR 10,000) in the individual case;
l) disposition of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights including copyrights or any other
property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation by the enterprise and/or a third
party, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
m) business dealings of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be shareholders, affiliated companies, as well as relatives of direct or indirect shareholders as far as
the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to
this lit. (m) does not apply if the business dealing belongs to the ordinary course of business of the Company and is at
arm's length;
n) amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensvertrage within the meaning of articles 291
et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));
o) exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that
this exercise would require the consent of the shareholders' meeting under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this article 22.8 lit. a) to p), article 17.1 or 17.2.
Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the prior consent of the Advisory
Board.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this article apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
75421
L
U X E M B O U R G
Art. 24. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall consist of six (6) voting members. The
shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of members
of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.
25.2 The shareholders' meeting shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of a
unanimous shareholders' resolution.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards
the Company as follows:
e) three (3) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet GmbH in
its sole discretion (such members the "Rocket-Members");
f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole
discretion;
g) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.á r.l.
in its sole discretion; and
h) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.á r.l.
in its sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. One of the Rocket-Members shall be the
chairman of the Advisory Board and shall not have a casting vote. The rules of procedure of the Advisory Board shall
provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which the shareholders' meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these
articles of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iii) by way of shareholders' resolution or (iv) in any
shareholders' agreement.
25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the
Company by way of a unanimous shareholders' resolution.
25.7 In addition to the consent requirements provided for in article 22.8 and article 22.9, the Advisory Board has a
consultative function and will not interfere in the management of the Company.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual accounts and allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
75422
L
U X E M B O U R G
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders
and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these
articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter
partes and to the extent permitted by Luxembourg law."
These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and
the German text, the English version shall prevail.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,500.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first
name and residence, the said proxyholders signed together with the notary the present deed."
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausend dreizehn, am sechzehnten April.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstraße
20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket Internet"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
April 2013, ausgestellt in Berlin, und
2. Kinnevik Online AB (vormals Kinnevik Online Ventures AB), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktiebolag)
nach schwedischem Recht, eingetragen im Gesellschaftsregister in Schweden (Bolagsverket), unter der Nummer
556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden („Kinnevik Online AB"),
75423
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
April 2013, ausgestellt in Stockholm, und
3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) nach deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
April 2013, ausgestellt in, Berlin und
4. AI European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
luxemburgischem Recht, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des
Sociétés), unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg („Al European
Holdings"),
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
April 2013, ausgestellt in Luxemburg, und
5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
luxemburgischem Recht, deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce
et des Sociétés) noch aussteht, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg (der
„Neue Investor" oder „Aismare Lux Holdings S.à r.l."), der ausschließlich für Punkt 4 ff. teilnahme- und stimmberechtigt
ist,
hier vertreten durch Katia Gauzès, Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12.
April 2013, ausgestellt in. Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1 bis 4 (die „Bestehenden Gesellschafter") sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft"), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324
Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738, gegründet
am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars, Maître Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim,
noch nicht veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt
am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars, Maître Jean-Joseph Wagner, vorbenannt, geändert und noch nicht
im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei der Neue Investor ausschließlich für Punkt 4 ff. teilnahme- und stimmberechtigt
ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, die als Anteile der Serie B bezeichnet werden
(die „Anteile der Serie B"), wodurch nunmehr insgesamt sieben (7) Anteilsklassen bestehen.
2. Annahme von Aismare Lux Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischem Recht, deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de
Commerce et des Sociétés) noch aussteht, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg (der „Neue Investor"), als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25.000) um einen Betrag von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 3.750) auf einen Betrag von achtund-
zwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 28.750) durch die Ausgabe von dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750)
Anteilen der Serie B.
4. Anschließende Änderung von Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 28.750),
aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii) einhun-
dertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807) Anteile
der Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c"),
(v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsundfünfzig
(1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b") und (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der
Serie B (die „Anteile der Serie B") mit einem Nominalwert von einem euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden."
75424
L
U X E M B O U R G
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. und Aismare Lux Holdings S.à r.l.
ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Invest-
mentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem
Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne des Artikels 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein "Drittin-
vestor") handelt), und der vom Beratenden Ausschuss zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten") - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. und
Aismare Lux Holdings S.à r.l. haben die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu
unterrichten, sofern Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchten."
5. Anschließende Änderung von Artikel sieben Punkt vier a (7.4 a) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l. und (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l.
(Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l. und Aismare Lux Holdings S.à r.l. im Folgenden
gemeinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor") an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);"
6. Anschließende Änderung von Artikel acht (8) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehrerer Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis" bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse") - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel
8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR 1.600
pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend
aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderer Ka-
pitaleinlagen (Punkt 115 des Luxemburger Standard-Kontenrahmens), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt
wurden).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie
A1b, Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteils-
klasse (und zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der
entsprechenden Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
in Euro
Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.554,76
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene") an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Beträge
mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Dritten Ebene und werden anschließend entspre-
chend dieser Dritten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten
und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Dritten Ebene erfolgt solange, bis alle
Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquidi-
tätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den
Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzu-
zahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den
Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Ge-
sellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
75425
L
U X E M B O U R G
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene ist auf alle entsprechenden Anteile der Serie
B, Anteile der Serie A1a, Anteile der Serie A1b, Anteile der Serie A1c, Anteile der Serie A2a und Anteile der Serie A2b
anwendbar, solange bei den jeweiligen Anteilen der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie Alb, Anteilen der
Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b der in Artikel 8.2 und/oder der in der Tabelle in Artikel
8.3 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde."
7. Anschließende Änderung der Artikel fünfundzwanzig Punkt eins (25.1) und fünfundzwanzig Punkt drei (25.3) der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lauten:
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschluss (der „Beratende Ausschluss"). Dieser besteht aus sechs (6)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen."
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schrift-
liche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
e) drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
g) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
h) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt."
8. Beschluss bezüglich der Änderung und gänzlichen Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
9. Verschiedenes.
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, eine (1) weiterer Anteilsklasse zu schaffen, die als Anteile der
Serie B bezeichnet werden (die „Anteile der Serie B").
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, deren Eintragung im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) noch aussteht, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Großherzogtum, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen
Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR
3.750) auf einen Betrag von achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 28.750) durch die Ausgabe von drei-
tausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteilen der Serie B zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß von Aismare Lux Holdings S.à
r.l., vorbenannt, zu einem Preis von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 3.750) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die vom Neuen Investor, vorbenannt, gezeichneten dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der Serie B wur-
den vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 3.750).
Der Nachweis für die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 3.750) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter erkennt an, dass Aismare Lux Holdings S.à r.l. nun der Inhaber der ausge-
gebenen dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der Serie B geworden ist.
Infolgedessen schließt sich Aismare Lux Holdings S.à r.l., stimmberechtigt und hier vertreten durch Katia Gauzès,
Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer ihr erteilen Vollmacht, für die nachstehenden Beschlüsse
der Hauptversammlung der Gesellschafter an.
75426
L
U X E M B O U R G
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 28.750),
aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii) einhun-
dertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807) Anteile
der Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c"),
(v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsundfünfzig
(1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b") und (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der
Serie B (die „Anteile der Serie B") mit einem Nominalwert von einem euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. und Aismare Lux Holdings S.à r.l.
ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Invest-
mentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem
Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne des Artikels 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein "Drittin-
vestor") handelt), und der vom Beratenden Ausschuss zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten") - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. und
Aismare Lux Holdings S.à r.l. haben die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu
unterrichten, sofern Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchten."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel sieben Punkt vier a (7.4 a) der Satzung der Gesellschaft
zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l. und (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l.
(Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l. und Aismare Lux Holdings S.à r.l. im Folgenden
gemeinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor") an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);"
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, Artikel acht (8) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehrerer Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis" bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse") - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel
8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR 1.600
pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend
aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderer Ka-
pitaleinlagen (Punkt 115 des Luxemburger Standard-Kontenrahmens), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt
wurden).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie
A1b, Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteils-
klasse (und zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der
entsprechenden Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:
75427
L
U X E M B O U R G
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
in Euro
Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.554,76
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene") an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Beträge
mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Dritten Ebene und werden anschließend entspre-
chend dieser Dritten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten
und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Dritten Ebene erfolgt solange, bis alle
Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquidi-
tätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den
Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzu-
zahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den
Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Ge-
sellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene ist auf alle entsprechenden Anteile der Serie
B, Anteile der Serie A1a, Anteile der Serie Alb, Anteile der Serie A1c, Anteile der Serie A2a und Anteile der Serie A2b
anwendbar, solange bei den jeweiligen Anteilen der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b, Anteilen der
Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b der in Artikel 8.2 und/oder der in der Tabelle in Artikel
8.3 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde."
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, die Artikel fünfundzwanzig Punkt eins (25.1) und fünfundzwanzig
Punkt drei (25.3) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welche nunmehr wie folgt lauten:
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschluss (der „Beratende Ausschluss"). Dieser besteht aus sechs (6)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen."
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schrift-
liche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt."
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die Änderung und
gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
75428
L
U X E M B O U R G
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und ihr zur
Erreichung dieser Zwecke, im Hinblick auf die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, förderlich
erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst
werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form
gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 28.750),
aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile"), (ii) einhun-
dertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a"), (iii) eintausendachthundertsieben (1.807) Anteile
der Serie A1b (die „Anteile der Serie Alb"), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c"),
(v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a"), (vi) eintausendsechshundertsechsundfünfzig
(1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b") und (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile der
Serie B (die „Anteile der Serie B"), mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. und Aismare Lux Holdings S.à r.l.
ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Invest-
mentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem
Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne des Artikels 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein "Drittin-
vestor") handelt), und der vom Beratenden Ausschuss zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten") - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Kinnevik Online AB, (ii) Al European Holdings S.à r.l. und
Aismare Lux Holdings S.à r.l. haben die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen zu
unterrichten, sofern Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l.
ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchten.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nennwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
75429
L
U X E M B O U R G
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann als Gegenleistung Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit") und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine zusätzliche Einwilligung zur
Übertragung der Anteile nicht erforderlich:
a) bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, jeder Abtretung oder jeder anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)
Rocket Internet GmbH, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l. und (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l.
(Rocket Internet GmbH, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l. und Aismare Lux Holdings S.à r.l. im Folgenden
gemeinschaftlich die „Investoren"; jeweils einzeln ein „Investor") an eine mit dem betreffenden Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne des Abschnitts 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
b) bei der Übertragung von Anteilen eines Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welches direkt
oder indirekt über einen Investor oder einen oder mehreren direkten oder indirekten Gesellschaftern des Investors
herrscht, von diesem abhängig ist, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht (jeweils eine „Kontrollierte
Gesellschaft"), wobei die Worte „Kontrolle" oder „Abhängig" oder „Herrscht" die direkte oder indirekte Kontrolle der
Gesellschaft bezeichnet (a) durch die Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) durch
das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimm-
vereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit die Richtung der Geschäftsleitung und Geschäftspolitik einer Person,
entweder durch den Besitz von Wertpapieren oder anderweitig Abstimmung zu bewirken oder (y) in welcher der Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter des Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
c) bei einer Übertragung von Anteilen an einen Dritten, welcher Anteile unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbe-
teiligung erwirbt, oder von einem Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer
Kaufoption im Rahmen eines Übertragungssystems.
7.5 Sofern eine Übertragung von Anteilen gemäß Artikel 7.4 keiner weiteren Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung bedarf, gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitver-
kaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn die Zustimmung zu einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit (unter Ausschluss der Anteile des
verstorbenen Gesellschafters), erteilt wurde. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern,
Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Ge-
sellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehrerer Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
75430
L
U X E M B O U R G
eignis" bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse") - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel
8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR 1.600
pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend
aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderer Ka-
pitaleinlagen (Punkt 115 des Luxemburger Standard-Kontenrahmens), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt
wurden).
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene") erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie
A1b, Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteils-
klasse (und zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der
entsprechenden Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
in Euro
Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.554,76
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene") an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Beträge
mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Dritten Ebene und werden anschließend entspre-
chend dieser Dritten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten
und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Dritten Ebene erfolgt solange, bis alle
Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquidi-
tätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den
Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzu-
zahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den
Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Ge-
sellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene ist auf alle entsprechenden Anteile der Serie
B, Anteile der Serie A1a, Anteile der Serie A1b, Anteile der Serie A1c, Anteile der Serie A2a und Anteile der Serie A2b
anwendbar, solange bei den jeweiligen Anteilen der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b, Anteilen der
Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b der in Artikel 8.2 und/oder der in der Tabelle in Artikel
8.3 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte jeder der von der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile werden aufgehoben, solange sie von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
a) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens aus Mangel an Vermögen abgelehnt wird;
b) ein Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil ein-
geleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Nach Erhalt der Rückkaufserklärung gesendet bei dem Geschäftsführungsrates durch diesen Gesellschafter werden
die Anteile automatisch zurückgekauft, wobei es keiner weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt ge-
meinsam mit der Rückkaufserklärung ein gültiges Schriftstück im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und
die Gesellschaft erkennt an und akzeptiert hiermit in einem solchen Fall die Übertragung der Anteile und verpflichtet sich
zur Eintragung der Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Hinter-
legung.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf im Bezug auf
eine Person ausreichend; unabhängig davon können die gemeinsam berechtigten Personen die Gesellschafterrechte nur
dann einheitlich ausüben, wenn eine dieser Personen zu diesem Zweck unverzüglich nach Aufkommen des gemeinsamen
Anteilsrechts ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Geschäftsführungsrat erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
75431
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Tag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Tribunal d'Arrondissement bestimmt. Die Entscheidung des
Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem ersuchenden Ge-
sellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der von diesem Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rückkaufspreis
verrechnet und dieser entsprechend herabgesetzt wird. Sofern die vom Gesellschafter zu tragenden Kosten für das
Gutachten nicht vom Rückkaufspreis gedeckt werden, gehen die restlichen Kosten zu Lasten des Gesellschafters.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung des Anteils an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst wer-
den. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail
oder Fax) oder telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht
wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses
Verfahren gegenüber dem Geschäftsführungsrat der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein
Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehm-
enden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen
und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form
gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter nach den
Vorschriften von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Hauptversammlung der Gesellschafter" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zu-
sammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter werden
vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 13. Hauptversammlung der Gesellschafter.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in der entsprechenden Einladung
genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Hauptversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4) Wochen
und bei außerordentlichen Hauptversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wochen einzuhalten
75432
L
U X E M B O U R G
ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der
Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und auf
Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung begleitet oder von einem anderen
durch eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter, oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer unter der Berufsverschwiegenheitspflicht vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 17. Beschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten bedürfen einer Qualifizierten Mehrheit und der vorherigen
Zustimmung des Beratenden Ausschusses:
a) Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens
einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Abwicklung der Gesellschaft;
b) Änderung dieser Satzung einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Um-
wandlung der Gesellschaft;
c) Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher
Gewinne auf neue Konten: Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;
d) Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der Artikel 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
e) Abschluss von Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Gesellschaften und sämtlicher Verträge,
durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche
vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der
Gesellschaft, einschließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder An-
gestellter abgeschlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge
zwischen der Gesellschaft und Werbepartnern;
f) Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr und des Jahresabschlusses;
g) Abberufung und Ernennung von Geschäftsführern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten bedürfen einer Qualifizierten Mehrheit und der vorherigen
Zustimmung der Investoren:
a) Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
b) Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß
Artikel 11.1 dieser Satzung.
D. Geschäftsführungsrat und beratender Ausschuss
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als
Verweis auf den alleinigen Geschäftsführer auszulegen.
75433
L
U X E M B O U R G
18.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehaltenen
Handlungen.
Art. 19. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche ihre
Bezüge und Amtszeit festlegt.
19.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund gemäß Artikel 17.1 g) gewählt oder abberufen werden.
19.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-
schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten werden und die Geschäftsführer sind der Kategorie zuzuordnen, der sie angehören.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Hauptversammlung der Gesellschafter neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
21.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Geschäftsfüh-
rungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsfüh-
rungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt haben und sie unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder ein anderes ver-
gleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis
dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
22.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Geschäftsführungsrats nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
75434
L
U X E M B O U R G
22.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Faxschreiben, oder per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können
ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft liegen, und - in jedem Fall - für die
untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen präzise definiert wurden und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der
Gesellschafterversammlung genehmigt wurden:
a) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen oder TeilGesellschaften;
b) Änderung der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Ausübung (oder der Aus-
schluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;
c) Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
d) Wesentliche Änderungen der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Einstellung eines wesentlichen Ge-
schäftsbetriebs;
e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihun-
derttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;
f) Gewährung von Darlehen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten,
unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft;
g) Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die einen Gesamtbetrag
von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, unter Ausschluss von
Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
h) Künftige Transaktionen bezüglich Devisen, Sicherheiten und börsengehandelten Gütern und Rechten sowie weitere
Transaktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
i) Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
j) Abschluss, Änderung oder Kündigung von
Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hin-
sichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
k) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert
von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;
l) Verfügung über Nutzungsrechte jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urhe-
berrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Weitergabe von Know-how zur eigenen Verwertung durch
die Firma und/oder Drittparteien, unter Ausschluss von Bestimmungen zwischen der Gesellschaft und direkten und in-
direkten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
m) Geschäfte der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen Personen und Einzelpersonen. Als
Gesellschafter werden verbundene Gesellschaften sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter angesehen,
sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmungsver-
pflichtung gemäß des vorliegenden Punktes m) ist nicht anwendbar, wenn das Geschäft zum gewöhnlichen Geschäftsgang
der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
n) Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der Artikel 291 ff. des deutschen Aktienge-
setzes (AktG));
o) Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, von der die Gesellschaft ein Gesellschafter
ist, sofern diese Ausübung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß
dieses Artikels 22.8, a) bis p), Artikel 17.1 oder 17.2.
Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Beratenden Ausschusses.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf und zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,
so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beratenden Ausschusses erfordern. Der Beratende Ausschuss kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten
von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für Geschäftsführer be-
schließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels, soweit gesetzlich möglich, auf
die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt oder
indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
75435
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäfts-
führers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, falls
vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vor-
handen), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), durch gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführer der Kategorie A (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), durch gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und
eines (1) Geschäftsführer der Kategorie A (oder deren Vertreter).
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, wirksam verpflichtet;
sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich
Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 25. Beratender Ausschuss.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beratenden Ausschuss (der „Beratende Ausschuss"). Dieser besteht aus sechs (6)
stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss
die Anzahl der Mitglieder des Beratenden Ausschusses erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht
stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses ernennen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung des Beratenden Ausschusses nur durch einen ein-
stimmigen Gesellschafterbeschluss genehmigen oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von den Gesellschaftern durch schriftliche
Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:
a) drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beratenden Ausschusses werden von dem Gesellschafter Rocket Internet
GmbH nach eigenem Ermessen ernannt (die „Rocket-Mitglieder");
b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB
nach eigenem Ermessen ernannt;
c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter AI European Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beratenden Ausschusses wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings
S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beratende Ausschuss hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Eines der Rocket-
Mitglieder ist der Vorsitzende des Beratenden Ausschusses und hat nicht die entscheidende Stimme. Die Geschäftsord-
nung des Beratenden Ausschusses hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des
Beratenden Ausschusses, zu enthalten.
25.5 Der Beratende Ausschuss ist zuständig für die Erteilung von Zustimmungen zu Transaktionen und Maßnahmen
der Geschäftsführer, die die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beratenden Ausschusses ent-
weder (i) in dieser Satzung, (ii) in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss
oder (iv) in jedweder Gesellschaftervereinbarung erteilt hat.
25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beratenden Ausschusses wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der
Gesellschaft durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.
25.7 Neben den in den Artikeln 22.8 und 22.9 vorgesehenen Zustimmungserfordernissen hat der Beratende Ausschuss
eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Hauptversammlung der Ge-
sellschafter ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
75436
L
U X E M B O U R G
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen
werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachten Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Gesellschafter im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung wie der verbleibende Jahresnettogewinns der Ge-
sellschaft verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt und
darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht
durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste
oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt
werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt.
Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Ver-
mögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der
Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel
dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaf-
tervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach Luxemburger Recht zulässig, maßgebend."
Die vorliegende Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
75437
L
U X E M B O U R G
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, gleichwelcher Form, welche der Gesellschaft entstehen, belaufen
sich auf ungefähr EUR 2.000,-.
Woraufhin diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der erschienenen Parteien,
dass diese Urkunde auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen der erschienenen
Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend.
Die Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, der dem Notar mit Name, Vorname, Familienstand
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von diesem gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet worden.
Gezeichnet: K. GAUZES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2013. Relation: LAC/2013/18724. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 14. Mai 2013.
Référence de publication: 2013062269/1575.
(130076575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Fagus Multimanager, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 64.333.
Le bilan de la Société au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour FAGUS MULTIMANAGER
i>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013061525/12.
(130076464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Degomex Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 149.577.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 30 avril 2013i>
L'associé unique de Degomex Holding S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A, une société incorporée le 29 août 1991, régie par les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B37974, en tant que Gérant de classe B de la Société et ce
avec effet au 2 Mai, 2013 pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 15 Mai 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013062236/17.
(130077367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Discovery A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 169.876.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66412 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
75438
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062246/10.
(130076941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Doosan Power Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 125.754.
<i>Extrait de la résolution prise par l'actionnaire unique en date du 30 avril 2013i>
M. Gee Won PARK a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
Luxembourg, le 15 mai 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Doosan Power Systems S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013062247/13.
(130076703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Dynamic Materials Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 134.213.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 31 janvier 2013.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2013062252/13.
(130076882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Arrcom Finance Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 98.759.
L'an deux mille dix, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ARRCOM FINANCE
HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 98.759, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER notaire à Luxembourg, agissant en rempla-
cement du notaire instrumentant, en date du 21 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 288 du 11 mars 2004,
L'assemblée est présidée par Madame Cristina SCHMIT, employée privée, demeurant professionnellement à Junglins-
ter.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ekaterina DUBLET, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Junglinster.
La président prie le notaire d'acter que:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations paraphées ne variateur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transformation de l'objet social de la société de Holding 29 en Soparfi.
75439
L
U X E M B O U R G
2.- Modification afférente de l'article 2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'abandonner le statut de société holding, régi par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter le statut
d'une simple société de participations financières.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en conformité avec ce qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article deux des statuts
de la société, pour lui donner la teneur suivante:
« 2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous
titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments
de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra
participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre
effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un porte-
feuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres
titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation,
ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées
et/ou à toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de
manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que
ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.
2.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
2.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.».
L'Assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Cristiana SCHMIT-VALENT, Ekaterina DUBLET, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 avril 2013. Relation GRE/2013/1765. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013062823/72.
(130078307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Box Lines - Transportes Internacionais S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.309.
EXTRAIT
Les comptes annuels du 22 février 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
75440
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013062849/14.
(130077593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Bufab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.721.
Par résolutions signées en date du 15 mai 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Jean Le Creurer, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey, au mandat
de gérant de classe B, avec effect au 15 mai 2013 et pour une durée indéterminée.
2. Acceptation de la démission d'Andrew Bennett, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier,
Jersey, de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 15 mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2013.
Référence de publication: 2013062850/15.
(130078144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
BNPP IP Lux, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 27.605.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 avril 2013 a décidé de renouveler le mandat de:
- Monsieur Marc RAYNAUD; Président; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France
- Monsieur Stéphane BRUNET; Administrateur et Administrateur Délégué; 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-
Hesperange, Luxembourg
- Monsieur Anthony FINAN; Administrateur; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France
- Monsieur Marnix ARICKX; Administrateur; 55, rue du Progrès, B-1210 Bruxelles, Belgique
- Madame Charlotte DENNERY; Administrateur; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France.
- Monsieur Max DIULIUS; Administrateur; 14, rue Bergère, F-75009 Paris, France
pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de
2014.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Eric MARTIN de son mandat d'administrateur avec
effet au 10 avril 2013.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale nomme Monsieur Carlo THILL (50 Avenue JF Kennedy, L-2951 Luxembourg) com-
me nouvel administrateur de la Société. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires en 2014.
Pour extrait conforme
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Référence de publication: 2013062864/25.
(130078084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Boca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 106.220.
RECTIFICATIF
Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée lors du dépôt de l'extrait des résolutions prises par les associées en
date du 16 avril 2013 concernant la démission de M. Philippe CAMU et de la société anonyme Shaftesbury Corporate
75441
L
U X E M B O U R G
Management Services (Luxembourg) S.A., déposé au Registre de Commerces et des Sociétés de Luxembourg en date du
7 mai 2013 sous la référence L130071927.
Il y a dorénavant lieu de lire que M. Philippe CAMU et la société anonyme Shaftesbury Corporate Management Services
(Luxembourg) S.A. non pas démissionnés mais qu'ils ont été révoqués.
Luxembourg, le 16 mai 2013.
Pour avis rectificatif sincère et conforme
<i>Pour BOCA S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013062865/18.
(130077954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Blackfont Group S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 138.883.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue le 6 mai 2013 que les admi-
nistrateurs ALICE MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151921, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg),
BEATRICE MANAGEMENT S.A., (R.C.S. Luxembourg B151931, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) et CLAIRE
MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151898, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) ont été remplacés par
Monsieur Gabor Kacsoh (demeurant professionnellement à 7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg, Grand- Duché du
Luxembourg) avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013062861/17.
(130077865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Inmet Panama I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 107.525.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 168.740.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société du 22 avril 2013:
1. Le mandat de Madame Sunny LOWE, Gérant de la Société, n'a pas été renouvelé.
2. Madame Karen TYLER, née le 7 décembre 1973 à Francfort (Allemagne) et demeurant professionnellement au 330,
Bay Street, M5H 2S8, Toronto, Ontario, Canada, a été nommée Gérant de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à
l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2014.
3. Les mandats de Gérants de Monsieur Emmanuel REVEILLAUD, Monsieur Fredy THYES et Monsieur Philippe SAL-
PETIER ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 16 mai 2013.
Référence de publication: 2013063141/19.
(130078323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Inmet Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.271.
EXTRAIT
Il résulte de la fusion entre la société mère de la Succursale, INMET MINING CORPORATION et FQM (Akubra) Inc.
que la société FQM (Akubra) Inc., issue de cette fusion, ayant son siège au 333 Bay Street, Suite 2400, Toronto M5H 2T6,
Ontario, Canada, enregistrée auprès du Canada Business Corporation Acts sous le numéro 848352-3 est désormais la
société mère de la Succursale.
75442
L
U X E M B O U R G
Les personnes ayant le pouvoir d'engager la société FQM (Akubra) Inc. sont:
- Philip PASCALL, administrateur, né le 2 décembre 1947 à Harare (Zimbabwe), résidant au 52, Irvine Street, Pep-
permint Grove, Western Australia, 6011, Australie.
- Christopher LEMON, administrateur, né le 28 janvier 1965 à Blackburn, Royaume-Uni, résidant au 5, The White-
house, Prince Albert Drive, Ascot, Berkshire, SL5 8AG, Royaume-Uni.
- Sharon LOUNG, administrateur, née le 11 février 1959 à Georgetown, Guyane, résidant au 2289 Lakeshore Blvd.
W, Toronto, Ontario, M8V 3Y2, Canada.
- Martin R. ROWLEY, administrateur, né le 14 décembre 1954 à Perth, Australie, résidant au 19 Canning Beach Road,
Applecross, Western Australia, 6153, Australia.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2013.
Référence de publication: 2013063140/23.
(130077406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Immo 55 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 1, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 138.626.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013063138/10.
(130077661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
IDR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 177.226.
STATUTS
L'an deux mille treize,
le treize mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
ont comparu:
1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199);
2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois,
établie et ayant son avec siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 97164).
Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.-sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Philippe LECLERC, employé privé, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Ber-
trange,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), le 07 mai 2013.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte con-
stitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: «IDR
S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
75443
L
U X E M B O U R G
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion de ses actifs immobiliers et également l'exploitation et l'investissement dans
des droits de propriété intellectuelle (brevet, marques, dessins) au sens large.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150'000. EUR) représenté par mille
(1'000) actions ordinaires d'une valeur nominale de CENT CINQUANTE EUROS (150.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée
par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires,
les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par
un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'adminis-
trateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition
qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.
Art. 7. Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président,
l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les adminis-
trateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois
derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
75444
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou
autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée
(s) par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un
administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le troisième vendredi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées
générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième (1/10ième) du capital social le demandent.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2013.
2,- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mai 2014.
<i>Souscriptioni>
Les mille (1'000) actions ordinaires ont été souscrites comme suit:
1.- La société «PROCEDIA S.à r.l.», prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- La société «CRITERIA S.à r.l.», prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
TOTAL: MILLE actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'000
75445
L
U X E M B O U R G
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199), Monsieur Gabriel JEAN, agira en tant que représentant per-
manent;
2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164), Madame Catherine DE WAELE, agira en tant que représentant
permanent;
3.- Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, avec adresse professionnelle au 10B rue
des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
En conformité avec l'article sept (7) des statuts de la Société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, est désigné premier
président du présent conseil.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
«MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise aux lois luxembourgeoises,
établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
145 419).
<i>Troisième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2019.
<i>Cinquième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec Nous le notaire instrumentant
le présent acte.
Signé: P. LECLERC, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 mai 2013. Relation: EAC/2013/6215. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2013063136/183.
(130078230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
75446
L
U X E M B O U R G
Investam, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 151.482.
EXTRAIT
Il résulte de la cession de parts intervenue en date du 18 mars 2013 que:
La société CHATEAUNEUF FINANCE, société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 35,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France a cédé 125 parts sociales qu'elle détenait dans la société INVESTAM ayant son
siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, à la société STAM EUROPE société par actions simplifiée
de droit français, ayant son siège social au 35, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France.
Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société INVESTAM en date du 18 mars 2013 conformément
à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Suite à cette cession, le capital social de la société INVESTAM est détenu comme suit:
- STAM EUROPE ayant son siège social au 35, Avenue de l'Opéra, 75002 Paris, France: 125 parts sociales
Luxembourg, le 16 mai 2013.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2013063147/20.
(130078099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 56.096.136,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.713.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 30 avril 2013i>
L'associé unique de JCF FPK I AIV ITB S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A, une société incorporée le 29 aout 1991, régie par les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B37974, en tant que Gérant de classe B de la Société et ce
avec effet au 2 Mai, 2013 pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 15 Mai 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013063152/17.
(130077506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
IBC Ugod Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 140.467.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue le 8 mai 2013 que les admi-
nistrateurs ALICE MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151921, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg),
BEATRICE MANAGEMENT S.A., (R.C.S. Luxembourg B151931, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) et CLAIRE
MANAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg B151898, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg) ont été remplacés par
Monsieur Gabor Kacsoh (demeurant professionnellement à 7, place du Théâtre, 2613 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg) avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013063133/17.
(130078101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
75447
L
U X E M B O U R G
Investcredit SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.409.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2013:i>
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 15 mai 2013, que Messieurs
José Luis Dorado, Carlos Fernández-Rubies de Lillo, Sergi Martin Amoros, Andrés Roldan Cubas, Ventura Vidal Flinch et
Carlo Alberto Montagna ont été réélus en leur qualité d'administrateur de la Société pour une période d'un an se terminant
lors de l'assemblée générale se tenant en 2014 et que KPMG Audit S.à r l. Luxembourg a été réélu en sa qualité de réviseur
d'entreprise de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2013.
<i>Pour INVESTCREDIT SICAV
i>Banque de Patrimoines Privés
Référence de publication: 2013063130/17.
(130077883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Intent Ventures Parallel S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 2.320.001,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 177.166.
Dans l'acte "Limited Liability Partnership Agrement" daté du 26 Mars 2013, il a été décidé d'augmenter le capital social
de la société pour le porter du montant de EUR 2.070.001, - à EUR 2.320.001,-: Mr Vittorio Massone, demeurant à
Johannesburg (République d'Afrique du Sud), 12 Killarney Road Hyde Park, a souscrit un montant de EUR 250.000,- pour
250.000 parts d'Associé commanditaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2013063128/18.
(130078200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Luxcare S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 24.351.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 16 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
- la société anonyme LUXCARE S.A., avec siège social à L-2314 Luxembourg, 2a, place de Paris, dénoncé en date du
1
er
juin 2010; B24351
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Martine LEYTEM, premier juge au tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Steve HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Maître Steve HOFFMANN
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2013063201/19.
(130077968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
75448
L
U X E M B O U R G
IBC Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 107.754.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 mai 2013.
Référence de publication: 2013063132/10.
(130077681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Iberint S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 27.857.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Laurence MOSTADE. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2018.
Luxembourg, le 19 décembre 2012.
IBERINT S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013063134/15.
(130078090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Immobilière Building BE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 141.748.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMMOBILIERE BUILDING BE S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013063139/11.
(130078035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Kirchberg Development GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 162.497.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 4 avril 2013 que les décisions suivantes
ont été prises:
- Il a été décidé que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Werner Weynand, demeurant profession-
nellement 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, a été renouvelé pour un an et ce
jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014 et qui statuera sur l'approbation des comptes au 31 décembre
2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 15 mai 2013.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013063164/18.
(130077588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
75449
L
U X E M B O U R G
Kilderkin S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 168.973.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 10 mai 2013i>
Le siège social de la société est transféré du 40 Avenue Monterey, L - 2163 Luxembourg au 15 - 17 Avenue Gaston
Diderich, L - 1420 Luxembourg avec effet au 2 Mai 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013063163/11.
(130078349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Kosmo Luxembourg Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.982.
En date du 23 avril 2013, l'Actionnaire unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Révocation de Robert van 't Hoeft de son poste de Président du conseil d'administration;
- Nomination de Johannes Laurens de Zwart, né le 19 juin 1967 à 's- Gravenhage, Pays- Bas, ayant pour adresse
professionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Luxembourg, au poste de Président du conseil d'ad-
ministration avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2012, et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kosmo Luxembourg Holdings S.A.
Paul Galliver
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013063165/17.
(130077860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Kosmoline S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 1, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 147.634.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013063166/10.
(130077660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Kazanorgsintez S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 110.183.
Il résulte de la décision prise par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société en date du 8 mai 2013:
- le renouvellement du mandat de L'Alliance Révision S.à r.l en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la Société avec
effet immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir
en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2013.
<i>Pour la Société
i>Florence Rao
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013063161/16.
(130077547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
75450
L
U X E M B O U R G
KPI III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.106.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 mai 2013.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2013063179/11.
(130077484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
KP Interiors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.528.
EXTRAIT
Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 15 mai 2013 que KP RSL S.à r.l., transfère une (1) part social qu'elle
détient dans la Société à Key Plastics L.L.C., une Limited Liability Company, enregistré au Bureau of Commercial Services,
Michigan, sous le numéro B07-062, avec siège social au 21700, Haggerty Road, Suite 100N, 48167 Northville, Michigan,
Etats-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2013.
Référence de publication: 2013063176/14.
(130077915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
KP RSL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.529.
EXTRAIT
Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 15 mai 2013 que Wayzata Opportunities Fund Offshore II, L.P.,
transfère toute les parts sociales (8) qu'elle détient dans la Société à Key Plastics LLC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2013.
Référence de publication: 2013063177/12.
(130077871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
HSH Investment Holdings FSO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 188.150,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.592.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 3 mai 2013i>
L'associé unique de HSH Investment Holdings FSO S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A, une société incorporée le 29 août 1991, régie par les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B37974, en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au
2 Mai, 2013 pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 15 Mai 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013063123/17.
(130077467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
75451
L
U X E M B O U R G
HSH Investment Holdings Coinvest-C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 212.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.591.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 30 avril 2013i>
L'associé unique de HSH Investment Holdings Coinvest-C S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Luxembourg Corporation Company S.A, une société incorporée le 29 août 1991, régie par les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 20, rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B37974, en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au
2 Mai, 2013 pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 15 Mai 2013.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013063122/17.
(130077457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Générale d'Hôtellerie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Luxembourg, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 25.464.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'administration réuni en date du 14 mai 2013 que:
- La convention de domiciliation conclue avec la société ECOGEST S.A. est résiliée de commun accord.
- Le siège social de la Société est transféré Route de Trèves à L-2632 Luxembourg.
- Monsieur Philippe CANU est révoqué de son poste de directeur.
- Madame Rosa-Maria CABRINETTY épouse BRIXHE, sous-directrice, née le 24 mars 1976 à Metz (France), demeurant
27, rue de Metz à F-57650 Fontoy, est nommée au poste de directrice de la Société, pour une durée indéterminée.
Madame Rosa-Maria CABRINETTY épouse BRIXHE sera chargée de la gestion technique et journalière de la Société
et pourra à cet effet valablement engager la Société par sa signature conjointe avec celle d'un administrateur.
- Le Conseil d'administration prend acte du décès de l'administrateur Monsieur Robert MOLINARI.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2013.
<i>Le Conseil d'Administration
i>André COINTET / Jean-Pierre HÉLAINE / Dan EPPS
<i>Président du Conseil d'Administration / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013064672/22.
(130079793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
Generali Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 86.432.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2013i>
En date du 30 avril 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Amerigo Borrini en tant qu'administrateur avec effet au 3 mai 2012,
- d'accepter la démission de Monsieur Luca Passoni en tant qu'administrateur avec effet au 16 avril 2013.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Generali Investments Sicav
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2013064661/15.
(130079399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
75452
L
U X E M B O U R G
Golden Flax Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.115.
EXTRAIT
Le nouveau nom de l'associé Elisavelio Holdings Limited, est désormais le suivant:
GOLDEN FLAX LIMITED
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2013064665/14.
(130079396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
Game Garden Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 171.045.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 mai 2013 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services Sàrl
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013064669/18.
(130079899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
FRBL022011 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 159.077.
EXTRAIT
Il résulte des décisions des Associés de la Société prise en date du 6 mars 2013 que:
- Monsieur Julien LAGREZE, né le 29 août 1977 à Marignane (France), demeurant à Chemin de l'Anglais, 1, F-13590
Meyreuil (France) a été nommé gérant de type A de la Société avec effet au 1
er
mars 2013 et ce pour une durée
indéterminée.
- La démission de Monsieur Luc GERONDAL de son poste de gérant de type B a été acceptée, avec effet au 6 mars
2013.
- Monsieur Patrick MOINET, né le 6 juin 1975 à Bastogne (Belgique), demeurant au 156 rue Albert Unden, L-2652
Luxembourg , a été élu gérant de type B, avec effet au 6 mars 2013 et pour une durée indéterminée.
La société prend acte que Monsieur Benoît BAUDUIN, gérant de type B, réside dorénavant professionnellement au
16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013064654/22.
(130079706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
75453
L
U X E M B O U R G
Framel Net S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 73, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 147.434.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013064653/10.
(130079453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
Frog Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 115.233.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 16 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société anonyme FROG PARTICIPATIONS SA, avec siège social à L-2522 Luxembourg,
6, rue Guillaume Schneider, dénoncé en date du 21 décembre 2010.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Martine LEYTEM, et liquidateur Maître Christilla MARTINOT,
Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire déclaration de leurs créances avant le 6 juin 2013 au greffe de la sixième section
de ce Tribunal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Maître Christilla MARTINOT
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013064655/21.
(130079805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
Shing Shuan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 56, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 56.815.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013065004/9.
(130080300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
T.T.V. Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.123.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 mai 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 mai 2013 que:
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Fransceco Abbruzzese de son mandat d'administrateur avec effet
au 21 septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
T.T.V. FINANCES S.A.
Référence de publication: 2013065037/14.
(130079842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
75454
L
U X E M B O U R G
SDL Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 192.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 123.059.
Par résolutions signées en date du 17 mai 2013, l'associé unique a décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Gérard Becquer de son mandat de gérant avec effet au 14 mai 2013 et de
nommer Peggy Murphy, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant,
avec effet au 14 mai 2013, et pour une durée indéterminée.
- De modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 6 rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg au 3
rue Mozart, L-2166 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
Référence de publication: 2013064999/16.
(130079802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
SCG STE Maurice 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 90.612.
Par résolutions signées en date du 17 mai 2013, l'associé unique a décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Gérard Becquer de son mandat de gérant B avec effet au 14 mai 2013 et de
nommer Peggy Murphy, avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant
B, avec effet au 14 mai 2013, et pour une durée indéterminée.
- De modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 6 rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg au 3
rue Mozart, L-2166 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2013.
Référence de publication: 2013064996/16.
(130080004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
StarCap SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 72.359.
<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung StarCap SICAVi>
Die Ordentliche Generalversammlung vom 21. Mai 2013 der StarCap SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:
Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich:
Herr Julien Zimmer (Vorsitzender)
Herr Bernhard Singer (Mitglied)
Herr Holger Gachot (Mitglied)
Herren Zimmer und Singer mit Geschäftsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
Herr Gachot mit Geschäftsadresse 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Die genannten Personen werden einstimmig von den Aktionären bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
im Jahr 2014 in den Verwaltungsrat gewählt.
Die Aktionäre beschließen, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung PricewaterhouseCoopers Société
coopérative, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.
Luxembourg, den 21. Mai 2013.
<i>Für StarCap SICAV
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2013064979/22.
(130079848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2013.
75455
L
U X E M B O U R G
GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.962.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.673.
<i>Rectificatif du dépôt L130036125i>
En date du 19 février 2013, les Associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
- Révocation de Robert van't Hoeft, du poste de gérant B;
- Révocation de Martinus Cornelis Johannes Weijermans, du poste de gérant B.
Suite aux décisions susmentionnées, Poul Lund CHRISTENSEN, gérant de catégorie A, étant le seul gérant, a un pouvoir
de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013062335/18.
(130077118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Hattersley Centre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 158.126.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de vente de parts sociales signé en date du 25 avril 2013 que:
- la société Prevprop Properties SA, ayant son siège social au 5, rue Xavier Brasseur, L-4040 Esch-sur-Alzette, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B104.403, a vendu 148.473.564
(cent quarante-huit millions quatre cent soixante-treize mille cinq cent soixante-quatre) parts sociales, représentant l'en-
tièreté du capital social de la Société, à Linda Susan Mackie, née le 26 juillet 1945 à Birmingham, Royaume-Uni, résidant
au 6, Chemin de Cyrano, 1009 Pully, Suisse.
Par conséquent, Linda Susan Mackie est l'associée unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Hattersley Centre S.à r.l.
Référence de publication: 2013062349/18.
(130076637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Imperial Innovations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 31.126,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.293.
Avec effet au 22 avril, 2013 Monsieur Russell Cummings, ayant son adresse professionnelle au, 52 Princes Gate, Ex-
hibition Road, SW7 2PG London, Royaume-Uni et né le 6 juin 1964 à North Shields, Royaume-Uni a été nommé Gérant
Classe A de la Société pour une durée indéterminée.
Avec effet au 22 avril, 2013 Madame Susan Searle, ayant son adresse professionnelle au, 52 Princes Gate, Exhibition
Road, SW7 2PG London, Royaume-Uni et née le 6 avril 1963 à Amersham, Royaume-Uni a été nommé Gérant Classe A
de la Société pour une durée indéterminée.
Egalement avec effet au 22 avril, 2013 Monsieur Julian Smith a démissionné de son mandat de gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2013.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013062364/18.
(130076936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
75456
Arrcom Finance Holding S.A.
Blackfont Group S.A.
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Boca S.à r.l.
Box Lines - Transportes Internacionais S.à r.l.
Bufab S.à r.l.
Degomex Holding Sàrl
Discovery A S.à r.l.
Doosan Power Systems S.A.
Dynamic Materials Luxembourg 2 S.à r.l.
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.
Fagus Multimanager
Finamore S.A.
Framel Net S.A.
FRBL022011 S.à r.l.
Frog Participations S.A.
Game Garden Company S.A.
Générale d'Hôtellerie S.A.
Generali Investments SICAV
GlobalSantaFe Financial Services (Luxembourg) S.à r.l.
Golden Flax Sàrl
Hattersley Centre S.à r.l.
HSH Investment Holdings Coinvest-C S.à r.l.
HSH Investment Holdings FSO S.à r.l.
IBC Lux Sàrl
IBC Ugod Luxembourg S.A.
Iberint S.A.
IDR S.A.
Immo 55 S.A.
Immobilière Building BE S.A.
Imperial Innovations S.àr.l.
Inmet Luxembourg
Inmet Panama I S.à r.l.
Intent Ventures Parallel S.C.S.
Investam
Investcredit SICAV
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l.
Kazanorgsintez S.A.
Kilderkin S.à r.l.
Kirchberg Development GP S.à r.l.
Kosmoline S.A.
Kosmo Luxembourg Holdings S.A.
KPI III S.à r.l.
KP Interiors S.à r.l.
KP RSL S.à r.l.
Luxcare S.A.
SCG STE Maurice 2 S.àr.l.
SDL Investments I S.à r.l.
Shing Shuan S.A.
StarCap SICAV
T.T.V. Finances S.A.