This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1550
28 juin 2013
SOMMAIRE
Aero International Finance S.A. . . . . . . . . .
74356
Aero International Finance S.A. . . . . . . . . .
74356
Agemat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74356
Akka Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74357
Alcoa Global Treasury Services S.à r.l. . . .
74356
Alcoa Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
74357
AMP Capital Investors (IDF No. 1) S.A. . .
74357
AMP Capital Investors (IDF No. 2) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74357
Avior S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74357
Barkingside S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74357
Belplant A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74358
Bousval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74358
Braiwait Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
74358
Cemira Investments A.G. . . . . . . . . . . . . . . .
74358
Cemira Investments A.G. . . . . . . . . . . . . . . .
74358
Centre de Recherche Public de la Santé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74358
Cinatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74359
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
74359
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
74360
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
74359
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
74359
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
74359
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
74359
COFRA Luxembourg s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
74399
Compagnie des Châteaux d'Europe Cen-
trale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74360
Conect Software Engineering S.à r.l. . . . . .
74360
Consolidation Company Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74360
CP Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
74360
CVI Global Lux Oil and Gas 2 S.à r.l. . . . . .
74360
CVI Global Lux Oil and Gas 4 S.à r.l. . . . . .
74361
Dachtechnic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74361
DD Productions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
74361
Delfzijl S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74361
Dodol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74361
Domange Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
74354
Eneris Wind Italia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74361
Gaia Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . .
74372
Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74374
Hamburg Harburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74362
Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . .
74375
Henderson Property Management Com-
pany (Luxembourg) No. 1 S.à r.l. . . . . . . .
74391
HeritageWealth SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .
74399
Herman International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
74380
Herman International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
74380
Homeschlach SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74386
ICG EFV Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
74376
IK Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . .
74400
JP Commercial 17 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
74392
Kedi 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74388
LYXOR Synopsis Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74370
Makemake Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
74362
Neutral Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
74354
NeXgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74400
Société Financière Himmesoete . . . . . . . . .
74355
Terelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74400
TRANSES Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
74355
Victoria Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74355
VIC-WIN A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74355
Wallace Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .
74356
Wenkelhiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74355
Wiesbaden (Bridge) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
74355
YV Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74400
Zama (Windhoek) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
74356
74353
L
U X E M B O U R G
Neutral Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 49.151.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012, tenue en
date du 25 avril 2013, que:
Suite à la démission en qualité d'Administrateur de catégorie A de:
- Monsieur Gerhard NIGGLI
Est élu nouvel Administrateur de catégorie A, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire, jusqu'à l'Assem-
blée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2018:
- Monsieur Francesco Maria RENNE, né le 09 novembre 1966 à Como (Italie), demeurant Via Zara 19, I-21100 Varese
(Italie)
Sont réélus Administrateurs de catégorie différentes, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2018:
- Monsieur Claudio SULSER, né le 08 octobre 1955 à Lugano (Suisse), demeurant au 13A, via del Sole, CH-6963
Pregassona, en qualité d'Administrateur de catégorie B,
- Monsieur Marius ANDRE, né le 27 février 1955 à Harlem (Pays-Bas), demeurant au 6, Fordaan, NL-1405 Bussum,
en qualité d'Administrateur de catégorie B,
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de catégorie A,
- Monsieur Thierry JACOB, né le 07 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de catégorie C,
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de catégorie C.
Pouvoir de signature: Conjointe à trois Administrateurs, un de catégorie A, un de catégorie B, un de catégorie C.
Est réélu Président du Conseil d'Administration, pour la même période:
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg
Est réélu Réviseur d'entreprises agréé, pour la même période:
- ERNST & YOUNG SA., avec siège social au 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 25 avril 2013.
Référence de publication: 2013059747/36.
(130072974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Domange Participations S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 156.965.
<i>Extrait du conseil d'administration du 28 mars 2013i>
Suite au décès de Monsieur Patrick ROCHAS en date du 20 novembre 2012, le conseil décide de coopter Madame
Aida FERREIRA, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, comme nouvel admi-
nistrateur en remplacement du défunt Monsieur Patrick ROCHAS.
Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2016.
L'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.
D'autre part, le Conseil d'Administration constate que la dénomination sociale de son Commissaire aux comptes
Mazars, société enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B56248, a été modifiée
en FIDUO avec effet au 1
er
juillet 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2013061453/18.
(130076255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
74354
L
U X E M B O U R G
TRANSES Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 93.975.
Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062695/9.
(130076726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Société Financière Himmesoete, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 156.731.
Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062645/9.
(130076810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Wenkelhiel, Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 123-125, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 105.149.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062733/9.
(130076753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
VIC-WIN A.G., Société Anonyme.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.661.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062720/9.
(130077336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Victoria Business S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 154.588.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062721/9.
(130077085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Wiesbaden (Bridge) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 119.217.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062729/9.
(130076593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
74355
L
U X E M B O U R G
Wallace Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.319.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062731/9.
(130076844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Zama (Windhoek) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 111.375.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062742/9.
(130076595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2013.
Alcoa Global Treasury Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 106.168.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062771/9.
(130077608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Aero International Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 32.378.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062790/9.
(130077393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Aero International Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 32.378.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062791/9.
(130077394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Agemat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6689 Mertert, Scheidberg.
R.C.S. Luxembourg B 65.566.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062794/9.
(130077709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
74356
L
U X E M B O U R G
Akka Development, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.
R.C.S. Luxembourg B 154.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062799/9.
(130078187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Alcoa Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 90.117.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062801/9.
(130077625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
AMP Capital Investors (IDF No. 1) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.071.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062807/9.
(130078259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
AMP Capital Investors (IDF No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.083.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062808/9.
(130078262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Avior S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 89.219.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062829/9.
(130077491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Barkingside S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 59.004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062853/9.
(130077735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
74357
L
U X E M B O U R G
Belplant A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 47, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.287.
Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062855/9.
(130077643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Bousval S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.844.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062870/9.
(130077383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Braiwait Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 118.337.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062872/9.
(130078258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Centre de Recherche Public de la Santé, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 84, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg J 34.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062894/9.
(130078000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Cemira Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.062.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062932/9.
(130077964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Cemira Investments A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.062.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062933/9.
(130077976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
74358
L
U X E M B O U R G
Cinatel, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 140.926.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062945/9.
(130077714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 133.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062948/9.
(130077515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 133.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062949/9.
(130077516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 133.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062950/9.
(130077517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 133.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062951/9.
(130077518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 133.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062952/9.
(130077540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
74359
L
U X E M B O U R G
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Triangle Vert.
R.C.S. Luxembourg B 133.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062953/9.
(130077541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Compagnie des Châteaux d'Europe Centrale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Zone Industrielle Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 124.367.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062958/9.
(130077556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Conect Software Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 96.926.
Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062960/9.
(130077644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Consolidation Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 67.384.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062962/9.
(130078179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CP Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 250.000,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 170.034.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062968/9.
(130077404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
CVI Global Lux Oil and Gas 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 140.886.
Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062977/9.
(130077663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
74360
L
U X E M B O U R G
CVI Global Lux Oil and Gas 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.051.
Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062978/9.
(130077664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Dachtechnic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 74.376.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062990/9.
(130077546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
DD Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 142.457.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062994/9.
(130078195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Delfzijl S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 112.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013062996/9.
(130078033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Dodol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 88.345.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013063006/9.
(130078399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
Eneris Wind Italia SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013063013/9.
(130077683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2013.
74361
L
U X E M B O U R G
Hamburg Harburg, Société Anonyme.
Capital social: EUR 68.600,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 123.944.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 03/12/2012i>
L'Assemblée décide de:
- Renouveler le mandat des Administrateurs suivants avec effet à partir du 03 décembre 2012:
* Brian Conroy, en tant qu'Administrateur de type A;
* Andrew Whitty, en tant qu'Administrateur de type A;
* Bastow Charleton S.à r.l., en tant qu'Administrateur de type B.
Durée du mandat pour les trois administrateurs: jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013059579/16.
(130073540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Makemake Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 177.065.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of the month of April.
Before us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of
the present deed.
There appeared:
BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered
office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 164.012,
represented by Me Joe Zeaiter, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 26 April 2013, which
shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Makemake Topco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Makemake Topco
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
74362
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-)
represented by seven hundred and fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each. The
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers has, the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
74363
L
U X E M B O U R G
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2013.
74364
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 2002, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of
shares
Subscription
price (GBP)
BRE/Europe 6Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 GBP 15,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 GBP 15,000.-
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 164.777,
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am dreißigsten Tag des Monats April.
74365
L
U X E M B O U R G
Vor Uns, dem unterzeichneten Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung
von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer in Verwahrung vorliegender Urkunde
bleibt.
Ist erschienen,
BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-) beträgt, und eingetragen ist im luxemburgischem Handels-und Gesellschaftsregister (Registre de com-
merce et des sociétés) unter der Nummer B 164.012,
hier vertreten durch Herrn Joe Zeaiter, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht
vom 26. April 2013, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht
zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Makemake Topco S.à r.l."(société à responsabilité limitée) wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Makemake Topco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-
rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts-und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend
Pfund Sterling (GBP 15.000,-), eingeteilt in siebenhundertundfünfzig (750) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von
je zwanzig Pfund Sterling (GBP 20,).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
74366
L
U X E M B O U R G
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers im Falle eines alleinigen Geschäftsführers
und durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft
ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, be-
ziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.
Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,
Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
74367
L
U X E M B O U R G
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; (iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht
unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2013 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
74368
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(GBP)
BRE/Europe 6Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
GBP 15.000,-
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.200,-betragen.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: J. ZEAITER und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2013. Relation: LAC/2013/20368. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 10. Mai 2013.
Référence de publication: 2013060890/425.
(130074484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
74369
L
U X E M B O U R G
LYXOR Synopsis Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.488.
In the year two thousand thirteen, on the twenty-ninth of April
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of "LYXOR Synopsis Fund", a public limited company (société
anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable)
having its registered office in L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, recorded in the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 82.488, incorporated pursuant to a notarial deed dated 20 June 2001, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 557 of 21 July 2001 (the "Company").
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated
9 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2777 of 17 December
2010.
The meeting was opened at 3.00 p.m. with Mr Grégoire GILFRICHE, employee, residing professionally in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Mrs Hélène SUBTIL, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Karine NARDINI, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the present general meeting was convening by registered mail sent on the 11 April 2013.
II. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Replacement of (i) all references in the articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation")
to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the "2002 Law"), by a reference to
the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law") and of (ii) all references
to specific articles of the 2002 Law by references to the relevant articles of the 2010 Law.
2. Amendment to the last paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation by the inclusion of a reference to
the Dodd Franck act and the possibility for the board of directors to require the mandatory repurchase from any US
person to comply with the terms of the Dodd Franck act, such that the two last sentences of the last paragraph of article
10 of the Articles of Incorporation shall read as follows (changes appear in bold): "Under the Investment Company Act
of 1940 (as amended by the Dodd-Franck Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 21 July 2011), if any U.S.
person holds one or more share(s) of the Company, the Company will have to report certain data in a Form ADV to
the SEC or will have to procure that such data be reported to the SEC. To ensure the ninety investors limit is maintained
or to benefit from exemption (including but not limited to exemption of such reporting to the SEC) under US Law and
Regulations, the board of directors may decline to register a transfer of shares to or for the account of any U.S. person
and may require the mandatory repurchase of shares beneficially owned by U.S. persons."
3.- Amendment of paragraph 3 of article 16 to reflect article 70 of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended such that such paragraph reads as follows (changes appear in bold): "It may also be called upon the request
of shareholders representing at least one tenth of the share capital."
4.- General update of the Articles of Incorporation, amending inter alia articles 3, 5, 31, 32, 35, 36, 39 et withdrawal
of the French translation as permitted by the Law of 17 December 2010.
III.- That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders
of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
IV.- That it results from the attendance list that out of 2,451,796.766 shares, 98,804 shares are present or represented
at the present general meeting.
V.- That a first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 28 February 2013 where the
quorum conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.
The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present
or represented.
VI.- As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.
Then the general meeting, after deliberation, takes the following resolutions:
74370
L
U X E M B O U R G
<i>First resolution:i>
The general meeting resolves to replace all references in the Articles of Incorporation to the 2002 Law by a reference
to the 2010 Law.
Subsequently, the general meeting resolves to amend paragraph 2 of article 3, paragraph 4 of article 5, paragraph 2 of
article 31, article 32, paragraphs 1 to 3 of article 35, paragraph 7 of article 36 and article 39 of the Articles of Incorporation
so as to give them henceforth the following wording:
" Art. 3. Corporate object. (second paragraph). The Company may take any measures and carry on any operations
which it may deem useful for the accomplishment and development of its object in the broadest sense permitted by Part
II of the Luxembourg law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment as may be amended from
time to time.»
" Art. 5. Share capital. (fourth paragraph). The board of directors may establish several portfolios of assets, each
constituting a sub-fund (a "Sub-Fund") within the meaning of Article 181 of the Luxembourg law dated 17 December 2010
on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time."
" Art. 31. Custodian and Other contractual parties. (second paragraph). The Company shall enter into a custodian
agreement with a bank or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended
(hereinafter referred to as the "Custodian"). The Custodian shall satisfy the requirements of the Luxembourg law dated
17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time. All assets of the
Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders
the responsibilities provided by law."
" Art. 32. Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be
supervised by an auditor ("réviseur d'entreprise agréé") who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to
respectability and professional experience and who shall perform the duties foreseen by the Luxembourg law dated 17
December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time. The auditors shall be
elected by the general meeting of shareholders."
" Art. 35. Dissolution and Liquidation of the Company. (paragraphs 1 to 3). The Company may at any time be dissolved
by a resolution taken by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined
in Article 17 hereof and in the Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective invest-
ment, as may be amended from time to time.
Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 17
December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time, the board of directors
has to submit the question of the dissolution of the Company to the shareholders in a general meeting which shall
deliberate without that a quorum shall be required and which shall decide on simple majority of the validly cast votes.
The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever
the capital fall below one quarter of the minimum capital as provided by the Luxembourg law dated 17 December 2010
on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time; in such event the general meeting shall
be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders holding one quarter of
the validly cast votes."
“ Art. 36. Dissolution and Merger of Sub-Funds or classes of shares. (seventh paragraph). Under the same circumstances
as provided in the first paragraph of this Article 36, the board of directors may decide to allocate the assets of any class
or Sub-Fund to those of another existing class or Sub-Fund within the Company or to another UCI organized under the
provisions of Part I or Part II of the Luxembourg law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment,
as may be amended from time to time (the "New class/Sub-Fund") and to redesignate the shares of such class or Sub-
Fund as shares of the New class/Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount
corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as
described in the first paragraph of this Article 36 (and, in addition, the publication will contain information in relation to
the New class/Sub-Fund), one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable share-
holders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period."
" Art. 39. General provisions. (first paragraph). All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be
determined in accordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial
companies and the Luxembourg law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be
amended from time to time."
This resolution is adopted by 98,804 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 0 abstention(s).
<i>Second resolution:i>
The general meeting resolves to amend last paragraph of article 10 of the Articles of Incorporation so as to give it
henceforth the following wording:
74371
L
U X E M B O U R G
" Art. 10. Limitation to the ownership of shares. (last paragraph). The Company will not be registered under the United
States Investment Company Act of 1940. Based on interpretations of the Investment Company Act by the staff of the
United States Securities and Exchange Commission (the "SEC") relating to foreign investment companies, if the Company
has more than one hundred beneficial owners of its securities who are U.S. persons, it may become subject to the
registration requirements under the Investment Company Act. The Directors will not knowingly permit the number of
holders of shares who are U.S. persons to exceed ninety (or such lesser number as the directors may determine). Under
the Investment Company Act of 1940 (as amended by the Dodd-Franck Wall Street Reform and Consumer Protection
Act of 21 July 2011), if any U.S. person holds one or more share(s) of the Company, the Company will have to report
certain data in a Form ADV to the SEC or will have to procure that such data be reported to the SEC. To ensure the
ninety investors limit is maintained or to benefit from exemption (including but not limited to exemption of such reporting
to the SEC) under US Law and Regulations, the board of directors may decline to register a transfer of shares to or for
the account of any U.S. person and may require the mandatory repurchase of shares beneficially owned by U.S. persons."
This resolution is adopted by 98,804 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 0 abstention(s).
<i>Third resolution:i>
The general meeting resolves to amend paragraph 3 of article 16 of the Articles of Incorporation so as to give it
henceforth the following wording:
" Art. 16. Annual general shareholders' meeting. (third paragraph). It may also be called upon the request of share-
holders representing at least one tenth of the share capital."
This resolution is adopted by 98,804 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 0 abstention(s).
<i>Fourth resolution:i>
The general meeting resolves to amend first sentence of paragraph 15 of article 10 of the Articles of incorporation so
as to give it henceforth the following wording: "The shares have not been and will not be registered under the United
States Securities Act of 1933 (as amended) (the "1933 Act") or the securities laws of any of the states of the United States
of America'" and to withdraw the French translation of the Articles of Incorporation as permitted by 2010 Law.
This resolution is adopted by 98,804 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 0 abstention(s).
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the
present deed is worded in English.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the
present deed.
Signé: G. GILFRICHE, H. SUBTIL, K. NARDINI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2013. LAC/2013 /20035. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 10 mai 2013.
Référence de publication: 2013060887/150.
(130074722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Gaia Fund S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.097.
In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth of April.
Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GAIA FUND S.A., SICAV-SIF, a société anonyme
qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, having its registered office at
Luxembourg, registered to the Luxembourg Trade and Companies' Register, under the number B 128097, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on the 9
th
May 2007, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number
1167 of June 15, 2007.
The meeting was opened with Mr Hugues de Monthébert, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in
the chair, who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sarah Schneider, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
74372
L
U X E M B O U R G
- I.- That all the shares being registered shares, the present meeting has been convened by notices containing the
agenda sent to all the shareholders by registered mail on April 8, 2013.
II. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to put the Fund into liquidation;
2. Appointment of Mazars 10A, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg, as Liquidator
3. Decision to convene a second extraordinary general meeting of shareholders in order
- To acknowledge the audited financial statements for the period from 1
st
January 2012 to the 31
st
December 2012.
- To grant discharge to the board of directors for the period from 1
st
January 2012 to the 31
st
December 2012
- To acknowledge the audited financial statements for the period from the 1
st
January 2013 to the date of liquidation.
- To grant discharge to the board of directors for the period from 1
st
January 2012 to date of the liquidation.
- To hear the report of the Liquidator on the liquidation of the Fund.
- To receive the report of the Auditor on the liquidation of the Fund.
- To give discharge to the Liquidator.
- To decide on the close of the liquidation and to entrust the central administration with the safekeeping for a period
of 5 years of all accounting documents, books, registers and all other documents of the Fund.
- To decide on any other business which will be brought before the extraordinary general meeting.
III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
IV. - That pursuant to the attendance list, 2,500 shares out of 2,500 shares in circulation, i.e. all the outstanding shares,
are represented at the present meeting, so that the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the
items of the agenda.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation as of this day.
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to appoint Mazars Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg (RCS Luxembourg
B 159962), as Liquidator.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting
in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period they will fix.
The liquidator is authorised to pay a provision on the liquidating dividends to the shareholders according article 148
of the law on commercial companies.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to convene a second extraordinary general meeting of shareholders in order
- To acknowledge the audited financial statements for the period from 1
st
January 2012 to the 31
st
December 2012.
- To grant discharge to the board of directors for the period from 1
st
January 2012 to the 31
st
December 2012
- To acknowledge the audited financial statements for the period from the 1
st
January 2013 to the date of liquidation.
- To grant discharge to the board of directors for the period from 1
st
January 2012 to date of the liquidation.
- To hear the report of the Liquidator on the liquidation of the Fund.
- To receive the report of the Auditor on the liquidation of the Fund.
- To give discharge to the Liquidator.
74373
L
U X E M B O U R G
- To decide on the close of the liquidation and to entrust the central administration with the safekeeping for a period
of 5 years of all accounting documents, books, registers and all other documents of the Fund.
- To decide on any other business which will be brought before the extraordinary general meeting.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Signé: H. DE MONTHÉBERT, A. SIEBENALER, S. SCHNEIDER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2013. Relation: LAC/2013/18508. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 mai 2013.
Référence de publication: 2013060765/82.
(130075154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6350 Dillingen, 6, route de Beaufort.
R.C.S. Luxembourg B 148.001.
Im Jahre zweitausenddreizehn,
Den dreissigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,
Ist erschienen:
Herr Jan GRÄFF, Kaufmann, geboren in Kaiserslautern (Bundesrepublik Deutschland) am 17. April 1985, wohnhaft in
L-5441 Remerschen, 10, Wisswee,
hier vertreten durch Herrn Wei ZHANG, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-1129 Luxemburg, 6, rue des Ané-
mones, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 23. April 2013.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Paraphierung, der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert
zu werden.
Dieser Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, handelnd in seiner Eigenschaft als handelsrechtlicher Geschäfts-
führer und augenblicklich alleiniger Teilhaber der vorerwähnten Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Gewerbe-und
Wirtschaftsverlag S.àr.l.", mit Sitz in L-6350 Dillingen, 6, route de Beaufort, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
durch Notar Dr. Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, am 2. September 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 1860 vom 25. September 2009, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch
den vorgenannten Notar Dr. SECKLER, am 27. April 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 1095 vom 26. Mai 2010, sowie abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar am 15. Oktober 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2796 vom 17.
November 2012, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 148.001,
hat nachfolgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt die Auflösung und die in Liquidationssetzung der Gesellschaft „Gewerbe- und Wirt-
schaftsverlag S.àr.l." mit Wirkung auf den heutigen Tag.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter ernennt zum Liquidator der Gesellschaft Herrn Wei ZHANG, vorbenannt, mit den ausgedehn-
testen Befugnissen wie dies in den Artikeln 144-148bis des zusammengefassten Gesetzes über die Handelsgesellschaften
vorgesehen ist.
Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, ohne in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Geneh-
migung der Generalversammlung, in den Fällen wo diese vorgeschrieben ist, zurückgreifen zu müssen.
Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft
berufen.
Er kann für bestimmte Geschäfte, und unter seiner Verantwortung, seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-
sonen übertragen, für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.
Der Liquidator hat als Aufgabe die Aktiva zu realisieren und die Passiva zu bereinigen.
Der Liquidationsverwalter kann die sich in Liquidation befindliche Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift unein-
geschränkt verpflichten.
74374
L
U X E M B O U R G
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, ist die Versammlung aufgehoben.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt, dem Geschäftsführer umfassende und vollständige Entlastung für die Ausführung seines
Amtes zu geben, ab dem Zeitpunkt seiner Ernennung bis zum heutigen Tag.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter des Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet W. Zhang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 mai 2013. Relation: LAC / 2013 / 20403. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
Für gleichlautende Kopie.
Luxemburg, den 13. Mai 2013.
Référence de publication: 2013060766/56.
(130075371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 77.949.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 13 mars 2013.i>
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement de mandat des administrateurs suivants, ceci jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014:
Jeremy Vickerstaff
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich Luxembourg
Iain Clark
Bischopsgate 201
EC2M 3AE Londres
Royaume-Uni
Tony Sugrue
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich Luxembourg
Stewart Cazier
Bischopsgate 201
EC2M 3AE Londres
Royaume-Uni
Leslie Aitkenhead
24 The Avenue Hitchin
Hertfordshire SG4 9RL
Royaume-Uni
Steven de Vries
43-45 Roemer Visscherstraat
1054 EW Amsterdam
Pays Bas
Jean-Claude Wolter
11B Boulevard Joseph II
L1840 Luxembourg
2. Election des réviseurs d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2014:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Numéro d'immatriculation: B 65477
Fonction: Réviseur d'entreprise agréé
74375
L
U X E M B O U R G
Siege social de la personne morale:
400 Route D'Esch
L-1014 Luxembourg
Référence de publication: 2013060794/43.
(130074549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
ICG EFV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.460.855,00.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 163.939.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen on the twenty-eighth day of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of ICG EFV Luxembourg S.à
r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg under number B 163939, incorporated
by deed of the undersigned notary on 1 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 2882 of 25 November 2011, page 138290 (the "Company").
The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary,
of 29 December 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 5 March 2012, number
571, page 27406.
The meeting was opened by Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg,
being in the chair, who appointed as secretary Mr. Gérard Maitrejean, Juriste, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me. Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary
to state that:
1. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
a. Increase of the Company's share capital by an amount of Two Million Four Hundred and Forty-Eight Thousand Three
Hundred and Fifty-Five Euros (EUR 2,448,355.-) so as to raise it from its current amount of Twelve Thousand Five Hundred
Euros (EUR 12,500.-) currently represented by Twelve Thousand Five Hundred (12,500) shares (parts sociales) with a
nominal value of One Euro (EUR 1.-) each, to Two Million Four Hundred and Sixty Thousand Eight Hundred and Fifty-
Five Euros (EUR 2,460,855.-) through the issue of Two Million Four Hundred and Forty-Eight Thousand Three Hundred
and Fifty-Five (2,448,355) shares (parts sociales) with a nominal value of One Euro (EUR 1.-) each (the "New Shares");
b. Acceptance of the subscription for the New Shares as follows:
i. Two Million One Hundred and Twenty-Seven Thousand Eight Hundred and Forty (2,127,840) shares (parts sociales)
by ICG Europe Fund V No. 1 Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having its
registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered with the Companies
Registry of the Jersey Financial Services Commission (the "Jersey Registry") under number 1377, acting by its general
partner ICG Europe Fund V GP Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having
its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered with the Jersey
Registry under number 1374, itself acting by its general partner ICG Europe Fund V GP Limited, a company incorporated
under the laws of Jersey, having its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY
and registered with the Jersey Registry under number 107484 (the "ICG Fund V" - the "ICG Fund V Shares") and full
payment by ICG Fund V of the ICG Fund V Shares at nominal value, by converting capital reserves of a total amount of
Two Million One Hundred and Twenty-Seven Thousand Eight Hundred and Forty Euros (EUR 2,127,840); and
ii. Three Hundred and Twenty Thousand Five Hundred and Fifteen (320,515) shares (parts sociales) by ICG EFV Jersey
Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte
Street, St Heller, Jersey, JE2 4 SY and registered with the Companies Registry of the Jersey Financial Services Commission
under number 108.779 ("ICG Jersey" - the "ICG Jersey Shares") and full payment by ICG Jersey of the ICG Jersey Shares
at nominal value, by converting capital reserves of a total amount of Three Hundred and Twenty Thousand Five Hundred
and Fifteen Euros(EUR 320,515.-);
c. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 6.1 of the articles of association of the Company; and
d. Miscellaneous.
2. The appearing parties are shown on an attendance list, signed ne varietur by the proxyholder of the represented
parties, the member of the bureau and the undersigned notary, which will remain annexed to the present deed.
74376
L
U X E M B O U R G
3. As a result of the aforementioned attendance list, all the existing shares (parts sociales) in issue are represented at
the present General Meeting, which is consequently validly constituted and may validly deliberate and decide on the items
of the agenda.
4. The appearing parties represented at the meeting declares (i) to waive the convening notice for the meeting and (ii)
to be fully aware of all the items of the agenda.
The appearing parties requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of Two Million Four Hundred
and Forty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty-Five Euros (EUR 2,448,355.-) so as to raise it from its current amount
of Twelve Thousand Five Hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by Twelve Thousand Five Hundred (12,500) shares
(parts sociales) with a nominal value of One Euro (EUR 1.-) each, to Two Million Four Hundred and Sixty Thousand Eight
Hundred and Fifty-Five Euros (EUR 2,460,855.-) represented by Two Million Four Hundred and Sixty Thousand Eight
Hundred and Fifty-Five (2,460,855) shares (parts sociales) with a nominal value of One Euro (EUR 1.-) each and to issue:
A. Two Million One Hundred and Twenty-Seven Thousand Eight Hundred and Forty (2,127,840) shares (parts sociales),
to be fully paid up at nominal value of one Euro (EUR 1) each.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon appears ICG Europe Fund V No. 1 Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws
of Jersey, having its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered
with the Companies Registry of the Jersey Financial Services Commission (the "Jersey Registry") under number 1377,
acting by its general partner ICG Europe Fund V GP Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the
laws of Jersey, having its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered
with the Jersey Registry under number 1374, itself acting by its general partner ICG Europe Fund V GP Limited, a company
incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier,
Jersey, JE2 4 SY and registered with the Jersey Registry under number 107484, ("ICG Fund V") represented by Andreea
Antonescu, pursuant to a proxy dated 27 March 2013, DECLARES to subscribe for Two Million One Hundred and
Twenty-Seven Thousand Eight Hundred and Forty (2,127,840) shares (parts sociales) (the "ICG Fund V Shares") and to
fully pay up such ICG Fund V Shares, at nominal value, by converting capital reserves of an amount of Two Million One
Hundred and Twenty-Seven Thousand Eight Hundred and Forty Euros (EUR 2,127,840) (the "Reserves").
The above-mentioned proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
B. Three Hundred and Twenty Thousand Five Hundred and Fifteen (320,515) shares (parts sociales), to be fully paid
up at nominal value of one Euro (EUR 1) each.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon appears ICG EFV Jersey Limited, a limited partnership incorporated under the laws of Jersey, having its
registered office at Liberté House, 19-23 La Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY and registered with the Companies
Registry of the Jersey Financial Services Commission under number 108.779 ("ICG Jersey") represented by Andreea
Antonescu, pursuant to a proxy dated 27 March 2013, DECLARES to subscribe for Three Hundred and Twenty Thousand
Five Hundred and Fifteen (320,515) shares (parts sociales) (the "ICG Jersey Shares") and to fully pay up such ICG Jersey
Shares, at nominal value, by converting capital reserves of an total amount of Three Hundred and Twenty Thousand Five
Hundred and Fifteen Euros (EUR 320,515. -) (the "Reserves").
The above-mentioned proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The amount of the Reserves has been confirmed through the issuance of a report issued by the Company, stating that
the Reserves amount to at least Two Million Four Hundred and Forty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty-Five Euro
(EUR 2,448,355) (the "Report").
The Report, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the tax administration
(administration de l'enregistrement et des domaines).
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolutions, the General Meeting RESOLVES to amend the first paragraph of Article 6.1 of
the Articles, which shall forthwith read as follows:
" 6.1. Subscribed and Authorised share capital. The Company's corporate capital is fixed at EUR 2,460,855.- (two
million four hundred and sixty thousand eight hundred and fifty-five Euros) represented by 2,460,855 (two million four
hundred and sixty thousand eight hundred and fifty-five) shares (parts sociales) of EUR 1,- (one Euro) each, all fully
subscribed and entirely paid up."
There being no further business, the meeting is terminated.
74377
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2.500,-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing and intervening parties, he signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française de ce qui précède
En l'an deux mille treize, le vingt-huitième jour de Mars.
Devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée Générale») de ICG EFV Luxembourg
S.à r.l, une société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163.939, constituée par acte du notaire soussigné le 1
er
Septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2882 du 25 Novembre 2011, page 138290 (la "Société").
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, du 29 Décembre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 Mars 2012, numéro 571, page 27406.
La réunion a été ouverte par Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
président, qui désigne comme secrétaire M,Gérard Maitrejean, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
1. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
a. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions quatre cent quarante-huit mille trois
cent cinquante-cinq Euros (EUR 2.448.355-.) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500, -.) actuellement représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un
Euro (EUR 1, -.) chacune, à deux millions quatre cent soixante mille huit cent cinquante-cinq Euros (EUR 2.460.855-.) par
l'émission de deux millions quatre cent quarante-huit mille trois cent cinquante-cinq (2.448.355) parts sociales d'une
valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune (les «Parts Sociales Nouvelles»);
c. Acceptation de la souscription des Parts Sociales Nouvelles comme suit:
i. Deux millions cent vingt-sept mille huit cent quarante (2.127.840) parts sociales par ICG Europe Fund V n°1 Limited
Partnership, un limited partnership constitué en vertu des lois de Jersey, ayant son siège social à Liberté House, 19-23
Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY, immatriculée au Registre du Commerce de la Jersey Financial Services Com-
mission (le «Registre de Jersey») sous le numéro 1377, agissant par son general partner ICG Europe Fund V GP Limited
Partnership, un limited partnership constitué en vertu des lois de Jersey, ayant son siège social à Liberté House, 19-23
Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et immatriculé au Registre du Jersey sous le numéro 1374, lui-même agissant par
son general partner ICG Europe Fund V GP Limited, une société constituée en vertu des lois de Jersey, ayant son siège
social à Liberté House, 19-23 Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et immatriculée au Registre du Jersey sous le
numéro 107484 (le «ICG Fund V» - les «Parts Sociales ICG Fund V») et paiement intégral par ICG Fund V des Parts
Sociales ICG Fund V à leur valeur nominale, par conversion des réserves de capital d'un montant total de deux millions
cent vingt-sept mille huit cent quarante Euros (EUR 2.127.840), et
ii. Trois cent vingt mille cinq cent quinze (320.515) parts sociales par ICG EFV Limited Jersey, une société constituée
en vertu des lois de Jersey, ayant son siège social à Liberté House, 19-23 Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et
inscrite au Registre de Commerce de la Jersey Financial Services Commission sous le numéro 108.779 ("ICG Jersey» -
les «Parts Sociales ICG Jersey») et le paiement intégral par ICG Jersey des Parts Sociales ICG Jersey à leur valeur nominale,
par conversion de réserves d'un montant total de trois cent vingt mille cinq cent quinze euros (EUR 320.515.-).
c. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société;
d. Divers.
2. Les comparants sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par le mandataire des parties représentées,
les membres du bureau et le notaire instrumentant, qui demeurera annexée au présent acte.
3. Il résulte de la suite de la liste de présence que toutes les parts sociales existantes émises sont représentées à la
présente assemblée générale, qui est par conséquent valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur
les points de l'ordre du jour.
74378
L
U X E M B O U R G
4. Les parties comparantes, représentées à la réunion déclarent (i) renoncer à la convocation à l'assemblée et (ii) être
pleinement informés de tous les éléments de l'ordre du jour.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions quatre cent
quarante-huit mille trois cent cinquante-cinq Euros (EUR 2.448.355) afin de le porter de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500-) représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale
de un Euro (EUR 1) chacune, à deux millions quatre cent soixante mille huit cent cinquante-cinq Euros (EUR 2.460.855)
représenté par deux millions quatre cent soixante mille huit cent cinquante-cinq (2.460.855) parts sociales d'une valeur
nominale de un Euro (EUR chacune et d'émettre:
A. Deux millions cent vingt-sept mille huit cent quarante (2.127.840) parts sociales devant être entièrement libérées
à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.
<i>Souscription / Paiementi>
A présent comparaît ICG Europe Fund V n ° 1 Limited Partnership, un limited partnership constitué en vertu des lois
de Jersey, ayant son siège social à Liberté House, 19-23 Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY, immatriculée au Registre
du Commerce de la Jersey Financial Services Commission (le «Registre de Jersey») sous le numéro 1377, agissant par
son general partner ICG Europe Fund V GP Limited Partnership, un limited partnership constitué en vertu des lois de
Jersey, ayant son siège social à Liberté House, 19-23 Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et immatriculée au Registre
du Jersey sous le numéro 1374, lui-même agissant par son general partner ICG Europe Fund V GP Limited, une société
constituée en vertu des lois de Jersey, ayant son siège social à Liberté House, 19-23 Motte Street, St Helier, Jersey, JE2
4 SY et immatriculée au Registre du Jersey sous le numéro 107484 («ICG Fund V»), représentée par Andreea Antonescu
en vertu d'une procuration datée du 27 mars 2013, déclare souscrire à deux millions cent vingt-sept mille huit cent
quarante (2.127.840) parts sociales (les «Parts Sociales ICG Fund V») et de libérer entièrement ces Parts Sociales ICG
Fund V, à leur valeur nominale, par conversion de réserves de capital d'un montant de deux millions cent vingt-sept mille
huit cent quarante Euros (EUR 2.127.840) (les «Réserves»).
La procuration mentionnée ci-dessus, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
B. Trois cent vingt mille cinq cent quinze (320.515) parts sociales devant être entièrement libérées à leur valeur
nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.
<i>Souscription / Paiementi>
A présent comparaît ICG EFV Limited Jersey, une société constituée en vertu des lois de Jersey, ayant son siège social
à Liberté House, 19-23 Motte Street, St Helier, Jersey, JE2 4 SY et inscrite au Registre de Commerce de la Jersey Financial
Services Commission sous le numéro 108.779 («ICG Jersey») représentée par Andreea Antonescu, en vertu d'une pro-
curation datée du 27 Mars 2013, déclare souscrire trois cent vingt mille cinq cent quinze (320.515) parts sociales (les
«Parts Sociales ICG Jersey») et de libérer entièrement ces Parts Sociales ICG Jersey à leur valeur nominale, par conversion
de réserves de capital d'un montant total de trois cent vingt mille cinq cent et quinze euros (EUR 320.515) (les «Réserves»).
La procuration mentionnée ci-dessus, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Le montant des Réserves a été confirmé par la délivrance d'un rapport émis par la Société, précisant que le montant
des réserves s'élève au moins à deux millions quatre cent quarante-huit mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR
2.448.355) (le «Rapport»).
Le Rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumis en même temps auprès de l'Administration de l'Enregistrement et des
Domaines.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée Générale DECIDE de modifier l'article 6.1, premier
paragraphe, des Statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
« 6.1. Capital souscrit et Libéré. Le capital social est fixé à EUR 2.460.855 (deux millions quatre cent soixante mille
huit cent cinquante-cinq Euros) représenté 2.460.855 (deux millions quatre cent soixante mille huit cent cinquante-cinq)
parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
Comme il n'y a pas d'autre élément à l'ordre du jour, la séance est levée. Les dépenses, coûts, rémunération ou charges
sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société suite au présent acte sont estimés à environ EUR
2.500,- Euros
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête de la partie comparante, cet acte a été
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante la version anglaise
fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.
74379
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent
acte.
Signé: Antonescu, Maîtrejean, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 avril 2013. Relation: EAC/2013/4579. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013060803/231.
(130075121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Herman International S.A., Société Anonyme,
(anc. Herman International S.à r.l.).
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 166.404.
L'an deux mille treize, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
- Monsieur Alexandre HERMAN, indépendant, né le 27 avril 1974 à Namur (Belgique), demeurant au 1, rue du Château,
B-5564 Wanlin (Belgique),
- La société anonyme EUREFI, avec siège social à F-54400 Longwy, Maison de la Formation, Centre Jean Monnet,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro B 382 532 554 et ayant son siège admi-
nistratif à L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps, ici représentée par Monsieur Daniel GHEZA, Directeur Général, né le
25 décembre 1952 à Virton (Belgique), demeurant à B-6769 Robelmont, rue du Tilleul 38,
agissant en leur qualité de seuls associés de HERMAN INTERNATIONAL S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-4702 Pétange, 24, rue Robert
Krieps, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B 166.404, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, le 29 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
9 mars 2012, sous le numéro 624 (ci-après la «Société»). Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
L’ordre du jour de l’assemblée se compose comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de sept cent quatre-vingt-quinze mille huit
cents euros (EUR 795.800) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté
par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à un montant de huit
cent huit mille trois cents euros (EUR 808.300) par l’émission de sept mille neuf cent cinquante-huit (7.958) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
2. Souscription et libération.
3. Transformation de la Société en une société anonyme.
4. Changement de la dénomination de la Société en «HERMAN INTERNATIONAL S.A.».
5. Transfert du siège social de la Société vers L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
6. Refonte complète des statuts de la Société.
7. Démission des gérants.
8. Nomination des administrateurs.
9. Nomination du commissaire.
10.Emission d’un emprunt obligataire convertible avec effet au 29 avril 2013.
11. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de soixante-quinze mille euros (EUR
75.000) pour le porter de son montant de huit cent huit mille trois cents euros (EUR 808.300) représenté par huit mille
quatre-vingt-trois (8.083) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à un montant de huit cent
quatre-vingt-trois mille trois cents euros (EUR 883.300) par l’émission de sept cent cinquante (750) actions nouvelles
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
12. Introduction d’un capital autorisé dans les statuts de la Société de un million trois cent quatre-vingt-neuf mille sept
cent euros (EUR 1.389.700.-) en ce compris le capital souscrit par la création et l'émission de cinq mille soixante-quatre
(5.064) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-). Approbation du rapport spécial du conseil
d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la Loi de 1915.
74380
L
U X E M B O U R G
13. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
14. Divers.
Après avoir analysé les différents points à l’ordre du jour, les comparants, représentant l’intégralité du capital social,
ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de sept cent quatre-vingt-
quinze mille huit cents euros (EUR 795.800) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à un
montant de huit cent huit mille trois cents euros (EUR 808.300) par l’émission de sept mille neuf cent cinquante-huit
(7.958) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les sept mille neuf cent cinquante-huit (7.958) parts sociales nouvelles sont souscrites et libérées comme suit:
1) Monsieur Alexandre HERMAN, prénommé, déclare souscrire cinq mille (5.000) parts sociales d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100) chacune, et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en neuf cent trente (930)
parts sociales de la société CROIX DU SUD SPRL, ayant son siège social à B-5564 Wanlin, 1, rue du Château, immatriculée
au registre de commerce sous le numéro 0865.978.782, pour un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000) entiè-
rement affecté au capital social de la Société.
Cette contribution a fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi en date du 29 avril 2013 par le conseil de gérance de
la Société, qui restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Monsieur Alexandre HERMAN, prénommé, certifie par la présente qu’au jour et au moment de la contribution:
1. il est propriétaire de toutes les parts sociales apportées;
2. toutes les formalités de transfert ont été respectées et il n’y a pas de droit de préemption ni autres droits attachés
aux parts par lesquels une quelconque personne serait en droit de demander qu’une ou plusieurs parts sociales lui soient
transférées;
3. il a tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les parts sociales sont, à sa meilleure connaissance, libres de toute charge et librement transférables à la Société;
5. le transfert des parts sociales dans la Société sera inscrit dans le registre des associés de la société CROIX DU SUD
SPRL.
Un certificat signé par la société CROIX DU SUD SPRL confirmant que Monsieur Alexandre HERMAN est bien inscrit
comme associé de ladite société et que les parts sociales sont librement transférables à la Société, a été fourni au notaire
soussigné et restera annexé au présent acte.
Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des parts sociales, Monsieur Alexandre
HERMAN, en tant qu’apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.
2) La société EUREFI, prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire deux mille neuf cent cin-
quante-huit (2.958) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et les libérer entièrement par
un apport en nature consistant en la conversion partielle d’une créance détenue par EUREFI contre la Société, pour un
montant de deux cent quatre-vingt-quinze mille huit cents euros (EUR 295.800.-) entièrement affecté au capital social de
la Société.
La réalité de cette créance a été prouvée au notaire soussigné par les comptes annuels de la Société arrêtés au 31
décembre 2012, qui resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.
Cette contribution a fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi en date du 29 avril 2013 par le conseil de gérance de
la Société, précité, qui restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps, et dont il résulte par ailleurs
que la créance apportée existe toujours au jour des présentes et qu’elle est certaine, liquide et exigible et librement
transférable à la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de convertir la Société de sa forme originale de société à responsabilité limitée en une société
anonyme, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après la «Loi de 1915»).
En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 31-1 de la Loi de 1915, un rapport sur la transformation de
la Société en société anonyme a été dressé en date du 29 avril 2013 par BDO Audit, cabinet de révision agréé, représenté
par Monsieur Daniel CROISE, réviseur d'entreprises agréé à Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte
pour être enregistré en même temps.
Ce rapport conclut comme suit:
74381
L
U X E M B O U R G
<i>«Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports de EUR 808.300.-ne corresponde pas au moins au nombre et à la valeur des 8.083 actions d’une valeur nominale
de EUR 100.-chacune à émettre en contrepartie.»
Suite à cette transformation, les huit mille quatre-vingt-trois (8.083) parts sociales détenues par les associés, ci-après
dénommés les «actionnaires», sont converties en huit mille quatre-vingt-trois (8.083) actions de la Société, d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune, attribuées aux actionnaires en proportion de leur participation dans le capital
social.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident de changer le nom actuel de la Société de «HERMAN INTERNATIONAL S.à r.l.» en «HER-
MAN INTERNATIONAL S.A.».
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires décident de transférer le siège social de la Société de son siège actuel à L-4702 Pétange, 24, rue Robert
Krieps vers L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires décident d’adopter les nouveaux statuts de la Société, qui auront la teneur suivante:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «HERMAN INTERNATIONAL S.A.".
Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet et pourra accomplir, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, tant pour elle-
même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement, en gros ou en détail, à la confection, à la fabrication, à l'achat, à la vente, à la diffusion, à la représentation
et à la distribution de tous chapeaux, coiffures et gants, ainsi que tous accessoires du vêtement et de la confection.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, y compris la fabrication et en général
le commerce de tous textiles, vêtements, articles de lingerie et bonneterie.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de l'entreprise.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet
social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à huit cent huit mille trois cents euros (EUR 808.300.-) représenté par huit mille quatre-
vingt-trois (8.083) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
74382
L
U X E M B O U R G
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs
peuvent émettre leur vote par écrit ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature individuelle de la personne à laquelle a été déléguée la gestion journalière de la Société, dans les limites de la
gestion journalière, ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de juin à 18.00 heures au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. Aux assemblées générales extraordinaires les délibérations ne sont valablement prises que si elles sont ad-
optées par les trois quart (3/4) des voix des actionnaires.
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Sixième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission des gérants de la Société et leur accordent décharge pour l’exécution de leurs
mandats jusqu’à ce jour.
74383
L
U X E M B O U R G
<i>Septième résolutioni>
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la Société, pour une
période expirant lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes de l’exercice social 2017:
a) La société à responsabilité limitée Europe et Croissance SARL, ayant son siège social à L-4702 Pétange, 24, rue
Robert Krieps, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés sous le numéro B 132.827, ayant pour représentant
permanent Monsieur Daniel GHEZA, prénommé;
b) La société privée à responsabilité limitée de droit belge PRIVATE AXESS MANAGEMENT, ayant son siège social à
B-6920 Wellin, 6, rue Jean Meunier, immatriculée au registre de commerce de Neufchateau sous le numéro BE
0500.955.015, ayant pour représentant permanent Monsieur Alexandre HERMAN, prénommé;
c) Monsieur Xavier GOEBELS, né à Arlon (Belgique), le 6 août 1971, demeurant à B-6820 Florenville, 16, Place Albert
I
er
.
<i>Huitième résolutioni>
Les actionnaires décident de nommer la société anonyme BDO Audit, cabinet de révision agréé, ayant son siège social
à "Le Dôme" Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle B.P. 351 L-2013 Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 12.039, comme commissaire de la Société, pour une période expirant lors de
l’assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes de l’exercice social 2013.
<i>Neuvième résolutioni>
Les actionnaires, ayant renoncé pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel, décident l’émission
d’un emprunt convertible d’un montant de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000) avec effet au 29 avril 2013.
Les actionnaires décident d’émettre quatre mille cinq cents (4.500) obligations d’une valeur de cent euros (EUR 100)
chacune aux conditions suivantes:
Durée: quatre (4) ans mais prolongeable d’un an
Intérêt: 6% payable par tranche trimestrielle
Prime de non-conversion: 8,018018%
Remboursement: clause Bullet
Période de conversion: de la date de souscription des obligations convertibles en actions jusqu’au 31 décembre 2017.
Base de conversion: la base de conversion est d‘une obligation pour une action.
Conformément aux prescriptions de l'article 32-4 de la Loi de 1915, ledit emprunt convertible est évalué dans un
rapport établi en date du 29 avril 2013 par BDO Audit, cabinet de révision agréé, représenté par Monsieur Daniel CROISE,
prénommé, qui conclut comme suit:
<i>„Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de souscription
de l’emprunt convertible d’EUR 450.000,00 ne corresponde pas au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre
en contrepartie, si la conversion était réalisée à la date de l’émission de l’emprunt convertible.“
Ledit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Les quatre mille cinq cents (4.500) obligations sont souscrites par la société EUREFI, prénommée, représentée comme
indiqué ci-avant, pour un montant total de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000.-). Ces obligations sont libérées
par un apport en nature consistant en la conversion partielle du compte courant d’actionnaire détenu par EUREFI contre
la Société à due concurrence. La réalité de ce compte courant d’actionnaire résulte des comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2012 ainsi que du prédit rapport, ci-annexés.
<i>Dixième résolutioni>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de soixante-quinze
mille euros (EUR 75.000) pour le porter de son montant actuel de huit cent huit mille trois cents euros (EUR 808.300)
représenté par huit mille quatre-vingt-trois (8.083) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, à un
montant de huit cent quatre-vingt-trois mille trois cents euros (EUR 883.300) par l’émission de sept cent cinquante (750)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, toutes les sept cent cinquante (750)
actions nouvelles sont souscrites par la société privée à responsabilité limitée de droit belge PRIVATE AXESS MANA-
GEMENT, prénommée, ici représentée par Monsieur Alexandre HERMAN, pour un montant de soixante-quinze mille
euros (EUR 75.000) entièrement affecté au capital social de la Société.
Toutes les sept cent cinquante (750) actions sont intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante-
quinze mille euros (EUR 75.000) est à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par un
certificat bancaire qui restera annexé aux présentes.
74384
L
U X E M B O U R G
<i>Onzième résolutioni>
Après avoir pris connaissance et approuvé le rapport spécial prévu par l'article 32-3 (5) de la Loi du 1915 dressé par
le Conseil d'Administration, qui restera annexé aux présentes, les actionnaires décident d'introduire dans les statuts de
la Société un capital autorisé d'un montant total de un million trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cents euros (EUR
1.389.700.-) en ce compris le capital souscrit par l'émission de cinq mille soixante-quatre (5.064) nouvelles actions d'une
valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, strictement réservé, d'un côté, (i) aux fins de conversion partielle
ou totale des obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) chacune dont l'émission
a été décidée ci-avant, à l'émission de quatre mille cinq cents (4.500) actions nouvelles à un prix d'émission par action de
cent euros (100.- EUR) et, de l'autre côté, (ii) à l'émission de cinq cent soixante-quatre (564) actions de la Société d'une
valeur nominale de cent euros (100.- EUR) pour un montant total de cent vingt-cinq mille euros (125.000.-EUR) affectés
à concurrence de cinquante-six mille quatre cents euros (EUR 56.400) au capital social de la Société et de soixante-huit
mille six cents euros (EUR 68.600) au compte prime d'émission de la Société.
Les actionnaires autorisent le Conseil d'Administration à supprimer le droit de souscription préférentiel des action-
naires existants en relation avec l'émission de cinq mille soixante-quatre (5.064) nouvelles actions dans le cadre et endéans
les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé à insérer dans les statuts de la Société sera libellé comme suit:
«Le capital social souscrit pourra être porté de son montant actuel de huit cent quatre-vingt-trois mille trois cents
euros (EUR 883.300) à un montant de un million trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cents euros (EUR 1.389.700) par
la création et l'émission de cinq mille soixante-quatre (5.064) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-
EUR) chacune, strictement réservé, d'un côté, (i) à l'émission de quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles actions d'une
valeur nominale de cent euros (100.- EUR ) chacune strictement réservé aux fins de conversion partielle ou totale des
obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, émises par la Société selon
les termes et modalités du contrat d'émission d'obligations convertibles y relatifs et, de l'autre côté, (ii) à l'émission de
cinq cent soixante-quatre (564) actions de la Société d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) pour un montant
total de cent vingt-cinq mille euros (125.000.- EUR) affectés à concurrence de cinquante-six mille quatre cents euros
(EUR 56.400) au capital social de la Société et de soixante-huit mille six cents euros (EUR 68.600) au compte prime
d'émission de la Société. Chacune des actions nouvelles jouira des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à procéder pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Société et
Associations, de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2013, à l'augmentation du capital social souscrit, endéans
la limite du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches par l'émission de nouvelles actions, sans réserver aux actionnaires
existants un droit préférentiel de souscription, la même assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant ex-
pressément autorisé le Conseil d'Administration à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires en
relation avec l'émission de nouvelles actions dans le cadre et endéans les limites du capital autorisé;
- à fixer le lieu et la date de l'émission des actions sous respect des dispositions du contrat d'émission d'obligations
convertibles;
- à fixer les conditions et modalités de conversion et de l'émission des quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles actions
à émettre dans le cadre du capital autorisé selon les termes et modalités du contrat d'émission d'obligations convertibles;
- à fixer le lieu et la date ainsi que les conditions et les modalités de l'émission des cinq cent soixante-quatre (564)
autres actions nouvelles à émettre.
Le Conseil d'Administration est expressément autorisé après chaque augmentation du capital social par émission de
nouvelles actions, dans le cadre et endéans les limites du capital autorisé, à procéder à la modification de l'article 5 des
statuts.»
<i>Douzième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, les actionnaires décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à huit cent quatre-vingt-trois mille trois cents euros (EUR 883.300) représenté par
huit mille huit cents trente-trois (8.833) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social souscrit pourra être porté de son montant actuel de huit cent quatre-vingt-trois mille trois cents
euros (EUR 883.300) à un montant de un million trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cents euros (EUR 1.389.700) par
la création et l'émission de cinq mille soixante-quatre (5.064) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-
74385
L
U X E M B O U R G
EUR) chacune, strictement réservé, d'un côté, (i) à l'émission de quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles actions d'une
valeur nominale de cent euros (100.- EUR ) chacune strictement réservé aux fins de conversion partielle ou totale des
obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, émises par la Société selon
les termes et modalités du contrat d'émission d'obligations convertibles y relatifs et, de l'autre côté, (ii) à l'émission de
cinq cent soixante-quatre (564) actions de la Société d'une valeur nominale de cent euros (100.-EUR) pour un montant
total de cent vingt-cinq mille euros (125.000.- EUR) affectés à concurrence de cinquante-six mille quatre cents euros
(EUR 56.400) au capital social de la Société et de soixante-huit mille six cents euros (EUR 68.600) au compte prime
d'émission de la Société. Chacune des actions nouvelles jouira des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à procéder pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Société et
Associations, de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2013, à l'augmentation du capital social souscrit, endéans
la limite du capital autorisé, en une ou plusieurs tranches par l'émission de nouvelles actions, sans réserver aux actionnaires
existants un droit préférentiel de souscription, la même assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant ex-
pressément autorisé le Conseil d'Administration à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires en
relation avec l'émission de nouvelles actions dans le cadre et endéans les limites du capital autorisé;
- à fixer le lieu et la date de l'émission des actions sous respect des dispositions du contrat d'émission d'obligations
convertibles;
- à fixer les conditions et modalités de conversion et de l'émission des quatre mille cinq cents (4.500) nouvelles actions
à émettre dans le cadre du capital autorisé selon les termes et modalités du contrat d'émission d'obligations convertibles;
- à fixer le lieu et la date ainsi que les conditions et les modalités de l'émission des cinq cent soixante-quatre (564)
autres actions nouvelles à émettre.
Le Conseil d'Administration est expressément autorisé après chaque augmentation du capital social par émission de
nouvelles actions, dans le cadre et endéans les limites du capital autorisé, à procéder à la modification de l'article 5 des
statuts.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, est évalué approximativement à la somme de
quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500.-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: A. HERMAN, D. GHEZA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2013. LAC / 2013 / 20036. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 13 mai 2013.
Référence de publication: 2013060796/349.
(130074829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Homeschlach SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.879.
L’an deux mille treize, le vingt-deux avril.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de HOMESCHLACH SA avec siège social à L-1273
Luxembourg, 7, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 168 879, constituée
suivant acte Frank MOLITOR de Dudelange en date du 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Numéro 1576 du 22 juin 2012.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Alain LE NENAN, demeurant à Herserange.
qui désigne comme secrétaire Alice CARVALHO GOMES, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Kindy FRITSCH, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Modification du nombre des actions.
2. Adaptation de l'article 5 des statuts
74386
L
U X E M B O U R G
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-
blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Elle augmente le nombre des actions de trente-et-une (31) à cent (100) en échangeant les trente-et-une (31) actions
d'une valeur nominale de mille (1.000. -) euros contre cent (1 00) actions d'une valeur nominale de trente-et-un (31.-)
euros.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de démembrer les cent (100) actions existantes en cinquante (50) actions A et cinquante (50)
actions B.
<i>Troisième résolutioni>
Le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000.-) euros, représenté par cent (1 00) actions de trois
cent dix (310. -) euros chacune, dont cinquante (50) actions A et cinquante (50) actions B, disposant chacune d'une voix
aux assemblées générales.
..."
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui auront désormais la
teneur suivante:
" Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil en nombre pair composé de quatre
membres au moins, dont une moitié est désignée par les actionnaires A et l'autre moitié par les actionnaires B et qui élit
un président dans son sein.
La présidence échoit à tour de rôle tous les deux ans à un administrateur A et un administrateur B.
Au sein du conseil d'administration les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les
affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes
aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion des affaires de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en cas d’administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en
cas de pluralité d’administrateurs, par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement un adminis-
trateur A et un administrateur B, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil."
<i>Cinquième résolutioni>
Elle révoque Kindy FRITSCH, employé privé, né à Luxembourg, le 20 avril 1983, demeurant à L-2320 Luxembourg,
55, boulevard de la Petrusse de ses fonctions d'administrateur unique et lui donne décharge quant à l'exécution de son
mandat.
74387
L
U X E M B O U R G
<i>Sixième résolutioni>
Elle nomme aux fonctions d'administrateur:
1. Kindy FRITSCH, employé privé, né à Luxembourg, le 20 avril 1983, demeurant à L-2320 Luxembourg, 55, Boulevard
de la Pétrusse, administrateur A;
2. Patrick KREINS, employé privé, né à Luxembourg, le 22 décembre 1963, demeurant à L-4979 Fingig, 38, rue Nicolas
Margue, administrateur A;
3.- Marc GIORGETTI, entrepreneur de constructions, né à Luxembourg, le 19 août 1961, demeurant professionnel-
lement à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, administrateur B;
4.- Paul GIORGETTI, entrepreneur de constructions, né à Luxembourg, le 30 août 1958, demeurant professionnelle-
ment à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, administrateur B;.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice social 2017. Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Le Nenan, Carvalho Gomes, Fritsch et Molitor
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 2 mai 2013. Relation EAC/2013/5803. Reçu soixante quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Référence de publication: 2013060797/90.
(130075290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Kedi 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.614.
In the year two thousand and thirteen, on thirtieth day of April.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Kedi 2 & 3 Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-), with registered office at 59, rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 165.580 (the "Shareholder"),
hereby represented by Maître Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30 April
2013.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of KEDI
2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one hundred
twenty five thousand euro (EUR 125,000.-), with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Edouard Delosch, then notary residing in Ram-
brouch, of 22 November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 326 of 7
February 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 165.614
(the "Company").
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Edouard
Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg of 27 December 2012, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 454 of 23 February 2013.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one million eight hundred seventy five thousand
euro (EUR 1,875,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred twenty five thousand euro (EUR 125,000.-)
to two million euro (EUR 2,000,000.-).
2 To issue one hundred eighty seven million five hundred thousand (187,500,000) new shares with a nominal value of
one euro cent (EUR 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
74388
L
U X E M B O U R G
3 To accept subscription for these new shares by KEDI Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed
by the laws of Luxembourg, having a share capital of one hundred twenty five thousand euro (EUR 125,000.-), with
registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 165550 and to accept payment in full for such new
shares by conversion of a convertible instrument issued by the Company.
4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the
capital increase.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million eight hundred
seventy five thousand euro (EUR 1,875,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred twenty five thousand
euro (EUR 125,000.-) to two million euro (EUR 2,000,000.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue one hundred eighty seven million five hundred thousand (187,500,000) new shares
with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared KEDI Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,
having a share capital of one hundred twenty five thousand euro (EUR 125,000.-), with registered office at 59, rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 165.550, represented by Maître Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given on 30 April 2013 which proxy shall be annexed to the present deed.
The Subscriber declared to subscribe for all the one hundred eighty seven million five hundred thousand (187,500,000)
new shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share, and to make payment in full for such new shares
by a conversion of yield free convertible preferred equity certificates in a nominal amount of one million eight hundred
seventy five thousand euro (EUR 1,875,000.-) (the "Consideration").
The Consideration represents a value in aggregate amount of one million eight hundred seventy five thousand euro
(EUR 1,875,000.-).
Proof of the ownership of the Consideration by the Subscriber has been given to the undersigned notary.
The Subscriber declared that the Consideration is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there
subsist no impediments to the conversion without restriction or limitation.
The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Consi-
deration is described and valued (the "Report").
The conclusions of the Report read as follows:
"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the converted
YFCPECs which is at least equal to the nominal value of the shares to be issued by the Company."
The Report, which after being signed "ne varietur" by the Shareholder, as above represented, and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one hundred eighty seven million
five hundred thousand (187,500,000) new shares according to the above mentioned subscription.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in
order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at two million euro (EUR 2,000,000.-) divided into
two hundred million (200,000,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully
paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at two thousand six hundred euro (EUR 2,600.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
74389
L
U X E M B O U R G
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le trentième jour du mois d'avril.
Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Kedi 2 & 3 Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), dont le siège social est situé au 59, rue de Rollin-
gergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 165.580 (l'«Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une
procuration donnée le 30 avril 2013.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de KEDI 2 S.à r.l., une
société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cent vingt-cinq mille euros
(EUR 125.000,-), dont le siège social est au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte de Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 22 novembre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 326 du 7 février 2012 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.614 (la «Société»).
Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch,
Grand Duché du Luxembourg en date du 27 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 454, en date du 23 février 2013.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de un million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR
1.875.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à deux millions d'euros
(EUR 2.000.000,-).
2 Emission de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (187.500.000) parts sociales nouvelles d'une valeur no-
minale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par Kedi Holdings S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR
125.000,-), dont le siège social est situé au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.550 et acceptation de la
libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par conversion d'un instrument convertible émis par la Société.
4 Modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.
5 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million huit cent soixante-quinze
mille euros (EUR 1.875.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à deux
millions d'euros (EUR 2.000.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (187.500.000) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Kedi Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), dont le siège social est situé au 59,
rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165.550 (le «Souscripteur»), représenté aux fins des présentes par Maître
74390
L
U X E M B O U R G
Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 30 avril 2013. La prédite
procuration restera annexée aux présentes.
Ensuite le Souscripteur a déclaré souscrire à l'ensemble des cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille (187.500.000)
parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement ces parts
sociales souscrites par conversion de yield free convertible preferred equity certificates ayant une valeur nominale de un
million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-) (la «Contrepartie»).
La Contrepartie représente un montant total de un million huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.875.000,-).
La preuve par le Souscripteur de la propriété de la Contrepartie a été rapportée au notaire soussigné.
Le Souscripteur a déclaré encore que la Contrepartie est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune
restriction ou limitation à la conversion.
Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel la Contrepartie est décrite
et évaluée (le «Rapport»).
Les conclusions du Rapport sont les suivantes:
«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur des YFCPECs
convertis qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre par la Société».
Le Rapport, après avoir été signé «ne varietur» par l'Associé, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné,
restera annexé au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les cent quatre-vingt-sept millions cinq
cent mille (187.500.000) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.
Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) divisé en deux cent
millions (200.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille six cents euros (EUR 2.600,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: N. GAUZÈS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 3 mai 2013. Relation: DIE/2013/5686. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 10 mai 2013.
Référence de publication: 2013060844/183.
(130075127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 96.114.
<i>Extrait des décisions de l’associé unique de la Société prises le 29 avril 2013i>
L’associé unique de la Société décide conformément aux statuts de la Société:
D’accepter la démission de Monsieur William Wallace Anderson en qualité de gérant de la Société avec effet au 29
mars 2013.
74391
L
U X E M B O U R G
De nommer Mr James Barnard Darkins, domicilié professionnellement au 201 Bishopsgate, EC2M 3AE Londres, Roy-
aume-Uni, gérant de la Société avec effet au 3 mai 2013.
Référence de publication: 2013059582/14.
(130073275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
JP Commercial 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 177.081.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
The company Jargonnant Partners S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office at
6, rue Dicks, 1417 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number
78830,
duly represented by Ms. Diane Wolf, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, on the 8th of April 2013, hereto attached.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of
association of a private limited company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws and the present
articles:
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a
company in form of a Gesellschaft mit beschrânkter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the
Companies' Act of August 10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of "JP Com-
mercial 17 S.à r.l.".
Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Lu-
xembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of the
manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager
(s).
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will be made
and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under
the given circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate
located in Luxembourg or abroad.
The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches,
as well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion,
sale and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnership or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Title II. Capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by ten thousand
(10,000) shares with a par value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, which have been fully subscribed.
74392
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of
the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority
consent of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change
the nationality of the company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The members may also take resolutions in writing without meeting if there are twenty-five (25) members or less.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings. The company will recognize
only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the
company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt
is encumbered by a pledge and his creditor.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes
or drawn-up in writing.
Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members
representing at least three quarters (3/4) of the company's share capital.
In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets
or documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.
Title III. Administration and Audit
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines
their powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are
appointed.
The managers may be removed without cause.
Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who needs
not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of the members.
The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of
the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, telegram
or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the managers. Any manager may participate in any meeting of the board
of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such
persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such
meeting.
Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by e-mail, telegram or telefax another
manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram or telefax.
74393
L
U X E M B O U R G
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those
reserved by law to be decided upon by the members.
Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. Each manager may, by prior resolution of the general meeting of shareholders, confer all powers and special
mandates to any person who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their
remuneration.
Art. 16. The company will be bound by the signature of two managers or by any person(s) to whom power has been
delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the
company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.
Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1
st
of each year and shall terminate on December
31
st
of the same year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual accounts and
in general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit and loss
account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the
net profit of the company.
Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but
will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this
threshold is not met anymore.
The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).
Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent auditors.
The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall determine
their number, remuneration and term of office.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the
shares they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
74394
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
The ten thousand (10,000) shares have been subscribed and fully paid-in by Jargonnant Partners S.à r.l., pre-named, so
that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the company, as was
certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>General meeting of the memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital represented
as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at three (3).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today for an unlimited period:
- Hubert Hansen, 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxembourg, born 17.10.1951 in Ettelbrùck, licencié en droit
- Lothar Rafalski, 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxembourg, born 29.11.1952 in Hamburg, Senior Consultant
- Daniel Schulenburg, professionally residing at Stollbergstr. 11, 80539 Munich, Germany, born 27.01.1961 in Algier,
Merchant.
3) The registered office of the Company is at 1417 Luxembourg, 6 rue Dicks.
4) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2013.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
this deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am fünfundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
Die Gesellschaft Jargonnant Partners S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, rue
Dicks, 1417 Luxembourg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg, unter der Sektion B, Num-
mer 78830
hier vertreten durch Frau Diane Wolf, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf Grund einer Voll-
macht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 8. April 2013, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt
bleibt.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung unterliegt, zu beurkunden.
Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, die später Gesellschafter der Gesellschaft wer-
den, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem derzeitig geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und der folgenden
Satzung unterliegt und die Bezeichnung "JP Commercial 17 S.à r.l." trägt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg).
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung einer Verlegung
an Dritte hat durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, das unter den gegebenen Umständen hierzu am besten in
der Lage ist.
74395
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über Im-
mobilien in Luxemburg oder im Ausland.
Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften und
Niederlassungen sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb, die Ent-
wicklung, die Förderung, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in Eigentum,
Eigentumsrechten und Einrichtungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die
der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann zudem als Komplementär oder Kommanditist mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung
für alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung
ihres Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.
Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingeteilt in zehntau-
send (10.000) Gesellschaftsanteile zu je einem Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), die vollständig einbezahlt wurden.
Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-
schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte
der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafter-
versammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters
oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-
undzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter besitzt.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen. Falls ein Geschäftsanteil im Besitz
von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuld-
ner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der Ge-
sellschaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, die im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Pro-
tokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesell-
schaftern übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der
Zustimmung der Gesellschafter, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren.
In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-
lebenden Lebenspartner erfolgt.
Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur
Folge.
74396
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-
sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.
Titel III. Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, die Vergütung und die Dauer des Mandats der Geschäfts-
führer, wobei diese ihr Amt solange ausüben, bis ein Nachfolger bestimmt wurde.
Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Sie kann weiterhin einen
Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Aufzeichnung der Protokolle der Sitz-
ungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar
an dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, in
denen die Art der Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann durch die schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder Fax erteilte Zustimmung eines jeden
Geschäftsführers verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen,
die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die aus einem Zeitplan hervorgehen, der vorher durch einen Geschäfts-
führungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen eine ununterbrochene
Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine
derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per e-mail, Telegramm
oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder Fax durchgeführt werden.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefaßt werden, wenn die
Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlußfassung dient.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des
Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden.
Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vor-
sitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung jeg-
liche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, die nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss, übertragen,
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Vergütung festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift jeder in
Übereinstimmung mit dem Artikel 15 bevollmächtigten Person verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den
Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der
Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.
Das Guthaben der Gewinn- und Verlustbilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-
visionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5 % (fünf Prozent)
zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn
74397
L
U X E M B O U R G
die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10 % (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt
aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen
auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über
die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde gegebenenfalls von dem Wirtschaftsprüfer geprüft;
4. Dieser Zwischenabschluss weist ausreichend Gewinne auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der an-
deren freien Reserven;
5. Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren, wird durch die Geschäftsführung getroffen.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unab-
hängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung einer
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die
natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über
diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu den Ge-
schäftsanteilen, die sie halten, zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung.
Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern
oder zwischen dem/den Geschäftsführer(n) und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes ("arbitrage') gemäß der Zivilprozeßordnung.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und vollständig einbezahlt durch Jargonnant Partners
S.à r.l., vorbenannt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft zur freien Ver-
fügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer
Gründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,-. geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, der das gesamte Stammkapital vertritt,
vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste folgende Beschlüsse:
1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen.
2) Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tage zu Geschäftsführern auf unbegrenzte Dauer
ernannt:
- Hubert Hansen, wohnhaft 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxemburg, geboren am 17.10.1951 in Ettelbrück,
licencié en droit
- Lothar Rafalski, wohnhaft 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxemburg, geboren am 29.11.1952 in Hamburg, Senior
Consultant
- Daniel Schulenburg, geschäftsansässig Stollbergstraße 11, 80539 München, Deutschland, geboren am 27.01.1961 in
Algier, Kaufmann.
3) Der Sitz der Gesellschaft ist in 1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
4) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-
zember 2013.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
74398
L
U X E M B O U R G
Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat dieser zusammen mit dem Notar die
vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: D. WOLF und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2013. Relation: LAC/2013/20051. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts- und Handelsregister
und der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 10. Mai 2013.
Référence de publication: 2013060839/384.
(130075049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
HeritageWealth SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.901.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013059584/10.
(130073563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
COFRA Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 148.647.
L'an deux mille treize, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée "Groupe LW s. à r.l.", ayant son siège social à L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin
de Fer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 147.940,
ici représentée aux fins des présentes par un de ses gérants Monsieur Jean WALCH, employé, demeurant à Differdange,
détentrice de cent (100) parts sociales.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée "COFRA Luxembourg
s. à r.l." (numéro d'identité 2009 24 27 243), avec siège social à L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin de Fer, inscrite
au R.C.S.L. sous le numéro B 148.647, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 octobre
2009, publié au Mémorial C, numéro 2151 du 4 novembre 2009,
s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associée unique décide de transférer le siège social de L-4556 Differdange, 15, rue du Chemin de Fer à L-3510
Dudelange, 38, rue de la Libération et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
« Art. 4. al. 1
er
. Le siège social est établi à Dudelange.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: WALCH, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2013. Relation: CAP/2013/1490. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): ENTRINGER.
74399
L
U X E M B O U R G
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 6 mai 2013.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2013059997/35.
(130073252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 779.250,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.911.
L’adresse de Monsieur Trygve Grindheim est désormais la suivante: Grand Chardonet 10, rue de Ransou 187, 1936
Verbier-Suisse
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013059612/12.
(130073380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
NeXgen, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.963.
Société anonyme fondée le 23 Mai 2008 et publication dans le Mémorial C-N° 1481.
Les comptes annuels de 2012 ont été clôturés au 31 Décembre 2012 et approuvés lors de l’assemblée ordinaire des
actionnaires le 15 Avril 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/05/2013.
Paddock Fund Administration
Référence de publication: 2013059737/14.
(130073079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Terelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 29.162.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 3 mai 2013i>
- L'Assemblée reconduit le mandat de KPMG Audit en tant que Réviseur d'entreprises jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2014 qui statuera sur les comptes 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013059917/12.
(130073546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
YV Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 130.360.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013064270/9.
(130078920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
74400
Aero International Finance S.A.
Aero International Finance S.A.
Agemat S.A.
Akka Development
Alcoa Global Treasury Services S.à r.l.
Alcoa Luxembourg S.à.r.l.
AMP Capital Investors (IDF No. 1) S.A.
AMP Capital Investors (IDF No. 2) S.à r.l.
Avior S.A.
Barkingside S.à r.l.
Belplant A.G.
Bousval S.A.
Braiwait Management S.A.
Cemira Investments A.G.
Cemira Investments A.G.
Centre de Recherche Public de la Santé
Cinatel
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l.
CMI TECH5I Luxembourg S.à r.l.
COFRA Luxembourg s.à r.l.
Compagnie des Châteaux d'Europe Centrale S.A.
Conect Software Engineering S.à r.l.
Consolidation Company Luxembourg S.A.
CP Finance Luxembourg S.à r.l.
CVI Global Lux Oil and Gas 2 S.à r.l.
CVI Global Lux Oil and Gas 4 S.à r.l.
Dachtechnic S.à r.l.
DD Productions S.à r.l.
Delfzijl S.A.
Dodol S.A.
Domange Participations S.A.
Eneris Wind Italia SA
Gaia Fund S.A., SICAV-SIF
Gewerbe- und Wirtschaftsverlag S.à r.l.
Hamburg Harburg
Henderson Gartmore fund
Henderson Property Management Company (Luxembourg) No. 1 S.à r.l.
HeritageWealth SICAV-SIF
Herman International S.A.
Herman International S.à r.l.
Homeschlach SA
ICG EFV Luxembourg S.à r.l.
IK Investment Partners S.à r.l.
JP Commercial 17 S.à r.l.
Kedi 2 S.à r.l.
LYXOR Synopsis Fund
Makemake Topco S.à r.l.
Neutral Holding S.A. SPF
NeXgen
Société Financière Himmesoete
Terelux S.A.
TRANSES Holding S.A.
Victoria Business S.A.
VIC-WIN A.G.
Wallace Investissement S.A.
Wenkelhiel
Wiesbaden (Bridge) S.à r.l.
YV Investments
Zama (Windhoek) S.à r.l.