This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1536
27 juin 2013
SOMMAIRE
AJYR Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
73712
Ascelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73688
BB Holding Investment S.A . . . . . . . . . . . . .
73688
BREDS II (LuxCo) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73713
Canaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73684
Canaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73684
Cardoso Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . .
73684
CC Optic Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
Centre Philosophique Spirite Attitude
d'Amour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73692
CEREP Bellini 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
CEREP Bellini 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
CEREP Bryggen Waterfront S.à.r.l. . . . . . .
73687
CEREP City Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
73688
CEREP Esplanade 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
73728
CEREP III Investment H S.à r.l. . . . . . . . . . .
73691
CEREP II Investment Ten S.à r.l. . . . . . . . .
73688
CEREP III Spain S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73689
CEREP Investment Fastighets S.à r.l. . . . .
73686
CEREP Investment France S.à r.l. . . . . . . .
73687
CEREP Investment Orosdi S.à r.l. . . . . . . .
73728
CEREP Investment Z S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
73687
CEREP Monument Investment S.à.r.l. . . .
73691
CEREP Picasso 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
CEREP Poole S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73691
Cerpi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
Château Sarasin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73686
Claudas Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
73683
Cliveden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73686
Clnergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73683
COFRA Luxembourg s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
73686
CompAM FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73684
Computer Resources International Group
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73683
Crèche mäh-ma-muh S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
73684
C.T.B. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
Elephant Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73690
Euroliberty-Lease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73685
FMC Finance VIII S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73682
Focus Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73688
Fuchs & Insurances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
73686
Gauthier Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
73689
GL Europe Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
73689
Global Select Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73690
Golden Heights S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73690
Grevlin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73689
Grund Beteiligungen A.G. . . . . . . . . . . . . . . .
73689
Habeco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73691
HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A. . . . . . . . . . . . .
73690
H.I.G. Europe - Silentnight S.à r.l. . . . . . . .
73690
Kacera S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73728
Luxairco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73710
Lux Planet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73687
Min.Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73725
MNRE (Midsomer Norton Retail Estate)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73694
Outlet Mall Sub Group Holding No. 2 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73703
Presto Plus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73728
Procap Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73728
Rewa Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73687
Sunset Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73683
The European Fund For Southeast Europe
S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73691
Vodafone Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
73706
wondermags Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73708
Word and Advice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73710
73681
L
U X E M B O U R G
C.T.B. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 343, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 77.841.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts sociales du 28 février 2013
que GESTACOM SA 68 rue de Schifflange L-3676 Kayl, cède et transporte vingt cinq (25) parts sociales qu'elle détient
dans la prédite société à Madame Tania FERNANDES, comptable, née le 06/12/1976 demeurant à L-3768 TETANGE, 31
rue de la Fontaine et ce acceptant.
Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €.
que GESTACOM SA 68 rue de Schifflange L-3676 Kayl, cède et transporte vingt cinq (25) parts sociales qu'elle détient
dans la prédite société à Madame Valérie BURG, comptable, née le 04/11/1964 demeurant à F-57480 SIERCK-LES-BAINS,
21 Quai des Ducs de Lorraine et ce acceptant.
Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €.
qu'à la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:
GESTACOM SA, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales,
Tania FERNANDES, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales,
Valérie BURG, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales,
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Fait à Kayl, le 28 février 2013.
GESTACOM SA
Signature
Référence de publication: 2013059379/25.
(130073366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Picasso 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 140.022.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059386/10.
(130073879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
FMC Finance VIII S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 162.959.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordiniare le 8 mai 2013i>
L’assemblée générale a renouvelé les mandats suivants pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle en relation avec les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2013:
- Madame Gabriele DUX, avec adresse professionnelle au 204, route de Luxembourg, L-7241 Bereldange, Grand-
Duché de Luxembourg; administrateur
- Monsieur Andrea STOPPER, avec adresse privée au 23 C, Cantonale, CH-6928 Manno, Suisse; administrateur
- Monsieur Khaled BAHI, avec adresse privée au Parc Médicis, 47, avenue des Pépinières, F-94832 Fresnes Cedex,
France; administrateur
- La société KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9 Allée Scheffer, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149133; commissaire aux comptes de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Référence de publication: 2013059535/19.
(130073298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73682
L
U X E M B O U R G
Claudas Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 9.348.387,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 131.368.
Les comptes annuels au 20 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 2013.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>Manfred Zisselsberger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013059390/14.
(130073865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Clnergie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 123, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 165.092.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2013059391/13.
(130073754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
C.R.I. Group, Computer Resources International Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 158.196.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Référence de publication: 2013059392/10.
(130073184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Sunset Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 79.357.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Jean-Paul EMMA, administrateur de
sociétés, demeurant professionnellement au 21 chemin de la Paumière, CH-1231 Conches/Genève. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2018.
Le 06/05/2013.
Certifié sincère et conforme
SUNSET INVESTMENT S.A.
G. GUISSARD / J-P. EMMA
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013059902/17.
(130073391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73683
L
U X E M B O U R G
CompAM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 92.095.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CompAM Fund
<i>Un agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2013059393/11.
(130073457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Crèche mäh-ma-muh S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5710 Aspelt, 8, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 160.180.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2013059395/13.
(130073769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Canaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 96.573.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 8 mai 2013.
Référence de publication: 2013059399/10.
(130073497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Canaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 96.573.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 8 mai 2013.
Référence de publication: 2013059400/10.
(130073646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Cardoso Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 127.531.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059401/10.
(130072994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73684
L
U X E M B O U R G
CC Optic Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 62-64, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 168.667.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 08/05/2013.
Référence de publication: 2013059402/10.
(130073665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Bellini 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.150.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059407/10.
(130072963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Bellini 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.126.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2013.
Référence de publication: 2013059408/10.
(130072958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Cerpi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.819.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
CERPI S.A.
Référence de publication: 2013059433/11.
(130072876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Euroliberty-Lease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 118.211.
Le bilan et le compte de pertes et profits abrégés au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire COFIGEST S.AR.L.
Platinerei, 8 - L-8552 OBERPALLEN
Isabelle PHILIPIN
Référence de publication: 2013059509/13.
(130073884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73685
L
U X E M B O U R G
Fuchs & Insurances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.450.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2013.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Léopold Wilmotte
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2013059522/13.
(130073058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Cliveden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 61.486.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CLIVEDEN S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013059442/11.
(130073160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
COFRA Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 148.647.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013059444/11.
(130073254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Château Sarasin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.905.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059438/10.
(130073321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Investment Fastighets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.278.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059412/10.
(130073778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73686
L
U X E M B O U R G
CEREP Investment France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.924.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2013.
Référence de publication: 2013059413/10.
(130072932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Rewa Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 59, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.195.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 13 mai 2013.
Référence de publication: 2013061018/10.
(130075114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
CEREP Investment Z S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.154.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059417/10.
(130073460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Bryggen Waterfront S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 96.890.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2013.
Référence de publication: 2013059409/10.
(130072950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Lux Planet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 486.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 169.407.
Mr. Richard Walter HAWEL, né le 14 Août 1964 à Jersey (Royaume-Uni), demeurant au 8 rue Yolande, L-2761
Luxembourg a démissionné de sa fonction de Gérant de catégorie B avec effet au 26 Avril 2013..
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme
Référence de publication: 2013059664/12.
(130073282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73687
L
U X E M B O U R G
CEREP II Investment Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 126.036.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059421/10.
(130073840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
BB Holding Investment S.A ., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 149.449.
Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2013.
Référence de publication: 2013061325/10.
(130075849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Ascelux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 164.229.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2013.
Référence de publication: 2013061285/10.
(130076359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
CEREP City Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.197.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059410/10.
(130073436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Focus Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 148.871.
EXTRAIT
Suite au transfert du siège social de la société l’adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:
- Monsieur Benoît de FROIDMONT, (administrateur de sociétés), demeurant professionnellement au 18, rue Robert
Stümper L-2557 Luxembourg
- Monsieur Adrien ROLLE, (ingénieur commercial), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper L-2557
Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013059539/14.
(130073244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73688
L
U X E M B O U R G
GL Europe Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.011.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 15 Avril 2013i>
L’associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Mr. Henry Anthony Saavedra, né le 17 Novembre 1978 à New York, demeurant professionnellement
au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 15 Avril 2013 et pour une
durée illimitée.
Luxembourg, le 8 Mai 2013.
Référence de publication: 2013059560/14.
(130073402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Gauthier Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 83.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Référence de publication: 2013059545/10.
(130073423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP III Spain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.280.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mai 2013.
Référence de publication: 2013059428/10.
(130073002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Grevlin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 40.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059569/10.
(130073278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Grund Beteiligungen A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 143.920.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013059571/10.
(130073111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73689
L
U X E M B O U R G
H.I.G. Europe - Silentnight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2013.
Référence de publication: 2013059575/10.
(130073886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 172.951.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 66316 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013059580/10.
(130073146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Elephant Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 141.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2013.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013059499/11.
(130073009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Global Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 60.611.
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013059564/11.
(130072864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Golden Heights S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 117.313.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2013059566/12.
(130073487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73690
L
U X E M B O U R G
CEREP III Investment H S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.866.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059426/10.
(130073741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Monument Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.155,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 111.991.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059429/10.
(130073861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
CEREP Poole S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.155,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.498.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059431/10.
(130073883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 114.452.
Le bilan au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 7 mai 2013.
<i>Pour le compte de THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE SA, SICAV-SIF
i>Citibank International plc (Luxembourg Branch)
Référence de publication: 2013059124/13.
(130072273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.
Habeco Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 62-64, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 145.733.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 08/05/2013.
*.
Référence de publication: 2013059589/10.
(130073667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73691
L
U X E M B O U R G
Centre Philosophique Spirite Attitude d'Amour, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1244 Luxembourg, 130, rue Jean-François Boch.
R.C.S. Luxembourg F 9.540.
STATUTS
Entre les soussignées:
- Maria Emilia FERREIRA DA SILVA demeurant au 130 rue Jean-François Boch, L-1244 Luxembourg, aide-malade de
nationalité portugaise
- Marcia DE SOUZA ALVES demeurant au 21 rue des Hautes-Voies, B-6880 Auby-sur-Semois, femme au foyer de
nationalité belge
- Marinela Cândida ALVES LOPES demeurant au 9 rue de Christnach, L-7680 Waldbillig, aide socio-familiale de natio-
nalité portugaise
et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie
par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.
I. Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination «Centre Philosophique Spirite Attitude d'Amour» association sans but
lucratif, en abréviation CPSAA.
Art. 2. L'association a pour objet:
1- l'étude théorique et pratique, ainsi que la diffusion et divulgation de la Philosophie Spirite en tous ses aspects, sur
base des œuvres d'Allan Kardec, ce qui constitue la Codification de la Philosophie Spirite;
2- la pratique de la charité spirituelle, morale et matérielle pour les moyens à sa portée, respectivement d'assistance
spirituelle, culturelle, volontaire et philanthropique;
3- d'apprendre ensemble à faire des choix de vie, sans pour autant donner préjudice à autrui, ni attirer des souffrances
à soi même.
Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique.
Art. 4. L'association a son siège social au 130 rue Jean-François Boch, L-1244 Luxembourg. Le siège social peut être
transféré par simple décision du conseil d'administration.
Art. 5. La durée de l'association est illimitée.
II. Exercice social
Art. 6. L'exercice social coïncide avec l'année civile.
III. Membres
Art. 7. L'association est composée de membres effectifs, dont le nombre ne peut être inférieur à trois et de membres
adhérents. Tous les membres sont admis par délibération du conseil d'administration à la suite d'une demande formulée
de manière écrite ou verbale.
a- Les membres effectifs ont les pouvoirs que leur confère la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et les
présents statuts. Ils constituent l'Assemblée générale de l'association.
b- Les membres adhérents sont informés des activités de l'association et peuvent participer à ses activités. Ils ne
constituent pas l'Assemblée générale de l'association.
Art. 8. Les membres s'engagent à respecter les principes philosophiques et l'objet de l'association, ainsi que les décisions
de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite
au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 6 mois à compter du jour de l'échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.
Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte
aux intérêts de l'association. À partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est
envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.
Art. 11. La liste des membres effectifs est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont
produites et ce au 31 décembre.
73692
L
U X E M B O U R G
IV. Cotisations
Art. 12. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre effectif de l'Association, seront tenus de payer
une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le montant de cette cotisation annuelle ne peut
être supérieur à 100 euros.
Art. 13. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement
des cotisations versées.
V. Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration
régulièrement une fois par an au mois de mars, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent
ou qu'un cinquième des membres le demande par écrit en proposant un ordre du jour au conseil d'administration.
Art. 15. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant courrier
postale ou électronique devant mentionner l'ordre du jour proposé.
Art. 16. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle
doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.
Art. 17. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- la modification des statuts et règlement interne;
- la nomination et révocation des administrateurs et des éventuels réviseurs de caisse;
- l'approbation des comptes et des budgets;
- la dissolution de l'association;
- l'exclusion d'un membre.
Art. 18. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions seront prises à majorité
absolue des voix des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions de l'article 26. Chaque membre ne
peut se faire représenter que par un seul autre membre.
Art. 19. Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par voie
postale ou courrier électronique. Elles sont conservées dans un registre au siège de l'association et signées par deux
membres du conseil d'administration; elles sont consultables par les membres associés et personnes tiers.
VI. Administration
Art. 20. L'association est gérée par un conseil d'administration composé entre 3 et 6 membres, élus à la majorité simple
des voix présentes à l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de 3 ans.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises de manière collégiale. Il désigne parmi ses membres un président,
un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 21. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que les intérêts de l'asso-
ciation l'exigent ou à la demande de deux tiers de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que si 2/3 membres au
moins sont présents ou représentés. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres élus.
Art. 22. Le Conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction
sont nécessaires.
Toutefois, la gestion journalière des affaires de l'association peut être déléguée par le Conseil d'administration, à
l'exclusion de tous autres pouvoirs, soit à un associé, soit à un tiers.
Art. 23. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités,
les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
Art. 24. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives
de toute rémunération.
Art. 25. Les ressources de l'association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- l'autofinancement
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur en sa faveur autorisés dans les conditions de l'article 16 de la loi modifiée du 21 avril
1928 sur les associations et les fondations dans but lucratif.
73693
L
U X E M B O U R G
VII. Modification des statuts, Dissolution et Liquidation
Art. 26. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou la dissolution de
l'association que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers
des membres. Aucune modification aux statuts ou dissolution ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des
voix.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut
être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; Toute décision prise par une
assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, sera soumise à l'homologation du tribunal civil.
Toutefois, si la modification aux statuts porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces
règles sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des
voix des membres présents,
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée
par le tribunal civil.
Art. 27. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté, après liquidation du passif, à une association
d'assistance sociale.
VIII. Dispositions finales
Art. 28. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre
aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur par l'assemblée
générale.
Ainsi fait à Luxembourg, le 01/02/13.
<i>Les membres fondateursi>
Référence de publication: 2013060499/124.
(130073723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
MNRE (Midsomer Norton Retail Estate) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 177.051.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,
ON THE THIRTIETH DAY OF THE MONTH OF APRIL;
Before the undersigned notary Maître Cosita DELVAUX, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared:
PAPIER-METTLER INTERNATIONAL GmbH, a private limited liability company, organised and validly existing under
the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered office at Hochwaldstr. 22, D-54497 Morbach (Germany),
registered with the Trade Register of the lower regional court of Wittlich under number HRB 21698,
duly represented by Mr. Pierre METZLER, lawyer, professionally residing in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on April 25
th
, 2013.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by
the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, requested the notary to state as follows the articles of in-
corporation of a public limited liability company which he incorporates herewith and to be governed by the laws of
Luxembourg and the present articles of incorporation, as they may be amended from time to time.
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. Name. There is hereby established a public limited liability company (société anoyme) under the name of MNRE
(Midsomer Norton Retail Estate) S.A. (hereafter called the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred
to any other place within Luxembourg City by a resolution of the board of directors. It may be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
73694
L
U X E M B O U R G
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 4. Purpose. The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in other
companies either Luxembourg or foreign, as well as the ownership, management and development of such participating
interests.
The company may by any and all means whatsoever acquire, manage, develop, enhance, hold and dispose of real estate
property in Luxembourg or abroad. It may grant mortgages and other securities of whatever kind over its property to
secure its own indebtness or the indebtness of companies being part of the same group of companies as itself.
The purpose of the Company is, in particular, the acquisition of any type of securities, whether negotiable or not,
stock, bonds, debentures, notes and other securities, including those issued by any Government or any other international,
national or local authority, and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription, option
or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner. Moreover, the Company may
proceed to the acquisition and development of connected patents and licenses.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures. The
Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company. The Company may
further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any form
whatsoever in any enterprise or any private corporation as well as to the administration, management, control and
development of these participating interests.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful
to enhance or to supplement its purpose.
Title II. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 50,000 (fifty thousand Euro) represented
by 50,000 (fifty thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
The authorised capital is set at EUR 250,000,000 (two hundred fifty million Euro) represented by 250,000,000 (two
hundred fifty million) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Furthermore, the board of directors is authorised during a period expiring five years after the date of incorporation
of the Company to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such
increased amount of capital may be subscribed for and issued against payment in cash or contribution in kind by observing
the then applicable legal requirements or integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into
the corporate capital by law, in each case with or without issue premium as the board of directors may from time to time
determine. The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserving to the then
existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to
any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting
subscriptions and receiving payments for the shares representing part or all such increased amount of capital.
Each time the board of directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame
mentioned here above, Article 5 of the articles of association shall be amended so as to reflect the result of such action
and the board of directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining
execution and publication of such amendment.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a
general meeting of the shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares and reimburse to the
shareholders all or part of the share premium account, if any.
Art. 6. Shares. The shares of the Company may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
Title III. General meetings of shareholders
Art. 7. Powers. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.
73695
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of
the Company, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the third
Wednesday of the month of June at 2.00 p.m. and for the first time in two thousand and fourteen.
If such day is a legal holiday in the Grand-Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following business day.
Except as otherwise required by law or the articles of association, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.
Any shareholder may participate in any general meeting of shareholders by conference call or by other similar means
of communication enabling the identification of such shareholder and all the persons taking part in the meeting to hear
one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The articles of association of the Company may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders.
The general meeting shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates
the proposed amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the object or the form
of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened by means of notices
published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C and in two Lu-
xembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed.
The votes expressed do not include the votes attached to the shares for which the shareholder has not taken part in
the vote or has abstained from voting or returned a blank or void voting paper. The nationality of the Company may only
be changed and the commitments of the shareholders may only be increased with the unanimous consent of the share-
holders.
Art. 9. Sole shareholder. If the Company has only one shareholder, the sole shareholder has all the powers of the
general meeting.
The resolutions of the sole Shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.
Title IV. Board of directors
Art. 10. Composition. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three
members who need not be shareholders of the Company.
Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by only one shareholder, or if a general
meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of directors may
be composed of one member only until the ordinary general meeting of shareholders following the acknowledgment of
the existence of more than one shareholder.
The director(s) are (is) appointed by the general meeting of the shareholders, which shall determine their number, fix
the term of their office as well as their remuneration.
They (He) shall hold office until their (his) successors are elected.
The director(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting
of the shareholders.
In the event of one or more vacancies at the board of directors by reason of death, retirement or otherwise, the
remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.
Art. 11. Organisation. The board of directors chooses from among its members a chairman, and may choose from
among its members a vice-chairman.
In case of a board of directors composed of one member, such sole director shall be the chairman of the board.
It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors; in his absence the board of directors may appoint
a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors.
Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled
to attend, at least a eight days' written notice of the board meetings shall be given. The meeting will be duly held without
prior notice if all the directors are present or duly represented.
73696
L
U X E M B O U R G
The notice may be waived by consent in writing of each director.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by
all the directors present at such a meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Resolutions shall be passed by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.
Art. 12. Powers. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and
disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the
general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of sharehol-
ders, to any member or members of the board. It may further delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any third person or
to any committee (the members of which may not be directors) deliberating under such terms and with such powers as
the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any person(s) who need(s) not be
directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 13. Representation. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature
of any two directors or by the single signature of any person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the
board of directors.
If only one director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal
entity, the signature shall be considered if given by its the Permanent Representative.
Title V. Supervision of the Company
Art. 14. Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commis-
saire aux comptes), which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory
auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
If the Company exceeds the thresholds fixed by the law, it will appoint an independent auditor.
Title VI. Accounting year - Annual Accounts
Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1 of each year and shall terminate
on December 31 of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
incorporation of the Company and shall terminate on December 31, 2013.
Art. 16. Annual accounts. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each accounting
year and will be at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual
net profits will be disposed of.
All shares will rank equally to dividend distributions.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Title VII. Winding up - Liquidation
Art. 17. Liquidator. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Title VIII. Final clause - Applicable law
Art. 18. Applicable law. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in
accordance with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and in particular with the law of August 10, 1915 on
commercial companies as amended.
73697
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
Capital
(EUR)
Paid-up
capital
(EUR)
Number
of shares
Papier-Mettler International GmbH, presaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000
50,000
50,000
The 50,000 (fifty thousand) shares of the Company have been fully paid-up by the subscriber, proof of which payment
having been given to the undersigned notary, so that the amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) is as of now available
to the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.
<i>Extraordinary General Meeting of the sole shareholderi>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has made
the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of statutory auditors at 1 (one).
2. The following persons are appointed director:
- Mr. Michael Mettler, businessman, born in Morbach (Federal Republic of Germany) on 12 March 1960, professionally
residing at Hochwaldstrasse 22, D-54497 Morbach;
- Ms. Karin Mettler, businesswoman, born in Birkenfeld (Federal Republic of Germany) on 2 February 1969, profes-
sionally residing at Hochwaldstrasse 22, D-54497 Morbach;
- Mr. Stéphane Deitz, Financial Director, born in Luxembourg on 26 Mars 1969, professionally residing at 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
3. Mr. Werner Tiedemann, Jurist, born in Wangen im Allgäu (Federal Republic of Germany) on 15 September 1965,
professionally residing at Hochwaldstrasse 22, D-54497 Morbach, has been appointed statutory auditor.
4. The registered office of the Company is at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
5. The term of office of the director and of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting of
shareholders approving the annual accounts as at December 31, 2013.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with the notary the present
deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
IM JAHRE ZWEITAUSENDUNDDREIZEHN, DEN DRESSIGSTEN APRIL.
Vor uns, Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtswohnsitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
PAPIER-METTLER INTERNATIONAL GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, organisiert und bestehend
gemäß den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, mit eingetragenen Sitz in Hochwaldstr. 22, D-54497 Morbach
(Deutschland), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter Nummer HRB 21698, hier ordnungsge-
mäß vertreten durch Herrn Pierre METZLER, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt am 25. April 2013.
Die besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, welche den Gründer
vertritt und den unterzeichnenden Notar an dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung anliegend.
Die erschienene Partei, vertreten wie zuvor genannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Akti-
engesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme) zu beurkunden, welche den geltenden Gesetzen und der
folgenden Satzung unterliegen wird:
73698
L
U X E M B O U R G
Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Name. Hiermit wird eine Aktiengesellschaft („société anonyme") unter dem Namen MNRE (Midsomer Norton
Retail Estate) S.A. (hiernach die "Gesellschaft" genannt), gegründet.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Verwal-
tungsrats an jeden beliebigen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Er kann durch Beschluss der
Hauptversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland gegründet werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art, welche die normale Tätigkeit am
Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen
könnten, auftreten oder sollten diese bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt
werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen betreffen jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die,
ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an
anderen Gesellschaften, in Luxemburg oder im Ausland, sowie das Eigentum, die Verwaltung und die Verwertung von
solchen Beteiligungen.
Der Gesellschaft kann in jedweder Form Immobilienbesitz in Luxemburg oder im Ausland erwerben, verwalten, ver-
werten, fördern, halten und verfügen. Die Gesellschaft kann Hypotheken und andere Sicherheiten jedweder Form über
ihr Eigentum bestellen, um ihre eigenen Verpflichtungen oder die Verpflichtungen von Gesellschaften derselben Gesell-
schaftsgruppe zu sichern.
Der Gesellschaftszweck ist, insbesondere, der Erwerb jeder Art von Wertpapieren, übertragbar oder nicht, Aktien,
Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheine und andere Papiere, einschließlich derer, die durch eine Regierung oder
eine andere internationale, nationale oder örtliche Behörde herausgegeben werden, und aller dazu gehörigen Rechte, sei
es durch Kauf, Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, als auch die Übertragung mittels Verkauf,
Tausch oder in jeder anderen Weise. Zudem kann die Gesellschaft verbundene Patentrechte und Lizenzrechte erwerben
und verwerten.
Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-
geben. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die
derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder
Sicherheiten gewähren.
Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen,
in jedweder Form an jedem Unternehmen oder jeder Personengesellschaft als auch die Verwaltung, Kontrolle, und Ver-
wertung dieser Beteiligungen betreffen.
Allgemein kann die Gesellschaft sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen,
welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.
Titel II. Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Kapital. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) eingeteilt in
50.000 (fünfzigtausend) vollständig einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro).
Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 250.000.000,- (zweihundertfünfzig Millionen Euro) eingeteilt in
250.000.000 (zweihundertfünfzig Millionen) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro).
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren nach Unterzeichnung der Gründungsurkunde, das ge-
zeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise innerhalb des Rahmens des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinzahlung oder Sacheinlage nach den
dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener
Gewinne, welche von Gesetzes wegen dem Kapital einverleibt werden können mit oder ohne Emissionsprämie, je nach
Beschluss des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt, diese Kapitaler-
höhungen durchzuführen ohne den dann bestehenden Aktionären ein Vorzugszeichnungsrecht zu gewähren. Der
Verwaltungsrat kann jedes ordnungsgemäß bevollmächtigte Verwaltungsratsmitglied, jeden Funktionsträger der Gesell-
schaft oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen zu akzeptieren und
Zahlungen für die Aktien entgegenzunehmen, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen.
Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird
Artikel 5 der Satzung entsprechend abgeändert und der Verwaltungsrat oder eine hierzu ermächtigte Person wird sämt-
liche notwendigen Schritte vorzunehmen, um die Durchführung und Veröffentlichung der Satzungsänderung wirksam
durchzusetzen.
73699
L
U X E M B O U R G
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in einem oder
mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden. Die Hauptversammlung der Aktionäre wird unter Einhaltung
derselben Voraussetzungen und Bedingungen abstimmen, welche für den Fall einer Satzungsänderung vorgesehen sind.
Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen und die Agiorüc-
klage, soweit vorhanden, den Gesellschaftern ganz oder teilweise zurückerstatten.
Art. 6. Aktien. Die Aktien der Gesellschaft können nach Wahl der Aktionäre Inhaberaktien oder Namensaktien sein.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als
einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis eine
Person als alleiniger und berechtigter Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Dieselbe Bestimmung ist
im Falle eines Widerstreites zwischen einem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire)
oder zwischen Pfandschuldner und Pfandgläubiger anzuwenden.
Titel III. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 7. Befugnisse. Jede ordnungsgemäß zusammengesetzte Aktionärsversammlung vertritt die Gesamtheit der Akti-
onäre der Gesellschaft. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der
Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.
Art. 8. Versammlungen. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft
oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am dritten Mittwoch des Monats Juni
um 14.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausendundvierzehn statt.
Sofern dieser Tag ein Feiertag im Großherzogtum Luxemburg ist, findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre
am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts Gegenteiliges vorsehen, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einbe-
rufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Dabei gewährt jede Aktie ein Stimmrecht.
Jeder Aktionär kann auf jeder Hauptversammlung durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikations-
mittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören und
miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese
Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.
Ein Aktionär kann sich auf jeder Hauptversammlung der Aktionäre durch eine andere Person mittels schriftlicher
Vollmacht vertreten lassen und durch diese handeln.
Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Einberufung
oder Bekanntmachung abgehalten werden.
Die Satzung kann wirksam abgeändert werden mittels Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre. Die Haupt-
versammlung kann nur dann rechtmäßig beraten, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, die
Tagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungsvorschläge enthält und diese, soweit anwendbar, den Zweck oder die
Form der Gesellschaft betreffen. Sollte die erste dieser Bedingungen nicht erfüllt sein, kann eine zweite Versammlung
mittels Einberufungschreiben, welches zweimal in einem Intervall von fünfzehn Tagen und mindestens fünfzehn Tagen vor
dieser Hauptversammlung im Mémorial C sowie in zwei luxemburgischen Tageszeitungen zu veröffentlichen ist, einbe-
rufen werden. Ein solches Einberufungsschreiben muss die Tagesordnung beinhalten sowie das Datum und die Ergebnisse
der letzten Hauptversammlung enthalten. Die zweite Hauptversammlung kann ungeachtet der Ratio des vertretenen
Kapitals rechtmäßig beraten. In beiden Versammlungen, benötigen Beschlüsse, um rechtswirksam angenommen zu sein,
einer Mehrheit von mindestens zweidrittel (2/3) der abgegebenen Stimmen.
Die abgegebenen Stimmen beinhalten nicht diejenigen den Aktien zugehörigen Stimmrechte eines Aktionärs, welcher
an der Stimmabgabe nicht teilgenommen, sich enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat.
Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Aktionäre können nur durch
die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre herbeigeführt werden.
Art. 9. Alleiniger Gesellschafter. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so besitzt dieser sämtliche Befugnisse der
Hauptversammlung.
Die im Rahmen des vorhergehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll
festgehalten.
Titel IV. Verwaltungsrat
Art. 10. Zusammensetzung. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei
Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionäre sein müssen.
Wurde die Gesellschaft von einem alleinigen Aktionär gegründet, oder wurde in einer Hauptversammlung der Akti-
onäre festgestellt, dass die Gesellschaft lediglich über einen Aktionär verfügt, so kann die Zusammensetzung des
Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die der Feststellung der Anwesenheit von mehr
als einem Aktionär folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden.
73700
L
U X E M B O U R G
Die (Das) Verwaltungsratsmitglied(er) werden (wird) von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre
Anzahl bestimmt und sowohl die Dauer des Mandats als auch ihre (seine) Vergütung festsetzt. Sie (Er) werden (wird) das
Mandat so lange innehaben, bis ihre (seine) Nachfolger gewählt sind.
Die (Das) Verwaltungsratsmitglied(er) können (kann) jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre
mit oder ohne Begründung (ad nutum) ihres (seines) Mandates enthoben werden.
Im Falle eines oder mehrerer freier Sitze(s) im Verwaltungsrat aufgrund eines Todesfalles, Rücktritts oder aus sons-
tigem Grund, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Gesetzes einen solchen freien Sitz besetzen. In einem solchen Falle genehmigt die Hauptversammlung der Aktionäre die
Wahl des Verwaltungsrats im Rahmen ihrer nächsten Sitzung.
Art. 11. Organisation. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden
Vorsitzenden wählen.
Falls der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, fungiert dieses alleinige Verwaltungsratsmitglied als Vorsit-
zender des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und dafür
verantwortlich ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen zu führen.
Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an
dem, in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.
Der Vorsitzende hat auf allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz inne. In seiner Abwesenheit kann der Verwal-
tungsrat einen pro tempore Vorsitzenden durch Mehrheitswahl der auf der Sitzung anwesenden Mitglieder einsetzen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln zu jeder Verwaltungsratssitzung geladen. Außer im Dringlichkeitsfalle,
welcher in der Einberufung angegeben ist oder mit vorhergehender Zustimmung all derer, die berechtigt sind zugegen zu
sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens innerhalb von acht Tagen zu erfolgen. Die
Sitzung ist ohne vorherige Einberufung ordnungsgemäß gehalten, falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ord-
nungsgemäß vertreten sind.
Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied
mittels schriftlicher Vollmacht handeln.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch Konferenzschaltung oder durch
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegen-
seitig zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls ausschließlich durch Konferenzschaltung
abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an
solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwal-
tungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben.
Die Verwaltungsratssitzung kann, einstimmig, Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichen Dokumenten durch Rund-
schreiben fassen, sofern dem schriftlich zugestimmt wurde. Die Gesamtheit wird das den Beschluss beweisende Protokoll
bilden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf der Ver-
waltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder
vertretenden Verwaltungsratsmitglieder gefasst.
Art. 12. Befugnisse. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungs-
handlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz
oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwal-
tungsrates.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-
sellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich einer solchen Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit
dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwal-
tungsrates übertragen. Er kann zudem seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung und Angelegenheiten
der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich einer solchen Geschäftsführung und Angelegenheiten
an eine Drittperson oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder sind), unter den vom Ver-
waltungsrat festgelegten Bedingungen und Befugnissen übertragen. Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sonder-
vollmachten an jede Person oder Personen, welche nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, übertragen,
Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen sowie ihre Bezüge festsetzen.
Art. 13. Vertretung. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unter-
schrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift der Person oder Personen, welchen eine
solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.
Sofern lediglich ein Alleinverwalter existiert, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters rechtlich
wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so ist deren permanenten Vertreter zeichnungsbe-
rechtigt.
73701
L
U X E M B O U R G
Titel V. Überwachung der Gesellschaft
Art. 14. Aufsichtskommissar. Die Überwachung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Auf-
sichtskommissar(en) (commissaire aux comptes), die Aktionäre sein können oder nicht. Die Hauptversammlung der
Aktionäre ernennt die Aufsichtskommissare und legt ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest, welches
sechs Jahre nicht überschreiten kann.
Sollte die Gesellschaft die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten, wird sie einen Wirtschaftsprüfer bestellen.
Titel VI. Geschäftsjahr - Jahresabschlüsse
Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31.
Dezember des gleichen Jahres, mit der Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Gründungstag der Gesellschaft
beginnt und am 31. Dezember 2013 endet.
Art. 16. Jahresabschluss. Die Jahresabschlüsse werden jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, vom Verwaltungsrat
erstellt und stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage
verwendet. Diese Verwendungsverpflichtung erlischt, wenn und soweit die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des
gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Auf Empfehlung des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Verfügung des jährli-
chen Reingewinns.
Alle Aktien nehmen hinsichtlich der Dividendenausschüttung den gleichen Rang ein. Im Falle von teilweise einbezahlten
Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.
Titel VII. Auflösung - Liquidation
Art. 17. Liquidator. In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren
(welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung der Aktionäre
ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheiden und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators /der
Liquidatoren festlegen.
Title VIII. Schlussbestimmung - Anwendbares Recht
Art. 18. Anwendbares Recht. Alle Angelegenheiten, welche nicht ausdrücklich durch die vorliegende Satzung geregelt
sind, werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, insbesondere durch das Gesetz
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert, bestimmt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Der Zeichner hatwie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:
Aktionär
Gezeichnetes
Kapital (EUR)
Eingezahltes
Kapital (EUR)
Anzahl
der
Aktien
Papier-Mettler International GmbH, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
50.000
50.000
Die 50.000 (fünfzigtausend) Aktien der Gesellschaft wurden durch den Zeichner vollständig eingezahlt; der Nachweis
dieser Zahlung ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro)
von heute an zur Verfügung der Gesellschaft steht.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften wie abgeändert vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt
worden sind.
<i>Kosteni>
Die infolge ihrer Gründung entstandenen Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welcher Form auch immer,
werden auf ungefähr EUR 1.400,- geschätzt und durch die Gesellschaft getragen.
<i>Außerordentliche Hauptversammlung des Aktionärsi>
Die vorgenannte Person, welche die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals vertritt und die sich als ordnungsgemäß
einberufen erklärt, hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) und die Zahl der Aufsichtskommissare auf 1 (einen)
festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
73702
L
U X E M B O U R G
- Herr Michael Mettler, Geschäftsmann, geboren in Morbach (Bundesrepublik Deutschland) am 12. März 1960, beruflich
ansässig in D-54497 Morbach, Hochwaldstrasse 22;
- Frau Karin Mettler, Geschäftsfrau, geboren in Birkenfeld (Bundesrepublik Deutschland) am 2. Februar 1969, beruflich
ansässig in D-54497 Morbach, Hochwaldstrasse 22;
- Herr Stéphane Deitz, Finanzdirektor, geboren in Luxemburg am 26. März 1969, beruflich ansässig in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg;
3. Herr Werner Tiedemann, Jurist, geboren in Wangen im Allgäu (Bundesrepublik Deutschland) am 15. September
1965, beruflich ansässig in D-54497 Morbach, Hochwaldstrasse 22, wird zum Aufsichtskommissar ernannt.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
5. Das Mandat des Verwaltungsratsmitglieds und des Aufsichtskommissars erlischt am Ende der jährlichen Hauptver-
sammlung der Aktionäre, welche den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 genehmigt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der obengenannten erschienenen Person in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer
deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie am Anfang des Dokuments erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde un-
terzeichnet.
Signé: P. METZLER, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 02 mai 2013. Relation: RED/2013/710. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 10. Mai 2013.
M
e
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013060314/492.
(130074096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.
Outlet Mall Sub Group Holding No. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 762.700,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 114.753.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty- ninth of April.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Outlet Mall Group Holding S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having its
registered office at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 97.674 (the "Appearing Company" or "OMGH"), here represented
by Mister Erwin VANDE CRUYS private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo L- 1750 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on April 26
th
, 2013.
The said proxy, signed "ne varietur" by the Appearing Company and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Such Appearing Company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that.
I. The Appearing Company is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité
limitée") established in Luxembourg under the name of "Outlet Mall Sub Group Holding No. 2 S.à r.l.", having its registered
office at 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 114.753 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 2
nd
, 2006, published in the "Mémorial
C - Recueil des Sociétés et Associations", number 984, on May 19
th
, 2006. The articles of association have been amended
for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, dated March 19
th
, 2013, not
published in the "Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Company's share capital is set at seven hundred and sixty-two thousand, six hundred Euro (EUR 762,600.-)
represented by seven thousand six hundred and twenty-six (7,626) shares having a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.-) each, all of which are fully paid up.
73703
L
U X E M B O U R G
III. The sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR
100.-), to raise it from its present amount of seven hundred and sixty-two thousand six hundred Euro (EUR 762,600.-)
to seven hundred and sixty-two thousand seven hundred Euro (EUR 762,700.-), by creation and issue of one (1) new
share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), along with the payment of a share premium whose aggregate
value amounts two million four hundred seventy-five thousand Euro (EUR 2,475,000.-).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon intervened OMGH, prenamed, through its proxyholder, and declared to subscribe to one (1) new share
to be issued, and have such share, whose subscription value amounts to one hundred Euro (EUR 100.-), and the related
share premium in the aggregate amount of two million four hundred seventy-five thousand Euro (EUR 2,475,000.-), both
fully paid-up by a contribution in kind consisting of the conversion and subsequent extinction of a certain, unquestionable
and undisputed debt in the total amount of two million four hundred seventy-five thousand and one hundred Euro (EUR
2,475,100.-) owed by the Company to OMGH (the "Contribution in Kind"), out of which only one hundred Euro (EUR
100.-) is used for a share capital increase corresponding to one (1) additional share with a nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.-), subscribed by the latter, the remaining amount being allocated to the share premium account of the
Company. It is further noted that such debt results from a declaration of the Company, as debtor company, dated April
29
th
, 2013, and from a declaration of OMGH, as holder of the receivable, dated April 29
th
, 2013. The copies of the
above mentioned declarations will remain annexed to the present deed.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
OMGH, prenamed, through its proxyholder, declared that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally
and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Contribution in Kind is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the country of location of the Contribution in Kind in order to duly carry out
and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
IV. Pursuant to the above resolution, article 5, first paragraph, of the Company's articles of association is amended and
shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at seven hundred and sixty-two thousand seven
hundred Euro (EUR 762,700.-) divided into seven thousand six hundred and twenty-seven (7,627) shares, with a nominal
value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up."
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued share in the share register of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand three hundred Euro (EUR 3.300.-) by the
undersigned notary.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the Appearing Com-
pany, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the Appearing Company and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in the Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the Appearing Company, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
73704
L
U X E M B O U R G
Outlet Mall Group Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4A, rue Henri Schnadt,
L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 97.674 (la «Comparante» ou «OMGH»), représentée par Monsieur Erwin VANDE CRUYS
employé privé, ayant son adresse professionnelle au 74 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 avril 2013.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la Comparante et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle Comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La Comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «Outlet Mall Sub Group Holding No. 2 S.à r.l.», ayant son siège social au 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 114.753 (ci-après la «Société»), constituée suivant un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 2 mars 2006, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 984, le 19 mai 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri
Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 19 mars 2013, non encore publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés
et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à sept cent soixante-deux mille six cents euros (762.600,- EUR) représenté
par sept mille six cent vingt-six (7.626) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, chaque
part sociale étant entièrement libérée.
III. L'associée unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent euros (100,- EUR), pour
le porter de son montant actuel de sept cent soixante-deux mille six cents euros (762.600,- EUR) à sept cent soixante-
deux mille sept cents euros (762.700,- EUR), par la création et l'émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR), avec le paiement d'une prime d'émission dont la valeur totale s'élève à deux millions
quatre cent soixante-quinze mille euros (2.475.000,- EUR).
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue, OMGH, prénommée, qui, par son mandataire, a déclaré souscrire à une (1) nouvelle part sociale
à émettre, et la libérer intégralement, pour une valeur de souscription totale de cent euros (100,-EUR) ainsi qu'à la prime
d'émission s'y afférant d'un montant total de deux millions quatre cent soixante-quinze mille euros (2.475.000- EUR), le
tout étant entièrement libéré par un apport en nature consistant en la cession et l'extinction subséquente d'une créance
certaine, liquide et exigible d'un montant total de deux millions quatre cent soixante-quinze mille et cent euros (2.475.100,-
EUR)détenue par OMGH sur la Société Apport en Nature»), dont cent euros (100,- EUR) seulement sont utilisés pour
une augmentation de capital correspondant à une (1) part sociale supplémentaire d'une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR), souscrite par cette dernière, le montant restant étant alloué au compte de prime d'émission de la Société.
Il est de plus noté que ladite créance résulte d'une déclaration de la Société, en tant que société débitrice, datée du 26
avril 2013, ainsi que d'une déclaration d'OMGH, prénommée, en tant que société détentrice de ladite créance, et datée
du 26 avril 2013. Les copies desdites déclarations demeureront annexées au présent acte.
<i>Réalisation effective de l'apport en naturei>
OMGH, prénommée, par son mandataire, a déclaré que:
- elle est la seule propriétaire de l'Apport en Nature et possède les pouvoirs d'en disposer;
- le transfert de l'Apport en Nature est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays du lieu de l'Apport en Nature, aux fins d'effectuer
la cession de l'Apport en Nature et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
IV. Suite à la résolution susmentionnée, l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social émis. Le capital social de la Société est fixé à sept cent soixante-deux mille sept cents euros
(762.700,- EUR) représenté par sept mille six cent vingt-sept (7.627) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent
euros (100,- EUR) chacune, lesquelles ont toutes été libérées.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des parts sociales de la Société.
73705
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille trois cents euros (EUR 3.300.-) par le
notaire soussigné.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la Comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la Comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé au Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connue du notaire soussigné par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: E. Vande Cruys et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 avril 2013. LAC/2013/20077. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2013.
Référence de publication: 2013060334/154.
(130074053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.
Vodafone Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 46.027.346.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 73.612.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-second day of March.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 15 Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 83088,
duly represented by Sean O'Brien, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 19 March 2013.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Vodafone Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, in-
corporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 15 Rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 73612, incorporated
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 31 De-
cember 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 20 March 2000, number 217. The
articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary
residing in Luxembourg, on 21 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 25
February 2013, number 461 (hereinafter the "Company").
The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder notes that the Company has received one hundred and ninety-two thousand nine hundred and
ninety-six (192,996) of its shares and USD 257.12 in cash from the sole shareholder on or just before 22 March 2013 as
compensation for the Company overpaying the 7.053.377 shares it bought back on 21 December 2012.
The sole shareholder decides to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred and ninety-
two million, nine hundred and ninety-six thousand US Dollars (USD 192,996,000), in order to bring it from its current
amount of forty-six billion two hundred and twenty million three hundred and forty-two thousand US Dollars (USD
46,220,342,000) to an amount of forty-six billion twenty-seven million three hundred and forty-six thousand US Dollars
(USD 46,027,346,000), through the cancellation of one hundred and ninety-two thousand nine hundred and ninety-six
(192,996) shares having a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each which are held by the Company and
73706
L
U X E M B O U R G
increase the share premium account by an amount of one hundred and ninety-two million, nine hundred and ninety-six
thousand two hundred and fifty-seven US Dollars and twelve cents (USD 192,996,257.12).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, Article 6 of the Articles of Association is amended and now reads as follows:
« Art. 6. The Company's share capital is set at forty-six billion twenty-seven million three hundred and forty-six
thousand US Dollars (USD 46,027,346,000), represented by forty-six million twenty-seven thousand three hundred and
forty-six (46,027,346) shares with a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000) each."
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that this deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille treize, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83088,
dûment représentée par Sean O'Brien demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 19 mars 2013.
La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est la seule associée de la société Vodafone Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
73612, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 31 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 20 mars 2000,
numéro 217. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de
résidence à Luxembourg, le 21 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 25 février
2013 numéro 461 (ci-après la «Société»).
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique prend note du fait que la Société a reçu de l'associée unique cent quatre-vingt-douze mille, neuf cent
quatre-vingt-seize (192.996) parts sociales dans la Société ainsi que USD 257.12 en espèces le 22 mars 2013 ou juste
avant. Ce transfert est fait en compensation du trop perçu par l'associée unique pour le rachat par la Société de 7.053.377
de ses parts sociales le 21 Décembre 2012.
L'associée unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-douze millions
neuf cent quatre-vingt-seize mille US Dollars (USD 192.996.000) pour réduire son montant actuel de quarante-six milliards
deux cent vingt millions trois cent quarante-deux mille US Dollars (USD 46.220.342.000) à un montant de quarante-six
milliards vingt-sept millions trois cent quarante-six mille US Dollars (USD 46.027.346.000) par l'annulation de cent quatre-
vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-seize (192.996) parts sociales d'une valeur nominale de mille US Dollars (USD
1.000) chacune, qui sont détenues par la Société, et par l'augmentation du compte prime d'émission d'un montant de
cent quatre-vingt-douze millions neuf cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-sept US Dollars et douze cents (USD
192.996.257,12).
<i>Seconde résolutioni>
A la suite de la première résolution, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à quarante-six milliards vingt-sept millions et trois cent quarante-six mille US Dollars
(USD 46.027.346.000) représenté par quarante-six millions, vingt-sept mille trois cent quarante-six (46.027.346) parts
sociales avec une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
73707
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. O'Brien et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 mars 2013. LAC/2013/13938. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Référence de publication: 2013060454/100.
(130073638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.
wondermags Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7A, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 177.088.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am neunzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,
sind erschienen:
1. Herr Sascha BRANDHORST, Geschäftsführer, geboren am 18. März 1970 in Siegen (Deutschland), wohnhaft in
D-57518 Betzdorf, Kettlerstrasse 26,
2. Herr Hans-Peter KAHNT, Kaufmann, geboren am 23. November 1952 in Halle/Saale (Deutschland), wohnhaft in
D-04571 Rötha, Heimstätten 18,
hier vertreten durch: Herr Sascha Brandhorst, Geschäftsführer, geboren am 18. März 1970 in Siegen (Deutschland),
wohnhaft in D-57518 Betzdorf, Kettlerstrasse 26
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 18. April 2013 in Siegen (Deutschland),
3. Herr Manfred UTSCH, Fabrikant, geboren am 24. März 1936 in Eiserfeld (Deutschland), wohnhaft in D-57080 Siegen,
Haspelweg 9,
hier vertreten durch: Herr Sascha Brandhorst, Geschäftsführer, geboren am 18. März 1970 in Siegen (Deutschland),
wohnhaft in D-57518 Betzdorf, Kettlerstrasse 26
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 18. April 2013 in Siegen (Deutschland),
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung „ne varietur" durch die Erschienenen und den beurkundenden Notar
als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
sie hiermit gründen, wie folgt festzulegen.
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „wondermags Sari" gegrün-
det.
Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Vermarktung von Software und Herstellungsverfahren für
IT Produkte mit, unter anderem, dem Ziel einer Internet basierten Lösung für das Erzeugen und die Bereitstellung elek-
tronischer Magazine.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Lizenzen, Patente, Konzessionen jeder Art, sowie davon abgeleitete
oder dieselben ergänzende Rechte, aktiv oder passiv, erwerben, verwerten, veräußern und verwalten.
Die Gesellschaft kann außerdem Beteiligungen in welcher Form auch immer an in- und ausländischen Gesellschaften
und Unternehmen jeglicher Art erwerben, verwalten, kontrollieren sowie verwerten.
Weiterhin ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder demselben dienen.
Art. 4. Der Gesellschaftsitz befindet sich in Wasserbillig. Er kann innerhalb derselben Ortschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500) Euro, eingeteilt in hundert (100)
Anteile zu je hundertfünfundzwanzig (125) Euro.
73708
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jedes Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter welche mit einer Stimmenmehrheit von wenigstens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals entscheiden muss. In einem solchen Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von
dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Im Todesfall kann eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter, inklusive pflichtteilsberechtigte
Erben oder der überlebende Ehepartner, nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschaftern, welche wenigstens
fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen. Ausgenommen von dieser Regelung im To-
desfall ist die Übertragung der Gesellschaftsanteile von Gesellschafter Sascha Brandhorst an dessen Ehefrau Annett
Brandhorst, welche keiner Genehmigung bedarf.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Sie können jederzeit (i) ohne
Einhaltung einer Frist und (ii) ohne Angabe eines Grundes von derselben abberufen werden.
Der oder die Geschäftsführer haben im Rahmen des Gesetzes die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft-
sangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten und zu verpflichten.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat so viele Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse desweiteren gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestim-
mungen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-
kapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für sämtliche in dieser Satzung nicht geregelte Punkte gelten die Luxemburger Gesetze.
<i>Übergangsregelungi>
Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die 100 (einhundert) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, wurden wie folgt gezeichnet:
1. Herr Sascha BRANDHORST, vorbezeichnet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Anteile
2. Herr Hans-Peter KAHNT, vorbezeichnet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Anteile
3. Herr Manfred UTSCH, vorbezeichnet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Anteile
Alle Anteile wurden voll in bar einbezahlt. Demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), was hiermit ausdrücklich von dem unterzeichneten Notar
festgestellt wurde.
73709
L
U X E M B O U R G
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungi>
Die aus Anlass der Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EUR 1.400.- geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversamm-
lung der Gesellschafter, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit
der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6630 Wasserbillig, 7a Grand Rue festgelegt.
2. Folgende Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:
- Herr Stojan RUDAN, Manager, geboren am 11. Februar 1978 in Karlovac, wohnhaft in D-57076 Siegen, Hainbu-
chenweg 52 und
- Dr. Peter LEU, Unternehmensberater, geboren am 22. Februar 1951, wohnhaft in D-24256 Stoltenberg, Am See 5.
Beide Geschäftsführer verfügen über eine uneingeschränkte Einzelzeichnungsberechtigung.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit Uns,
Notar, diese Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: S. BRANDHORST und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2013. Relation: LAC/2013/19288. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts- und Handelsregister
und der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 10. Mai 2013.
Référence de publication: 2013060543/117.
(130075071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Word and Advice S.A., Société Anonyme,
(anc. Luxairco S.A.).
Siège social: L-8410 Steinfort, 58, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 169.824.
L'an deux mille treize, le vingt-deux avril.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUXAIRCO S.A." (numéro
d'identité 2012 22 10 899), avec siège social à L-4751 Pétange, 165C, route de Longwy, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 169.824, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 juin 2012, publié au Mémorial C,
numéro 1915 du 1
er
août 2012.
L'assemblée est présidée par Monsieur le Baron René PAULUS de CHATELET, retraité, demeurant à Bridel.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique).
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit: I.- L'ordre
du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination sociale en «WORD AND ADVICE S.A.» et modification subséquente de l'article
1
er
des statuts.
2) Modification de l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet le courtage, la communication, le conseil, l'organisation d'événements tant dans les
domaines financier, commercial ou intellectuel qu'en matière d'oeuvres artistiques et/ou de leurs dérivés.
Elle pourra être détentrice d'actifs commerciaux, mobiliers ou de tout autre ordre pour compte propre ou pour
compte de tiers et quelle que soit la nature de l'actif.
73710
L
U X E M B O U R G
Elle pourra éditer, détenir, vendre, réaliser, encaisser des produits d'auteur ou des droits d'auteur pour compte propre
ou pour compte de tiers ou en participation.
Elle pourra organiser le transport de tous biens meubles, de valeurs et d'objets d'art et assurer leur conservation tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule
ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.
La société peut emprunter sous toutes les formes et accorder tous cautionnements ou garanties.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-
cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement
de son objet.»
3) Transfert du siège social à L-8410 Steinfort, 58, route d'Arlon et modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article
2 des statuts.
4) Administrateur.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte. Les
procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en «WORD AND ADVICE S.A.».
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «WORD AND ADVICE S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet le courtage, la communication, le conseil, l'organisation d'événements tant dans les
domaines financier, commercial ou intellectuel qu'en matière d'oeuvres artistiques et/ou de leurs dérivés.
Elle pourra être détentrice d'actifs commerciaux, mobiliers ou de tout autre ordre pour compte propre ou pour
compte de tiers et quelle que soit la nature de l'actif.
Elle pourra éditer, détenir, vendre, réaliser, encaisser des produits d'auteur ou des droits d'auteur pour compte propre
ou pour compte de tiers ou en participation.
Elle pourra organiser le transport de tous biens meubles, de valeurs et d'objets d'art et assurer leur conservation tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule
ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.
La société peut emprunter sous toutes les formes et accorder tous cautionnements ou garanties.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-
cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement
de son objet.»
73711
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social à L-8410 Steinfort, 58, route d'Arlon et en conséquence de modifier
le 1
er
alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. al. 1
er
. Le siège de la société est établi à Steinfort.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Alessandro TROVATO comme administrateur unique de la
société et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique Monsieur le Baron René PAULUS de CHATE-
LET. retraité, né à Ixelles (Belgique) le 14 septembre 1947, demeurant à L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, avec
pouvoir de signature individuelle.
Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2018 et sera exercé
à titre gratuit.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (€ 1.100.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: PAULUS de CHATELET, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2013. Relation: CAP/2013/1493. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): ENTRINGER.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 6 mai 2013.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2013060524/106.
(130074109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.
AJYR Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 144.324.
L'an deux mille treize, le vingt-cinq avril
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AJYR Investissement S.A., établie et ayant
son siège social à L-8522 BECKERICH, 6 rue Jos Seyler,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 144.324,
constituée suivant acte reçu par le notaire Karine REUTER, de résidence à Redange/Attert en date du 19 janvier 2009,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 352, en date du 17 février 2009
La séance est ouverte à 9.20 heures sous la présidence de Monsieur Grégory HUBERT, employé, demeurant à B-6700
Arlon, 4, rue de la Porte Neuve;
L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
II.- Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
73712
L
U X E M B O U R G
III.- Que la présente assemblée, réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Beckerich, vers L-8832 Rombach, 5, route
d'Arlon et modification du deuxième alinéa de l'article 1 des statuts comme suit:
« Art. 1
er
. (Deuxième alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que Monsieur Philippe MARTIN, né le 22 février 1965 à Bourlers en Belgique et demeurant à
Chimay en Belgique, rue de la Brasserie, est l'actionnaire unique de la société qui est dès lors à considérer comme société
unipersonnelle.
L'assemblée révoque avec effet immédiat et avec décharge pour l'exercice de leurs fonctions les administrateurs AJYR
HOLDING SA et Monsieur Gabriel MARQUES MENDES; Monsieur Philippe MARTIN reste seul administrateur avec
pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
Pour une durée de six ans à partir des présentes est nommé commissaire aux comptes La Fiduciaire comptable
COMPTAFISC S.à r.l., établie et ayant son siège social à L8832 Rombach, 18, route de Bigonville, RSCS 144.397;
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Grégory HUBERT, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 26 avril 2013. Relation: DIE/2013/5495. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€
<i>Le Receveuri>
(signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 13 mai 2013.
Référence de publication: 2013060573/55.
(130075435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
BREDS II (LuxCo) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 177.094.
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of April.
Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
"Stichting BREDS II", a foundation (Stichting) established under the laws of the Netherlands, having its address at
Spoorhaven 88, 2654AV Berkel en Rodenrijs, The Netherlandsand registered with the Dutch Chamber of Commerce
(Kamer van Koophandel) under number 57767920.
here represented by Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy given under private seal given on 25 April 2013,
which proxy, after been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.
73713
L
U X E M B O U R G
BY-LAWS:
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Compartments, Duration
1. Form, Corporate Name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") go-
verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The
Company shall be subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation
Law").
1.2 The Company exists under the name of "BREDS II (LuxCo) S.A.".
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders
by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.
2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole
Director") is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.
2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole
Director.
3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several
securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.
3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through
another entity or synthetically, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or
part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be
financed by the issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on
the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company is not subject to any risk-
diversification requirements.
3.3 The Company may not perform any activities which do not form part of its securitisation activity and it must in
particular not carry out transactions or schemes in which neither (i) an asset or pool of assets is transferred to the Issuer,
nor (ii) the credit risk of an asset or pool of assets, or part thereof, is transferred to the investors in the Instruments
issued by the Issuer. The Issuer may in particular not originate new loans (as opposed to purchasing them from another
lender) and it will therefore neither originate new loans on its own account, nor on-lend proceeds from the issuance of
Instruments.
3.4 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense
of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;
(b) subscribe or acquire any other participations in companies, partnerships or other undertakings, which do not qualify
as securities or financial instruments, provided that the Company will not actively intervene with the management of such
undertakings in which it holds a holding, directly or indirectly;
(c) acquire loan receivables in the course of secondary transactions which may or may not be embedded in securities;
(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial ins-
truments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;
(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;
(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)
and any similar transactions;
(g) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity
securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and
(h) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund
the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company
acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any
73714
L
U X E M B O U R G
agreement entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within the
context of the transaction.
3.5 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development.
4. Compartments.
4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors or the Sole Director is entitled to create one
or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.
4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder
and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.
4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company
attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other
creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that
compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors or the Sole Director may allocate
such assets to one or several other compartments or to the general estate of the Company.
4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may
be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Board of Directors or the Sole Director
between the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis
as it may deem more appropriate.
4.5 The Board of Directors or the Sole Director or its delegates, shall establish and maintain separate accounting
records for each compartment of the Company.
4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Directors or by the Sole Director.
5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II - Capital
6. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and
ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
7. Form of the shares. The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.
The ownership of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.
8. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and
upon conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount
called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.
9. Modification of capital.
9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or by
resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III - Bonds, Notes and Other debt instruments
10. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or
bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or con-
verted into bearer form.
Chapter IV - Directors, Board of directors, Approved statutory Auditor(s)
11. Board of directors or sole director.
11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least
three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.
11.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders,
it is established that the Company has only one shareholder left, the Company can be managed by a Board of Directors
consisting of one Director, named the Sole Director, or of two Directors until the next ordinary general meeting of the
shareholders noticing the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of
Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent
representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only
remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.
11.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders deciding on the re-
muneration and the term of appointment for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed
at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors
73715
L
U X E M B O U R G
have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected
for six years from the date of his election.
11.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, resignation or
otherwise, the remaining Director(s) thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy
until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. In the event of vacancy of the
Sole Director because of death, retirement, resignation or otherwise, an extraordinary general meeting of the Sharehol-
ders or the Sole Shareholder shall elect a Director to fill such vacancy. In case of resignation, the resigning Director will
remain in function until his/her successor has been appointed.
12. Meetings of the board of directors.
12.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman
may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxies.
12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his
proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.
12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
12.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that
each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology,
shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the
Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by
fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings,
duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
12.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event
such vote is confirmed in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts
shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
13. General powers of the board of directors or the sole director.
13.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of adminis-
tration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director.
13.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose
of the assets of the Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors or the Sole Director
deems appropriate.
14. Delegation of powers.
14.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs
of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members
of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under
such terms and with such powers as the Board of Directors or the Sole Director shall determine.
14.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons
who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
15. Representation of the company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole
Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the joint signatures of
any two Directors or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two
Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.
16. Approved statutory auditor(s).
16.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises
agree(s)) appointed by the Board of Directors or the Sole Director.
16.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with
the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
16.3 The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.
73716
L
U X E M B O U R G
Chapter V - General Meeting of shareholders
17. Powers of the sole shareholder / General Meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.
17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting
of shareholders and shall take the decision in writing.
17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. Its resolutions are binding for all shareholders of the Company, irrespective of classes of shares they
hold.
17.4 Any general meeting shall be convened in accordance with the 1915 Law by means of convening notice sent to
each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. It must be convened following
the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In the event that all
the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
they may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent
(10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general
meeting of shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office be registered mail at least
five (5) days before the date of the meeting.
17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive
or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three
(3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to, shall be taken into account.
17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the de-
liberations and resolutions are transmitted on a continuous basis.
17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
17.9 When the Company has a Sole Shareholder, his decisions are written resolutions.
17.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by two-thirds of the votes cast of the shareholders present
or represented.
17.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.
18. Place and Date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg, on the first Wednesday
of June of each year at 3.00 p.m., If such day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held
on the next following business day.
19. Other General Meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened
at the written request of the shareholders which together represent ten per cent (10%) of the capital of the Company
with an indication of the agenda.
20. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general
meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
Chapter VI - Business year, Distribution of profits
21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year.
21.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It
shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the
annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such
documents.
73717
L
U X E M B O U R G
22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This
allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.
22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and
distribution of net profits.
22.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms
prescribed by law.
Chapter VII - Dissolution, Liquidation
23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.
23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or general meeting of shareholders, the Directors or the
Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.
Chapter VIII - Applicable law
24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the Securitisation Law.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends exceptionally on 31 December
2013.
The first annual general meeting shall be held on the first Wednesday of June 2014.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for three hundred and ten (310)
shares as follows:
"Stichting BREDS II", prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
All these shares have been partly paid up, each as to twenty-five percent (25%), so that the sum of seven thousand
seven hundred fifty Euro (€ 7,750.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand one hundred and fifty Euro
(€ 1,150.-).
<i>First resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting BREDS II, considering itself as
duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of
the shareholders passed the following resolutions:
1. The Company's address is fixed at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general
meeting of shareholders to be held in 2019:
(a) Philip Godley, company director, born on 21 March 1974 in Scheffield, United Kingdom, with professional address
at 51, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(b) Peter Dickinson, company director, born on 1 March 1966 in Nuneaton, United Kingdom, with professional address
at 51, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(c) James Saout, company director, born on 11 October 1978 in Jersey, British Islands, with professional address at
13, Castle Street, St Helier, JE4 5UT, Jersey;
(d) Genevieve Blauen-Arendt, company director, born on 28 September 1962 in Arlon, Belgium, with professional
address at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
73718
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said person signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am fünfundzwanzigsten April.
Vor Uns Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
"Stichting BREDS II", eine Stiftung (Stichting) gegründet nach dem Recht der Niederlande mit Adresse in Spoorhaven
88, 2654AV Berkel en Rodenrijs, The Netherlands, eingetragen bei der Handelskammer der Niederlande (Kamer van
Koophandel) unter der Nummer 57767920
hier vertreten durch Monique Drauth, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer ihm, am 25. April 2013 erteilten privatschriftlichen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den
unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den
Registerstellen eingereicht wird.
Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu errichten wünscht.
SATZUNG:
Kapitel I. - Firma, Sitz, Gesellschaftszweck, Teilvermögen, Dauer des Bestehens
1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt
dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").
1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Firmennamen "BREDS II (LuxCo) S.A.".
2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.1 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"),
beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderun-
gen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung in eine andere Gemeinde innerhalb des Groß-
herzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft
(der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der
sich der Sitz der Gesellschaft befindet.
2.3 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorste-
hen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem
Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände
vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt,
die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins
Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende
und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbergesellschaft und/oder Emittentin zu fungieren.
3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar oder über eine andere
Gesellschaft oder synthetisch Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder
Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der
Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst
oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesell-
schaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft
keinen Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.
3.3 Die Gesellschaft darf keine Tätigkeiten ausüben, die nicht Bestandteil der Verbriefungsaktivitäten ist und darf
insbesondere keine Transaktionen oder Strukturen durchführen, bei denen weder (i) ein Vermögensgegenstand oder ein
Pool von Vermögensgegenständen auf die Emittentin übertragen wird, noch (ii) das Kreditrisiko eines Vermögensgegen-
standes oder eines Pools von Vermögensgegenständen ganz oder teilweise auf die Investoren der durch die von der
73719
L
U X E M B O U R G
Gesellschaft emittierten Instrumente übertragen wird. Die Gesellschaft darf insbesondere keine Darlehen selbst ausrei-
chen (in Abgrenzung vom Ankauf von eine anderen Darlehensgeber) und will daher weder selbst neue Darlehen für eigene
Rechnung ausreichen, noch die Erlöse aus der Emission der Instrumente darlehensweise weiterreichen.
3.4 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:
(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften
begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwer-
ben;
(b) andere Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder anderen Unternehmen
erwerben, die nicht die Kriterien für Wertpapiere oder Finanzinstrumente erfüllen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft
nicht aktiv in das Management solcher Unternehmen eingreift, in welchen sie, direkt oder indirekt, Unternehmensbetei-
ligungen hält;
(c) Darlehensforderungen im Rahmen von Sekundärgeschäften zu erwerben, die verbrieft oder unverbrieft sein kön-
nen;
(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente
verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an
den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfand-
rechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;
(e) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte
abschließen;
(f) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen
abschließen und durchführen;
(g) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte
ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt
und
(h) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum
Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner,
sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr
aufgrund der von ihr gehaltenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren
Tätigkeiten abgeschlossen hat und insoweit diese im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich
erscheinen.
3.5 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,
die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.
4. Teilvermögen.
4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat berechtigt, ein oder
mehrere Teilvermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.
4.2 Unter Vorbehalt des Artikels 4.4 stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Teilvermögen zugeordnet sind,
ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusam-
menhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung dieses Teilvermögens entstanden sind.
4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der
Gesellschaft, die einem Teilvermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen aller
Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen
Kreditverbindlichkeiten oder Gründung, Verwaltung oder Auflösung des betreffenden Teilvermögens entstanden sind,
noch Vermögenswerte des betreffenden Teilvermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwal-
tungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte auf ein beziehungsweise mehrere andere Teilvermögen oder die allge-
meine Vermögensmasse der Gesellschaft umverteilen darf.
4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung eines bestimmten
Teilvermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder von
dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat auf die Aktiva der einzelnen Teilvermögen auf pro rata Basis
oder auf jede andere Weise aufgeteilt werden, die als geeignet erscheint.
4.5 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat beziehungsweise deren Bevollmächtigte sollen einzelne
Kontenführungsberichte für jedes Teilvermögen der Gesellschaft erstellen und führen.
4.6 Die Auflösung von Teilvermögen kann von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat beschlossen
werden.
5. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
73720
L
U X E M B O U R G
Kapitel II. - Kapital
6. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in drei-
hundertzehn (310) Anteile als Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,- EUR).
7. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen.
Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesell-
schaft geführt wird.
8. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren,
können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwal-
tungsrat jeweils festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll
eingezahlten Anteilen zu gleichen Teilen eingefordert.
9. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzungen.
9.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Ak-
tionäre erhöht oder herabgesetzt werden, wobei dieser den rechtlichen Anforderungen an eine Satzungsänderung
entsprechen muss.
9.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.
Kapitel III - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere Schuldtitel
10. Namens - Oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel
als Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als
Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.
Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Zugelassener Wirtschaftsprüfer
11. Verwaltungsrat oder Alleiniger Verwaltungsrat.
11.1 Im Falle des Vorhandenseins einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen
Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein
"Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.
11.2 Soweit die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet wurde oder während einer Hauptversammlung der
Aktionäre festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionär hat; können die Geschäfte der Ge-
sellschaft durch einen Verwaltungsrat geführt werden, der aus einer einzigen Person, genannt der alleinige Verwaltungsrat,
oder zwei Direktoren. Dies gilt solange, bis die nächste ordentliche Hauptversammlung die Existenz von mehr als nur
einem einzigen Aktionär feststellt. Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle
muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen
Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie
gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.
11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Akti-
onäre gewählt. Diese legt sowohl deren Vergütung als auch die jeweilige Amtszeit fest. Die Amtszeit darf sechs Jahre
nicht überschreiten, wobei eine Wiederwahl der jeweiligen Mitglieder zulässig ist. Sie können jederzeit durch einen Be-
schluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt
worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt es als für einen Zeitraum
von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.
11.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds oder
aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer
Mehrheit der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung
stattfindet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird. Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes,
Ausscheidens, Rücktritts des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, soll eine außerordent-
liche Hauptversammlung der Aktionäre oder der Alleinaktionär ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz
ausfüllt. Im Fall des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds bleibt das zurücktretende Verwaltungsratsmitglied solange
im Amt, bis sein/ihr Nachfolger ernannt worden ist.
12. Sitzungen des Verwaltungsrats.
12.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann
von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann,
wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.
12.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied
einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Ein-
haltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.
12.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.
73721
L
U X E M B O U R G
12.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes
Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes
Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Abstimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
12.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt,
dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese
Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt
per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
12.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-
terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaire). Die Zustimmung kann in
einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem
Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwal-
tungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
12.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon,
wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmit-
gliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
13. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats oder des Alleinigen Verwaltungsrats.
13.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme
von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts
wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des
Verwaltungsrats oder der alleinige Verwaltungsrats.
13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in einer
Weise und für eine solche Ausgleichszahlung zu verkaufen, übertragen, abzutreten, belasten oder anderweitig darüber zu
verfügen, wie sie der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat für angemessen erachtet.
14. Übertragung von Befugnissen.
14.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der
Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft
handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat oder der alleinige
Verwaltungsrat fest.
14.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch
an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte
und Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.
15. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen
Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmit-
gliedern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift der
Person, die eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern übertragen wurde, jedoch nur, soweit
diese Befugnis reicht.
16. Zugelassener Wirtschaftsprüfer.
16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftsprüfern (re-
viseur(s) d'entreprises agree(s)) geprüft, welche(r) vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat gewählt wird.
16.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird aus dem Kreis der bei der Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfer gewählt und für eine bestimmte Zeit bestellt.
16.3 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.
Kapitel V. - Hauptversammlung
17. Befugnisse des Alleinaktionärs/ der Hauptversammlung.
17.1 Die Gesellschaft kann bei ihrer Gründung mit einem Alleinaktionär errichtet werden oder entstehen, wenn alle
Anteile von einer einzigen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung
der Gesellschaft.
17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser sämtliche Befugnisse erhalten, die der Hauptversammlung
zustehen; Beschlussfassungen sollen schriftlich durch den Alleinaktionär erfolgen.
17.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre
der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von
73722
L
U X E M B O U R G
Angelegenheiten der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche
Klassen von Anteilen sie halten.
17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwal-
tungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungs-
mitteilung per Einschreiben erfolgen. Eine Hauptverhandlung muss einberufen werden, wenn dies ein oder mehrere
Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, verlangen Sofern sämtliche
Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie
von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen
bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten. Ein oder mehrere Aktionäre,
die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, können verlangen dass ein oder mehrere
zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens
fünf Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft zu schicken.
17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder
durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss,
und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu
lassen.
17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder
Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der
Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird,
eingegangen sind, werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt.
17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie
identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit
und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht
geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
ständig zu übertragen sind.
17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß
einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, ungeachtet des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.
17.9 Sofern die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, ergehen dessen Beschlüsse schriftlich.
17.10 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirk-
sam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der
Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Ver-
sammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen
werden. In der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der
vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versamm-
lung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer
Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.
17.11 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten
der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfor-
dernisse beschlossen werden.
18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Mittwoch im Juni
um 15.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmitteilung näher angegeben wird.
Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Jahreshauptversammlung an dem nächstfolgenden Geschäftstag
abgehalten.
19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine
Hauptversammlung ist auf schriftliches Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam zehn Prozent (10%) des
Kapitals der Gesellschaft vertreten unter Angabe der Tagesordnung.
20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jah-
reshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember des jeweiligen Jahres.
21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung er-
stellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der
Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorge-
legten Unterlagen erstellen.
73723
L
U X E M B O U R G
22. Gewinnausschüttung.
22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5%) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine
solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens
ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.
22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Ver-
wendung und Ausschüttung der Nettogewinne.
22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen
Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
23. Auflösung, Liquidation.
23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden, wobei dieselben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung
der Satzung.
23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär
beziehungsweise von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.
23.3 Wenn keine Liquidatoren von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Ver-
waltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).
Kapitel VIII. - Geltendes Recht
24. Geltendes Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des
Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet ausnahmsweise am 31 Dezember 2013.
Die erste Generalversammlung findet am ersten Mittwoch im Juni 2014 statt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei 310 (dreihundertzehn) Anteile wie nachstehend
angegeben gezeichnet:
"Stichting BREDS II", vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile
TOTAL: dreihundertzehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile
Diese Anteile sind teilweise eingezahlt, jeder zu fünfundzwanzig Prozent (25%), so dass der Betrag von siebentausend-
siebenhundertundfünfzig Euro (7.750,- EUR) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar
nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von
1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer
Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf eintausendeinhundertfünfzig Euro
(€ 1.150,-) geschätzt.
<i>Erste Beschlüsse des Alleinaktionärsi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting BREDS II, die die Versamm-
lung als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der
Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Als Anschrift der Gesellschaft wird L-1855 Luxemburg, 51, avenue John F. Kennedy, Großherzogtum Luxemburg
vorgesehen.
2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre
2014 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
(a) Herr Philip Godley, Geschäftsführer, geboren am 21. März 1974 in Scheffield, Großbritannien, geschäftsansässig in
51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
(b) Herr Peter Dickinson, Geschäftsführer, geboren am 1. März 1966, in Nuneaton, Großbritannien, geschäftsansässig
in 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
(c) Herr James Saout, Geschäftsführer, geboren am 11. Oktober 1978, in Jersey, geschäftsansässig in 13 Castle Street,
St Helier, JE4 5UT, Jersey, und
73724
L
U X E M B O U R G
(d) Frau Genevieve Blauen-Arendt, Geschäftsführer, geboren am 28. September 1962, in Arlon, Belgien, geschäftsan-
sässig in 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache mächtig, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten
erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt.
Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, wird der englische Text maßgebend sein.
Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg
errichtet.
Nachdem die Urkunde dem Vollmachtnehmer der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete der Voll-
machtnehmer gemeinsam mit dem amtierenden Notar diese Originalurkunde.
Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19444. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 6. Mai 2013.
Référence de publication: 2013060623/640.
(130075063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2013.
Min.Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8217 Mamer, 36, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 58.847.
L'an deux mil treize, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MIN.PARTICIPATIONS
S.A.", avec siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DEL-
VAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 25 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, numéro 390 du 21 juillet 1997, modifiée suivant résolutions portant notamment conversion du capital
en euros prises en assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue sous seing privé en date du 20 décembre 2001,
dont le procès-verbal a été publié par extrait au Mémorial C, numéro 744 du 15 mai 2002, ci-après "la Société",
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 58.847.
La séance est présidée par Madame Jeanne JACQUES-FISCHER, administratrice de société, demeurant à L-8217 Ma-
mer, 36, op Bierg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DE LIMA PEREIRA, salariée, demeurant professionnellement
à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
L'assemblée élit comme scrutateurs:
a) Madame Sylvie SCHEER, salariée, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie;
b) Madame Gisèle BECKER-TRUM, salariée, demeurant professionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bon-
nevoie.
<i>Composition de l'assembléei>
Les noms des actionnaires présents ou représentés, et des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le
nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
"ne varietur" par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité
de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
"1. Transfert du siège social de la Société de L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, à L-8217 Mamer, 36, Op Bierg.
Modification afférente de la première phrase de l'article 2.- des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (première phrase). Le siège social de la société est établi à Mamer.";
73725
L
U X E M B O U R G
2. Acceptation des démissions de Monsieur Claude BALK et de Monsieur Guy THILL de leurs fonctions d'adminis-
trateurs de la Société, et décharge;
3. Renouvellement du mandat de l'administrateur unique restant.
4. Modification de l'article 9.- des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois
membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limité à
un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire. Les administrateurs
ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six
ans et sont toujours révocables par elle; les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un
administrateur présent désigné à cet effet.";
5. Modification de l'article 12.- des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 12. Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.";
6. Modification de l'article 16.- des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés
au nom de la société, en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur, ou, en cas de
pluralité d'administrateurs, par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administra-
tion.";
7. Suppression du dernier alinéa de l'article 20.- des statuts de la Société;
8. Modification du premier alinéa de l'article 21.- des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 21. (premier alinéa). L'assemblée générale annuelle se tiendra le 15 septembre de chaque année à 11.00 heures.";
9. Modification du deuxième alinéa de l'article 25.- des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 25. (deuxième alinéa). L'assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur.";
10. Suppression de la deuxième phrase de l'article 27.- des statuts de la Société;
12. Divers."
II.- Il apparaît de la liste de présence que toutes les cinq mille deux cent cinquante (5.250) actions, représentant
l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points
à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l'assembléei>
L'exposé du Président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère
comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, à
L-8217 Mamer, 36, Op Bierg.
Suite au transfert du siège social de la Société, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 2.- des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (première phrase). Le siège social de la société est établi à Mamer."
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accepter les démissions de Monsieur Claude BALK et Monsieur Guy THILL de leurs
fonctions d'administrateurs de la Société avec effet à l'issue de la présente assemblée.
Décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour leur est accordée.
73726
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur unique restant Madame Jeanne JACQUES-
FISCHER, administratrice de société, née à Luxembourg, le 1
er
septembre 1947, demeurant à L-8217 Mamer, 36, op
Bierg, pour une durée de six ans à partir de ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 9.- des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil d'administration composé de trois
membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire. Les administrateurs
ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six
ans et sont toujours révocables par elle; les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un
administrateur présent désigné à cet effet."
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 12.- des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 12. Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration."
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 16.- des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés
au nom de la société, en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur, ou, en cas de
pluralité d'administrateurs, par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administra-
tion."
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 20.- des statuts de la Société, de sorte que cet
article aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-
tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l'assemblée."
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 21.- des statuts de la Société pour lui donner la
teneur suivante:
" Art. 21. (premier alinéa). L'assemblée générale annuelle se tiendra le 15 septembre de chaque année à 11.00 heures."
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 25.- des statuts de la Société pour lui donner
la teneur suivante:
" Art. 25. (deuxième alinéa). L'assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur."
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la deuxième phrase de l'article 27.- des statuts de la Société, de sorte que
cet article aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 27. L'année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de chaque année."
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président a clôturé l'assemblée.
73727
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).
Dont acte, fait à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte
avec Nous Notaire.
Signé: Jeanne JACQUES-FISCHER, Sylvie DE LIMA PEREIRA, Sylvie SCHEER, Gisèle BECKER-TRUM, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19445. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2013.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2013060525/148.
(130074082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.
Kacera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 127.669.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013061632/9.
(130076108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
CEREP Investment Orosdi S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. CEREP Esplanade 1 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.197.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2013.
Référence de publication: 2013059414/10.
(130073771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Procap Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 4, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 50.225.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013061839/9.
(130076232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Presto Plus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 83.915.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013061837/9.
(130076113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
73728
AJYR Investissement S.A.
Ascelux
BB Holding Investment S.A .
BREDS II (LuxCo) S.A.
Canaco S.A.
Canaco S.A.
Cardoso Constructions S.à r.l.
CC Optic Sàrl
Centre Philosophique Spirite Attitude d'Amour
CEREP Bellini 1 S.à r.l.
CEREP Bellini 2 S.à r.l.
CEREP Bryggen Waterfront S.à.r.l.
CEREP City Office S.à r.l.
CEREP Esplanade 1 S.à r.l.
CEREP III Investment H S.à r.l.
CEREP II Investment Ten S.à r.l.
CEREP III Spain S.à r.l.
CEREP Investment Fastighets S.à r.l.
CEREP Investment France S.à r.l.
CEREP Investment Orosdi S.à r.l.
CEREP Investment Z S.à r.l.
CEREP Monument Investment S.à.r.l.
CEREP Picasso 2 S.à r.l.
CEREP Poole S.à.r.l.
Cerpi S.A.
Château Sarasin S.A.
Claudas Investments S.à r.l.
Cliveden S.A.
Clnergie
COFRA Luxembourg s.à r.l.
CompAM FUND
Computer Resources International Group
Crèche mäh-ma-muh S.à r.l.
C.T.B. s.à r.l.
Elephant Project S.A.
Euroliberty-Lease S.A.
FMC Finance VIII S.A.
Focus Park S.à r.l.
Fuchs & Insurances S.A.
Gauthier Immobilien S.A.
GL Europe Holdings I S.à r.l.
Global Select Sicav
Golden Heights S.A.
Grevlin S.A.
Grund Beteiligungen A.G.
Habeco Sàrl
HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A.
H.I.G. Europe - Silentnight S.à r.l.
Kacera S.à r.l.
Luxairco S.A.
Lux Planet S.à r.l.
Min.Participations S.A.
MNRE (Midsomer Norton Retail Estate) S.A.
Outlet Mall Sub Group Holding No. 2 S.à r.l.
Presto Plus S.A.
Procap Holding
Rewa Lux S.à r.l.
Sunset Investment S.A.
The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF
Vodafone Luxembourg S.à r.l.
wondermags Sàrl
Word and Advice S.A.