This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1528
27 juin 2013
SOMMAIRE
1618 Investment Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
73300
ABN AMRO Multi-Manager Funds . . . . . . .
73306
Banque Privée Edmond de Rothschild Eu-
rope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73304
Cool-Tec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73344
Effinpro s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73342
Elektra-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73343
ENN European Transportation Fuels S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73325
Exarchus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73333
Global Select Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73298
Gutzeit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73298
Guy Frères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73300
Headstart S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73300
Hôtel Bel Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73299
Hugo Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73299
IBI Partners Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73344
J. Castelain & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73301
J. Chahine Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73301
JoDan Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73302
Jos FLIES-MAJERUS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
73300
Kakim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73299
Kalan Capital Sea Freight Arbitrage S.àr.l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73302
Kalan Capital Ship Owning S.àr.l . . . . . . . .
73303
Kalan Capital Special Opportunities (Glo-
bal) Captive S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73303
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l. . .
73314
Kglynvest - Mundi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73304
KHEPHREN Drancy Invest S.C.A. . . . . . . .
73306
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. . . . . . . . . . .
73305
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. . . . . . . . . . .
73304
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s. . . . . . . . . . .
73304
Laboratoire Dentaire Kayl S.à r.l. . . . . . . . .
73299
Landbesitz Alpha A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73305
Landmark Student Transportation Luxco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73305
Latina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73307
LFP I SICAV - SIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73308
LHF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73309
Licht Toitures S.N. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
73309
Liette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73313
Linares Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73308
LTIC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73305
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding . . . . . . .
73307
Lux-Top 50 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73310
LV Trans S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73306
Magic Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
73311
Magic Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
73343
Magic Production Group (M.P.G.) S.A. . . .
73310
Magna Invest Corporation S.A. . . . . . . . . . .
73312
Margaux Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
73308
Maritime Business Management S.A. . . . .
73311
Maritime Business Management S.A. . . . .
73311
Maritime Business Management S.A. . . . .
73311
Marlow Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73312
Marsh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73310
MML Enterprises S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
73311
Monte Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73313
Nordic Noel Street Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .
73312
Novapol Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
73312
OHI Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73312
Pictet Alternative Funds . . . . . . . . . . . . . . . .
73313
Resitalia Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
73305
S.A. des Services Techniques et Généraux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73301
Simar Overseas S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73301
Tishman Speyer French Core V S.à r.l. . . .
73303
Vepha Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73298
73297
L
U X E M B O U R G
Global Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 60.611.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2013, les actionnaires de la société 'Global Select SICAV' ont pris
les résolutions suivantes:
- Renouvellement des mandats de Patrick Fürer, Manuel Hauser, Andrea Battilani et Thomas Miguel Reeg comme
administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Désormais, le conseil d'administration est composé comme suit:
Patrick Fürer
Manuel Hauser
Andrea Battilani
Thomas Miguel Reeg
- Renouvellement du mandat de Deloitte S.A., en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société, jusqu'à la date
de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2013059563/20.
(130072863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Gutzeit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 114.299.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société GUTZEIT S.A. en liquidation, avec siège social à 13, avenue
du Bois, L-1251 LUXEMBOURG.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe du tribunal de
commerce avant le 24 mai 2013.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Pour extrait conforme
Cédric SCHIRRER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013059572/19.
(130073347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Vepha Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 173.258.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 23 avril 2013i>
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Jean-Hugues DOUBET. Ce dernier
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2018.
Certifié sincère et conforme
VEPHA HOLDING S.A.
I. SCHUL / J.-H. DOUBET
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013059953/15.
(130072823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73298
L
U X E M B O U R G
Hôtel Bel Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6409 Echternach, 1, route de Berdorf.
R.C.S. Luxembourg B 91.550.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 27 avril 2013i>
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1) Le mandat de Monsieur André SCHWALL n'est pas renouvelé.
2) Les mandats respectifs des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de cinq ans:
- Madame Andrée LINSTER-HOFFMANN, demeurant à
L-1272 LUXEMBOURG, 68, rue Bourgogne.
- Monsieur Marc HENGEN, demeurant à
L-3899 FOETZ, 52, rue Théodore de Wacquant
3) Est nommé administrateur pour une durée de cinq ans
Monsieur Philippe SCHWALL, né le 24 mars 1960 à ESCH-SUR-ALZETTE et demeurant à L-4037 ESCH-SUR-AL-
ZETTE, 26, rue Simon Bolivar
4) Le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Alphonse WEBER, demeurant à L-6833 BIWER, 9, Neie Wée
est renouvelé pour une période de trois ans.
Echternach, le 30 avril 2013.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013059599/23.
(130073199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Hugo Insurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 117.417.
Le bilan pour l'exercice social 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059601/10.
(130073774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Kakim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 155.069.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013059643/10.
(130073548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Laboratoire Dentaire Kayl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 83.152.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE KAYL SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013059668/11.
(130073028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73299
L
U X E M B O U R G
Guy Frères, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5312 Contern, 7, Bourgheid.
R.C.S. Luxembourg B 35.320.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2013059573/13.
(130073631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Headstart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 149.993.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2013059581/13.
(130073434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Jos FLIES-MAJERUS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3762 Tétange, 28, Langertgaas.
R.C.S. Luxembourg B 20.782.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2013059623/13.
(130073643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
1618 Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 42.619.
<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 20 mars 2013:i>
Le Conseil d’Administration a décidé d’annuler la nomination du 12 décembre 2012 de M. Thierry WEBER en tant
que Administrateur-Délégué de la SICAV.
En outre le Conseil d’Administration a décidé de déléguer la gestion journalière des affaires de la SICAV à M. Alain
PEIGNEUX, Dirigeant, (résidant professionnellement à L-8011 STRASSEN, 283 route d’Arlon) qui disposera d’un pouvoir
de signature individuel lui permettant de signer toutes les décisions relatives à la gestion et au développement de la SICAV.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2013.
Référence de publication: 2013059977/15.
(130073266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73300
L
U X E M B O U R G
J. Castelain & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 117.512.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de J. Castelain & Cie tenue au siège social le 30 avril 2013 à 11i>
<i>heuresi>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée approuve l’augmentation du capital social d’un montant de un million vingt-deux mille cinq cent euros
(1.022.500 eur.).
2. L’Assemblée approuve l’augmentation du nombre de parts émises, suite à l’augmentation du capital social, comme
suit:
- Cinquante mille cinq cents Parts détenues par l’associé commandité: Monsieur Jo Castelain
- Quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Parts détenues par l’associé commandité: Madame Trees
Coppens
- Une Part détenue par l’associé commanditaire: Monsieur Wim Coppens
Toutes les résolutions sont prises à l’unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-
verbal par les membres du bureau.
Solange Leurquin / Vincent Demeuse / Pascal Jungling
<i>Secrétaire / Scrutateur / Présidenti>
Référence de publication: 2013059618/23.
(130073253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
J. Chahine Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 100.623.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059619/10.
(130072921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
S.A. des Services Techniques et Généraux, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 48.146.
p.a. Monsieur Gust Welter
La présente pour vous informer que je démissionne de mon poste de Directeur et de celui d’administrateur de la
société S.T.G. S.A., avec effet au 31 décembre 2012.
Marc MINN.
Référence de publication: 2013059851/11.
(130073238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Simar Overseas S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 147.261.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059856/10.
(130073362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73301
L
U X E M B O U R G
JoDan Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R.C.S. Luxembourg B 157.473.
L'an deux mille treize, le seize avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Madame Judith GOLOOBA née MAPANJE, indépendante, née le 21 janvier 1976 à Zomba (Malawi), demeurant à
L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin. Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée "JoDan Services", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-3377
Leudelange, 43, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 157473, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 6 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 296 du 12 février 2011.
- Que la comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris la résolution
suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de L-3377 Leudelange, 43, rue de la Gare à L-1358 Luxembourg,
4, rue Pierre de Coubertin, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner
les teneurs suivantes:
« Art. 2. (Première phrase). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite
comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. GOLOOBA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 avril 2013. LAC/2013/17944. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 6 mai 2013.
Référence de publication: 2013059624/35.
(130073072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Kalan Capital Sea Freight Arbitrage S.àr.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 138.835.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société KALAN Capital SEA FREIGHT ARBITRAGE Sàrl en
liquidation, avec siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au Tribunal d'Arrondissement de et
à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe du tribunal de
commerce avant le 24 mai 2013.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Pour extrait conforme
Cédric SCHIRRER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013059633/19.
(130073353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73302
L
U X E M B O U R G
Kalan Capital Ship Owning S.àr.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 138.837.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société KALAN Capital SHIP OWNING Sàrl en liquidation, avec
siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au Tribunal d'Arrondissement de et
à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe du tribunal de
commerce avant le 24 mai 2013.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Pour extrait conforme
Cédric SCHIRRER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013059634/19.
(130073354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Kalan Capital Special Opportunities (Global) Captive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 141.637.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commer-
ciale, a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société KALAN Capital SPECIAL OPPORTUNITIES (GLOBAL)
CAPTIVE Sàrl en liquidation, avec siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au Tribunal d'Arrondissement de et
à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Maître Cédric SCHIRRER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances au greffe du tribunal de
commerce avant le 24 mai 2013.
Luxembourg, le 3 mai 2013.
Pour extrait conforme
Cédric SCHIRRER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013059635/19.
(130073365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Tishman Speyer French Core V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 988.675,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.949.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 30 avril 2013.
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2013059908/16.
(130073118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73303
L
U X E M B O U R G
Kglynvest - Mundi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 35A, A Staeves.
R.C.S. Luxembourg B 124.159.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée, «KGLYNVEST - MUNDI S.à
r.l.», établie et ayant son siège social au 35A, A Staeves, L-9780 Wincrange, reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 11 juillet 2011, déposé auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés le 22 août 2011, référence: L110136669, publié au Mémorial C N°2436 du 11 octobre 2011, que le code postal
du siège social a été erronément indiqué. Le code postal du siège social est L-9780 et non L-9870.
Il y a donc lieu de rectifier le code postal en L-9780.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 mai 2013. Relation: EAC/2013/5796. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 30 avril 2013.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013059645/19.
(130073267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 100.356.
Les documents de clôture de l'année 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059647/10.
(130072847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 100.356.
Les documents de clôture de l'année 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059648/10.
(130072884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 19.194.
<i>Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 28 février 2013 à Luxembourgi>
2.3 Réviseur d'Entreprises (PriceWaterhouseCoopers SARL)
Le Conseil renouvelle son mandat de réviseur de la Banque pour un nouveau terme d'une année expirant à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes sociaux 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2013.
Luc Grégoire / Marc Ambroisien
<i>Secrétaire Général / Administrateur - Directeur Générali>
Référence de publication: 2013059995/15.
(130073273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73304
L
U X E M B O U R G
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 100.356.
Les documents de clôture de l'année 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059650/10.
(130073432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Landmark Student Transportation Luxco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 19.950,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 164.688.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2013.
Référence de publication: 2013059657/10.
(130073625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Landbesitz Alpha A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 43.603.
Es geht aus dem Protokoll der ordentliche Generalversammlung vom 25. April 2013 hervor dass:
Die Kündigung des Verwaltungsratmitgliedes und des Verwaltungsratdelegiertes Heinrich Volkmar MERZ wird ange-
nommen.
An seiner Stelle wird bestellt Herr Heinrich MERZ, Industrieller, geboren am 14.12.1932 in Arzberg (D) wohnhaft in
Urb. Pujoi Xalet Anna., 400 Erts Andorra, bis zur Generalversammlung 2014.
Für gleichlautenden Auszug
Référence de publication: 2013059669/13.
(130072844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Resitalia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 95.325.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2013059825/11.
(130073517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
LTIC S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 76.200,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 144.078.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
Référence de publication: 2013059687/10.
(130073734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73305
L
U X E M B O U R G
KHEPHREN Drancy Invest S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 156.131.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire à Luxembourg, le 7 mai 2013i>
Après délibérations, l'assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
Les actionnaires décident de renouveler le mandat du Conseil de Surveillance jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2014 et plus précisément:
- Asyris S.A.
RCS Luxembourg B 88.247,
17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
représenté par M. Yves Deschenaux;
- Zentric S.à r.l.
RCS Luxembourg B 94.346,
17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
représenté par M. Yves Deschenaux;
- Vantage Management S.A.
RCS Luxembourg B141.946,
17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
représenté par Patrick Leonard.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013059646/26.
(130073230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
LV Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4670 Differdange, 207, rue de Soleuvre.
R.C.S. Luxembourg B 102.362.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-4670 Differdange, le 07 mai 2013.
Monsieur Vaduva Laurentiu
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013059702/12.
(130073000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 78.762.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2012i>
En date du 25 mai 2012, l'Assemblée a pris la résolution suivante:
Elle ne renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société Ernst & Young S.A.;
Elle nomme la Société PricewaterhouseCoopers Sàrl, avec adresse professionnelle, 400 route d'Esch, L- 1014 Luxem-
bourg, comme nouveau réviseur d'entreprises pour l'exercice 2012.
Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 25 mai 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ABN AMRO Multi-Manager Fundsi>
Référence de publication: 2013060032/16.
(130074080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.
73306
L
U X E M B O U R G
Latina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.393.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires et par le conseil d’administration en date du 26 avril 2013i>
1) M. Xavier SOULARD a démissionné de ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration.
2) Mme Stéphanie MEYER, administrateur de sociétés, née à Saint-Mard (Belgique), le 14 août 1987, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
3) La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
4) M. Sébastien ANDRE a été nommé comme président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2018.
Veuillez noter que le commissaire, COMCOLUX S.à r.l., a changé d’adresse et se situe désormais à L-1331 Luxem-
bourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour LATINA S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013059671/22.
(130073451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 59.732.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2013i>
I. Nominations statutaires
L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2012, le terme du mandat des Admi-
nistrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au
Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2014:
M. Jean-Claude FINCK, président
M. Michel BIREL, vice-président
M. John BOUR, administrateur
M. Gilbert ERNST, administrateur
M. Gilbert HATZ, administrateur
M. Pit HENTGEN, administrateur
M. Guy HOFFMANN, administrateur
M. Aly KOHLL, administrateur
M. Guy ROSSELJONG, administrateur
Mme Françoise THOMA, administrateur
II. Nomination du Commissaire aux Comptes
L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Carlo MATAGNE, a été fixé à un an,
c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale. Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomi-
nation du Commissaire aux Comptes, Monsieur Carlo MATAGNE, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en avril 2014.
Luxembourg, le 8 avril 2013.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Référence de publication: 2013059694/32.
(130072916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73307
L
U X E M B O U R G
LFP I SICAV - SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 151.371.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires que:
- Monsieur Jonathan Burger, avocat, né le 07 septembre 1979 à Thionville (France) et demeurant au 12, rue Jean Engling,
L-1466 Luxembourg, est nommé administrateur du fonds en date du 25 avril 2013, en remplacement de l'administrateur
démissionnaire Monsieur Bert De Vos. Le nouvel administrateur reprend le mandat de son prédécesseur.
- La société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et dûment
inscrite au RCSL sous le numéro B 65 477 est nommée réviseur d'entreprises agréé en date du 25 avril 2013 et son
mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes se terminant au 31 décembre 2012.
L'adresse professionnelle de messieurs Luc Leleux et Julien Renaux est transférée au 2, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Le nouveau conseil d'administration se résume comme suit:
- Monsieur Luc Leleux;
- Monsieur Julien Renaux;
- Monsieur Jonathan Burger.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour le fonds
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013059680/25.
(130073212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Linares Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 48.037.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 26i>
<i>avril 2013i>
1) M. Xavier SOULARD a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2) Mme Stéphanie MEYER, administrateur de sociétés, née à Saint-Mard (Belgique), le 14 août 1987, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
3) M. Sébastien ANDRE a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2014.
Luxembourg, le 8 mai 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LINARES HOLDING S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013059684/19.
(130073155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Margaux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.071.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059706/10.
(130073324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73308
L
U X E M B O U R G
Licht Toitures S.N. Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 1, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 142.293.
L'an deux mille treize, le deux mai.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- Madame Frédérique SCHOKMEL, épouse de Monsieur Olivier HALLE, employée privée, née le 3 janvier 1977 à
Villerupt (France), demeurant à F-57480 Rettel, 85, route de Sierck.
2.- Monsieur Olivier HALLE, indépendant, né le 9 septembre 1970 à Metz (France), demeurant à F-57480 Rettel, 85,
route de Sierck.
Lesquels comparantes sont ici représentés par Madame Sophie BATARDY, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date
du 22 avril 2013.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent et requièrent le notaire instrumentant
d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée "LICHT TOITURES S.N. SARL", établie et ayant son siège social à L-5441
Remerschen, 16A, Route de Mondorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 142.293 (NIN 2008 2442 023), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de rési-
dence à Junglinster, en date du 26 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
N° 2650 du 30 octobre 2008.
Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seuls associés de la Société et que les com-
parants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la
résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de transférer, avec effet au premier mai 2013, le siège de la Société à L-5690 Ellange, 1, route de
Remich et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. Le siège social est établi à Ellange (Grand-Duché de Luxembourg)."
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. BATARDY, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 03 mai 2013. Relation: ECH/2013/858. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 07 mai 2013.
Référence de publication: 2013059683/41.
(130073050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
LHF S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 164.416.
<i>Décision unique du gérant unique en date du 3 avril 2013i>
Le gérant a décidé que de nommer RSM AUDIT Luxembourg, S.à r.l. (une société à responsabilité limitée) ayant son
siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B113621 aux fonctions de réviseur d’entreprises agréé avec effet rétroactif au 12 octobre 2011 dont le
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013059681/13.
(130073370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73309
L
U X E M B O U R G
Lux-Top 50 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 59.731.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société tenue à Luxem-
bourg, le 8 avril 2013, enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 2013, LAC/2013/16356 l'ordre du jour suivant:
1. Echéance des mandats des membres actuels du conseil d'administration
2. Nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2014:
- M. Jean-Claude FINCK, président
- M. Michel BIREL, administrateur
- M. John BOUR, administrateur
- M. Gilbert ERNST, administrateur
- M. Gilbert HATZ, administrateur
- M. Pit HENTGEN, administrateur
- M. Guy HOFFMANN, administrateur
- M. Aly KOHLL, administrateur
- M. Guy ROSSELJONG, administrateur
- Mme Françoise THOMA, administrateur
3. Echéance du mandat du Réviseur d'Entreprises
4.
4. Nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG avec siège social au 7 rue Gabriel Lippmann L-5365
MUNSBACH jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 Mai 2013.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013059695/30.
(130073166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Magic Production Group (M.P.G.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.
R.C.S. Luxembourg B 81.825.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale de la société en date du 25 avril 2013i>
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Lino MONCADA de son mandat d'administrateur de la Société
avec effet au 26 mars 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08/05/2013.
Référence de publication: 2013059705/12.
(130073226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Marsh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 19.002.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 7 mai 2013.
Philippe Bioul / Jean-Pierre de Chestret
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013059720/12.
(130073203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73310
L
U X E M B O U R G
Maritime Business Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 96.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059707/10.
(130073006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Maritime Business Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 96.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059708/10.
(130073491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Maritime Business Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 96.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059710/10.
(130073797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
MML Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.191.
Le bilan de la société au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
MML Enterprises S.à r.l.
Référence de publication: 2013059726/11.
(130073442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Magic Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 75.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L - 1746 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2013059717/13.
(130073103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73311
L
U X E M B O U R G
Magna Invest Corporation S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 99.472.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 30 avril 2013 a prolongé le mandat du commissaire aux comptes, Montbrun Révision Sàrl,
avec siège à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle pour une nouvelle période d'une année, expirant à l'issue
de l'assemblée générale de 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013059718/13.
(130073509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
OHI Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 171.842.
Les statuts coordonnés au 22 février 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013059755/11.
(130073268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Marlow Investments, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 123.745.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
Référence de publication: 2013059712/10.
(130073505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Nordic Noel Street Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 3.295.876,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.148.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
Référence de publication: 2013059739/10.
(130073737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Novapol Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 147.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013059740/10.
(130073539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73312
L
U X E M B O U R G
Pictet Alternative Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.485.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 16 avril 2013 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L'assemblée a noté la démission de Mr Nicolas Campiche avec effet au 20 décembre 2012.
2. L'assemblée a reconduit les mandats d'administrateurs de:
- Mme Michèle Berger, 15 Avenue J.F Kennedy, 1855 Luxembourg
- M. Pascal Chauvaux, 15 Avenue J.F Kennedy, 1855 Luxembourg
- M. Francesco Ilardi, 60 route des Acacias, 1211 Genève
pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2014.
3. L'assemblée a approuvé la nomination de Mr Nicolas Tschopp (60 route des Acacias, 1211 Genève) pour une période
d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2014.
4. L'Assemblée a reconduit le mandat de Deloitte Audit S.à.r.l à la fonction de «réviseur d'entreprises agréé» pour
une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2014.
Référence de publication: 2013059799/19.
(130073606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Monte Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 70.346.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s'est tenue le 18 mars 2013, a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Davide SOSIO,
ANIMA Asset Management Limited, 10
th
Floor, George's Quay, Plaza, Dublin Ireland
Monsieur Nicolaus BOCKLANDT,
Independant, Certified Director, 6B Route de Trèves L-2633 Senningerberg.
Monsieur Claudio TOSATO,
Anima SGR S.p.A., Corso Garibaldi 99, 20121 MILANO
Monsieur Armando CARCATERRA,
Anima SGR S.p.A., Corso Garibaldi 99, 20121 MILANO
en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2014,
- de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg, S.à.r.l. (anciennement KPMG Audit, S.à.r.l.), 9, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, RCS B-149.133, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
<i>Pour MONTE SICAV
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013059727/26.
(130072726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Liette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 130.940.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013061667/9.
(130076229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
73313
L
U X E M B O U R G
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 172.676.
In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of April.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1° SIGNA Prime Luxembourg S.àr.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg trade and companies' register under the number B164984, having its registered office at
L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff,
2° BSG Real Estate (Netherlands) I B.V., a besloten vennootschap existing under the laws of the Netherlands, registered
with the trade and companies' register of Amsterdam, under the number 56642482, having its registered office at Haaks-
bergweg 59, 1101 BR Amsterdam Zuidoost, the Netherlands,
Both here represented by Mr Jean-Pierre Dias, private employee, with its professional address in Senningerberg, by
virtue of two proxies given under private seal which shall be signed "ne varietur" by the appearing parties and the un-
dersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.
The prenamed companies are the sole members of Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., a société à responsabilité
limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under
number B 172676, incorporated on 9 November 2012 pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2988 on 10 December 2012 (the "Company"). The
articles of association of the Company have not been amended since.
Which appearing entities, representing the entire capital of the Company, requested the undersigned notary to draw
up as follows:
That the agenda of the present meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Creation of new classes of A and B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
2. Conversion of twelve thousand (12,000) existing shares held by the shareholder SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l.
into twelve thousand (12,000) class A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
3. Conversion of twelve thousand (12,000) existing shares held by the shareholder BSG Real Estate (Netherlands) I
BV into twelve thousand (12,000) class B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
4. Classification of existing managers into class A and B managers.
5. Change of the representation of the Company towards third parties.
6. Change of the language of the Company's articles of association from German to English.
7. Appointment of an auditor.
8. Full restatement of the Company's articles of association (without amending the corporate purpose).
9. Miscellaneous.
The general meeting of the Shareholders has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to create the new classes of A shares and B shares with a nominal value of one euro
(EUR 1) each.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to convert twelve thousand (12,000) existing shares currently held by the shareholder
SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l. into twelve thousand (12,000) class A shares having a nominal value of one euro (EUR
1) each and subject to the conditions set forth in the articles of association of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to convert twelve thousand (12,000) existing shares currently held by the shareholder
Real Estate (Netherlands) I BV into twelve thousand (12,000) class B shares having a nominal value of one euro (EUR 1)
each and subject to the conditions set forth in the articles of association of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to classify the existing managers, who have been previously appointed for an unlimited
period of time.
The following existing managers shall be classified as A managers of the Company:
73314
L
U X E M B O U R G
- Mr. Christian Bäumer, born on 11 July 1974 in Dortmund (Germany), with professional address at 5, rue Heienhaff,
L-1736 Senningerberg; and
- Mr. Manuel Pirolt, born on 10 October 1983 in Feldkirch, Vorarlberg (Austria), with professional address at 31,
Maria-Theresien-Straße, A-6020 Innsbruck,
The following existing managers shall be classified as B managers of the Company:
- Mr. Gregg Blackstock, born on 24 September 1974 in Mbabane (Swaziland), with professional address at 7 Old Park
Lane, Mayfair, London W1K 1QR, United Kingdom; and
- Mr. Michael Lange, born on 28 June 1964 in Scheeßel (Germany), with professional address at 16, rue Jean-Pierre
Brasseur, L-1258 Luxembourg.
<i>Fifth Resolutioni>
Following the previous resolution the general meeting resolves to change the representation of the company and
changes the article 10 which shall be read as follows:
Art. 10. Representation of the Company.
10.1 The Company shall be bound towards third parties (i) by the joint signature of the A Managers of the Company;
and (ii) by the signature of any person to whom such signatory power may have been delegated by an authorized Manager
in accordance with (i).
<i>Sixth Resolutioni>
The general meeting resolves to change the language of the articles of association of the Company from German to
English followed by a German translation. The English text shall prevail.
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting resolves to appoint the following person as independent auditor until the general meeting of
shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B65477,
having its registered office at 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
<i>Eighth Resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to fully restate the articles of association
(without amending the corporate purpose) which shall henceforth read as follows:
"Chapter I. - Form, Name, Registered office, Purpose, Duration
Art. 1. Form - Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of
«Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l.», which shall be governed by Luxembourg law applicable to such legal entity (the
"Company") by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law") as well as by the
present articles of association (the "Articles").
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the city of Sennigerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the share-
holders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles.
2.3 Within the municipality of Niederanven, the registered office may be transferred by decision of the Board of
Managers (as defined below).
2.4 In the event that the Board of Managers (as defined below) determines that extraordinary political, economic or
social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company. The transfer
of the registered office abroad is made by decision of the Board of Managers (as defined below).
2.5 The Company may establish branches or other offices either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 3. Purpose.
3.1 The main purpose of the Company is the direct and indirect acquisition, holding, administration, developpement
and sale of participations and shares in Luxembourg and foreign legal entities, corporations and/or partnerships and capital
companies (each a "Subsidiary"), in any form and particulary also by way of incorporation and conducting the business of
such Subsidiaries.
73315
L
U X E M B O U R G
3.2 The Company may - directly and/or (multiple times if applicable) indirectly through its Subsidiaries - make real
estate related investments, particulary the acquisition, holding, administration, development and sale of real estate pro-
perties.
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold in any form whatsoever, assets of any form.
3.4 The Company may particularly carry out the following the following activities, it being understood that the Company
will not carry out any business that involves activities that are deemed regulated activities in the financial sector:
(a) borrow funds in any form whatsoever, accept loans in any form whatsoever and raise funds, especially, but not
limited to and except by way of public offering, by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and
debentures, convertible and non-convertible as well as through the use of financial derivatives or any other form.
(b) advance, borrow or deposit funds or grant loans to a Luxembourg or foreign legal entity or subscribe for or acquire
any kind of debt instrument issued by such entity, under conditions deemed suitable, with or without security.
(c) grant/engange into guarantees, assumptions of liability, personal securities, pledges und/or any other form of se-
curity, through personal commitment or mortgage or encumbrance of the enterprise or part of it, of (current or future)
assets or through all or one of these methods, for the purpose of execution of agreements or liabilities of the Company
as well as for the purpose of execution of agreements or liabilities or any other way in favour of its Subsidiaries, within
the boudaries of and according to the provisions of Luxembourg law.
3.5 The Company may proceed to all legal, business related, technical and financial investments or transactions and
generally carry out all transactions that are directly or indirectly related to the fullfilment of its corporate purpose in all
aforementioned areas.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-four thousand euro (EUR 24,000), represented by twelve thousand
(12,000) class A shares (the "Class A Shares") and twelve thousand (12,000) class B shares (the "Class B Shares"), all
having a nominal value of one euro (EUR 1,00) (the Class A Shares and the Class B Shares being hereinafter collectively
referred to as the "Shares").
5.2 Subject to anything expressly stated to the contrary in the present Articles, each Share entitles to the exercise of
the same rights.
5.3 The Company may redeem its own Shares within the limit provided by law.
Art. 6. Indivisibility of the Shares.
6.1 The Shares of the Company are indivisible vis-à-vis the Company as only one holder per Share is allowed. In case
a Share is owned by several persons, they shall appoint one person as representative vis-à-vis the Company.
Art. 7. Transfer of Shares.
7.1 In the case of a sole shareholder, the Shares of the Company held by such shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of a plurality of shareholders, the Shares held by such shareholders may be (i) transferred freely between
the existing shareholders subject to the provisions of article 7.3 below and (ii) in accordance with the provisions of articles
189 and 190 of the Law to non-shareholders.
7.3 All transfers of Shares shall be subject to any transfer restrictions which may be set out in any agreement made
between the shareholders of the Company for the purpose of regulating the affairs of the Company (a "Shareholders
Agreement").
Chapter III. - Management
Art. 8. Management.
8.1 The Company shall be managed by two (2) class A managers (the "A Managers") and two (2) class B managers (the
"B Managers", and together with the A Managers, the "Managers") who shall form a board of managers (the "Board of
Managers").
8.2 The A Managers shall be nominated for appointment by the holders of the Class A Shares and B Managers shall be
nominated for appointment by the holders of the Class B Shares.
The shareholders shall be obliged to effect the appointment of the nominated individuals as Managers of the Company.
A shareholder shall only be entitled to refuse such appointment by another shareholder for good cause being an objective
test in the best interest of the Company, provided that the reason for the refusal lies with the proposed individual.
The right of each shareholder to respectively nominate for appointment two (2) A Managers or two (2) B Managers
shall also apply to subsequent appointments (e.g. as a consequence of a revocation or resignation of a Manager).
8.3 At the request of the respective shareholder, the individual nominated by it shall be revoked as Manager of the
Company.
8.4 The chairman of the Board of Managers, if any, shall not have any superseding right (casting vote).
73316
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Powers of the Board of Managers - Composition of the Board of Managers.
9.1 The Board of Managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, provided that the provisions of this article shall
be respected.
9.2 The shareholders acting in general meeting shall draw up internal rules of procedure, which shall be known to the
Board of Managers who shall be bound by them (the "Rules of Procedure"). For the avoidance of doubt, the Rules of
Procedure may only be amended by a decision of the Company's general meeting of shareholders.
9.3 All powers that are not expressly reserved to the meeting of the shareholders in accordance to the Law or the
present Articles are deemed to belong to the Board of Managers.
9.4 The day-to-day operations of the Company shall be conducted by such persons as appointed from time to time
by the Board of Managers among the A Managers subject to such limitations of authority as provided for in the Rules of
Procedure.
Art. 10. Representation of the Company.
10.1 The Company shall be bound towards third parties (i) by the joint signature of the A Managers of the Company;
and (ii) by the signature of any person to whom such signatory power may have been delegated by an authorized Manager
in accordance with (i).
Art. 11. Delegation and Appointee of the Board of Managers.
11.1 The Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more Ad-hoc appointees.
11.2 Any Manager shall set the responsibilities and compensation (if applicable) of the relevant appointee, the duration
of the mandate as well as all other relevant conditions of such appointee.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers.
12.1 The meetings of the Board of Manager are convened by any Manager. The Board of Managers may elect a chairman.
The meetings of the Board of Manager shall be held in Luxembourg.
12.2 The Board of Managers may validly deliberate and resolve when all Managers are present or represented, who
have waived the necessity of convening notices and formalities.
12.3 Any manager may appoint another manager as his proxy for any meeting of the board of managers by either in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. Oral appointment is valid if confirmed in writing at a later point in time (by facsimile sufficient).
12.4 The Board of Manager may only validly deliberate and resolve, if the majority of its members is present or
represented. Resolutions of the Board of Managers are taken at a majority of the Managers present or represented, such
majority to include at least one Manager designated by the holders of each of the classes of Shares.
12.5 The use of conference-call or video conference equipment is allowed, insofar each participating Manager can hear
and can be heard by all other participating Managers, it being disregarded whether such technology is used or not, and
any participant is demand to be present and has the power to vote via video or telephone. The use of conference-call or
video conference equipment shall be limited to exceptional circumstances.
12.6 Further, resolutions may be passed in written form (fascimile or mail), if passed by all Managers unianimously.
Such resolution may be documented in one or several documents, who shall have the same contents and be signed by all
members of the Board of Managers. Such written resolutions are valid and effective, as if they were taken at a duly convene
meeting of the Board of Managers. The passing of written resolutions shall be limited to exceptional circumstances.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at
such meeting.
12.8 Extracts shall be certified by any Manager or any other person that has been appointed by such Manager or at a
meeting of the Board of Managers.
Art. 13. Remuneration of Managers. The Managers of the Company shall not be entitled to compensation for the
exercising of the function, unless agreed by the shareholders otherwise.
Chapter IV. - Meeting of the shareholders
Art. 14. Powers of the meeting of the shareholders - Votes.
14.1 If there exists only one shareholder, such shareholder shall assume all powers that are granted to the meeting of
the shareholders pursuant to the Law and shall pass resolutions in written form.
14.2 If there exist several shareholders, each shareholder may participate at the meetings of the shareholders irres-
pective of the number of Shares which he owns. Each shareholder's voting rights are pro rate to the Shares he owns. All
Shares grant the same voting rights.
14.3 The Board of Managers shall convene the meetings of the shareholders or propose written resolutions of the
shareholders. Any shareholder may request the Board of Managers to convene a meeting of the shareholders or propose
resolutions to be adopted by the shareholders. The Board of Managers shall be obliged to convene a meeting of the
73317
L
U X E M B O U R G
shareholders of the Company or to submit the resolutions to a shareholders' vote within 30 days of such request being
made as set out in this article.
14.4 The convening notice of a meeting of the shareholders together with the agenda in relation thereto shall be sent
to each shareholder at least eight (8) days before the meeting. Exceptionally, the annual ordinary general meeting shall
be convened at least twenty-one (21) days before the date at which the meeting is to take place.
14.5 Each shareholder is entitled to request that certain items be put in the agenda of the next meeting of the share-
holders, provided that this request is made within three (3) days after the day of the receipt of a convening notice. Such
request has to set out the reasons and must be in writing. The other shareholders shall be promptly informed about the
new item of the agenda.
14.6 If all shareholders are present or represented, they may waive all formalities in regard to the convening and the
meeting may be validly held without prior notice.
14.7 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions of the shareholders must be passed at
meetings that shall be convened according to the relevant provisions of the law.
14.8 If there are several shareholders, but not more than twenty-five (25) shareholders, the resolutions of the share-
holders may be passed in written form. When the text of the resolutions to be passed have been transmitted to the
shareholders by the Managers, the shareholders shall be bound to make their decision within fifteen (15) calendar days
from the reception of the text of the proposed resolution to be passed and to communicate the decision to the Company
by way of any written form of communication. Such decisions shall be limited to exceptional circumstances.
14.9 A shareholder may be represented at a meeting of the shareholder by a proxyholder which is to be appointed in
written form (or by fascimile or e-mail or any similar way). The proxyholder must not be a shareholder.
14.10 Resolutions are - subject to any other provisions of the law and these Articles - only validly taken if passed by
shareholders representing a majority of the share capital at least, except however resolutions amending the Articles or
a resolution in relation to a change of nationality, to be taken unanimously.
Chapter V. - Financial year, Distribution of profits
Art. 15. Financial year.
15.1 The financial year of the Company is the calendar year (1 January until 31 December).
15.2 Each year on the thirty-first of December the annual accounts are closed and the Board of Managers of the
Company draws up an inventory, which sets out all assets and liabilities of the Company.
15.3 Any Manager or his proxy may inspect the inventory and the balance sheet at the Company's registered office.
15.4 If the Company consists out of more than twenty-five (25) shareholders, this right can only be exercised within
fifteen (15) calendar days before the holding of the annual general meeting.
Art. 16. Supervision of the Company.
16.1 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by a
supervisory board composed of one or more internal auditors (commissaires). They may be shareholders or non-sha-
reholder.
16.2 When the limits provided by article 35 of the law of 19 December 2002 (as amended) on the Luxembourg Trade
and Companies register are met, the Company shall have the annual accounts audited by one or more independent
auditiors (réviseurs d'entreprise agrées). The independent auditors are elected among the members of the «Institut des
réviseurs d'entreprises».
16.3 Irrespective of the aforementioned limits, the sole shareholder or the meeting of the shareholders may at any
time by way of resolution appoint one or more independent auditors and set the modalities of execution of their mandate
(s).
Art. 17. Allocation and Distribution of profits, Repatriation of net proceeds.
17.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
17.2 If, after the allocation to the legal reserve, distributable reserves exist, the Board of Managers shall recommend
the way the remaining annual net profits shall be allocated, by way of either full or partial allocation to a reserve, carrying-
forward to the next financial year or, together with carried-forward profits, distributable reserves or share premiums
distribution to the shareholders.
17.3 The shareholders shall participate to the Company's profits and losses pro rata to the Shares held by the share-
holders in the Company.
17.4 The decision to distribution and the amount of the distribution shall be taken by the shareholders in accordance
with the provisions of article 16.
17.5 Irrespective of the above provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of
interim financial statements prepared by the board of managers to shareholders before the end of the financial year, while
it is assumed (i) that the amount to be distributed may not exceed the realized profits since the end of the last financial
73318
L
U X E M B O U R G
year for which the annual accounts have been approved,increased by the carried forward profits and decreased by with-
drawals out of the available reserves and losses carried forward and sums to be allocated to a reserve in accordance with
the law or these Articles and (ii) that distributed amounts, that do not correspond to actual profits shall be refunded by
the shareholders.
Chapter VI. - Liquidation
Art. 18. Dissolution and Liquidation.
18.1 The Company is not dissolved through death, the repeal of civil rights, the insolvency or the bankruptcy of the
sole shareholder or one of the shareholders.
18.2 The liquidation of the Company is decided by the meeting of the shareholders in accordance with the relevant
legislation.
18.3. The liquidation of the Company shall be carried out by one more liquidators who are appointed by the meeting
of the shareholders, who can be shareholders or other (natural or legal) persons and whose powers and compensation
are determined by the shareholders.
Chapter VII. - Governing law; Final provisions
Art. 19. Governing Law. All matters not specifically governed by the Articles shall be determined in accordance with
the relevant provisions of the Law.
Art. 20. Final provisions. In the case that single provisions of these Articles become fully or partially invalid or any
omission is contained in these Articles, the validity of the remaining provisions shall - subject to the Law - not be affected.
The shareholders are in fact obliged to replace any invalid or missing provision according to the provisions of the Law
and these Articles by a provision that would have reasonably been agreed upon by the shareholders if they would have
identified the invalidity or incompleteness of the relevant provision at the time of the adoption of these Articles."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to be EUR 1,600.-.
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholders of the appearing persons, the said proxyholders of the persons
appearing signed together with the notary, the present original deed.
Follows the German version:
Im Jahre zweitausenddreizehn, den siebzehnten April.
Vor mir, Maître Paul Bettingen, Notar mit dem Amtssitz in Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1° SIGNA Prime Luxembourg S.àr.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach dem Recht von Luxemburg,
eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Luxemburg, unter der Nummer B164984, mit dem Gesellschaftssitz in
L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff,
2° BSG Real Estate (Netherlands) I B.V., eine besloten vennootschap, gegründet nach dem Recht von Niederlanden,
eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Amsterdam, unter der Nummer 56642482, mit dem Gesellschaftssitz
in Haaksbergweg 59, 1101 BR Amsterdam Zuidoost, Netherlands,
beide hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre Dias, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in Senningerberg, auf
Grund zwei privatschriftlichen Vollmachten, welche, nachdem sie durch den Erschienenen und den unterzeichnenden
Notar "ne varietur" unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.
Die vorbezeichneten Gesellschaften sind die einzigen Gesellschafter der Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine
société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit dem Gesellschaftssitz in 5, rue Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Luxemburg, unter
der Nummer B 172676, gegründet am 9. November 2012 durch Urkunde des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2988 am 10. Dezember 2012 (die "Gesellschaft"). Die koor-
dinierte Satzung wurde seit dem nicht gändert.
Die Erschienenen, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellen, ersuchen den unterzeichnenden Notar,
folgendes zu beurkunden:
Das gegenwärtige Versammlung folgende Tagesordnung hat:
<i>Tagesordnungi>
1. Schaffung neuer Klassen von A und B Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1).
73319
L
U X E M B O U R G
2. Umwandlung von zwölftausend (12.000) existierenden Anteilen, die gegenwärtig vom Gesellschafter SIGNA Prime
Luxembourg S.à r.l. gehalten werden, in zwölftausend (12.000) Anteile der Klasse A mit einem Nominalwert von jeweils
einem Euro (EUR 1).
3. Umwandlung von zwölftausend (12.000) existierenden Anteilen, die gegenwärtig vom Gesellschafter BSG Real Estate
(Netherlands) I BV gehalten werden, in zwölftausend (12.000) Anteile der Klasse B mit einem Nominalwert von jeweils
einem Euro (EUR 1).
4. Klassifizierung der gegenwärtigen Geschäftsführer der Gesellschaft.
5. Änderung der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Drittpersonen.
6. Änderung der Sprache der Satzung der Gesellschaft von Deutsch auf Englisch.
7. Ernennung eines Wirtschaftsprüfers.
8. Vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft (ohne Abänderung des Gesellschaftszwecks).
9. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter fassen folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Anteilsklassen A und B mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR
1) zu schaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, zwölftausend (12.000) existierende Anteile, die gegenwärtig vom Gesellschafter
SIGNA Prime Luxembourg S.à r.l. gehalten werden, in zwölftausend (12.000) Anteile der Klasse A mit einem Nominalwert
von jeweils einem Euro (EUR 1) und den in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bestimmungen unterstellt, umzu-
wandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, zwölftausend (12.000) existierende Anteile, die gegenwärtig vom Gesellschafter
BSG Real Estate (Netherlands) I BV gehalten werden, in zwölftausend (12.000) Anteile der Klasse B mit einem Nominal-
wert von jeweils einem Euro (EUR 1) und den in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bestimmungen unterstellt,
umzuwandeln.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die gegenwärtigen Geschäftsführer, die für einen unbegrenzten Zeitraum ernannt
wurden, neu zu klassifizieren.
Folgende gegenwärtige Geschäftsführer werden zu A Geschäftsführern der Gesellschaft klassifiziert:
- Herr Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Dortmund (Deutschland), berufsansässig an 5, rue Heienhaff,
L-1736 Senningerberg; und
- Herr Manuel Pirolt, geboren am 10. Oktober 1983 in Feldkirch, Vorarlberg (Österreich), berufsansässig an 31, Maria-
Theresien-Straße, A-6020 Innsbruck,
Folgende gegenwärtige Geschäftsführer werden zu B Geschäftsführern der Gesellschaft klassifiziert:
- Herr Gregg Blackstock, geboren am 24. September 1974 in Mbabane (Swaziland), berufsansässig an 7 Old Park Lane,
Mayfair, London W1K 1QR, Vereinigtes Königreich; und
Herr Michael Lange, geboren am 28. Juni 1964 in Scheeßel (Deutschland), berufsansässig an 16, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg.
<i>Fünfter Beschlussi>
Laut vorstehenden Beschluss beschließt die Hauptversammlung die Vertretung der Gesellschaft abzuändern und dem-
entsprechend Artikel 10 der Satzung abzuändern wie folgt:
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift
der Geschäftsführer A; und, (ii) durch die Unterschrift von jeglicher Person, der durch den gemäß vorstehend (i) jeweils
vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die Sprache der Satzung der Gesellschaft von Deutsch auf Englisch gefolgt von einer
deutschen Übersetzung abzuändern. Der englische Text soll maßgeblich sein.
<i>Siebenter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, die folgende Person zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, bis zur
Verabschiedung durch die Hauptversammlung, der Jahresabschlüsse des ersten Geschäftsjahres, zu ernennen:
73320
L
U X E M B O U R G
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und existierend unter den Gesetzen
des Großherzogstums Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Luxemburg, unter der Nummer B
65477, mit dem Gesellschaftssitz in 400, Route d'Esch, L-1471 Luxemburg.
<i>Achter Beschlussi>
Als Konsequenz der vorangegangenen Beschlüsse, beschließt die Hauptversammlung die Satzung der Gesellschaft (ohne
Abänderung des Gesellschaftszwecks) vollständig umzuschreiben, welche fortan wie folgt lautet:
"Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Form - Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen «Kaufhaus Immobilien
Holding A S.à r.l.", die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend
die "Gesellschaft") insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung
(nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").
Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Senningerberg (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschafter, die in der Weise
beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.
2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Niederanven durch einfachen
Beschluss des des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.
2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial,
welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig
ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die
Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische
Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Vorstand.
2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.
Art. 3. Zweck.
3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und
der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaf-
ten und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine "Tochtergesellschaft"), und zwar in jeder Form gleich
welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu führen.
3.2 Die Gesellschaft kann - direkt und/oder (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften - grund-
stückbezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.
3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese er-
werben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.
3.4 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine
Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu be-
trachten ist:
(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld
aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen,
Schuldscheinen, Eigenwechseln und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch
die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;
(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuld-
instrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person ausgegeben wurde, zu zeichnen
oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;
(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit ab-
schließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder
eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden,
und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung
von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochtergesellschaften, innerhalb der Grenzen
und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.
3.5 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen
vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie
alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.
73321
L
U X E M B O U R G
Kapitel II. - Kapital, Anteile
Art. 5. Anteilskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital wird auf vierundzwanzigtausend Euro (EUR 24.000,00) festgesetzt, eingeteilt in zwoelf-
tausend (12.000) Anteile der Anteilsklasse A (die "Klasse A-Anteile") und zwoelftausend (12.000) Anteile der Anteilsklasse
B (die "Klasse B-Anteile") mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die Anteile der Anteilsklasse A, sowie die
Anteile der Anteilsklasse B werden fortan kollektiv als "Anteile" bezeichnet).
5.2 Sofern in dieser Satzung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur Ausübung
gleicher Rechte.
5.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein
Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft bestimmen.
Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der
Gesellschaft frei übertragbar.
7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei
zwischen den Gesellschaftern unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 7.3 nachstehend, und (ii) in Anwendung
der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an Nichtgesellschafter übertragen werden.
7.3 Alle Anteilsübertragungen unterliegen jeglichen Beschränkungen die in einem von den Gesellschaftern der Gesell-
schaft zum Zweck der Regelung von
Gesellschaftsangelegenheiten abgeschlossenen Vertrags aufgeführt sind (ein "Gesellschaftervertrag").
Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 8. Geschäftsführung.
8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt zwei (2) Geschäftsführern der Klasse A (die "A Geschäftsführer") und zwei
(2) Geschäftsführern der Klasse B (die "B Geschäftsführer" und zusammen mit den A Geschäftsführern, die "Geschäfts-
führer") die einen Geschäftsführervorstand bilden (der "Vorstand").
8.2 Die A Geschäftsführer sollen von den Inhabern der der Klasse A¬Anteile zur Ernennung vorgeschlagen werden
und B Geschäftsführer sollen von den Inhabern der Klasse B-Anteile zur Ernennung vorgeschlagen werden.
Die Gesellschafter sind dazu verpflichtet die Ernennung der vorgeschlagenen Personen zu Geschäftsführern der Ge-
sellschaft zu bewirken. Ein Gesellschafter kann eine solche Ernennung durch einen anderen Gesellschafter nur unter
Angabe von einschlägigen Gründen verweigern, die im besten Interesse der Gesellschaft liegen, vorausgesetzt, dass diese
Gründe ausschlieslich die vorgeschlagene Person betreffen.
Das Recht jedes Gesellschafters zwei (2) Geschäftsführer A oder zwei (2) Geschäftsführer B zur Ernennung vorzu-
schlagen ist auf nachfolgende Ernenunngen anwendbar (z.B. als Folge der Entlassung oder Kündigung eines Geschäftsfüh-
rers).
8.3 Auf Anfrage des jeweiligen Geschäftsführers muss die von ihm vorgeschlagene Person von seinem Amt als Ge-
schäftsführer der Gesellschaft entlassen werden.
8.4 The Vorsitzende des Vorstands, sofern ernannt, soll keine ersetzende Stimmbefugnis haben (Stichentscheid).
Art. 9. Befugnisse des Vorstands.
9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im
Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem
Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei
eingehalten werden.
9.2 Die Gesellschafter in einer Hauptversammlung handelnd, müssen eine interne Geschäftsordnung erlassen, über die
der Vorstand in Kenntnis gesetzt wird und die für diesen jeweils bindend ist (die "Geschäftsordnung". Zur Vermeidung
jedes Zweifels, kann die Geschäftsordnung nur durch Beschluss der Gesellschafterhauptversammlung abgeändert werden.
9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-
halten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands.
9.4 Der tägliche Betrieb der Gesellschaft wird von Personen ausgeführt die zeitweilig vom Vorstand unter den Ge-
schäftsführern A ernannt werden, unter Vorbehalt von Befugnisbeschränkungen, die in der Geschäftsordnung aufgeführt
sind.
Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift
der Geschäftsführer A; und, (ii) durch die Unterschrift von jeglicher Person, der durch den gemäß vorstehend (i) jeweils
vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.
73322
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Delegierung und Beauftragter des Vorstands.
11.1 Der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n de-
legieren.
11.2 Jeder Geschäftsführer wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Be-
auftragten, die Daür des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung
festlegen.
Art. 12. Sitzung des Vorstands.
12.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:
Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsit-
zenden ernennen. Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
12.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer
anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.
12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die
schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen
Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.
12.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einer Mehrheit angenommen.
12.5 Der Einsatz von Video- und/oder Telefonkonferenzanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäfts-
führer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern
gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende
Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video- und/oder
Telefonkonferenzanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer
hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Doku-
menten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.
Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen
soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführern unterzeichnet.
12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden
Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.
Art. 13. Vergütung der Geschäftsführer. Den Geschäftsführern steht zur Ausführung ihres Amtes keine Vergütung zu,
sofern nicht anderweit von den Gesellschaftern festgelegt.
Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.
14.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.
14.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum
befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum ent-
sprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.
14.3 Der Vorstand beruft die Gesellschafterversammlungen ein oder schlägt schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor.
Jeder Gesellschafter hat das Recht, den Vorstand zur Einberufung der Gesellschafterversammlung zu ersuchen und durch
die Gesellschafter zu fassende Beschlüsse vorzuschlagen. Der Vorstand ist dazu verpfichtet innerhalb von 30 Tagen nach
Anfrage gemäss dieses Artikels eine Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft einzuberufen oder die Beschlüsse
zur Abstimmung durch die Gesellschafter vorzulegen.
14.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung an jeden
einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme
hiervon ist die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21
(einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.
14.5 Jeder Gesellschafter darf anfragen, bestimmte Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Gesellschafterver-
sammlung zu setzen, vorausgesetzt, dass die Anfrage innerhalb von drei (3) Tagen nach Erhalt des Einberufungsschreibens
erfolgt. Eine solche Anfrage muss begründet sein und schriftlich erfolgen. Die anderen Gesellschafter müssen unverzüglich
über den neuen Punkt der Tagesordnung in Kenntnis gesetzt werden.
14.6 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung
verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.
73323
L
U X E M B O U R G
14.7 Existieren mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Ver-
sammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.
14.8 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Be-
schlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäfts-
führern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15)
Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der
Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige
Beschlussfassungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
14.9 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu
ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss
kein Gesellschafter sein.
14.10 Beschlüsse sind - vorbehaltlich jeglicher sonstiger Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung - nur dann
rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des
Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedochBeschlüsse, welche die Satzung ändern oder ein Beschluss über die Ände-
rung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert.
Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
Art. 15. Geschäftsjahr.
15.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
15.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein
Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
15.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz
nehmen.
15.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der
fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.
Art. 16. Aufsicht der Gesellschaft.
16.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat
bestehend aus einem oder mehreren Prüfern (commissaires) erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als auch
Nichtgesellschafter sein.
16.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten
Fassung) über das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahres-
bilanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé) prüfen
lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt.
Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.
16.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmoda-
litäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.
Art. 17. Gewinnverteilung, - Ausschüttung, Erlösrückführung.
17.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage
zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.
17.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,
schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder
teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen,
ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten.
17.3 Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft pro rata zu den von den Gesellschafter gehaltenen
Anteilen der Gesellschaft beteiligt.
17.4 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von
Artikel 13 getroffen.
17.5 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können der/die Gesellschafter, auf Grundlage eines Jahres-
berichts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des Geschäftsjahres
auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten Geschäftsjahrs,
dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus
den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund gesetzlicher und
satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii) ausgezahlte Be-
träge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.
73324
L
U X E M B O U R G
Kapitel VI. - Liquidation
Art. 18. Auflösung und Liquidation.
18.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den
Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
18.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften beschlossen.
18.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt,
die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung
durch die Gesellschafter festgelegt werden.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen
Art. 19. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf
die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
Art. 20. Schlussbestimmungen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll - soweit vom Gesetz erlaubt - dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder
fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren,
wie sie die vernünftigerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder
das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt."
Es ist über keine weiteren Angelegenheiten abzustimmen, die Hauptversammlung ist demnach geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die der Gesellschaft obliegen und die der Ge-
sellschaft in Rechnung gestellt werden in Verbindung mit den Gründen der vorliegenden Urkunde betragen EUR 1.600,-.
Worüber die vorliegende Urkunde in Senningerberg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde
erwähnt wird.
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der
erschienenen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Deutsch abgefasst ist nebst einer englischen Fassung; auf Anfrage
der erschienenen Partei und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Fassung, soll die englische
Fassung maßgeblich sein.
Das Dokument wurde den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen, der besagte Bevollmächtigte der
erschienenen Parteien unterzeichnet zusammen mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde.
Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 30 avril 2013. LAC / 2013/ 20097. Reçu 75,-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Carole Frising.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 13. Mai 2013.
Référence de publication: 2013061636/634.
(130075553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
ENN European Transportation Fuels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 177.156.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the second day of May;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
ENN Gas Hong Kong Investment Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Hong
Kong Special Administrative Region, registered with the Hong Kong Companies Registry under the number
38591788-000-10-12-0, having its registered office at Rooms 3101-04, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong
Kong,
duly represented by Me Shaohui ZHANG, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
73325
L
U X E M B O U R G
Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the
shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of: «ENN European
Transportation Fuels S.à r.l.» (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
3.5. The Company may also carry out all commercial activities, including domestic and international trade, in accordance
with the provisions of the law of September 2, 2011 relating to the right of establishment and regulating the access to
the occupations of craftsman, tradesman, industrialist as well as certain liberal professions.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand Euros (EUR 20,000.-), represented by twenty thou-
sand (20,000.-) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
73326
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member, to third parties.
If the Company has more than one member, the transfer of shares to non-members is subject to the prior approval
of the general meeting of members representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A members' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each member who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single member or the general
meeting of members which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers. The manager
(s) need not to be member(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or
not, by the manager, or if there is more than one manager, by the joint signature of two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the
board of managers are validly taken by the majority of the votes presents or represented provided that any resolution
shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager.
The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented
at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters in case of a sole manager,
by the signature of the sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature two managers in case of
non-distinction of class, or, in case of distinction of class, two managers composed of one (1) class A manager and one
73327
L
U X E M B O U R G
(1) class B manager or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly
delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of members
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The single member assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of members.
12.2. Each member has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the members in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The members shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the members may appear on a
single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the members owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
15.2. The general meeting of members has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or the general meeting of members;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each
member in the Company.
73328
L
U X E M B O U R G
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, ENN Gas Hong Kong Investment Limited, represented as stated hereabove, declares to have subscribed
to twenty thousand (20,000) shares of the share capital of the Company, representing the whole share capital, and declares
to have fully paid up the twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, by contribution
in cash, so that the amount of twenty thousand Euros (EUR 20,000.-) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
share capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Zhiqiang CUI, company director, born in Beijing, People's Republic of China ("PRC"), on March 16, 1966, with
professional address at 19 Lyoner street, 60528, Frankfurt am Main, Germany;
- Mr. Dongzhi WANG, company director, born in Hebei, PRC, on November 14, 1968, residing at 22-2-501, Kangzhuan
Garden, Kangzhuan Road, Guangyang District, Langfang City, Hebei Province, PRC;
- Mr. Yongxin LIU, company director, born in Honghu, PRC, on September 4, 1963, residing at Room 901, Unit 4,
Building 3, Xinhua Place, Langfang City, Hebei Province, PRC.
2. The registered office of the Company is set in L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le deux mai;
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
ENN Gas Hong Kong Investment Limited, une société privée de droit de la Région administrative spéciale de Hong
Kong, immatriculée au Registre de Commerce de Hong Kong sous le numéro 38591788-000-10-12-0, ayant son siège à
Rooms 3101-04, Tower One, Lippo Center, 89 Queensway, Hong Kong,
ici représentée par Maître Shaohui ZHANG, avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi entre les comparant(e)s et tous ceux qui pourront devenir détenteurs des parts
sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination: «ENN European Transportation Fuels
S.à r.l.» (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
73329
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change,
de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent
de manière directe ou indirecte.
3.5. La Société pourra accomplir toutes activités commerciales, y compris du commerce national et international, en
conformité avec les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès
aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille Euros (EUR 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous
forme nominative avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
73330
L
U X E M B O U R G
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés
laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de
gérance composé d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A et (1) ou plusieurs gérants de classe B. Le(s) gérant(s) n'est/
ne sont pas nécessairement un/des associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés
sous réserve qu'une résolution ne sera valablement adoptées sans être approuvées par au moins un (1) gérant de classe
A et au moins une(1) gérant de classe B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous
les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, en cas de gérant unique,
par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes deux gérants en cas de
non distinction de classes, ou, en cas de distinction de classes, de deux gérants composé d'un (1) gérant de classe A et
d'un (1) gérant de classe B, ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
73331
L
U X E M B O U R G
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à
l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, ENN Gas Hong Kong Investment Limited, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à vingt
mille (20.000) parts sociales du capital social, représentant la totalité du capital social de la Société et avoir entièrement
libéré les vingt mille (20.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, par versement en
espèces, de sorte que la somme de vingt mille Euros (EUR 20.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
73332
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Zhi Qiang CUI, administrateur de sociétés, né le 16 mars 1966 à Pékin, République Populaire de Chine
(«RPC»), demeurant à 19 Lyoner street, 60528, Frankfurt am Main, Allemagne;
- Monsieur Dongzhi WANG, administrateur de sociétés, né le 14 novembre 1968, à Hebei, RPC, demeurant à 22-2-501,
Kangzhuan Garden, Kangzhuan Road, Guangyang District, Langfang City, Hebei Province, RPC;
- Monsieur Yongxin LIU, administrateur de sociétés, né le 4 septembre 1963, à Honghu, RPC, demeurant à Room 901,
Unit 4, Building 3, Xinhua Place, Langfang City, Hebei Province, RPC.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. ZHANG, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mai 2013. LAC/2013/21080. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 13 mai 2013.
Référence de publication: 2013061493/424.
(130076545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Exarchus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 177.148.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-thirteenth day of April.
Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
There appeared:
- Mr. Angelo BURATTI, born on 24 february 1958 in Cervia (Italy), and residing in viale Emilia n. 34, Comune di Cervia,
frazione Pinarella (Italy),
- Mrs Marika VERNA, born on 11 march 1945 in Zurich (Switzerland) and residing in piazza Almerici n. 4, in Cesena
(Italy),
(the "Shareholders"),
hereby represented by Mirko LA ROCCA, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
by virtue of two proxies given under private seal, which, initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The aforementioned party is referred to hereafter as the "Shareholders".
Such appearing party, acting in the herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée).
ARTICLES OF INCORPORATION
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. 1.1 There is hereby established by the current owner of the Shares created hereafter and among
all those who may become Shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time
(the "Law") and by the present articles of association (the "Articles").
73333
L
U X E M B O U R G
1.2 The company exists under the name of "EXARCHUS S.à r.l." (the "Company").
1.3 The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders (the "Shareholders").
1.4 Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if
the Company has only one shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
2.3 However, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company (the "Board
of Managers") is authorized to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers of the Company.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquires, hold or dispose of interests and participations in
Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.
3.2 The Company may make real estate and private equity related investments whether directly or through direct or
indirect participations in subsidiaries of the Company owning such investments.
3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged
in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law;
3.6 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or
operations and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital and Shares.
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20.000.-) represented by two hundred (200) shares having
a nominal value of one hundred each (100.-) (the "Shares").
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholders.
5.3 All Shares will have equal rights. Each Share is entitled to one (1) vote at ordinary and extraordinary general
meetings of Shareholders.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Board of Managers subject to
the availability of funds determined by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.
73334
L
U X E M B O U R G
5.5 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders' register in
accordance with the applicable law.
5.6 Shares may be subscribed through a contribution in kind each time it is expressly provided for in the decisions of
the Board of Managers.
Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one (1) owner is admitted per
Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III. - Management
Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case of
one (1) manager, he/she/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute
a board of managers ("Conseil de Gérance") (the "Board of Managers").
8.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the Shareholders.
8.3 The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound
by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of its managers
for commitments which do not exceed two thousand Euro (EUR 20,000.-) and by the joint signature of any two (2)
managers in any other situation or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a
Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.
Art. 11. Delegation and Agent of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific
tasks to one (1) or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The
Shareholders may appoint a chairman from amongst the managers to convene over meetings of the Board of Managers.
The chairman has a casting vote in case of ballot.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage. A manager may represent more than one of his colleagues.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Where there are only two (2) managers appointed, both members must be present or represented. Deci-
sions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from Luxembourg shall be allowed provided
that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using
this technology and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video
or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers. The date of
such decision shall be the date of the last signature.
73335
L
U X E M B O U R G
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the
meeting.
12.8 Copies or excerpts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a
meeting of the Board of Managers.
Art. 13. Liabilities of the managers.
13.1 The manager(s) does(do) not assume, by reason of its(their) position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
13.2 The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Chapter IV. - General Meeting of shareholders.
Art. 14. Powers of the sole shareholder / the general meeting of shareholders / Vote.
14.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
14.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which she/he/it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All
Shares have equal voting rights.
14.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14.4 If there are more than twenty-five (25) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings
to be convened in accordance with the applicable legal provisions.
14.5 If there are less than twenty-five (25) Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast her/his/its vote in writing.
14.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax, e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority
(in number) of the Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company's Share capital, subject to any
other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.
Chapter V. - Financial year, Distribution of profits.
Art. 15. Financial year.
15.1 The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2013.
15.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board
of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. Distribution of profits.
16.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent (5%) shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth (10%) of the Company's nominal capital.
16.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
16.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of article 14.7 above.
16.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by
73336
L
U X E M B O U R G
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the sole Shareholder or of one of the Shareholders.
17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions, it being understood that in case of a sole Shareholder, such sole Shareholder may decide to dissolve the
Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the
Company.
17.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. - Applicable law.
Art. 18. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
- Mr Angelo BURATTI, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Shares
- Mrs Marika VERNA, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Shares
All these Shares have been fully paid up so that the sum twenty thousand Euro (EUR 20.000,-) corresponding to a
share capital of twenty thousand Euro (EUR 20.000,-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proven
to the notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate
on 31
st
December 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately nine hundred seventy Euro (EUR 970,-).
<i>Resolutions of the shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders represented as stated above, representing the
entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg;
2. The Shareholders resolve to appoint as sole manager of the Company for an undetermined period:
- Mr. Angelo BURATTI, born on 24 february 1958 in Cervia (Italy), and residing in viale Emilia n. 34, Comune di Cervia,
frazione Pinarella (Italy),
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, he/she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-trois avril,
Par-devant le notaire soussigné, Maître Roger ARRENSDORFF, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- Monsieur Angelo BURATTI, né le 24 février 1958 à Cervia (Italie) et demeurant à viale Emilia n. 34, Comune di
Cervia, frazione Pinarella (Italie),
- Madame Marika VERNA, née le 11 mars 1945 à Zurich (Suisse) et demeurant à piazza Almerici n. 4, à Cesena (Italie),
73337
L
U X E M B O U R G
ici représentés par M. Mirko LA ROCCA, employé, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, 30 Boulevard Royal en vertu de deux procurations données sous seing privé,
lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La partie susmentionnée désignée ci-après comme l'«Associé».
Laquelle comparante, agissant en dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société à responsabilité limitée.
STATUTS
Titre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme, Nom.
1.1 Il est ici établi par le détenteur actuel de Parts Sociales crées ci-après et entre tous ceux qui deviendront associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée de temps à autre (la «Loi de 1915»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
1.2 La société adopte la dénomination de «EXARCHUS S.à r.l.» (la «Société»).
1.3 La Société peut avoir un seul associé (l'«Associé Unique») ou plusieurs associés (les «Associés»).
1.4 Toute référence aux associés dans les Statuts doit être une référence à l'Associé Unique de la Société si la Société
n'a qu'un seul associé.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de
l'assemblée générale extraordinaire des Associés délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3 Cependant, le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société (le «Conseil
de Gérance») est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la commune de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique, ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est de, directement ou indirectement, d'acquérir, détenir ou disposer d'intérêts et participation
au Luxembourg ou d'entités étrangères, par tout moyen et d'administrer, développer et gérer une telle détention d'in-
térêts ou participations.
3.2 La Société peut procéder à des investissements relatif à l'immobilier soit directement ou par la participation directe
ou indirecte dans des filiales de la Société possédant de tels investissements.
3.3 La Société peut aussi, directement ou indirectement, investir, acquérir, détenir ou disposer d'actifs de quelque
nature que ce soit.
3.4 La Société peut également apporter toute assistance financière aux entités faisant partie du groupe de la Société,
que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a
un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore
à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»),
étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait
considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
3.5 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes pouvant être considérée
comme pertinents;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
73338
L
U X E M B O U R G
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.
3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, immobilières, commerciales, techniques ou financières et en
général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital et Parts sociales.
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille Euros (20.000,- EUR) représenté par deux cents (200) parts sociales, d'une
valeur nominale de cent Euro chacune (100,- EUR) (les «Parts Sociales»).
5.2 En complément du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux. Chaque Part Sociale a droit à un (1) vote lors des
réunions des assemblées ordinaires et extraordinaires des Associés.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décision du Conseil de Gérance sous réserve
de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur base des comptes intérimaires.
5.5 Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne en particulier, et inscrites dans le registre des
Associés en conformité avec la loi applicable.
5.6 Les actions pourront être souscrites à travers un apport en nature à tout moment sur base d'un agrément et
décision du Conseil de Gérance.
Art. 6. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
Titre III. - Gérance.
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des Associé(s). Dans le cas
d'un seul gérant, il sera défini ci-après comme le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associés.
8.3 La mort ou la démission d'un gérant, pour quelle que raison que ce soit, ne doit pas entraîner la dissolution de la
Société.
Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, a tous
les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi de 1915 ou les Statuts
seront de la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée
par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de tout gérant pour
les engagements ne dépassant pas vingt mille Euros (20.000,EUR) et par la signature conjointe de deux (2) gérants dans
toute autre situation ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique,
par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.
Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs à un (1)
ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la
rémunération quelconques (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres con-
ditions de leur mandat.
73339
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Les Associés
peuvent nommer un président parmi les gérants pour convoquer les réunions du Conseil de Gérance. La voix du président
est prépondérante en cas de partage.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux exigences et formalités de convocation.
12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure. Un gérant peut représenter plus d'un (1) de ses collègues.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Quand seulement deux (2) gérants sont nommés, ils doivent être tous les deux présents
ou représenté. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée depuis Luxembourg est autorisée si
chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type
de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via vidéo ou
téléphone.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance. La date d'une
telle décision sera la date de la dernière signature.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représentés
aux réunions.
12.8 Des extraits ou copies seront certifiés par tout gérant ou par toute personne désignée par un gérant ou pendant
une réunion du Conseil de Gérance.
Art. 13. Responsabilité des gérants.
13.1 Les gérants ne sont pas responsables personnellement en raison de leur position du fait des engagements régu-
lièrement pris au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés et sont par conséquent responsables seulement de
l'exécution de leur mandat.
13.2 La Société doit indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs, pour les dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès ou procédures auxquels il aura
été partie en raison de ses activités pour la Société en tant que gérant ou fondé de pouvoir, ou à sa requête de toute
autre entité dont la Société est un associé ou un créditeur et pour laquelle il n'a pas été indemnisé, sauf le cas où, dans
pareils actions, procès ou procédures, il serait finalement condamné pour négligence, faute ou manquement volontaire.
En cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera octroyée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que la personne devant être indemnisée n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à l'indemnisation
n'est pas exclusif d'autres droits.
Titre IV. - Assemblée générale des associés.
Art. 14. Pouvoirs de l'associé unique / l'assemblée générale des associés / Votes.
14.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé Unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
14.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts
Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
14.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
14.4 S'il y a plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors des réunions convoquées
conformément aux dispositions légales applicables.
14.5 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et
donner son vote par écrit.
14.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax, e-mail ou par tout
autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
14.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises qu'à la condition que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité
d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sous réserve des toutes autres dispo-
sitions de la Loi de 1915. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.
73340
L
U X E M B O U R G
Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices.
Art. 15. Année sociale.
15.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, sauf pour la
première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2013.
15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance, et le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 16. Répartition des bénéfices.
16.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant
de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.
16.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que de
ces Statuts, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.
16.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'article 14.7 ci-dessus.
16.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou, en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux
bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'Associé(s).
Titre VI. - Dissolution, Liquidation.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite
de l'Associé Unique ou de l'un de ses Associés.
17.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables étant entendu qu'en cas d'un Associé Unique, un tel Associé Unique pourra décider de dissoudre la Société
et de procéder à sa liquidation assumant personnellement tous les actifs et passifs, connu ou inconnu de la Société.
17.3 La liquidation sera assurée par un (1) ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - Loi applicable.
Art. 18. Loi applicable. La Loi de 1915 trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents
Statuts.
<i>Souscription et Paiementi>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
- Mr Angelo BURATTI, susdit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts sociales
- Mme Marika VERNA, susdite, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Parts sociales
Chacune des Parts Sociales a été intégralement payées de sorte que la somme de vingt mille Euros (20.000,- EUR)
correspondant à un capital social de vingt mille Euro (20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et se terminera au 31 décembre 2013.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent soixante-dix Euros (EUR
970,-).
<i>Première assemblée générale des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les Associés représentés comme indiqué ci-dessus, représentant
l'intégralité du capital social souscrit et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, ont passé les résolutions suivantes:
73341
L
U X E M B O U R G
1. Le siège social de la Société sera au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les Associés décident de nommer comme gérant unique de la Société pour une période indéterminée:
- Monsieur Angelo BURATTI, né le 24 février 1958 à Cervia (Italie) et demeurant à viale Emilia n. 34, Comune di
Cervia, frazione Pinarella (Italie).
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Le document ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte.
Signé: LA ROCCA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 avril 2013. Relation: LAC / 2013 / 19754. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signe): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 14 mai 2013.
Référence de publication: 2013061508/479.
(130076423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Effinpro s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 161.477.
L'an deux mil treize, le vingt-six avril,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
ont comparu:
Monsieur Armand SCHMITT, conseil en propriété intellectuelle, né à Luxembourg le 1
er
juillet 1957, demeurant à
L-8082 Bertrange, 3, rue Alphonse München et
La société PRONOVEM INTERNATIONAL s.à r.l. avec siège à L-4361 Esch/Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll, im-
matriculée au RCSL sous le numéro B 143.644, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 11 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 84 du 14 janvier 2009, repré-
sentée aux fins des présentes par un de ses gérants, savoir:
Madame Joëlle Van Malderen, conseil en propriété industrielle, né à Anderlecht, le 1
er
août 1962, demeurant à B1060
Saint-Gilles, 91 b2, rue d'Espagne, nommée à cette fonction aux termes de l'assemblée générale constitutive et habilitée
à engager la société sous sa signature individuelle conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts et à la décision
des associés prises lors de l'assemblée générale constitutive,
elle-même représentée par Monsieur Armand SCHMITT, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé,
laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant, restera annexée aux présentes avec lesquelles
elle sera enregistrée.
Après avoir établi, au moyen de l'acte de constitution qu'ils possèdent ensemble toutes les trois cents (300) parts de
la société à responsabilité limitée EFFINPRO s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-8011 Strassen, 261, route d'Arlon,
inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 161.477,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mai 2011, publié au Mémorial C
numéro 1877 du 17 août 2011,
et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,
les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit
la résolution suivante:
Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-4361 Esch/Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.
La première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:
«Le siège social est établi dans la Commune d'Esch/Alzette.»
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a
signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.
Signé: A. SCHMITT, C. MINES.
73342
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Capellen, le 30 avril 2013. Relation: CAP/2013/1505. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Entringer.
Pour copie conforme,
Capellen, le 3 mai 2013.
Référence de publication: 2013061484/43.
(130075883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Elektra-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 169.820.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ELEKTRA-LUX S.A., tenue au siège social le 24 Avril 2013 ài>
<i>09 heuresi>
<i>Résolutionsi>
1. L'Assemblée approuve la radiation de l'actuel Administrateur-Délégué à savoir Monsieur Daniel LOUIS, ayant son
adresse au 19, rue de la République F-57390 Audun-Le-Tiche (FRANCE).
2. L'Assemblée approuve la radiation de l'Administrateur à savoir Monsieur Daniel LOUIS, ayant son adresse au 19,
rue de la République F-57390 Audun-Le-Tiche (FRANCE).
3. L'Assemblée approuve la nomination de l'Administrateur à savoir Monsieur José MOREIRA DOS SANTOS José,
ayant son adresse au 60, rue Pasteur L-3543 Dudelange.
4. L'Assemblée approuve la nomination de l'Administrateur-Délégué à savoir Monsieur José MOREIRA DOS SANTOS
José, ayant son adresse au 60, rue Pasteur L-3543 Dudelange.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels du 31 Décembre
2016.
Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 10 heures après signature du présent procès-
verbal par les membres du bureau.
Celso FRANCISCO CHAVES / Maximino LOUSADA / Richard GAUTHIER
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2013061485/25.
(130076049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2013.
Magic Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 75.789.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 avril 2013 à Luxembourgi>
<i>Résolutions:i>
- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de:
1) renouveler les mandats d'Administrateur de M. Pierre SCHILL et M. Joseph WINANDY
et
2) de nommer en tant qu'Administrateur, la Société JALYNE SA, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg représentée
par Monsieur Jacques Bonnier, 39, rue des Champs, B-6791 Athus.
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2013.
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de
Fiduciaire Glacis S.à r.l. pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice clôturant au 31 décembre 2013.
Pour copie conforme
JALYNE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013059716/23.
(130073099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
73343
L
U X E M B O U R G
IBI Partners Invest, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 600.000,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 136.849.
<i>Extrait des décisions d'associé unique du 3 mai 2013i>
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a nommé M. Peter Bun, avec adresse professionnelle au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg en tant
que gérant, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique autorise en outre à la Société de changer le siège social de son adresse actuelle 6, place de Nancy,
L-2212 Luxembourg, au 8, rue Philippe II L-2340 Luxembourg avec effet immédiat.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique a décidé de nommer ISOSTRESS, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 29,
rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B128503 en tant que nouveau commissaire aux comptes, jusqu'à l'assemblée générale annuelle tenue en 2014,
avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/05/2013.
Référence de publication: 2013059610/22.
(130072935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Cool-Tec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R.C.S. Luxembourg B 107.990.
Il se dégage de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société "COOL-TEC S.A.", établie et ayant son siège social
à Zone Industrielle, L-5280 Sandweiler, inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B107.990, tenue en date du 25 avril
2013 par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, numéro 830/2013 de son répertoire,
acte enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 avril 2013, LAC/2013/19572, aux droits de 12.- € que:
Monsieur Jeannot BAUSTERT a démissionné de sa fonction d'administrateur délégué de la société avec effet au 31
mars 2013. Il restera en fonction concernant son poste d'administrateur de la société.
Monsieur Marc WINTERSDORF, technicien en électromécanique et énergie, né le 7 mars 1977 à Luxembourg, de-
meurant au 3, rue Beronis Villa, L-6550 Berdorf, a été nommé comme nouvel administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Victor WENNER;
- Monsieur Jeannot BAUSTERT;
- Monsieur Nicolas THOMMES; et
- Monsieur Marc WINTERSDORF.
Monsieur Marc WINTERSDORF, préqualifié, a été désigné de l'accord préalable de l'assemblée aux fonctions d'admi-
nistrateur-délégué dans le domaine d'activité de l'électricité avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature dans
ce domaine.
Sa nomination définitive reste de la compétence du conseil d'administration.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 7 mai 2013.
Pour extrait conforme
Martine SCHAEFFER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013059448/30.
(130073394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
73344
1618 Investment Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Cool-Tec S.A.
Effinpro s.à r.l.
Elektra-Lux S.A.
ENN European Transportation Fuels S.à r.l.
Exarchus S.à r.l.
Global Select Sicav
Gutzeit S.A.
Guy Frères
Headstart S.à r.l.
Hôtel Bel Air S.A.
Hugo Insurance S.A.
IBI Partners Invest
J. Castelain & Cie
J. Chahine Capital
JoDan Services
Jos FLIES-MAJERUS S.à r.l.
Kakim S.A.
Kalan Capital Sea Freight Arbitrage S.àr.l
Kalan Capital Ship Owning S.àr.l
Kalan Capital Special Opportunities (Global) Captive S.à r.l.
Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l.
Kglynvest - Mundi S.A.
KHEPHREN Drancy Invest S.C.A.
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.
KITOPH S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.
Laboratoire Dentaire Kayl S.à r.l.
Landbesitz Alpha A.G.
Landmark Student Transportation Luxco
Latina S.A.
LFP I SICAV - SIF S.A.
LHF S.C.A.
Licht Toitures S.N. Sàrl
Liette S.à r.l.
Linares Holding S.A.
LTIC S.A.
Lux-Top 50 Advisory S.A. Holding
Lux-Top 50 SICAV
LV Trans S.à r.l.
Magic Finance S.A., SPF
Magic Finance S.A., SPF
Magic Production Group (M.P.G.) S.A.
Magna Invest Corporation S.A.
Margaux Investments S.à r.l.
Maritime Business Management S.A.
Maritime Business Management S.A.
Maritime Business Management S.A.
Marlow Investments
Marsh S.A.
MML Enterprises S.à r.l.
Monte Sicav
Nordic Noel Street Lux S.à r.l.
Novapol Holdings S.àr.l.
OHI Finance S.A.
Pictet Alternative Funds
Resitalia Holding S.à r.l.
S.A. des Services Techniques et Généraux
Simar Overseas S.àr.l.
Tishman Speyer French Core V S.à r.l.
Vepha Holding S.A.