logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1518

26 juin 2013

SOMMAIRE

Actival Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72821

agri.capital Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72818

Alpine Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72823

Amasing Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72822

AME Life Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72823

Amundi Money Market Fund  . . . . . . . . . . . .

72823

Angelab International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

72821

Antri S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72824

Aquila s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72836

Argos Soditic Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . .

72824

Aries Investment S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

72842

Arma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72827

Arrena S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72824

Asia Internet Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

72842

Atreyu S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72825

AVT AC Holding and Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72827

Azmalo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72853

Beim Tiirmchen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72832

BERF Luxco 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72864

B-Fly 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72825

B-Fly 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72826

B-Fly 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72826

B.I.E. Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72826

B.I.E. Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72825

BI Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72827

Blueventure Investment S.A. . . . . . . . . . . . .

72828

BNP Paribas L Fix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72828

Boissons & Alimentation Hanff S.à.r.l. . . . .

72828

Boss Concept IPC Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . .

72832

Boss Concept IPC Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . .

72820

B.R.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72819

B.V. Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72825

Café Dancing Votre Choix S.à r.l. . . . . . . . .

72826

Calisson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72830

Calisto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72829

Canepa Management GP COOP S.A.  . . . .

72832

Capauvent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72830

Capauvent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72829

CEREP Cumbernauld S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

72829

CEREP Italy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72829

CEREP Manresa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72830

Cerep USA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72829

Click'n Taste s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72833

Coiffure Pia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72824

Come2Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72831

Come2Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72830

Compagnie Générale Européenne de Fi-

nance et d'Investissement S.A.  . . . . . . . . .

72830

COSTRUZIONI E APPALTI 2000 S. à r.l.

en liquidation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72831

CPPL Lux 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72831

Crèche Pétronille S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

72831

Crèche ZOO magique  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72824

Development Finnish Feeder III S.C.A. . . .

72828

D'Wierkstat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72832

Eurolever Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72864

Eurotag Europe s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72839

RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72819

SKR Management HOLDING S.A. . . . . . . .

72820

Transworld Resources S.A.  . . . . . . . . . . . . .

72820

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72821

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72822

Vitol Holding II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72863

White Mountain S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72818

Zeus Enterprises International S.A.  . . . . . .

72821

72817

L

U X E M B O U R G

White Mountain S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 169.815.

Suite à l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique de la Société en date du 2 mai 2013 les décisions suivantes

ont été prises:

1. Démission des administrateurs de catégorie B suivants à compter du 2 mai 2013:
-  Monsieur  Martinus  Cornelis  Johannes  Weijermans,  né  le  26  août  1970  à  's-Gravenhage,  Pays-Bas,  avec  adresse

professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Nomination des administrateurs de catégorie B suivants à compter du 2 mai 2013 jusqu'à l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2017:

- Monsieur Franciscus W.J.J. Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Patrick L.C. van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est comme suit:
Monsieur Ben Burton, administrateur de catégorie A;
Monsieur Andrew Le Gal, administrateur de catégorie A;
Monsieur Franciscus W.J.J. Welman, administrateur de catégorie B;
Monsieur Patrick L.C. van Denzen, administrateur de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

White Mountain S.A.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Administrateur de catégorie B

Référence de publication: 2013058392/29.
(130071386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

agri.capital Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 132.659.

Suite aux résolutions des actionnaires en date du 29 avril 2013 de la Société les décisions suivantes ont été prises:
- Démission de l'Administrateur A suivant à compter de la date des résolutions des actionnaires:
Monsieur James Peter Burke, avec adresse professionnelle au Close End, Manor Close, Penn, GB - HP10 8HZ High

Wycombe, Bucks.

- Nomination de l'Administrateur A suivant à compter de la date des résolutions des actionnaires jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui aura lieu en 2016:

Madame Catherine Koch née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au 19, rue

Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'Administration de la société est comme suit:
- M. Alexander W. Black, Administrateur A;
- Mme Catherine Koch, Administrateur A;
- M. R. Simon Riggall, Administrateur A;
- M. Kevin Parker, Administrateur B;
- M. George Parker, Administrateur B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF (Luxembourg) S.A.
Fabrice Rota
<i>Employee

Référence de publication: 2013058450/25.
(130072470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72818

L

U X E M B O U R G

RBS Global Banking (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.923.

<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 16 avril 2013

Au cours de l'assemblée générale annuelle l'actionnaire unique a approuvé les résolutions suivantes:
L'actionnaire unique décide à l'unanimité de nommer les personnes suivante en tant qu'administrateur de la société

jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2019:

- Monsieur Christian, Sébastien, Jean, Marie, Rozès né à Paris 17 

éme

 , France, le 4 juillet 1967 et demeurant profes-

sionnellement, 94 boulevard Haussmann, Paris, France 75008.

- Monsieur Etienne, Claude, André, Georges, Bernard né à Nimes, France, le 15 octobre 1966 et demeurant profes-

sionnellement, 250, Bishopsgate, Londres, UK EC2M 4AA.

- Monsieur Prakash, Advani né à Mumbai, Inde, le 16 décembre 1976 et demeurant professionnellement, 17, rue de la

Chancellerie, Brussels, Belgique 1000.

- Monsieur Gert, Jozef, Gummarus, Marc, Dillen né à Aarshot, Belgique, le 18 juillet 1965 et demeurant profession-

nellement, 17, rue de la Chancellerie, Brussels, Belgique 1000.

- Monsieur Michel, Emmanuel, Geneviève, Marie, Funck né à Etterbeek, Belgique, le 12 janvier 1966 et demeurant

professionnellement, 17, rue de la Chancellerie, Brussels, Belgique 1000.

- Monsieur Jean, Marc, Lahaye né à Rocourt, Belgique, le 10 mai 1964 et demeurant professionnellement, 46, avenue

J.F.Kennedy, Luxembourg, L-1855 Grand Duché de Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2013.

RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.
Blaise Garban
<i>Head of Legal

Référence de publication: 2013058437/28.
(130071570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

B.R.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.548.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipé le 26 avril 2013

<i>Résolutions:

Les  mandats  des  administrateurs,  de  l'administrateur-délégué  et  du  commissaire  aux  comptes  venant  à  échéance,

l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

<i>Conseil d'administration:

MM. Cassinelli Umberto, demeurant au 21F Via Castagnola, CH-6900 Lugano (Suisse), administrateur et administra-

teur-délégué;

Sébastien Schaack, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, adminis-

trateur;

Mme Gaëlle Kwiatkowski, demeurant professionnellement 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 68, Rue de Koerich, L-8437 Steinfort
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2013058516/26.
(130072433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72819

L

U X E M B O U R G

SKR Management HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener.

R.C.S. Luxembourg B 49.897.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement N° 328/13 du 28 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:

De la société SKR Management HOLDING S.A., B49897, ayant eu son siège social à 1, rue Mathias Koener, L-8387

Koerich.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

Pour extrait conforme
Michèle STOFFEL
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013058438/16.
(130071794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

Transworld Resources S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 9, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 21.657.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement N° 329/13 du 28 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:

De la société TRANSWORLD RESOURCES S.A., B21657, ayant eu son siège social à 9, rue Principale, L-5465 Wald-

bredimus.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

Pour extrait conforme
Michèle STOFFEL
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013058442/16.
(130071797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung der Boss Concept IPC Sicav

Die Ordentliche Generalversammlung der Boss Concept IPC Sicav vom 2. Mai 2013 hat folgende Beschlüsse gefasst:
Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich:
- Herr Bernhard Singer, Vorsitzender
- Herr Uwe Gillen, stellv. Vorsitzender
- Herr Wolfgang Steilen, Mitglied
Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung

im Jahr 2014, als Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2014, Pricewate-

rhouseCoopers Société coopérative, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 2. Mai 2013.

<i>Für Boss Concept IPC Sicav
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2013058535/22.
(130072478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72820

L

U X E M B O U R G

Universal-Investment-Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 75.014.

Die Ordentliche Generalversammlung hat am 07. Dezember 2012 beschlossen, KPMG Luxembourg S.à r.l., mit Ge-

sellschaftssitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister unter Nummer RCS B 149133 (als Folgegesellschaft nach Fusion der KPMG Audit S.à r.l.), zum Wirtschaftsprüfer
der Universal-Investment-Luxembourg S.A. bis zur Ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2013 stattfinden wird,
zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 03. Mai 2013.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
<i>Alain Nati / Holger Emmel

Référence de publication: 2013058444/16.
(130071328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

Zeus Enterprises International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 62, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 48.990.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement N° 330/13 du 28 février 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:

De la société ZEUS ENTERPRISES INTERNATIONAL S.A., B.48990, ayant eu son siège social à 62, route d'Echternach,

L-6617 Wasserbillig.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

Pour extrait conforme
Michèle STOFFEL
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013058449/16.
(130071798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

Actival Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 107.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ACTIVAL PARTNERS S.A.

Référence de publication: 2013058478/11.
(130072614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Angelab International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.956.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ANGELAB INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2013058495/11.
(130072664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72821

L

U X E M B O U R G

Amasing Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 175.154.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2013

- les démissions de Messieurs Luc Gerondal, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, demeurant professionnellement au 12, rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Olivier Liegeois, né le 27 octobre 1976 à Bastogne (B), demeurant profes-
sionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg et de Madame Sandrine Bisaro, né le 28 juin 1969 à
Metz (F), demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de leur mandat d'admi-
nistrateurs ainsi que la démission de la société Reviconsult Sàrl, siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, RCS B 139013 de son mandat de commissaires aux comptes sont acceptées.

- Monsieur Pascal DE GRAEVE, employé privé, né le 18 décembre 1969 à Arlon (B), demeurant au 8, rue du Stade à

B-6741 Vance, Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L- 3912 Esch-sur Alzette, domicilié
au 19, rue des Champs, L-3912 Mondercange et Monsieur Fabrice CAURLA, employé privé, né le 04 février 1983 à Esch-
sur-Alzette (L), demeurant au 3, rue Emile Eischen à L-4107 Esch-sur-Alzette sont nommés en leur remplacement, en
tant qu'administrateurs, tandis que la société HIFIN S.A., ayant son siège social au 3, Place Dargent à L-1413 Luxembourg,
RCS Luxembourg B 49454 est nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes. Leurs mandats prendront fin lors
de l'Assemblée Générale de 2017.

- L'adresse de la société est transférée du L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider à la nouvelle adresse suivante

3, Place Dargent, L-1413 Luxembourg

Certifié sincère et conforme
AMASING FINANCE S.A.

Référence de publication: 2013058490/25.
(130072207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Universal-Investment-Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 75.014.

In Übereinstimmung mit Artikel 8 der Satzung der Universal-Investment-Luxembourg S.A. (die „Gesellschaft") wird

die Gesellschaft aufgrund erteilter Vollmachten, sowie gemäß Beschluss vom 28. Januar 2013 im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung rechtsverbindlich durch die Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder zwei Geschäfts-
führern/geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern oder zwei Unterschriftsberechtigten (Vollmacht Typ A) oder von
einem Verwaltungsratsmitglied und einem Geschäftsführer/geschäftsführendem Verwaltungsratsmitglied oder von einem
Verwaltungsratsmitglied und einem Unterschriftsberechtigten (Vollmacht Typ A) oder von einem Geschäftsführer/ge-
schäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und einem Unterschriftsberechtigten (Vollmacht Typ A) vertreten.

Die nachfolgend genannten Personen sind aufgrund Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft berechtigt, gemäß

den vorstehenden Bedingungen die Gesellschaft zu vertreten und im Namen der Gesellschaft zu unterzeichnen:

<i>Präsident des Verwaltungsrates:

Bernd Vorbeck

<i>Verwaltungsratsmitglieder:

Alain Nati, Markus Neubauer, Stefan Rockel

<i>Geschäftsführer:

Johannes Höring
Unterschriftsberechtigte (Vollmacht Typ A):
Holger  Emmel,  Erich  Hein,  Melanie  Pies,  Anja  Richter,  Marc-Oliver  Scharwath,  Patrick  Schmitt,  Anja  Steilen,  Erik

Wimmers; alle beruflich ansässig 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 03. Mai 2013.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Alain Nati / Holger Emmel

Référence de publication: 2013058443/29.
(130071327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

72822

L

U X E M B O U R G

Alpine Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.713.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil de Gérance de la société en date du 4 avril 2013 que sur base des

contrats de transfert de parts sociales signé en date du 4 avril 2013, le Conseil de Gérance accepte de transférer les 200
parts sociales de EUR 100,- chacune, représentant 100 % du capital de la société, de son actionnaire actuel, la société
italienne ALPINA IMMOBILIARE S.R.L., ayant son siège social à Piazza Matteotti 8/1, 16036 Recco, Italie, comme suit:

1. 50 parts sociales à Monsieur Alberto BALLESTRERO, né le 01.11.1948 à Genova en Italie, résidant au 4 Via Mario

Emilio Scauro, 16030 Zoagli, Italie, et avec code fiscal BLLLRT48S01D969D;

2. 75 parts sociales à Madame Natalina PICCHIO, née le 06.09.1944 à Borgoratto Alessandrino (AL) en Italie, résidant

au 40/B via Privata Giovo, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), Italie, et avec code fiscal PCCNLN44P46B029W;

3. 75 parts sociales à Monsieur Pierluigi REMOTTI, né le 01.10.1941 à La Spezia en Italie, résidant au 40/B Via Privata

Giovo, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), Italie, et avec code fiscal RMTPLG41R01E463Z

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013058489/19.
(130072337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Amundi Money Market Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 156.478.

<i>Extrait Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social le 30 avril 2013

En date du 30 avril 2013, l'assemblée générale ordinaire a décidé de:
- Reconduire le mandat de M. Laurent Bertiau, M. Guillaume Abel, M. Giorgio Gretter, Mme Christine Moser et M.

Thierry Darmon en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires en 2014.

- Reconduire le mandat de Pricewaterhouse Coopers S.à r.l., en qualité de réviseur d'entreprises de la Société, pour

une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2014.

Luxembourg, le 06 mai 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Giorgio GRETTER
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2013058494/19.
(130072819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

AME Life Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 41, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 30.566.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2013

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la démission en qualité d'Administrateur de Monsieur Jean FLEURY avec effet au 18 mars

2013.

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'Administrateur, Monsieur Patrice FORGET domicilié à F-78170

LA CELLE ST CLOUD, avenue Pasteur 23, dont le mandat expirera lors de l'Assemblée Générale de 2019 qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2018.

En conséquence, le Conseil est composé de Messieurs Geoffrey BROSSIER, Patrice FORGET, Frank JEUSETTE, Olivier

LE BORGNE, Romain ROSSETTI, Dominique SALVY et Germain SOREE.

Référence de publication: 2013058491/16.
(130072465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72823

L

U X E M B O U R G

Antri S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 24.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mai 2013.

<i>Pour compte de Antri S.A.
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2013058496/12.
(130072700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Argos Soditic Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 50.717.

RECTIFICATIF

Cette mention rectificative remplace la version déposée antérieurement le 6 novembre 2012 sous le No: L120190038
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058497/11.
(130071943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Arrena S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.391.

Suite à une réunion du conseil d'administration en date du 7 mai 2013, les modifications suivantes ont été adoptées:
- Monsieur Patrick Meunier, demeurant professionnellement au siège de la société, a été nommé administrateur délégué

avec effet immédiat et pour ce, pour une durée de 6 ans.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013058500/11.
(130072284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Crèche ZOO magique, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 150, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 166.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013058596/10.
(130072202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Coiffure Pia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 121.021.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058582/10.
(130072527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72824

L

U X E M B O U R G

B.V. Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 68.514.

Les comptes annuels du 1 

er

 avril 2010 au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Référence de publication: 2013058518/11.
(130072510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Atreyu S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 180.759,91.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 65.724.

Les comptes au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ATREYU S.C.A.
Luca ANIASI
<i>Gérant Associé Commandité

Référence de publication: 2013058505/12.
(130071948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

B-Fly 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 121.593.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

B-Fly 2 S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager A

Référence de publication: 2013058519/14.
(130071983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

B.I.E. Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.

R.C.S. Luxembourg B 99.118.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société a décidé en date du 6 mai 2013 de renouveler les mandats de

messieurs Salvatore RIZZO, José CARABIN et Jean-Marc BASTIN en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société appelée à approuver
les comptes annuels de la Société en 2019.

La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances, sous réserve des matières exigeant

une  co-signature  de  un  ou  plusieurs  administrateurs  délégués,  par  la  signature  individuelle  d'un  administrateur  de  la
Société.

Pour Extrait
La société

Référence de publication: 2013058514/17.
(130072010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72825

L

U X E M B O U R G

B.I.E. Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.

R.C.S. Luxembourg B 99.118.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé en date du 6 mai 2013 de renouveler les mandats de messieurs José

CARABIN et Jean-Marc BASTIN en tant qu'administrateurs délégués à la gestion journalière de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société appelée à approuver
les comptes annuels de la Société en 2019.

La co-signature d'un administrateur-délégué est exigée pour tous les actes liés aux activités soumises à l'autorisation

d'établissement.

Pour Extrait
La société

Référence de publication: 2013058515/16.
(130072327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

B-Fly 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 121.593.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

B-Fly 2 S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager A

Référence de publication: 2013058520/14.
(130071985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

B-Fly 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 121.593.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

B-Fly 2 S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager A

Référence de publication: 2013058522/14.
(130071990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Café Dancing Votre Choix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 1, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.795.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013058599/10.
(130072630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72826

L

U X E M B O U R G

Arma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3725 Rumelange, 20, rue Dr Flesch.

R.C.S. Luxembourg B 166.355.

<i>Extrait de la convention de cession de parts

Conformément à la convention de cession de parts signée entre parties au siège social à Rumelange en date du 19

avril 2013, l'associé a décidé ce qui suit:

a) Monsieur Maxime AREND, né à Thionville (France), le 31 janvier 1988, demeurant à L-3733 Rumelange, 49, Cité

Kiirchbierg, déclare céder à la société «VLM sàrl», établie et ayant son siège social à L-3725 Rumelange, 20, rue Dr Flesch,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 175731, constituée suivant
acte notarié par-devant Me Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 6 mars 2013, dûment
représentée par son associé unique Monsieur Maxime AREND, demeurant à L-3733 Rumelange, 49, Cité Kiirchbierg, la
pleine propriété de cent (100) parts sociales qu'il possède dans la société ARMA S.à r.l., prédite.

b) Conformément aux dispositions qui précèdent, les parts sociales sont souscrites et réparties comme suit:

- VLM sàrl, pré-désigné, cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Total: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Rumelange, le 19 avril 2013.

Référence de publication: 2013058499/20.
(130072040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

AVT AC Holding and Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 176.494.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Date 3 mai 2013

Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de associé unique du 03.05.2013 de la société AVT AC

Holding and Management S.A. il à été décidé:

Détermination de Monsier Vladimir Kostylev, russe, né le 29 janvier 1947 à Sverdlovskaïa oblast, Union Soviétique,

adresse  privée  14,  Rue  Tony  Neumann,  L-2241,  Luxembourg,  comme  administrateur  de  catégorie  A  avec  effet  du
26.03.2013 jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2018;

Nomination de Monsier Alexander Tkachenko, russe, né le 5 fevrier 1974 à Moscou, Russie, adresse professionnelle

6, Rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg, comme administrateur de catégorie B avec effet du 03.05.2013 jusqu'à l'As-
semblée Générale Ordinaire de l'année 2019;

Nomination de Madame Khatuna Koroglishvili, géorgienne, née le 2 mars 1974 à Tbilissi, Géorgie, adresse profes-

sionnelle 6, Rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg, comme administrateur de catégorie B avec effet du 03.05.2013 jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2019;

Luxembourg, le 07.05.2013.

Référence de publication: 2013058513/21.
(130072357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

BI Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.116.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BI SICAV
SICAV
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2013058553/13.
(130072723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72827

L

U X E M B O U R G

Blueventure Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.144.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2012

1. La liquidation de la société BLUEVENTURE INVESTMENT S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et au commissaire de liquidation pour l'exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés au 412F, route d'Esch, Luxembourg, (L-2086) et y seront conservés

pendant cinq ans au moins.

Extrait certifié sincère et conforme
MERLIS S.à.r.l.
Signatures
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2013058555/17.
(130071889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

BNP Paribas L Fix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 50.443.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BNP Paribas L Fix

Référence de publication: 2013058559/12.
(130072626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Boissons &amp; Alimentation Hanff S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 79, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 109.248.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013058562/14.
(130072655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Development Finnish Feeder III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013058647/10.
(130072255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72828

L

U X E M B O U R G

Capauvent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 108.025.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013058603/14.
(130072660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

CEREP Cumbernauld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 16.858,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.333.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mai 2013.

Référence de publication: 2013058607/10.
(130072799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

CEREP Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 86.846.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mai 2013.

Référence de publication: 2013058608/10.
(130072795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Calisto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 108.707.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2013.

Référence de publication: 2013058601/10.
(130072158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Cerep USA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.336.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 mai 2013.

Référence de publication: 2013058610/10.
(130072815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72829

L

U X E M B O U R G

Capauvent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 108.025.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013058602/14.
(130072659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Calisson, Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.832.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CALISSON S.A.

Référence de publication: 2013058600/10.
(130071970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

CEREP Manresa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.793.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 mai 2013.

Référence de publication: 2013058609/10.
(130072807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Come2Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 161.702.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013058624/10.
(130071908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Compagnie Générale Européenne de Finance et d'Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 50.850.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013058625/10.
(130072613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72830

L

U X E M B O U R G

CPPL Lux 1, Société Anonyme.

Capital social: EUR 126.850,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 77.025.

Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
un mandataire

Référence de publication: 2013058634/12.
(130072108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

COSTRUZIONI E APPALTI 2000 S. à r.l. en liquidation, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.954.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation

de la société COSTRUZIONI E APPALTI 2000 sàrl (n°R.C.S B 0102954), ayant eu son siège social à L-2449 Luxem-

bourg, 8, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse

Pour extrait conforme
Me Kamilla LADKA
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2013058631/15.
(130071843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Crèche Pétronille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8303 Capellen, 89, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 150.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Crèche Pétronille SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013058595/11.
(130071842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Come2Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 161.702.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique du 6 mai 2013

<i>Troisième décision

L'associé unique nomme en remplacement de la société MS Gestion S.A., commissaire aux comptes, la société SO-

COGESCO INTERNATIONAL S.A. (immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 44 906) ayant son siège
social 84, Grand Rue, L-1660 Luxembourg pour une durée qui prendre fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans
l'année 2016.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013058623/16.
(130071907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72831

L

U X E M B O U R G

Canepa Management GP COOP S.A., Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 174.494.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les Informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse professionnelle de Messieurs Francisco Felix RODRIGUEZ, Elias ESBER et Jose VICINI, administrateurs de

classe B de la Société, doit se lire désormais comme suit:

- 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2013.

Canepa Management GP COOP S.A.
Signature

Référence de publication: 2013058569/16.
(130072712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

D'Wierkstat, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5955 Itzig, 10, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 18.272.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013058637/10.
(130071873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für Boss Concept IPC Sicav
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2013058536/12.
(130072479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Beim Tiirmchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9976 Wilwerwiltz, 2, Am Duerf.

R.C.S. Luxembourg B 158.370.

<i>Décision du 6 mai 2013 de l'associé unique de la société «Beim Tiirmchen S.à r.l.»

L'associé accepte la démission avec effet à ce jour de Monsieur Carlo WEIBEL, né le 27.05.1951 à Luxembourg et

demeurant à L- 9776 Wilwerwiltz, 2, Am Duerf de son poste de gérant.

L'associé décide de nommer en remplacement, pour une durée indéterminée, Madame Essamba MBARGA, née le

27.08.1959 à Yaoundé (Cameroun) et demeurant à L- 9776 Wilwerwiltz, 2, Am Duerf au poste de gérante unique avec
pouvoir d'engager la société avec sa seule signature.

Wilwerwiltz, le 6/5/2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>L'Associé unique

Référence de publication: 2013058527/16.
(130071834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72832

L

U X E M B O U R G

Click'n Taste s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 177.019.

STATUTS

L'an deux mille treize, le huit avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- La société anonyme «F &amp; F S.A.», ayant son siège social à L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie, Bâtiment W22,

en voie d'inscription au R.C.S.L.,

ici représentée aux fins des présentes par ses deux administrateurs de catégorie A, à savoir:
a) Madame Séverine CRUCHTEN, ergomotricienne, demeurant à Hettange-Grande (France);
b) Monsieur Stéphane CARLIER, employé privé, demeurant à Libramont (Belgique).
2.- Madame Déborah LEGOIN, épouse L'HOPITAL, employée privée, née à Vernon (France) le 28 décembre 1976,

demeurant à L-3397 Roeser, 43, rue d'Alzingen.

3.- La société à responsabilité limitée «Phil et Jean S. à r.l.», ayant son siège social à L-8011 Strassen, 373, route d'Arlon,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 152.504,

ici représentée aux fins des présentes par ses deux gérants, à savoir:
a) Monsieur Jean-Charles HOSPITAL, cuisinier, demeurant à Hellange;
b) Monsieur Philippe L'HOPITAL, maître d'hôtel, demeurant à Roeser.
4.- Monsieur Lionel LITT, employé privé, né à Sarreguemines (France) le 4 novembre 1985, demeurant à F-57650

Fontoy, 6, rue de Verdun.

5.- Monsieur Vincent FINCK, employé privé, né à Thionville (France) le 1 

er

 novembre 1981, demeurant à L-4831

Rodange, 120, route de Longwy.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer

entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "Click'n Taste s.à r.l.". Elle pourra exercer son activité commerciale

sous l'enseigne «Click'n Taste».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Windhof; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation, pour son propre compte ou en participation, d'un débit de boissons

alcoolisées ou non-alcoolisées avec établissement de restauration et sandwicherie.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte. Elle peut notamment se porter caution

et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financière ou autrement dans toutes autres sociétés, associations et entreprises, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise et toutes prestations de services dans

le cadre des activités prédécrites.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières  ou  autres  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  susceptibles  d'en  favoriser  la
réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent dix mille euros (€ 110.000.-), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une

valeur nominale de cent dix euros (€ 110.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires, ainsi qu'à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 6.
1) Un associé ne peut céder ses parts entre vifs, même à des associés, qu'avec le consentement des autres associés,

qui disposent d'un droit de préemption.

72833

L

U X E M B O U R G

a) A cet effet, l'associé cédant devra en informer ses co-associés au moyen d'une lettre recommandée à la poste en

indiquant le nombre des parts dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires
proposés, ainsi que le prix de vente des parts et les conditions de la cession.

b) Les autres associés auront alors un droit de préemption pour l'achat des parts dont la cession est proposée aux

clauses et conditions projetées. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun de ces
autres associés.

c) L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le cédant par lettre recommandée endéans

les trente jours de l'information du projet de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

i) En cas de non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption, le cédant en informera les autres

associés endéans les huit jours de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption par lettre recommandée à la
poste. Les autres associés pourront, endéans les huit jours de cette notification et par lettre recommandée, exercer un
droit de préemption sur les parts proposées à la cession et pour lesquelles un droit de préemption n'a pas été exercé.
Passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préemption.

ii) En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des parts devra se faire aux clauses et conditions proposées

endéans les deux semaines, faute de quoi le droit de préemption devient caduc,

d) Si aucun des associés n'a exercé son droit de préemption, ou si le droit de préemption n'a été exercé que pour

partie, le cédant est libre de céder les parts pour lesquelles aucun droit de préemption n'a été exercé au cessionnaire
proposé. Dans ce cas la cession devra intervenir obligatoirement endéans les deux semaines qui suivent l'expiration du
dernier délai utile pour l'exercice du droit de préemption, et ce aux clauses et conditions initialement convenues. Toute
cession intervenue à un prix moindre ou à des conditions de paiement autres que celles proposées est nulle.

2) Les parts sociales ne peuvent être transmises à cause de mort, même à des associés, qu'avec l'agrément des associés

survivants qui disposent d'un droit de préemption. A cet effet les héritiers ou bénéficiaires d'institutions testamentaires
ou contractuelles de l'associé décédé informeront les autres associés survivants, par lettre recommandée à la poste, du
décès de leur auteur et de sa dévolution successorale aux fins d'agrément.

Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour informer, par lettre recommandée à la poste, les héritiers de leur agrément.

A défaut d'agrément endéans ledit délai, les héritiers sont censés ne pas avoir été agréés.

En cas de non-agrément, les héritiers, légataires ou institués contractuels peuvent, à défaut d'avoir trouvé un cession-

naire  conformément  au  point  1)  du  présent  article  pour  l'ensemble  des  parts  sociales  de  leur  auteur,  provoquer  la
dissolution de la société trois mois après mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux
associés par pli recommandé à la poste. Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales de l'associé défunt
peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même si elle remplit
les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses titres, sur base d'un prix de rachat calculé sur la base du
bilan moyen des trois dernières années, ou à défaut de trois exercices, sur base du bilan de la dernière ou des deux
dernières années.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10.
10.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et

toujours révocables par elle a la majorité simple; le(s) gérant(s) statutaire(s) ne peu(ven)t être révoqué(s) qu'en respectant
les conditions requises pour une modification des statuts.

L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, détermine la

durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.

Le(s) gérant(s) est/sont rééligible(s).  Le  mandat  du/des  gérant(s) sortant  non  réélu(s) cesse immédiatement après

l'assemblée générale qui a statué sur un remplacement.

72834

L

U X E M B O U R G

10.2 Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de

disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Ainsi, acquérir, vendre des biens immobiliers et/ ou emprunter sous toute forme et en outre gager, hypothéquer, céder
ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs est soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale
des associés statuant à la majorité des associés représentant 3/4 du capital social.

Le ou les gérants pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires

ad hoc et détermineront les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période
de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société.

10.3 En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
10.4 L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est

rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportion-
nelles  qui  seront  allouées  au(x)  gérant(s)  et  portées  en  frais  généraux  indépendamment  de  tous  frais  éventuels  de
représentation, voyages et déplacements.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) La société «F &amp; F S.A.», préqualifiée, six cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

660

2) Madame Déborah LEGOIN, épouse L'HOPITAL, préqualifiée, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . .

150

3) La société «Phil et Jean S.à r.l.», préqualifiée, cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

4) Monsieur Lionel LITT, préqualifié, quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

72835

L

U X E M B O U R G

5) Monsieur Vincent FINCK, préqualifié, quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent dix

mille euros (€ 110.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille trois cents euros (€ 1.300.-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Stéphane CARLIER, employé privé, né à Libramont-Chevigny (Belgique) le 14 novembre 1979, demeurant

à B-6800 Libramont, rue Haynol, 8A, boîte 4 et Madame Déborah LEGOIN, épouse L'HOPITAL, préqualifiée, sont nom-
més gérants techniques de la société pour une durée indéterminée.

2) La société «F &amp; F S.A.», préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un des gérants techniques

et de la gérante administrative.

Toutefois, pour tout paiement de factures de fournisseurs inférieur à deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-), la société

sera valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant technique.

4) Le siège social est fixé à L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie, Bâtiment W22.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: CRUCHTEN, CARLIER, LEGOIN, HOSPITAL, L'HOPITAL, LITT, FINCK, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 15 avril 2013. Relation: CAP/2013/1313. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 23 avril 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013059996/200.
(130073328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

Aquila s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6981 Rameldange, 3, rue Joseph Schroeder.

R.C.S. Luxembourg B 177.013.

STATUTS

L'an deux mille treize, le quinze avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Grégoire AGUILAR, retraité, né à Schifflange le 20 décembre 1929, demeurant à L-4335 Esch-sur-Alzette,

28, rue Henri Tudor.

2.- Madame Rosette WELFRING, épouse de Monsieur Grégoire AGUILAR, retraitée, née à Esch-sur-Alzette le 7

novembre 1930, demeurant à L-4335 Esch-sur-Alzette, 28, rue Henri Tudor.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer

entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "AQUILA s.à r.l.".

72836

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder ou participer à la gestion d'autres sociétés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Rameldange. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décisions des associés.
Il peut être créé, par simple décision des associés et/ou de l'organe de gérance, des filiales, succursales ou bureaux,

tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables et indivisibles.
Lorsque la propriété d'une part sociale est litigieuse ou démembrée, les droits de vote rattachés à cette ou ces part

(s) sociale(s) sont suspendus jusqu'à ce que la société ait été informée qui va représenter cette ou ces parts(s) sociale(s).

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales à un non-

associé, il doit les offrir préalablement à ses co-associés. L'importance des parts offertes aux coassociés doit se faire
proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins six (6)
mois avant la fin de l'exercice en cours.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines de la notification de l'offre

de cession aux co-associés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent
de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de
désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si
la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales,
les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur
participation dans la société.

L'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore

réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date
de l'offre et suivant les conditions de celle-ci.

Toute cession de parts sociales doit être, sous peine de nullité, acceptée par la société.

Art. 8. Les dispositions de l'article 6 sont applicables à toute aliénation de parts sociales.
Les parts sociales sont indivisibles et elles ne peuvent être saisies pour aucun motif.
Dans le cas où la propriété d'une ou de plusieurs parts sociales est contestée ou litigieuse, les droits y afférents sont

suspendus, jusqu'à ce qu'un propriétaire puisse être désigné à la société.

La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison d'un cautionnement quelconque ainsi que l'apport

des parts sociales comme contre-valeur d'une fraction ou de la totalité du capital, dans le capital d'une société, sont
interdites sans l'accord des associés statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 9. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

72837

L

U X E M B O U R G

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné

en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises à des héritiers réservataires.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont

pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée au conseil d'administration par exploit d'huissier et notifiée aux associés
par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

soit par un tiers agréé par eux.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par

l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum par

l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations. Le ou les gérants et/ou la société peuvent procéder à
la nomination d'un ou de plusieurs fondés de pouvoir. La rémunération et les pouvoirs du et/ou des fondés de pouvoir
sont fixés lors de sa/leur nomination.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 13. Le ou les gérants ainsi que le ou les fondés de pouvoir ne contractent, en raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année le ou les gérants établissent le bilan et le compte de profits et pertes de la société. Cinq pour cent des

bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et
aussi longtemps que le réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Après dotation à la réserve légale, l'assemblée décide de la répartition et de la distribution éventuelle du solde des

bénéfices nets.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Grégoire AGUILAR, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Madame Rosette WELFRING, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros  (€ 12.500.-)  se  trouve dès  à  présent  à  la libre  disposition de la société, ainsi  qu'il  en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

72838

L

U X E M B O U R G

1. L'adresse de la société est établie à L-6981 Rameldange, 3, rue Joseph Schroeder.
2. Le nombre de gérants est fixé à deux.
3. Sont nommés gérants de la société pour une durée illimitée: Monsieur Grégoire AGUILAR et Madame Rosette

WELFRING, tous deux préqualifiés.

4. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
Chaque gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration, y compris ceux qui consistent

à accorder des hypothèques ou donner mainlevée d'hypothèques, d'ouvrir et/ou de clôturer des comptes en banque.

5. Le nombre de fondé de pouvoir est fixé à un.
6. Est nommé fondé de pouvoir de la société pour une durée illimitée:
Monsieur Marc AGUILAR, directeur de banque, né à Dudelange le 15 octobre 1961, demeurant à L-6981 Rameldange,

3, rue Joseph Schroeder.

7. Le fondé de pouvoir exercera sa fonction à titre gratuit.
8. La société sera également valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du fondé de

pouvoir, lequel a le pouvoir d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration, y compris ceux qui consistent
à accorder des hypothèques ou donner mainlevée d'hypothèques, d'ouvrir et/ou de clôturer des comptes en banque.

Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: AGUILAR, WELFRING, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 24 avril 2013. Relation: CAP/2013/1429. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): ENTRINGER.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 29 avril 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013059993/157.
(130073172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

Eurotag Europe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal.

R.C.S. Luxembourg B 177.010.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Germain WELVAERT, administrateur de société, né à Bruges (Belgique) le 2 octobre 1950, demeurant à

B-1380 Ohain, rue du Printemps, 28.

Lequel  comparant  a  arrêté  ainsi  qu'il  suit  les  statuts  d'une  société  à  responsabilité  limitée  unipersonnelle  qu'il  va

constituer.

Titre I 

er

 . Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la conception, la production et la vente de systèmes d'identification de clés présentant

des solutions adaptées à tous les départements des entreprises.

72839

L

U X E M B O U R G

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières  ou  autres  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  susceptibles  d'en  favoriser  la
réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de "EUROTAG EUROPE s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et: opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

72840

L

U X E M B O U R G

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et Assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par, la gérance aux associés.

Le Vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins dé dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, dès charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2013.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Germain WELVAERT, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Germain WELVAERT, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social est établi à L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal.
Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

72841

L

U X E M B O U R G

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: WELVAERT, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 29 avril 2013. Relation: CAP/2013/1494. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): ENTRINGER.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 6 mai 2013.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2013059998/139.
(130073133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

Aries Investment S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 84.034.

<i>Extract of the resolution taken by the Quotaholders on January 14 

<i>th

<i> , 2013

- The company's registered offices is transferred from 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg to 5, rue du Plebiscite

L-2341 Luxembourg, with effect as from 1 

st

 January 2013.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 14 janvier 2013

- Le siège social administratif de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 5, rue du

Plébiscite L-2341 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2013.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Certifié sincère et conforme
ARIES INVESTMENT S.à r.l.
A. SCHOLTES / M.F. RABINO
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2013058498/20.
(130072159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Asia Internet Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 177.038.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of

Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

here represented by Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 16 April 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

72842

L

U X E M B O U R G

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Asia Internet Holding S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

72843

L

U X E M B O U R G

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

72844

L

U X E M B O U R G

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

72845

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24 Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

72846

L

U X E M B O U R G

H. Final clause - Governing law

Art. 25 Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-

tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; and

- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausend dreizehn, am neunzehnten April.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 16. April 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

72847

L

U X E M B O U R G

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Asia Internet Holding S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft

72848

L

U X E M B O U R G

ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

72849

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-

schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats  ist  nicht  erforderlich,  wenn  Zeit  und  Ort  in  einem  vorausgehenden  Beschluss  des  Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung und wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer  der  Kategorie  B),  werden  Beschlüsse  des  Geschäftsführungsrats  nur  dann  wirksam  gefasst,  wenn  sie  von  der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

72850

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer  unterzeichnet  wird.  Kopien  und  Auszüge  solcher  Protokolle,  die  in  einem  Gerichtsverfahren  oder  auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-

schrift  des  Einzelgeschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere  Geschäftsführer  hat,  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

72851

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung  stehen.  Der  ausschüttbare  Betrag  darf  nicht  die  Summe  der  seit  dem  Ende  des  vergangenen  Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetzes von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25 Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember

2013.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.200,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; und

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

72852

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19499. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 8. Mai 2013.

Référence de publication: 2013060028/573.
(130073788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.

Azmalo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 177.040.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of April.
Before us MaTtre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of

Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

here represented by Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 16 April 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Azmalo S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

72853

L

U X E M B O U R G

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices

72854

L

U X E M B O U R G

of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

72855

L

U X E M B O U R G

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

72856

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-

tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:

72857

L

U X E M B O U R G

- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; and

- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausend dreizehn, am neunzehnten April.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 16. April 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Azmalo S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

72858

L

U X E M B O U R G

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

72859

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-

schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die

Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Ge-

schäftsführer per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben
haben, wobei eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsfüh-
rungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

72860

L

U X E M B O U R G

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.

17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung und wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer  der  Kategorie  B),  werden  Beschlüsse  des  Geschäftsführungsrats  nur  dann  wirksam  gefasst,  wenn  sie  von  der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer  unterzeichnet  wird.  Kopien  und  Auszüge  solcher  Protokolle,  die  in  einem  Gerichtsverfahren  oder  auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-

schrift  des  Einzelgeschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere  Geschäftsführer  hat,  durch  die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

72861

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung  stehen.  Der  ausschüttbare  Betrag  darf  nicht  die  Summe  der  seit  dem  Ende  des  vergangenen  Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetzes von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

72862

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember

2013.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.200,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; und

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19501. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 8. Mai 2013.

Référence de publication: 2013060031/573.
(130073789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2013.

Vitol Holding II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 43.512.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 2 mai 2013 que:
L'actionnaire unique de la Société a constaté que les mandats de MM. Russel Hardy, Paul Greenslade, David Fransen,

Roland Favre, and Hui Meng Kho en tant qu'administrateurs de catégorie A de la société ont expiré au 1 

er

 mai 2013.

L'actionnaire unique de la Société a décidé de renouveler les mandats de MM. Russel Hardy, Paul Greenslade, David

Fransen, Roland- Favre, and Hui Meng Kho en tant qu'administrateurs de catégorie A de la société avec effet au 2 mai
2013 et pour une durée de quatre (4) mois prenant fin au 31 août 2013.

72863

L

U X E M B O U R G

L'actionnaire unique de la Société a décidé de nommer en tant que nouvel administrateur de catégorie B avec effet au

2 mai 2013 et pour une période de trois ans prenant fin au 1 

er

 mai 2016:

- M. Giuseppe Di Modica, administrateur, né le 31 mai 1974 à Enna (Italie), résidant professionnellement au 13-15

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

En conséquence de quoi, le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Russel Hardy, Administrateur de catégorie A,
- M. Paul Greenslade, Administrateur de catégorie A,
- M. David Fransen, Administrateur de catégorie A,
- M. Hui Meng Kho, Administrateur de catégorie A,
- M. Jeffrey Dellapina, Administrateur de catégorie A,
- M. Ian Taylor, Administrateur de catégorie A,
- M. Miguel Angel Loya, Administrateur de catégorie A,
- M. Roland Favre, Administrateur de catégorie A,
- M. Dirk Richter, Administrateur de catégorie B, et
- M. Giuseppe Di Modica, Administrateur de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 Mai 2013.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2013058447/33.
(130071400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2013.

Eurolever Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 500.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 49.993.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générales des actionnaires de la société tenue le 5 juin 2012

Le 5 juin 2012, les associés de la Société, ont décidé:
- de renouveler les mandats de Luxembourg Corporation Company S.A., TCG Gestion S.A. et CMS Management

Services S.A. en tant que administrateurs de la Société, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale de ordinaire
prévue en 2018;

- de renouveler le mandat de C.A.S. Services S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société, son mandat

expirant lors de l'assemblée générale de ordinaire prévue en 2018;

Luxembourg, le 12 avril 2013.

TCG Gestion S.A. / CMS Management Services S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Représenté par Mme. Catherine Noens / Représenté par M. Fabio Spadoni
<i>Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2013058697/20.
(130071982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

BERF Luxco 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 160.384.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013058545/11.
(130072445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

72864


Document Outline

Actival Partners S.A.

agri.capital Group S.A.

Alpine Sàrl

Amasing Finance S.A.

AME Life Lux S.A.

Amundi Money Market Fund

Angelab International S.A.

Antri S.A.

Aquila s.à r.l.

Argos Soditic Partners S.A.

Aries Investment S.à.r.l.

Arma S.à r.l.

Arrena S.A.

Asia Internet Holding S.à r.l.

Atreyu S.C.A.

AVT AC Holding and Management S.A.

Azmalo S.à r.l.

Beim Tiirmchen S.à r.l.

BERF Luxco 1

B-Fly 2 S.à r.l.

B-Fly 2 S.à r.l.

B-Fly 2 S.à r.l.

B.I.E. Lux

B.I.E. Lux

BI Sicav

Blueventure Investment S.A.

BNP Paribas L Fix

Boissons &amp; Alimentation Hanff S.à.r.l.

Boss Concept IPC Sicav

Boss Concept IPC Sicav

B.R.E. S.A.

B.V. Investment S.A.

Café Dancing Votre Choix S.à r.l.

Calisson

Calisto S.A.

Canepa Management GP COOP S.A.

Capauvent S.A.

Capauvent S.A.

CEREP Cumbernauld S.à r.l.

CEREP Italy S.à r.l.

CEREP Manresa S.à r.l.

Cerep USA S.à r.l.

Click'n Taste s.à r.l.

Coiffure Pia S.à r.l.

Come2Lux S.A.

Come2Lux S.A.

Compagnie Générale Européenne de Finance et d'Investissement S.A.

COSTRUZIONI E APPALTI 2000 S. à r.l. en liquidation

CPPL Lux 1

Crèche Pétronille S.à r.l.

Crèche ZOO magique

Development Finnish Feeder III S.C.A.

D'Wierkstat

Eurolever Holding S.A.

Eurotag Europe s.à r.l.

RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.

SKR Management HOLDING S.A.

Transworld Resources S.A.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Vitol Holding II S.A.

White Mountain S.A.

Zeus Enterprises International S.A.